logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1915

5 août 2008

SOMMAIRE

Alcantara Engineering S.A.  . . . . . . . . . . . . .

91914

Aletta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91916

Apax Med A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91917

Ariadne S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91901

BRE/Vasakronan Holding I S. à r.l.  . . . . . . .

91881

Capricorn Administration Services Lu-

xembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91920

Clementina Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

91912

CL Immobilien GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91920

Compagnie de Gestion Foncière S.A.  . . . .

91900

CORSAIR (Luxembourg) N°11 S.A.  . . . . .

91875

Cristal Consult S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91913

Dakarinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91909

Dakarinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91912

Decibel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91919

Dino S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91917

Divinter SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91875

Dose S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91913

Dumanet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91910

ECIP Agree S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91919

ESP Europe (Funds) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

91914

European Real Estate Capital S.à r.l.  . . . . .

91900

Europe Universal Holding . . . . . . . . . . . . . . .

91919

Flower Power S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91917

Foncière des Anes S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

91896

Gilmour S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91915

ILP Acquisitions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

91902

Ivanhoe Cambridge Pologne II  . . . . . . . . . .

91899

Ivanhoe Cambridge Pologne III . . . . . . . . . .

91900

JCLC Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91911

Karsira Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91896

Leaf Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91917

Lend Lease International Distressed Debt

Fund, S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91874

Lilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91913

Lux Santé S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91912

Martello Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91916

Montrachais S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91914

Mozaica Luxco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91899

Newcontainer No. 4 (Luxembourg) Shipp-

ing S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91915

Ocamut S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91913

OOCL (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

91915

Orgalux A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91920

Orient Overseas Container Line (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91916

Paintbox S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91888

Paunsdorf/Zwickau Arcaden  . . . . . . . . . . . .

91900

Pella Immobilien Gesellschaft 4  . . . . . . . . .

91888

Quincaillerie Schleich S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . .

91920

Raynouard International S.A.  . . . . . . . . . . .

91911

Realest Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91874

Rosace S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91911

Rubens Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91910

ScienceImmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91916

Selargius S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91910

Seton House International S.A. . . . . . . . . . .

91874

SL Option S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91918

Sortalogic (Lux) Holding Company S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91902

Tau Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91896

Um Schlass S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91901

Um Schlass S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91901

Vasakronan S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91875

Velusina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91915

Vera F. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91901

Von Sanders A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91919

Wisberg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91914

Zeta Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91888

Zwickau Arcaden Luxco  . . . . . . . . . . . . . . . .

91911

91873

Realest Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 45.601.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008090392/587/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05279. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080103402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2008.

Lend Lease International Distressed Debt Fund, S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 81.952.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires

<i>tenue à Luxembourg le 26 juin 2008

Il résulte dudit extrait que
PricewaterhouseCoopers sàrl a été réélue en tant que réviseur d'entreprises de la Société. Son mandat expirera à

l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se réunira pour approuver les comptes de l'année 2008.

Luxembourg, le 7 juillet 2008.

Pour extrait conforme
Alain STEICHEN
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008092031/275/18.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2008, réf. LSO-CS06012. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080105786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.

Seton House International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 66.466.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrats der Gesellschaft vom 7. Juli 2008

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat folgende Beschüsse gefaßt:
- Herrn Michael Arthur Kayser, geboren am 21. Juni 1955 in London, England, geschäftsansässig in Watchmoor Point,

Watchmoor Road, Camberley, Surrey GU15 3EX, England,

mit Wirkung zum 7. Juli 2008 als Verwaltungsratmitglied der Gesellschaft zu ernennen, und für eine Dauer bis zur

Generalversammlung, welche im Jahre 2009 stattfindet, zu bestellen.

- den Rücktritt von Herrn Paul Carter mit Wirkung zum 7. Juli 2008 an zu nehmen
Die Geschäftsführung der Gesellschaft setzt sich demnach wie folgt zusammen:
- Herr Karl Asamer
- Herr Guy Harles
- Herr Michael Arthur Kayser
Zum Vermerk im Luxemburger Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. Juli 2008.

Seton House International S.A.
Unterschrift

Référence de publication: 2008092104/250/24.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07715. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.

91874

CORSAIR (Luxembourg) N°11 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 90.447.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2005

- Est nommée comme commissaire aux comptes Mazars, société anonyme, 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxem-

bourg, en remplacement de Elpers &amp; Co Réviseurs d'entreprises S.à r.l.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle

qui se tiendra en 2008 statuant sur les comptes annuels de 2007.

Luxembourg, le 26 juin 2008.

<i>Pour le conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2008087469/1463/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01451. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080099771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2008.

Divinter SA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 20.088.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DIVINTER S.A., Société Anonyme Holding
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008090388/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05386. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080103406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2008.

Vasakronan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 140.160.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth day of June.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

BRE/Vasakronan  Holding  I  S.à  r.l,  a  société  à  responsabilité  limitée  governed  by  the  laws  of  the  Grand-Duchy  of

Luxembourg and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, not yet registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register,

BRE/Vasakronan Holding II S.à r.l, a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of

Luxembourg and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, not yet registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register,

here represented by Ms. Emilie Viard, maître en droit, residing in Nancy, by virtue of proxies, given under private seal

in Luxembourg, on 25 June 2008.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the
articles of incorporation of which shall be as follows:

91875

A. Purpose - duration - name - registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the "Company") which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration,  control  and  development.  For  that  purpose,  the  Company  may  require  and  retain  the  assistance  of  other
advisors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will assume the name of "Vasakronan S.à r.l".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.

B. Share capital - shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500. -) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25. -) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or documents

of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by

private instrument.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members

a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the
shareholders.

91876

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.

Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - annual accounts - distribution of profits

Art. 21. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

91877

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The 500 shares have been subscribed as follows:
- 250 shares by BRE/Vasakronan Holding I S.à r.l, prequalified; and
- 250 shares by BRE/Vasakronan Holding II S.à r.l, prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of

December 2008.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately EUR 1.900,-.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its

registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under section B number 96323, is appointed manager of the Company for an indefinite period of time.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendacht, den fünfundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

BRE/Vasakronan Holding I S.à r.l, eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großherzogtums

Luxemburg, mit in Sitz 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, noch nicht eingetragen im Luxemburger Handelsund
Gesellschaftsregister,

BRE/Vasakronan Holding II S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großherzogtums

Luxemburg, mit in Sitz 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, noch nicht eingetragen im Luxemburger Handelsund
Gesellschaftsregister,

hier vertreten durch Frau Emilie Viard, maître en droit, wohnhaft in Nancy, aufgrund privatschriftlicher Vollmächte,

ausgestellt in Luxemburg, am 25. Juni 2008.

Die Vollmachten bleiben nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die

sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter  werden,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend  die  „Gesell-
schaft") gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

91878

Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-

leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Vasakronan S.à r.l.".

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei

Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaft-

santeile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-

lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters dürfen unter keinen Umständen Siegel an Ver-

mögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei

Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei

Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen.
Die Versammlungen finden am Gesellschaftssitz statt.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

91879

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.

Art. 20. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine

natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.

E. Geschäftsjahr - Konten- Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt

91880

Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- 250 Anteile wurden von BRE/Vasakronan Holding I S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet; und
- 250 Anteile wurden von BRE/Vasakronan Holding II S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2008.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

EUR 1.900,- geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz

in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion
B Nummer 96323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten

Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.

Gezeichnet: E. VIARD - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juillet 2008. LAC/2008/27555. - Reçu soixante-deux euros cinquante cents à 0,50%:

EUR 62,50.

FÜR GLEICHLAUTENDE ABLICHTUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations erteilt.

Luxemburg, den achtzehnten Juli zweitausendacht.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008092639/242/331.
(080106635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

BRE/Vasakronan Holding I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 140.158.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth day of June.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Blackstone Real Estate Partners Europe III-NQ L.P., a limited partnership existing under the laws of England, having its

principal place of business at 40 Berkley Square, London, W1J 5AL, England, registered with the Companies House under
number LP 12903,

91881

Blackstone Real Estate Holdings Europe III-NQ L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Alberta,

Canada,  having  its  principal  place  of  business  at  345  Park  Avenue,  New  York  NY  10154,  United  States  of  America,
registered with the Corporate Registry of Canada under number LP 14020184,

Blackstone Family Real Estate Partnership Europe III-SMD L.P., a limited partnership existing under the laws of the

State of Alberta, Canada, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York NY 10154, United States
of America, registered with the Corporate Registry of Canada under number LP 13708011,

here represented by Ms. Emilie Viard, maître en droit, residing in Nancy, by virtue of proxies, given under private seal

in Luxembourg, on 25 June 2008.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the "Company") which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will assume the name of "BRE/Vasakronan Holding I S.à r.l".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of ma-
nagers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500. -) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25. -) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or documents

of the Company.

91882

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by

private instrument.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members

a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the
shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.

Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

91883

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The 500 shares have been subscribed as follows:
- 470 shares by Blackstone Real Estate Partners Europe III-NQ L.P., prequalified;
- 9 shares by Blackstone Real Estate Holdings Europe III-NQ L.P., prequalified; and
- 21 shares by Blackstone Family Real Estate Partnership Europe III-SMD L.P., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of

December 2008.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,900.,-

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its

registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under section B number 96323, is appointed manager of the Company for an indefinite period of time.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendacht, den fünfundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

Blackstone Real Estate Partners Europe III-NQ L.P., eine limited partnership gegründet nach dem Recht von England,

mit in Sitz 40 Berkley Square, London, W1J 5AL, England, eingetragen im Companies House unter der Nummer LP 12903,

Blackstone Real Estate Holdings Europe III-NQ L.P., eine limited partnership gegründet nach dem Recht des Staates

Alberta, Kanada, mit in Sitz 345 Park Avenue, New York NY 10154, Vereinigten Staaten von Amerika, eingetragen im
kanadischen Gesellschaftsregister unter der Nummer LP 14020184,

91884

Blackstone Family Real Estate Partnership Europe III-SMD L.P., eine limited partnership gegründet nach dem Recht des

Staates Alberta, Kanada, mit in Sitz 345 Park Avenue, New York NY 10154, Vereinigten Staaten von Amerika, eingetragen
im kanadischen Gesellschaftsregister unter der Nummer LP 13708011,

hier vertreten durch Frau Emilie Viard, maître en droit, wohnhaft in Nancy, aufgrund privatschriftlicher Vollmächte,

ausgestellt in Luxemburg, am 25. Juni 2008.

Die Vollmächten bleiben nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die

sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter  werden,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend  die  „Gesell-
schaft") gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in-und ausländischen Gesellschaften und

die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-

leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „BRE/Vasakronan Holding I S.à r.l.".

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei

Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-

lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters dürfen unter keinen Umständen Siegel an Ver-

mögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

91885

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei

Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei

Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen.
Die Versammlungen finden am Gesellschaftssitz statt.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

91886

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.

Art. 20. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine

natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- 470 Anteile wurden von Blackstone Real Estate Partners Europe III-NQ L.P., vorgenannt, gezeichnet;
- 9 Anteile wurden von Blackstone Real Estate Holdings Europe III-NQ L.P., vorgenannt, gezeichnet; und
- 21 Anteile wurden von Blackstone Family Real Estate Partnership Europe III-SMD L.P., vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2008.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

EUR 1.900,- geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz

in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion
B Nummer 96323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten

Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.

Gezeichnet: E. VIARD - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juillet 2008, LAC/2008/27556. — Reçu à 0,50%: soixante-deux euros cinquante

cents (EUR 62.50,-).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

91887

FÜR GLEICHLAUTENDE ABLICHTUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations erteilt.

Luxemburg, den achtzehnten Juli zweitausendacht.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008092642/242/339.
(080106598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Paintbox S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 97.862.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 11 mars 2008

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2011:

- Madame Pia MYRVOLD, artiste, demeurant 327, rue St Martin, 75003 Paris, France, administrateur-délégué
- Madame Lillann MYRVOLD, curateur, demeurant 21, Lyngvollvn, 4017 Stavanger, Norvège;
- LEBOEUF LIMITED, ayant son siège social 325, Waterfront Drive, Wickham's Cay, Road Town, Tortola, British

Virgin  Islands,  représenté  par  Monsieur  Claude  SCHMITZ,  demeurant  professionnellement  au  2,  avenue  Charles  de
Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2011:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 juin 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008092107/534/23.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2008, réf. LSO-CS06126. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.

Zeta Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.533.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008092226/6566/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07556. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.

Pella Immobilien Gesellschaft 4, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 140.144.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the tenth of July.
Before the undersigned notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg);

APPEARED:

The public limited company "PELLA REAL ESTATE INVESTMENT S.A.", with registered office in L-2311 Luxembourg,

55-57, avenue Pasteur,

here duly represented by two of its directors, namely:
- Mr. Nico HANSEN, private employee, professionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, and
- Mrs. Sophie BATARDY, private employee, professionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

91888

Both are here represented by Mr. Christian DOSTERT, private employee, professionally residing in L-6130 Junglinster,

3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur"
by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, requests the officiating notary to enact the articles of association of

a private limited liability company, ("Gesellschaft mit beschrankter Haftung"), to establish as follows:

A. Name - purpose - duration - registered office

Art. 1. There is hereby formed a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschrankter Haftung") under the

name of "PELLA IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 4") ("the Company"), which will be governed by the present articles of
association ("the Articles") as well as by the respective laws and particularly by the modified law of 10 August 1915 on
commercial companies (the "Law of 1915").

Art. 2. The purpose of the Company is the purchase and sale of immoveable properties as well as real estate man-

agement.

The  Company's  purpose  is  also the  participation  in businesses and  companies  of any kind and  the establishment,

development, administration and supervision of businesses and companies. The Company may acquire its participations
by subscription, contribution in kind, exercise of option rights and in any other way, manage and exploit them and dispose
of them by sale, assignment, exchange or in any other way.

The Company may use its means to create, administer, develop and exploit a portfolio consisting of securities and

patents of any kind and origin. For this it may acquire all kinds of securities by purchase, subscription or in any other way
and alienate them by sale, assignment, exchange or in any other way.

The Company may give loans and grant advance payments and sureties to and for the benefit of its subsidiaries, affiliated

companies or any other company in which it has an economic interest, as well as to companies belonging to the same
group of companies, and support them in any way, under reserve and allowing for the respective legal provisions and
without carrying on a bank business or of the financial sector. Moreover, it may borrow in any form with or without
guaranty and mortgage, issue debt securities, loan notes or other debt instruments, pledge or otherwise hypothecate for
the benefit of its own creditors or for the benefit of creditors of companies of the aforementioned kind.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security

for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible

notes), preferred equity certificates, convertible preferred equity certificates and debentures.

The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which are

in direct or indirect relation with Its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its
purposes.

Art. 3. The duration of the Company is unlimited.

Art. 4. The Company's registered office is established in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg).
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or the board

of managers.

The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a collective

decision of the shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as abroad by a simple decision of the board of managers.

B. Share capital - shares

Art. 5. The Company's capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by one

hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euros (125.- EUR) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the Law of 1915.

Art. 6. The Company will recognize only one holder per share.
The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 7. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
remaining share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse.

91889

Art. 8. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 9. The creditors, the assignees and the heirs of the shareholders may not for whatever reason affix seals to the

property and the documents of the Company nor may they interfere in any manner in the management of the Company.
They have to refer to the Company's inventories.

C. Management

Art. 10. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company may be managed by a board of managers.
In that case, the Company will be validly bound in all circumstances by the joint signature of two managers.
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason.

Art. 11. The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also

choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
board of managers.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram or facsimile

another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone conference, videoconference or

by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board
of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entire set of
such circular resolutions will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers.

Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 14. The manager(s) do not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Supervision

Art. 15. The Company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by

a decision of the sole shareholder or by a collective decision of the general meeting of the shareholders, which determines
their number and their remuneration; they can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

E. Decisions of the sole shareholder - general meeting of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

91890

The amendment of these Articles requires the approval of a majority of shareholders representing at least three

quarters of the share capital.

Art. 18. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the Law of 1915 concerning commercial companies, as amended.

F. Financial year - annual accounts - distribution of profits

Art. 19. The Company's accounting year begins on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

Art. 20. Each year, with reference to December 31st, the Company's accounts are established and the Managers

prepare an annual account in the form of a financial statement including profits and losses.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortizations,

expenses and other burdens is allocated as follows:

- five percent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital;

- the remaining amount is at the disposal of the shareholders.

Art. 21. The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these Articles.

G. Dissolution - liquidation

Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 23. Any litigation which will occur during the liquidation of the Company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the Company, will be settled insofar as the Company's business is concerned by
arbitration in compliance with the civil procedure.

H. General dispositions

Art. 24. For all points not regulated by these bylaws, reference is made to the provisions of the modified Law of 1915

on commercial companies.

<i>Subscription and payment of the shares

The Articles having thus been established, the one hundred (100) shares have been subscribed by the sole shareholder

the company "PELLA REAL ESTATE INVESTMENT S.A.", prenamed and represented as said before, and fully paid up by
the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR)
is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who
expressly attests thereto.

<i>Transitional dispositions

The first accounting year starts with the present day and ends on the 31st December 2008.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.

<i>Decisions taken by the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of

the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1. The registered office of the Company is established at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
2. The following persons are appointed, for an undetermined period, as the managers of the Company:
a) Mr. Patrick TEROERDE, private employee, born in Düsseldorf, (Germany), on the 12th of July 1974 residing in

SW73BJ London, South Kensington, 32 Evelyn Gardens, flat 2, (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);

b) Mr. Nico HANSEN, private employee, born in Differdange, on the 31st of March 1969, professionally residing in

L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;

c) Mrs. Sophie BATARDY, private employee, born in Lille, (France), on the 22nd of January 1963, professionally residing

in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

91891

3. The private limited liability company "MGI FISOGEST S.à r.l.", with registered office in L-2311 Luxembourg, 55-57,

avenue Pasteur, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 20,114,
has been appointed as statutory auditor.

The mandate of the statutory auditor will expire at the general annual meeting in the year 2014.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the

above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing party, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning.
The deed having been read to the mandatory of the appearing party, known to the notary by their first and last name,

civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendacht, den zehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Die Aktiengesellschaft "PELLA REAL ESTATE INVESTMENT S.A.", mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pas-

teur,

hier rechtmäßig vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder, namentlich:
- Herr Nico HANSEN, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, und
- Frau Sophie BATARDY, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
Beide sind hier vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster,

3, route de Luxembourg, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht nachdem sie vom
Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben worden ist, bleibt der gegenwärtigen Urkunde
beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Statuten einer zu

gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "PELLA IMMOBILIEN GE-

SELLSCHAFT 4" („die Gesellschaft") gegründet, welche durch gegenwärtige Satzungen („die Statuten"), sowie durch die
anwendbaren Gesetze und besonders durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
(das „Gesetz von 1915") geregelt wird.

Art. 2. Der Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien.
Der Gesellschaftszweck ist ebenfalls die Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art und die Grün-

dung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann ihre Beteili-
gungen durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder in sonstiger Art und Weise erwerben
und durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise verwerten.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios verwenden,

welches sich aus Wertpapieren und Patenten jedweder Art und Herkunft zusammensetzen kann. Sie kann dabei alle Arten
von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder in sonstiger Art und Weise erwerben und diese durch Verkauf, Ab-
tretung oder Tausch oder in sonstiger Weise veräußern.

Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, wie auch Un-

ternehmen,  die  zu  der  gleichen  Gruppe  gehören,  unter  Vorbehalt  und  Beachtung  der  diesbezüglich  zur  Anwendung
gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des
Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese in jedweder Art und Weise zu unters-
tützen. Sie kann darüber hinaus Darlehen mit oder ohne Garantie aufnehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige
Sicherheiten aller Art zugunsten ihrer eigenen Gläubiger oder zugunsten von Gläubigern von Unternehmen der vorbe-
zeichneten Art bestellen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen und kann Schuldinstrumente sowie nicht verzinslichen PEC,

CPEC, Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Wertpapieren ausgeben.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.

91892

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).
Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann Innerhalb der Gemeinde durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder

des Geschäftsführerrates verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen,

die für eine Änderungen der Statuten maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums
Luxemburg verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen, Filialen, Agenturen, Büros oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großher-

zogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend-fünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euros (125,- EUR).

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesetzes von

1915 festgelegt ist.

Art. 6. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an.
Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 7. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaft-

santeile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des restlichen

Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendenten, Deszendenten
oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 8. Der Tod, der Verlust der Bürgerrechte, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters wird

nicht die Auflösung der Gesellschaft herbeiführen.

Art. 9. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Dokumente

der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungshandlungen
einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.

C. Geschäftsführung

Art. 10. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen.
Der/Die Geschäftsführer wird/werden von der Hauptversammlung ernannt, die die Dauer seines/ihres Mandates fest-

legt.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat verwaltet.
In  diesem  Fall  wird  die  Gesellschaft  rechtmäßig  in  allen  Umständen  durch  die  gemeinsame  Unterschrift  von  zwei

Geschäftsführern verpflichtet.

Vollmachten werden durch den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei Sondervollmachten nur aufgrund

notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Art. 11. Der Geschäftsführerrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch

einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates
sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberu-

fungsschreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner
Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied
zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm oder Telefax oder durch
ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann auf die
Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des
Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

91893

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates vertreten
lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates vertreten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung. Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder
vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der je-
weiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden,
unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das als
Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 12. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 13. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund

auch immer, aufgelöst.

Art. 14. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Überwachung

Art. 15. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare, welche nicht Gesellschafter sein

müssen,  überwacht,  welche  durch  einen  Beschluss  des  Alleingesellschafters  oder  durch  einen  Kollektivbeschluss  der
Generalversammlung der Gesellschafter, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt, ernannt werden; sie können beliebig
abberufen werden.

Die Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt, welche die Dauer von 6 Jahren nicht

überschreiten kann.

E. Beschluss des alleingesellschafters - Generalversammlung der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Generalversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Statuten benötigt die Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens

drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes von 1915 zustehen.

F. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 20. Jedes Jahr, am 31. Dezember, werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jah-

resabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen, Rückstellungen und sonstigen Lasten verbleibende Nettogewinn wird

wie folgt verteilt:

- fünf Prozent (5%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen,

bis diese 10% des gezeichneten Kapitals erreicht;

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 21. Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines

von den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur
Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag selbstverständlich nicht die seit dem Ende des letztes Steuerjahres
erzielten Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich
der übertragenen Verluste und der Summen, die einer gesetzlich oder durch diese Statuten vorgeschriebenen Reserve
zugewiesen werden.

91894

G. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 22. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 23. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern

selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in den Statuten festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes

von 1915 über die Handelsgesellschaften, verwiesen.

<i>Zeichnung und Zahlung der Anteile

Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die einhundert (100) Anteile durch die alleinige Gesell-

schafterin, die Gesellschaft "PELLA REAL ESTATE INVESTMENT S.A.", vorgenannt und vertreten wie hiervor erwähnt,
gezeichnet und voll in bar eingezahlt worden, so dass der Betrag von zwölftausend-fünfhundert Euro (12.500,- EUR) der
Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich
bestätigt.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausend Euro.

<i>Beschlussfassung der alleinigen Gesellschafterin

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die erschienene Partei, welche das gesamte gezeichnete Ge-

sellschaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur.
2. Folgende Personen werden, für eine unbestimmte Dauer, zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
a) Herr Patrick TEROERDE, Privatangestellter, geboren in Düsseldorf, (Bundesrepublik Deutschland), am 12. Juli 1974,

wohnhaft in SW73BJ London, South Kensington, 32 Evelyn Gardens, flat 2, (Vereintes Königreich Großbritannien und
Nordirland);

b) Herr Nico HANSEN, Privatangestellter, geboren in Differdingen, (Großherzogtum Luxemburg), am 31. März 1969,

beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;

c) Frau Sophie BATARDY, Privatangestellte, geboren in Lille, (Frankreich), am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft in

L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur.

3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "MGI FISOGEST S.à r.l.", mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue

Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 20.114, ist
zum Kommissar ernannt worden.

Das Mandat des Kommissars endet sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2014.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der

erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen
derselben erschienenen Partei, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird
die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem anfangs oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, dem instrumentierenden

Notar nach Vor-und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe Bevollmächtigte mit Uns, dem Notar,
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: DOSTERT; SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 juillet 2008. Relation GRE/2008/2894. - Reçu soixante deux euros et cinquante cents
0,50 % = 62,50 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

91895

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Junglinster, den 21. Juli 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008092666/231/397.
(080106292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Karsira Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 78.535.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008092238/6566/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07566. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080106151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.

Tau Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.532.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008092230/6566/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07561. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.

Foncière des Anes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2620 Luxembourg, 14, rue Joseph Tockert.

R.C.S. Luxembourg B 140.182.

STATUTS

L'an deux mille huit, le quatre juillet.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- la société VITEC SA, ayant son siège social à L-2620 Luxembourg, rue Tockert 14, Grand Duché de Luxembourg,
inscrite au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 55.493 et représentée par Monsieur Eric AUBRY

en sa qualité d'administrateur délégué de la société.

2.- Monsieur Eric AUBRY, administrateur de sociétés, demeurant à L-2620 Luxembourg, 14, rue Joseph Tockert.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une

société anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme, (ci-après la société), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
et par les présents statuts.

La société existe sous la dénomination de: "FONCIERE DES ANES S.A.".
La société peut avoir un associé unique (ci-après, l'Associé Unique) ou plusieurs actionnaires. La société ne pourra

pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banque route de l'Associé
Unique.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des

actionnaires délibérant en assemblée générale dans les conditions requises pour une modification des statuts.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

91896

Le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration de la société ou, dans le cas d'un

administrateur unique par une décision de l'administrateur unique, dans les limites de la commune de Luxembourg ou
dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économi-

que ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement, par simple décision du conseil d'administration à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition
desdits événements. Cette mesure n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, qui restera une société
luxembourgeoise.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,

sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères se présentant sous forme de société
de capitaux ou de sociétés de personnes, ainsi que la gestion, l'administration, le contrôle et le développement de ces
participations. La société pourra procéder à l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de
souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de titres, de brevets
et de licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement
à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations
qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des
sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

La société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
La société a en outre pour objet le conseil, les études, les services, les réalisations et publications ainsi toutes les

prestations pour les systèmes d'information, numériques ou autres, des entreprises, des organisations et des personnes
privées, ainsi que toutes opérations commerciales, financières, civiles ou commerciales pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000.- (trente et un mille euros), représenté par 100 (cent) actions de EUR

310.- (trois cent dix euros) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix de l'actionnaire

unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues

ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur
la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter le/les action(s) à l'égard de la société.
L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même
règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi luxembourgeoise du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son

sein. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée envers les tiers, soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué, soit par la

signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'adminis-
tration.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la loi, par

un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années et il est
rééligible.

91897

Le commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la société qui détermine leur

nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment,
avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de l'année suivante.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit selon convocation d'un des actionnaires ou de l'admi-

nistrateur délégué dans les délais fixés par la loi luxembourgeoise et qui suivent la date de clôture de l'exercice, au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

A défaut d'indications contraires portées sur les convocation, l'assemblée générale annuelle se tiendra le troisième

lundi du mois de juin à 17h00. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'assemblée générale
annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Dans l'hypothèse d'un associé unique, l'associé unique a tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale. Dans ces

statuts, toutes références aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'assemblée est une référence aux décisions
prises ou aux pouvoirs exercés par l'associé unique tant que la société n'a qu'un associé unique. Les décisions prises par
l'associé unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse de la pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée

représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les
actes relatifs aux opérations de la société.

Art. 12. Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement par la loi ou par les statuts, les décisions de l'assemblée générale

dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des actionnaires de la société, et déclarent

avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale, celle-ci pourra être tenue sans
convocation préalable.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la
société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit conformément aux présents statuts.

L'assemblée générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des

dividendes, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la société.

Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil d'administration et doivent

être payés aux lieu et place choisis par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut décider de payer des
dividendes intermédiaires sous les conditions et dans les limites fixées par la loi sur les sociétés de 1915.

Art. 14. La société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'assemblée générale statuant comme en

matière de modification des statuts.

En cas de dissolution, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, qui pourront être des

personnes physiques ou morales et qui seront nommés par la décision de l'assemblée générale décidant cette liquidation.

L'assemblée générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 15. Les présents statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'assemblée générale extraordinaire, dans

les conditions de quorums et de majorité requises par la loi sur les sociétés de 1915.

Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2008.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

actions

1.- VITEC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

2.- Eric AUBRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 25% (vingt cinq

pour cent) du capital social, de sorte que la somme de EUR 7.750.-(sept mille sept cent cinquante euros) se trouve dès
maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

91898

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales

et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:
1.- VITEC S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 14, rue Tockert, L-2620 Luxembourg.
2.- Monsieur Eric AUBRY, employé privé, demeurant à 14, rue Joseph Tockert, L-2620 Luxembourg.
3.- Monsieur Robert GODART, employé privé, demeurant à L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.
La durée de leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2013.

<i>Deuxième résolution

Monsieur Serge KRAEMER, employé privé, demeurant à 11, rue des Sports, L-5774 Weiler la Tour, est nommé Com-

missaire aux Comptes.

La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2013.

<i>Troisième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-2620 Luxembourg, 14, rue Joseph Tockert.
Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Quatrième résolution

Monsieur Eric AUBRY, prénommé, est nommé Administrateur Délégué et accepte le mandat.
La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2013.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: E. AUBRY, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 juillet 2008. LAC/2008/28211. — Reçu à 0,5 %: cent cinquante cinq euros (155 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 18 juillet 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008092677/211/177.
(080106813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Mozaica Luxco, Société à responsabilité limitée,

(anc. Ivanhoe Cambridge Pologne II).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.244.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

91899

Luxembourg, le 18 juillet 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008092737/7446/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04834. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

European Real Estate Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Ivanhoe Cambridge Pologne III).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.243.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008092738/7446/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04832. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Paunsdorf/Zwickau Arcaden, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.143.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008092739/7446/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04770. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Compagnie de Gestion Foncière S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 73.810.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/07/08.

<i>COMPAGNIE DE GESTION FONCIERE S.A.
Signature

Référence de publication: 2008092836/3258/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2008, réf. LSO-CS06404. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

91900

Um Schlass S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6616 Wasserbillig, 45, rue Duchscher.

R.C.S. Luxembourg B 74.704.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22.07.08.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008092879/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS07932. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080106316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Um Schlass S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6616 Wasserbillig, 45, rue Duchscher.

R.C.S. Luxembourg B 74.704.

Le bilan au 31/12/2006 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22.07.08.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008092880/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS07929. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Ariadne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 79.122.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/07/2008.

<i>Pour Ariadne S.A.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2008092881/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2008, réf. LSO-CS05818. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Vera F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 7-9, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 72.357.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

91901

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 22 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008092867/578/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04340. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

ILP Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 19.489.775,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 109.755.

Le bilan et l'annexe au 31/12/2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>ILP Acquisitions S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008092868/5480/16.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07639. - Reçu 48,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Sortalogic (Lux) Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 140.194.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the seventh of July.
Before Us Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, acting on behalf of Maître Jean SECKLER, notary

residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, actually prevented, who will keep the original of the present deed.

THERE APPEARED:

Sortalogic Investments Limited, with registered office at The Offices of Paget-Brown Trust Company Ltd., Boundary

Hall, Cricket Square, P.O. Box 1111, Grand Cayman, KY1-1102 Cayman Islands, British West Indies, registered with the
Trade and Companies Register of Cayman Islands under number PB-213559,

duly represented by Mr. Alain Thill, private employee, professionally residing at L-6130 Junglinster, 3, route de Lux-

embourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - registered office - object - duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

Sortalogic (Lux) Holding Company S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg,
in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as
by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange (Grand Duchy of Luxem-

bourg). It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the
case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or

91902

events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

91903

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of one

A Manager and one B Manager or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such
signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

91904

V. Annual accounts - allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of March of each year and end on the last day of

February.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board

of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular

allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who

do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder
(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.

VI. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 28 February 2009.

<i>Subscription - payment

Thereupon, Sortalogic Investments Limited, prenamed and represented as stated above declares to subscribe to five

hundred (500) shares in registered form, with a par value of twenty five euros (EUR 25) each, and to fully pay them up
by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500).

The amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved

to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euros.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety

of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

<i>A Manager:

- Mr Olivier Dorier, Company Director, born in Saint-Remy (France) on 25 September 1968, with professional address

at L-5365 Munsbach, 6C, Pare d'Activités Syrdall.

<i>B Managers:

- Mr Henry A. Thompson, lawyer, born in Egypt on 16 November 1961, with professional address in 15, Sloane Square,

2nd Floor, London SW1W 8ER, United Kingdom;

- Mr Mohammed Chowdhury, banker, born in Sylhet (Bangladesh) on 8 December 1967, residing in Villa 15, Gate 30,

Avenue 35, Janabiyah 561, Bahrain;

- Mr Manuel Barbieux, banker, born in Seoul (South Korea) on 9 March 1970, with professional address in 15, Sloane

Square, 2nd Floor, London SW1W 8ER, United Kingdom.

2. The registered office of the Company is set at L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall.

91905

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le sept juillet.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé
restera dépositaire du présent acte.

A COMPARU:

Sortalogic Investments Limited, ayant son siège social à The Offices of Paget-Brown Trust Company Ltd., Boundary

Hall, Cricket Square, P.O. Box 1111, Grand Cayman, KY1-1102 Cayman Islands, British West Indies, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro PB-213559,

valablement représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster,

3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - siège social - objet social - durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination Sortalogic (Lux) Holding

Company S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi dans la commune de Schuttrange (Grand-Duché de Luxembourg). Il peut être transféré

dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales

ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime
que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces évè-
nements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée
entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition
et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou
des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra
aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur
toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements
de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

91906

3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes trans-

actions  se  rapportant  à  la  propriété  immobilière  ou  mobilière,  qui  directement  ou  indirectement  favorisent  ou  se
rapportent à la réalisation de son objet social.

4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500)

parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la

Loi.

III. Gestion - représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de

l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils
constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous
pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,

associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des

gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de

la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de
son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de
la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

91907

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou

représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les procès-verbaux
des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.7. En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-

blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par
lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe

d'un  gérant  A  et  d'un  gérant  B,  ou,  le  cas  échéant,  par  les  signatures  individuelle  ou  conjointe  ou  unique  de  toutes
personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier mars de chaque année et se termine le dernier jour de février.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,

doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

91908

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.

VI. Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 28 février 2009.

<i>Souscription - libération

Ces faits exposés, Sortalogic Investments Limited, prénommé et représenté comme dit ci-dessus, déclare souscrire

cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25) chacune et les
libérer entièrement par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au

notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Coûts

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

<i>Décisions de l'associé unique

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:

<i>Gérant A:

- Monsieur Olivier Dorier, directeur de sociétés, né à Saint-Remy (France) le 25 septembre 1968, demeurant profes-

sionnellement au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.

<i>Gérants B:

- Monsieur Henry A. Thompson, avocat, né en Egypte le 16 novembre 1961, demeurant professionnellement à 15,

Sloane Square, 2nd Floor, London SW1W 8ER, Royaume-Uni;

- Monsieur Mohammed Chowdhury, banquier, né à Sylhet (Bangladesh) le 8 décembre 1967, demeurant à Villa 15,

Gate 30, Avenue 35, Janabiyah 561, Bahrain;

- Monsieur Manuel Barbieux, banquier, né à Séoul (Corée du Sud) le 9 mars 1970, demeurant professionnellement à

15, Sloane Square, 2nd Floor, London SW1W 8ER, Royaume-Uni.

2. Le siège social de la Société est établi au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: THILL- J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 juillet 2008. Relation GRE/2008/2823. — Reçu soixante deux euros et cinquante cents
0,5%= 62,50 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 22 juillet 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008092688/231/404.
(080106997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Dakarinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 77.080.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

91909

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008092894/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2008, réf. LSO-CS03716. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Rubens Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 82.374.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RUBENS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008092891/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07253. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Dumanet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 114.864.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DUMANET S.A, Société Anonyme
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008092890/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07251. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Selargius S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 122.913.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SELARGIUS S.A., Société anonyme
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008092889/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07246. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

91910

Zwickau Arcaden Luxco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.926.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008092736/7446/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04831. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080106910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Rosace S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 116.062.

Le bilan et l'annexe au 30.09.2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ROSACE S.A., Société Anonyme
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008092885/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07225. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Raynouard International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 97.923.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RAYNOUARD INTERNATIONAL S.A., Société anonyme
Guy HORNICK / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008092886/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07228. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

JCLC Invest S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 33.440.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue extraordinairement le 7 juillet 2008 que:
- Monsieur Jean de GRANDCOURT, Avocat, demeurant à Paris.
- Monsieur François WINANDY, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille GEHLEN, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L).
- Monsieur Thierry JACOB, diplômé de l'Institut Commercial de Nancy (France), demeurant à Luxembourg.

91911

Sont réélus Administrateurs pour une durée de une année, leurs mandats prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

Et que
- Monsieur Armand BERCHEM, Diplômé HEC Paris, demeurant à Luxembourg.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de une année, son mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée

Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 7 juillet 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008092123/802/24.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07431. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080106136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.

Lux Santé S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 112.632.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/07/2008.

<i>Pour Lux Santé S.A.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2008092883/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2008, réf. LSO-CS05819. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Clementina Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 79.130.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CLEMENTINA FINANCE S.A., Société Anonyme
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008092884/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07219. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Dakarinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 77.080.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008092895/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2008, réf. LSO-CS03713. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

91912

Ocamut S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Bellevue.

R.C.S. Luxembourg B 48.899.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21/07/08.

Signature.

Référence de publication: 2008092898/5878/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS01955. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080106372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Lilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 72.880.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/07/2008.

<i>Pour Lilux S.A.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2008092912/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2008, réf. LSO-CS05810. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Dose S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 85.188.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/07/2008.

<i>Pour Dose SA
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2008092911/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2008, réf. LSO-CS05809. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Cristal Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 75.927.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008092942/4181/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07495. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

91913

Alcantara Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 83.076.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008092948/1005/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS08259. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080106659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Wisberg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 122.892.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour WISBERG S.A., Société Anonyme
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008092892/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07256A. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Montrachais S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.318.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MONTRACHAIS S.A., Société Anonyme
Claude SCHMITZ / Thierry FLEMING
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008092888/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07237. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

ESP Europe (Funds) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 101.036.

Le bilan au 31/12/2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008092949/1005/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS08254. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

91914

Newcontainer No. 4 (Luxembourg) Shipping S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 122.553.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008092957/6341/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07395. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080106692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Gilmour S.A. Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 98.848.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/07/08.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008092901/550/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2008, réf. LSO-CS06357. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Velusina S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 114.533.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour VELUSINA S.A, Société Anonyme
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008092887/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07232. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

OOCL (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 123.690.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008092962/6341/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07371. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

91915

Orient Overseas Container Line (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 122.746.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008092963/6341/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07367. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080106677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Aletta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 53.842.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008092964/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2008, réf. LSO-CS07078. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Martello Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 117.853.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008092965/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2008, réf. LSO-CS07079. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

ScienceImmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 130.714.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008092966/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2008, réf. LSO-CS07080. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

91916

Flower Power S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9353 Bettendorf, 2, route d'Eppeldorf.

R.C.S. Luxembourg B 92.408.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008092980/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07176. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080106792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Leaf Holding SA, Société Anonyme,

(anc. Dino S.A.).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 102.846.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire datée du 26 juin 2008 que:
1. Les mandats des administrateurs suivants ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui approuvera

les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Administrateurs de classe A:
1. M. Robert Jan Alphons Marie van Ogtrop, né à Johannesburg (Afrique du sud) le 14 avril 1956, résidant à Stukkenlaan

10, 1272 NX Huizen (Pays-Bas);

2. M. Adrianus Nuhn, né à Maastricht (Pays-Bas) le 6 juillet 1953, résidant à Burgemeester's Jacoblaan 24, 1041 BR

Bussum (Pays-Bas);

3. M. Jan Reinier Voûte, né à Amsterdam (Pays-Bas) le 28 juin 1973, résidant à avenue du Vivier d'Oie 17, 1000 Bruxelles

(Belgique);

4. M. Stef Oostvogels, né à Bruxelles (Belgique) le 21 avril 1962, résidant au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg;
- Administrateurs de classe B:
1. M. Ove Anonsen, né à Falköping (Suède) le 17 décembre 1938, résidant à Runebergsvägen 28A, 80267 Gavle (Suède);
2. M. Robert Andreen, né à Göteborg (Suède) le 5 février 1943, résidant à Strandvagen 37, 114 59 Stockholm (Suède);
3. M. Hans Eckerstrom, né à Karlskoga (Suède) le 16 février 1972, résidant à Norrstigen 44, 181 31 Lidingo (Suède);
4. Mme. Noella Antoine, née à Saint-Pierre (Belgique) le 11 janvier 1969, résidant à 5, rue Guillaume Kröll, L-1025

Luxembourg;

2. Le mandat du commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers S.àr.l., ayant son siège social à 400, route d'Esch,

L-2014 Luxembourg a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui approuvera les comptes annuels au 31
décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2008.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008093144/1035/35.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2008, réf. LSO-CS06323. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Apax Med A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 139.477.

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 12 juin 2008 que:

91917

- Monsieur Gérard Maitrejean, avocat à la cour, né le 13 juin 1967 à Charleroi (Belgique), demeurant professionnel-

lement au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a démissionné de sa fonction de gérant de la Société et ce avec effet
au 12 juin 2008;

- Monsieur Stef Oostvogels, avocat à la cour, né le 21 avril 1962 à Bruxelles (Belgique), demeurant professionnellement

au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, est nommé gérant de classe A de la Société pour une durée illimitée et ce
avec effet au 12 juin 2008;

- Monsieur Geoffrey Henry, expert-comptable, né le 5 mai 1972, à Chenée (Belgique), demeurant professionnellement

au 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, est nommé gérant de classe A de la Société pour une durée illimitée
et ce avec effet au 12 juin 2008;

- Monsieur Richard Newton, gérant, né le 5 janvier 1974, à Edimbourg (Grande-Bretagne), demeurant professionnel-

lement au 33 Jermyn Street, Londres, SW1Y 6DN, Grande-Bretagne, est nommé gérant de classe B de la Société pour
une durée illimitée et ce avec effet au 12 juin 2008; et

- Madame Denise Fallaize, directeur général, née le 9 décembre 1973, à Guernsey (Grande-Bretagne), demeurant au

Le Campere, rue du Campere, St Pierre du Bois, Guernsey, GY7 9DA Grande-Bretagne, est nommée gérant de classe B
de la Société pour une durée illimitée et ce avec effet au 12 juin 2008.

Le conseil de gérance se compose donc dorénavant comme suit:
- Monsieur Stef Oostvogels, gérant de classe A;
- Monsieur Geoffrey Henri, gérant de classe A;
- Monsieur Richard Newton, gérant de classe B; et
- Madame Denise Fallaize, gérant de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 3 juillet 2008.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008093166/1035/36.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2008, réf. LSO-CS06309. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080107051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

SL Option S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 322.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 109.974.

EXTRAIT

1. Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 17 juin 2008 que les gérants suivants

ont démissionné:

- Monsieur Robert Whitton gérant de catégorie A avec effet au 31 mai 2008;
- Monsieur Stéphane Hadet gérant de catégorie B avec effet au 4 juin 2008.
2. Il résulte de ces mêmes résolutions que les gérants suivants ont été nommés en remplacement des gérants démis-

sionnaires avec effet au 17 juin 2008:

- Monsieur James Helton, né le 26 février 1967 à Welwyn Garden City (Grande-Bretagne), demeurant professionnel-

lement au 100 Piccadilly Street, Londres W1J 7NH (Grande-Bretagne), en tant que gérant de catégorie A, en remplace-
ment de Monsieur Robert Whitton;

- Monsieur Costas Constantinides, né le 17 septembre 1979 à Lefkosia Nicosia (Chypre), demeurant professionnel-

lement  au  41,  boulevard  Prince  Henri,  L-1724  Luxembourg  (Grand-Duché  de  Luxembourg),  en  tant  que  gérant  de
catégorie B, en remplacement de Monsieur Stéphane Hadet;

- Monsieur Russell Perchard, né le 16 janvier 1978 à Jersey (Iles Britanniques), demeurant professionnellement au 41,

boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que gérant de catégorie B, en
remplacement de Monsieur Stéphane Hadet.

Suite à ces changements le conseil de gérance de la société est désormais composé des gérants suivants:
- Mr. James Elton, gérant de catégorie A;
- Mrs. Candace Valiunas, gérant de catégorie A;
- Mr. François Pfister, gérant de catégorie B;
- Mr. Russell Perchard, gérant de catégorie B;

91918

- Mr. Costas Constantinides, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 09 juillet 2008.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008093202/1035/37.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS07943. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

ECIP Agree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 139.366.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 juin 2008, acte n 

o

 318 par-devant

Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jacques DELVAUX
Boîte Postale 320, L-2013 Luxembourg
<i>Notaire

Référence de publication: 2008093039/208/14.
(080106435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Von Sanders A.G., Société Anonyme,

(anc. Decibel S.A.).

Siège social: L-5470 Wellenstein, 33, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 98.277.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 51811 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008093043/211/12.
(080106991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Europe Universal Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 29, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 106.928.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008093006/8479/12.
Enregistré à Diekirch, le 21 juillet 2008, réf. DSO-CS00352. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080106869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

91919

Capricorn Administration Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 108.601.

<i>Extrait des résolutions prises par les administrateurs de la société réunis en conseil d'administration en date du 1 

<i>er

<i> avril 2008

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1 

er

 avril 2008 du 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008093063/3906/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2008, réf. LSO-CS09288. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080106989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Orgalux A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 103.954.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 22 juillet 2008.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2008093033/667/15.
Enregistré à Diekirch, le 14 juillet 2008, réf. DSO-CS00125. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080106559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Quincaillerie Schleich S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 52, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 99.467.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008092985/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04772. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

CL Immobilien GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7680 Waldbillig, 6, rue de Christnach.

R.C.S. Luxembourg B 99.252.

Die verkürzte Bilanz zum 31. Dezember 2007 wurde hinterlegt im Handelsregister.
Zum Vermerk Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Den 12/06/08.

Unterschrift.

Référence de publication: 2008092984/785/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07173. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

91920


Document Outline

Alcantara Engineering S.A.

Aletta S.A.

Apax Med A S.à r.l.

Ariadne S.A.

BRE/Vasakronan Holding I S. à r.l.

Capricorn Administration Services Luxembourg S.à r.l.

Clementina Finance S.A.

CL Immobilien GmbH

Compagnie de Gestion Foncière S.A.

CORSAIR (Luxembourg) N°11 S.A.

Cristal Consult S.A.

Dakarinvest S.A.

Dakarinvest S.A.

Decibel S.A.

Dino S.A.

Divinter SA

Dose S.A.

Dumanet S.A.

ECIP Agree S.à r.l.

ESP Europe (Funds) S.à r.l.

European Real Estate Capital S.à r.l.

Europe Universal Holding

Flower Power S.à r.l.

Foncière des Anes S.A.

Gilmour S.A. Holding

ILP Acquisitions S.à r.l.

Ivanhoe Cambridge Pologne II

Ivanhoe Cambridge Pologne III

JCLC Invest S.A.

Karsira Holding S.A.

Leaf Holding SA

Lend Lease International Distressed Debt Fund, S.C.A.

Lilux S.A.

Lux Santé S.A.

Martello Invest S.A.

Montrachais S.A.

Mozaica Luxco

Newcontainer No. 4 (Luxembourg) Shipping S.à r.l.

Ocamut S.A.

OOCL (Luxembourg) S.A.

Orgalux A.G.

Orient Overseas Container Line (Luxembourg) S.A.

Paintbox S.A.

Paunsdorf/Zwickau Arcaden

Pella Immobilien Gesellschaft 4

Quincaillerie Schleich S.à.r.l.

Raynouard International S.A.

Realest Finance S.A.

Rosace S.A.

Rubens Holding S.A.

ScienceImmo S.A.

Selargius S.A.

Seton House International S.A.

SL Option S.à.r.l.

Sortalogic (Lux) Holding Company S.à r.l.

Tau Holding S.A.

Um Schlass S.A.

Um Schlass S.A.

Vasakronan S.à r.l.

Velusina S.A.

Vera F. S.A.

Von Sanders A.G.

Wisberg S.A.

Zeta Holding S.A.

Zwickau Arcaden Luxco