logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1828

24 juillet 2008

SOMMAIRE

Apone S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87724

Asset Finance Management Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87737

Axess Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87725

Baki-Paysage S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87700

Baya S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87698

Beau Soleil Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87698

Brixton Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87721

C71  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87724

Carib Power Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

87718

Cetrel Securities S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87699

Cocteau S.A.-SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87698

Compagnie de Banque Privée  . . . . . . . . . . .

87725

Connecting You Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87698

Datheda Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

87699

Delphi Automotive Systems Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87720

Delphi Automotive Systems Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87725

Dograd Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87740

Eadred International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

87743

FCM Finance S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87699

Financière Centuria Luxembourg S.A.  . . .

87700

Financière du Fruit S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

87718

Hellenger Café  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87700

IK Investment Partners S.à r.l.  . . . . . . . . . .

87714

Indian Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

87699

Industri Kapital Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

87714

Inofinance S.A. Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . .

87702

Kaytwo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87717

Latincom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87729

Laumor Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

87738

Lindinger Management Services S.A.  . . . .

87738

Lindinger Management Services S.A.  . . . .

87739

Losty S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87718

Mamm'out Luxembourg S.à.r.l.  . . . . . . . . .

87720

Martine S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87713

Morgan Stanley Infrastructure S.A.  . . . . . .

87744

Ophelius S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87719

Parker Hannifin Luxembourg Investments

1 S.à. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87741

PGF III S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87740

PGF III S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87740

Planetarium Advisor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

87701

Plastichem S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87737

P.T.R. Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87701

Rolic Invest S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87720

Rolly Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87701

ROMAKA, société à responsabilité limitée

& Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87700

Safeharbor S.A. Holding  . . . . . . . . . . . . . . . .

87707

Samson International Holding S.A.  . . . . . .

87726

Société d'Etudes pour Travaux et Partici-

pations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87728

Sustainable Energy Solutions S.à r.l.  . . . . .

87739

Svendborg Brakes International S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87729

T.O.Summit S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87717

Valbay International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

87744

Van Kanten S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87719

World Trade Stones s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

87729

87697

Beau Soleil Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 120.966.

Le bilan au 30 novembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008087971/6341/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS04136. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080101313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Connecting You Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5573 Remich, 6, Montée Saint-Urbain.

R.C.S. Luxembourg B 93.960.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 11 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008088027/7884/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01644. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Cocteau S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 50.275.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/07/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008088045/660/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2008, réf. LSO-CR10305. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Baya S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 116.431.

A la suite de la convention de cession en date du 17 septembre 2007 des 250 parts sociales détenues par la société

anonyme SUDIMOLUX S.A., celles-ci sont dorénavant toutes détenues comme suit:

- 250 parts sociales par la société anonyme BARYLUX S.A., R.C.S. Luxembourg B n 

o

 127.683, avec siège social à

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 20.6.2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BAYA S.àr.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Sébastien ANDRE / Signature

Référence de publication: 2008088129/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR10965. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080100872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

87698

FCM Finance S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 29.244.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/07/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008088046/660/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2008, réf. LSO-CR10306. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080101300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Indian Investment S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 31.162.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/07/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008088047/660/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2008, réf. LSO-CR10308. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Cetrel Securities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 117.298.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,

en date du 15 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n 

o

 1654 du 1 

er

 septembre 2006.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2008.

<i>Pour CETREL Securities, Société Anonyme
Sonja Streicher

Référence de publication: 2008088048/9032/16.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04732. - Reçu 113,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Datheda Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 93.954.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008088056/263/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05920. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

87699

ROMAKA, société à responsabilité limitée &amp; Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 27.595.

Les statuts coordonnés au 20 janvier 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008088049/507/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS03961. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080100645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Baki-Paysage S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4324 Esch-sur-Alzette, 7-9, rue des Sports.

R.C.S. Luxembourg B 81.001.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/07/08.

Signature.

Référence de publication: 2008088050/3256/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03597. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080100840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Hellenger Café, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3334 Hellange, 15, Garerbierg.

R.C.S. Luxembourg B 114.657.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/07/08.

Signature.

Référence de publication: 2008088051/3256/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03596. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080100844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Financière Centuria Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 96.465.

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration

<i>qui a eu lieu le 9 juin 2008 au siège social

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration que:
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers, en tant que

Réviseur d'Entreprises de la société, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle devant approuver les comptes de
la société au 31 décembre 2008.

<i>Pour FINANCIERE CENTURIA LUXEMBOURG S.A.
Renaud Labye
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008088155/6654/18.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05737. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080100851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

87700

Rolly Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 115.177.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue en date du 21 mai 2008 que:
- les mandats d'administrateur de Monsieur Eric VANDERKERKEN, employé privé, ayant son adresse professionnelle

au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, de Monsieur Massimo LONGONI, consultant, ayant son adresse privée au 10,
rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg, de Monsieur Johan DEJANS, administrateur délégué, ayant son
adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg et de Monsieur Richardus BREKELMANS, employé privé,
ayant  son  adresse  professionnelle  au  73,  Côte  d'Eich,  L-1450  Luxembourg,  ainsi  que  le  mandat  de  commissaire  aux
comptes de Marcel STEPHANY, réviseur d'entreprises, ayant son adresse professionnelle au 23, Cité Aline Mayrisch,
L-7268 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au
31 décembre 2008.

Luxembourg, le 21 mai 2008.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008088153/751/23.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2008, réf. LSO-CR08576. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Planetarium Advisor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 59.791.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 17 mars 2008 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
Monsieur Umberto Trabaldo Togna (Président du Conseil), Président de la Direction Générale, PKB Privatbank AG,

12, rue Charles-Galland, CH-1211 Genève 12

Monsieur Marc Schammo, Deputy Director, Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470

Luxembourg

Madame Anne-Marie Arens, Vice-President, RBC Dexia Investor Services Bank SA, 14, Porte de France, L-4360 Esch-

sur-Alzette

en leur qualité d'administrateurs, pour une période d'un an se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des

actionnaires devant se tenir en 2009,

- de renouveler le mandat de ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg, à la fonction de Commissaire aux Comptes pour la

même période d'un an.

Luxembourg, le 30 juin 2008.

<i>Pour PLANETARIUM ADVISOR S.A., Société Anonyme
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2008088152/1126/25.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02738. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

P.T.R. Finances S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.200.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 98.009.

Constituée suivant acte reçu par M 

e

 Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 2003,

87701

publié au Mémorial C-N 

o

 127 du 30 janvier 2004.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2008

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée déplore le décès de notre Administrateur Monsieur Michel ROQUEPLO.
L'Assemblée ratifie la cooptation de Gilles ALIX, demeurant professionnellement à F-92800 Puteaux, 31-32, Quai de

Dion Bouton, en qualité d'Administrateur, faite par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 25 mars 2008 pour
la période du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Pour extrait conforme
Signatures

Référence de publication: 2008088151/2308/20.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2008, réf. LSO-CR08079. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080100934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Inofinance S.A. Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 98.841.

L'an deux mille huit, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "INOFINANCE S.A. HOLD-

ING", avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 30 décembre 2003, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C, numéro 314 du 18 mars 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annette SCHROEDER, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur René SCHLIM, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Adoption d'une version anglaise des statuts.
2) Transfert du siège social et de l'Administration Centrale de la Société vers les Iles Vierges Britanniques.
3) Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007.
4) Décharge aux administrateurs et au commissaire.
5) Acceptation de la démission du commissaire actuellement en fonction.
6) Confirmation du mandat des administrateurs
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'adopter un version anglaise des statuts et décide qu'en cas de divergences entre le texte français

et le texte anglais, le texte français fera foi.

Les statuts auront dans leur version anglaise la teneur suivante:

Art. 1. There is hereby established a holding company (société anonyme) under the name of "INOFINANCE S.A.

HOLDING".

The registered office is established in Luxembourg.

87702

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct

and substantial interest.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In  general, the corporation may  take  any measure  and  carry out any operation which  it may  deem useful  to  the

accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of
July 31, 1929, concerning Holding Companies.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-five thousand euros (EUR 35,000.-) represented by three hundred and

fifty (350) shares without a designation of a par value.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law

prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

If the capital is increased, rights attached to the new shares are the same as those attached to the existing shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the company.

The corporation is committed in all circumstances by the individual signature of each director.

Art. 6. The board of directors may elect among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between  directors,  which may be given  by  letter,  telegram, telex or  telefax, being  permitted.  In case of  emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
For the first time the meeting to be held immediately after the incorporation may proceed to the appointment of the

managing director.

Art. 7. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

The first financial year will begin today and end on the thirty-first of December two thousand and four.

Art. 9. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated

in the convening notices on the second Thursday of the month of March at 11.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

87703

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who
need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It

has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the legal dispositions.

Art. 12. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies and the Law of July 31, 1929, on Holding Companies,

as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la nationalité de la Société et de transférer le siège social et l'Administration Centrale

de la Société vers les Iles Vierges Britanniques, sans dissolution préalable de la Société.

L'assemblée décide que la Société continuera d'exister en tant qu'une BVI Business Company aux Iles Vierges Britan-

niques conformément à la Section 180 du BVI Business Companies Act, 2004.

L'assemblée décide en outre, qu'avec effet de la date de continuation de la société aux Iles Vierges Britanniques, le

siège social de la société aux Iles Vierges Britanniques est fixé à Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town,
Tortola, Iles Vierges Britanniques.

Il est décidé que l'Agent Domiciliataire de la Société aux Iles Vierges Britanniques sera ICAZA, GONZALEZ-RUIZ &amp;

ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Iles Vierges Bri-
tanniques et qu'il est autorisé à procéder à l'inscription de la Société au "Registrar of Corporate Affairs".

La Société ne maintiendra pas de succursale ou autre entité juridique au Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2007, dont un exemplaire est annexé aux présentes.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice se terminant au 31 décembre

2007.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée accepte la démission du commissaire actuel, savoir la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée confirme le mandat des administrateurs actuellement en fonction, savoir Monsieur Robert RECKINGER,

Monsieur Jacques RECKINGER et Monsieur Guy WAGNER.

<i>Septième résolution

L'Assemblée autorise ICAZA, GONZALEZ-RUIZ &amp; ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED à signer au nom des adminis-

trateurs le Mémorandum et les statuts de la société.

<i>Huitième résolution

L'assemblée adopte le Memorandum et les statuts conformément au BVI Business Companies Act, 2004.

<i>Neuvième résolution

L'Assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Jacques RECKINGER ou à Madame Annette SCHROEDER pour re-

présenter la société vis à vis des instances administratives et fiscales à Luxembourg à la suite du transfert de siège et du
changement de nationalité comme dit ci- avant et en vue d'accomplir toutes les formalités requises, notamment pour
faire constater par devant notaire la réalisation de la condition suspensive ci-après.

<i>Condition suspensive

Les résolutions ci-dessus sont prises sous la condition suspensive de l'inscription de la Société par les autorités des

Iles Vierges Britanniques.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en français suivi d'une version française suivi d'une version anglaise; sur demande des comparants et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte français fait foi.

87704

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and eight, on the eighteenth of June.
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg,

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "INOFINANCE S.A. HOLDING" having its reg-

istered office in Luxembourg, incorporated by a notarial deed on December 30, 2003, published in the Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations C number 314 of March 18, 2004.

The Meeting is presided over by Mr Jacques RECKINGER, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Annette SCHROEDER, employee, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr René SCHLIM, employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed

by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be annexed
to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are repre-

sented  at  the  present  meeting,  so  that  the  meeting  can  validly  decide  on  all  the  items  of  the  agenda  of  which  the
shareholders have been beforehand informed.

III.- That the agenda of the Meeting is the following:
1. Adoption of an English version of the Articles of Incorporation.
2. Transfer of the registered office and central administration of the company to the British Virgin Islands.
3. Approval of annual accounts as of December 31, 2007.
4. Discharge to the directors and to the auditor.
5. Acceptance of the resignation of the statutory auditor.
6. Confirmation of the mandates of the directors.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resoles to adopt an English version of the Articles of Incorporation and decides that in case of divergences

between the French text and the English text, the French text will prevail.

The articles of incorporation in English are as follows:

Art. 1.  There  is  hereby  established  a  holdig  company  (société  anonyme)  under  the  name  of  "INOFINANCE  S.A.

HOLDING".

The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct

and substantial interest.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In  general, the corporation may  take  any measure  and  carry out any operation which  it may  deem useful  to  the

accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of
July 31, 1929, concerning Holding Companies.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-five thousand euros (EUR 35,000.-) represented by three hundred and

fifty (350) shares without a designation of a par value.

87705

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law

prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

If the capital is increased, rights attached to the new shares are the same as those attached to the existing shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the company.

The corporation is committed in all circumstances by the individual signature of each director.

Art. 6. The board of directors may elect among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between  directors, which  may  be  given by letter,  telegram,  telex or telefax, being permitted.  In  case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
For the first time the meeting to be held immediately after the incorporation may proceed to the appointment of the

managing director.

Art. 7. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

The first financial year will begin today and end on the thirty-first of December two thousand and four.

Art. 9. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated

in the convening notices on the second Thursday of the month of March at 11.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who
need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It

has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the legal dispositions.

Art. 12. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies and the Law of July 31, 1929, on Holding Companies,

as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Second resolution

The meeting resolves to change the nationality of the Company and to transfer the registered office and the central

administration of the Company to the British Virgin Islands, without dissolution of the Company.

The meeting resolves that the Company be continued as a BVI Business Company in the British Virgin Islands pursuant

to Section 180 of the BVI Business Companies Act, 2004.

87706

The meeting further resolves, that with effect from the date of continuation of the company in the British Virgin Islands,

the Company's Registered Office in the British Virgin Islands will be Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands.

It was resolved that the Company's Registered Agent in the British Virgin Islands will be ICAZA, GONZALEZ-RUIZ

&amp; ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands and it be and hereby is authorized to file the Continuation of the Company with the Registrar of Corporate Affairs.

The Company will not maintain a subsidiary or other legal entity in the Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

The meeting approves the annual accounts as of December 31, 2007, a copy of which will remain attached to the

present deed.

<i>Fourth resolution

The meeting grants discharge to the directors and the auditor for the execution of their mandate for the fiscal year

2007.

<i>Fifth resolution

The meeting accepts the resignation of the statutory auditor, namely FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

<i>Sixth resolution

The meeting confirms the mandate of the directors on duty, namely Mr Robert RECKINGER, Mr Jacques RECKINGER

and Mr Guy WAGNER.

<i>Seventh resolution

The meeting authorizes ICAZA, GONZALEZ-RUIZ &amp; ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED to sign on behalf of the Di-

rectors the Memorandum and Articles of Association of the Company.

<i>Eighth resolution

The meeting resolves to adopt the Memorandum and Articles of Association in compliance with the BVI Business

Companies Act, 2004.

<i>Ninth resolution

The meeting confers all powers to Mr Jacques RECKINGER or to Mrs Annette SCHROEDER to represent the Com-

pany vis-à-vis the administrative authorities and the fiscal authorities after this transfer and change of nationality in order
to accomplish all formalities, and especially to appear before the notary to state the fulfilment of the condition precedent
hereafter.

<i>Condition precedent

The above resolutions have been taken under the condition precedent that the Company is registered in the British

Virgin Islands.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Signé: J. RECKINGER, A. SCHROEDER, R. SCHLIM et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juin 2008. Relation: LAC/2008/26385. — Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008088518/242/299.
(080101781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Safeharbor S.A. Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 98.840.

L'an deux mille huit, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

87707

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SAFEHARBOR S.A. HOLD-

ING", avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 30 décembre 2003, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C, numéro 314 du 18 mars 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annette SCHROEDER, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur René SCHLIM, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Adoption d'une version anglaise des statuts.
2) Transfert du siège social et de l'Administration Centrale de la Société vers les Iles Vierges Britanniques.
3) Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007.
4) Décharge aux administrateurs et au commissaire.
5) Acceptation de la démission du commissaire actuellement en fonction.
6) Confirmation du mandat des administrateurs
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'adopter un version anglaise des statuts et décide qu'en cas de divergences entre le texte français

et le texte anglais, le texte français fera foi.

Les statuts auront dans leur version anglaise la teneur suivante:

Art. 1. There is hereby established a holding company (société anonyme) under the name of "SAFEHARBOR S.A.

HOLDING".

The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct

and substantial interest.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the corporation may  take any  measure  and  carry out any  operation  which it  may deem  useful to the

accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of
July 31, 1929, concerning Holding Companies.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-five thousand euros (EUR 35,000.-) represented by three hundred and

fifty (350) shares without a designation of a par value.

87708

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law

prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

If the capital is increased, rights attached to the new shares are the same as those attached to the existing shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the company.

The corporation is committed in all circumstances by the individual signature of each director.

Art. 6. The board of directors may elect among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between  directors,  which may be given  by  letter,  telegram, telex or  telefax, being  permitted.  In case of  emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
For the first time the meeting to be held immediately after the incorporation may proceed to the appointment of the

managing director.

Art. 7. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8.  The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

The first financial year will begin today and end on the thirty-first of December two thousand and four.

Art. 9. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated

in the convening notices on the third Wednesday of the month of March at 10.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who
need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It

has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the legal dispositions.

Art. 12. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies and the Law of July 31, 1929, on Holding Companies,

as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la nationalité de la Société et de transférer le siège social et l'Administration Centrale

de la Société vers les Iles Vierges Britanniques, sans dissolution préalable de la Société.

L'assemblée décide que la Société continuera d'exister en tant qu'une BVI Business Company aux Iles Vierges Britan-

niques conformément à la Section 180 du BVI Business Companies Act, 2004.

87709

L'assemblée décide en outre, qu'avec effet de la date de continuation de la société aux Iles Vierges Britanniques, le

siège social de la société aux Iles Vierges Britanniques est fixé à Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town,
Tortola, Iles Vierges Britanniques.

Il est décidé que l'Agent Domiciliataire de la Société aux Iles Vierges Britanniques sera ICAZA, GONZALEZ-RUIZ &amp;

ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Iles Vierges Bri-
tanniques et qu'il est autorisé à procéder à l'inscription de la Société au "Registrar of Corporate Affairs".

La Société ne maintiendra pas de succursale ou autre entité juridique au Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2007, dont un exemplaire est annexé aux présentes.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice se terminant au 31 décembre

2007.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée accepte la démission du commissaire actuel, savoir la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A..

<i>Sixième résolution

L'Assemblée confirme le mandat des administrateurs actuellement en fonction, savoir Monsieur Robert RECKINGER,

Monsieur Jacques RECKINGER et Monsieur Guy WAGNER.

<i>Septième résolution

L'Assemblée autorise ICAZA, GONZALEZ-RUIZ &amp; ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED à signer au nom des adminis-

trateurs le Mémorandum et les statuts de la société.

<i>Huitième résolution

L'assemblée adopte le Memorandum et les statuts conformément au BVI Business Companies Act, 2004.

<i>Neuvième résolution

L'Assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Jacques RECKINGER ou à Madame Annette SCHROEDER pour re-

présenter la société vis à vis des instances administratives et fiscales à Luxembourg à la suite du transfert de siège et du
changement de nationalité comme dit ci- avant et en vue d'accomplir toutes les formalités requises, notamment pour
faire constater par-devant notaire la réalisation de la condition suspensive ci-après.

<i>Condition suspensive

Les résolutions ci-dessus sont prises sous la condition suspensive de l'inscription de la Société par les autorités des

Iles Vierges Britanniques.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en français suivi d'une version française suivi d'une version anglaise; sur demande des comparants et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte français fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and eight, on the eighteenth of June.
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg,

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "SAFEHARBOR S.A. HOLDING" having its reg-

istered office in Luxembourg, incorporated by a notarial deed on December 30, 2003, published in the Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations C number 314 of March 18, 2004.

The Meeting is presided over by Mr Jacques RECKINGER, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Annette SCHROEDER, employee, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr René SCHLIM, employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed

by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be annexed
to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are repre-

sented  at  the  present  meeting,  so  that  the  meeting  can  validly  decide  on  all  the  items  of  the  agenda  of  which  the
shareholders have been beforehand informed.

87710

III.- That the agenda of the Meeting is the following:
1. Adoption of an English version of the Articles of Incorporation.
2. Transfer of the registered office and central administration of the company to the British Virgin Islands.
3. Approval of annual accounts as of December 31, 2007.
4. Discharge to the directors and to the auditor.
5. Acceptance of the resignation of the statutory auditor.
6. Confirmation of the mandates of the directors.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resoles to adopt an English version of the Articles of Incorporation and decides that in case of divergences

between the French text and the English text, the French text will prevail.

The articles of incorporation in English are as follows:

Art. 1. There is hereby established a holding company (société anonyme) under the name of "SAFEHARBOR S.A.

HOLDING".

The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct

and substantial interest.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In  general,  the  corporation  may  take  any  measure  and  carry out any operation which  it may  deem useful  to  the

accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of
July 31, 1929, concerning Holding Companies.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-five thousand euros (EUR 35,000.-) represented by three hundred and

fifty (350) shares without a designation of a par value.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law

prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

If the capital is increased, rights attached to the new shares are the same as those attached to the existing shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the company.

The corporation is committed in all circumstances by the individual signature of each director.

87711

Art. 6. The board of directors may elect among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between  directors,  which  may be  given by letter,  telegram,  telex or telefax, being permitted.  In  case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
For the first time the meeting to be held immediately after the incorporation may proceed to the appointment of the

managing director.

Art. 7. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

The first financial year will begin today and end on the thirty-first of December two thousand and four.

Art. 9. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated

in the convening notices on the third Wednesday of the month of March at 10.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who
need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It

has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the legal dispositions.

Art. 12. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies and the Law of July 31, 1929, on Holding Companies,

as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Second resolution

The meeting resolves to change the nationality of the Company and to transfer the registered office and the central

administration of the Company to the British Virgin Islands, without dissolution of the Company.

The meeting resolves that the Company be continued as a BVI Business Company in the British Virgin Islands pursuant

to Section 180 of the BVI Business Companies Act, 2004.

The meeting further resolves, that with effect from the date of continuation of the company in the British Virgin Islands,

the Company's Registered Office in the British Virgin Islands will be Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands.

It was resolved that the Company's Registered Agent in the British Virgin Islands will be ICAZA, GONZALEZ-RUIZ

&amp; ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands and it be and hereby is authorized to file the Continuation of the Company with the Registrar of Corporate Affairs.

The Company will not maintain a subsidiary or other legal entity in the Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

The meeting approves the annual accounts as of December 31, 2007, a copy of which will remain attached to the

present deed.

<i>Fourth resolution

The meeting grants discharge to the directors and the auditor for the execution of their mandate for the fiscal year

2007.

<i>Fifth resolution

The meeting accepts the resignation of the statutory auditor, namely FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A..

<i>Sixth resolution

The meeting confirms the mandate of the directors on duty, namely Mr Robert RECKINGER, Mr Jacques RECKINGER

and Mr Guy WAGNER.

87712

<i>Seventh resolution

The meeting authorizes ICAZA, GONZALEZ-RUIZ &amp; ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED to sign on behalf of the Di-

rectors the Memorandum and Articles of Association of the Company.

<i>Eighth resolution

The meeting resolves to adopt the Memorandum and Articles of Association in compliance with the BVI Business

Companies Act, 2004.

<i>Ninth resolution

The meeting confers all powers to Mr Jacques RECKINGER or to Mrs Annette SCHROEDER to represent the Com-

pany vis-à-vis the administrative authorities and the fiscal authorities after this transfer and change of nationality in order
to accomplish all formalities, and especially to appear before the notary to state the fulfilment of the condition precedent
hereafter.

<i>Condition precedent

The above resolutions have been taken under the condition precedent that the Company is registered in the British

Virgin Islands.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Signé: J. RECKINGER, A. SCHROEDER, R. SCHLIM et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juin 2008. Relation: LAC/2008/26387. — Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008088514/242/299.
(080101753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Martine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 111.898.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le vingt-quatre juin.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société T&amp;F TAX AND FINANCE S.A., ayant son siège social au 6, Via Bossi, CH-6900 Lugano, Suisse,
ici représenté par Monsieur Marc KOEUNE, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Lugano, le 30 mai 2008.
Ladite procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:
- La société anonyme ''MARTINE, S.à r.l.'', N 

o

 R.C.S. Luxembourg N 

o

 B 111 898, fut constituée par Maître Joseph

ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 septembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 377 du 21 février 2006;

- La société a actuellement un capital de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en dix (10) parts sociales

d'une valeur nominale mille deux cent quarante euros (EUR 1.240,-) chacune, entièrement libérées;

- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des parts sociales de la société ''MARTINE,

S.à r.l.''.

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la société ''MARTINE, S.à

r.l.'' avec effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société ''MARTINE, S.à r.l.'' déclare que l'activité de la société a

cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné;

87713

- L'actionnaire unique s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister

à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société
est à considérer comme faite et clôturée.

- la comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuvé les comptes annuels et de profits et pertes de la société

au 31.12.2007 ainsi que le bilan de clôture daté de ce jour;

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux gérants pour leur mandat jusqu'à ce jour;
- le mandant donne tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A. pour procéder au dépôt desdits comptes annuels et des

déclarations fiscales y afférentes;

- les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER

S.A., 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des parts sociales qui a été immédiatement

lacéré.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société ''MARTINE S.à r.l.''.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: M. Koeune et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 27 juin 2008, LAC/2008/26213. — Reçu douze euros Eur 12.-.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008088523/5770/50.
(080101776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

IK Investment Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Industri Kapital Luxembourg S.à r.l.).

Capital social: EUR 2.235.950,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.911.

In the year two thousand eight, on the eighth of May.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Industri Kapital Europa B.V., a company duly incorporated under the laws of The Netherlands and having its regis-

tered office in Claude Debussylaan 44, 1082 MD Amsterdam, Netherlands;

2. Brialmont AB, having its registered office at Cardellgatan 3, 11436 Stockholm, Sweden;
3. Kalexa Förvaltning AB, having its registered office at Odenvagen 18, 13338 Saltsjobaden, Sweden;
4. Mikaros AB, having its registered office at Osterangsvagen 46B, 18247 Enebyberg, Sweden;
5. Ricks Holding Limited, having its registered office at Libra Tower, 23, Olympian Street, 3605 Limassol;
6. Mr. Christopher Masek, residing at Flat 4, 3 Palace Gate, London, W8 5LS, United Kingdom;
7. Mr. Mads Ryum Larsen, residing at 41 Bradbourne Street, London, SW6 3TF, United Kingdom;
8. SoMaLo AB, having its registered office at Grönviksvägen 141, 167 76 Bromma, Sweden;
9. Mr. James Yates, residing at 20 Onslow Avenue, Richmond, TW10 6QB, United Kingdom;
10. Mr. Kristiaan Nieuwenburg, residing at 92 Ifield Road, London, SW10 9AD, United Kingdom;
11. MAJA Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH, having its registered office at Parkllee, D-9620144 Hamburg;
12. IK Investment Partners Sàrl, with registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Here represented by Mrs. Delphine Tempé, lawyer, residing at Luxembourg, acting by virtue of twelve proxies given

in May 2008. The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of the registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
That they are the actual shareholders of "IK INVESTMENT PARTNERS Sàrl", a private limited liability company (société

à responsabilité limitée) having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the notary public Maître
Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, on December 31st, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et

87714

Associations number 316 of March 19th, 2004, the articles of which have been amended for the last time pursuant to a
deed of the undersigned notary on April 30th, 2008, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associ-
ations.

Pursuant to a share redemption agreement dated 8 May 2008, the Company has redeemed 6,183 (Six Thousand One

Hundred Eighty Three) preferential class E shares representing all the issued class E preferential Shares issued by the
Company.

All this having been declared, the appearing parties, holding 100% of the share capital of IK INVESTMENT PARTNERS

Sàrl, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have requested the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to withdraw all 6,183 (Six Thousand One Hundred Eighty Three) preferential class E shares and to reduce

accordingly the Company's subscribed share capital in the amount of ONE HUNDRED FIFTY FOUR THOUSAND FIVE
HUNDRED SEVENTY FIVE Euros (EUR 154,575) in order to bring the Company's subscribed share capital from its
current amount of TWO MILLION THREE HUNDRED NINETY THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY FIVE EUROS
(EUR 2,390,525) to TWO MILLION TWO HUNDRED THIRTY FIVE THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY euros (EUR
2,235,950) by cancellation of all these 6,183 preferential class E shares;

2. Modification of the provisions of Article 7.1 (Subscribed and paid Up Share Capital) of the articles of association of

the Company as a result of the capital reduction;

3. Amendment of the articles of association in order to eliminate the references to the class E preferential shares,
4. Miscellaneous.
After approval of the foregoing, the meeting passed the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to reduce the Company's subscribed share capital by an amount of ONE HUNDRED

FIFTY FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED SEVENTY FIVE Euros (EUR 154,575) in order to bring the Company's
subscribed share capital from its current amount of TWO MILLION THREE HUNDRED NINETY THOUSAND FIVE
HUNDRED TWENTY FIVE EUROS (EUR 2,390,525) to TWO MILLION TWO HUNDRED THIRTY FIVE THOUSAND
NINE HUNDRED FIFTY euros (EUR 2,235,950) by cancellation of all these 6,183 preferential class E shares, having a par
value of TWENTY FIVE EUROS (EUR 25), held by the Company in its own portfolio.

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend article 7.1 (Subscribed and Paid Up Share Capital) subsequently, that will read

as follows.

7.1. Subscribed and Paid Up Share Capital. The Company's corporate capital is fixed at TWO MILLION TWO HUN-

DRED  THIRTY  FIVE  THOUSAND  NINE  HUNDRED  FIFTY  euros  (EUR  2,235,950)  represented  by  SIXTY  FOUR
THOUSAND SEVEN HUNDRED SIX (64,706) Class A Ordinary Shares, SIX THOUSAND ONE HUNDRED EIGHTY
THREE (6,183) Class F Preference Shares, SIX THOUSAND ONE HUNDRED EIGHTY THREE (6,183) Class G Prefer-
ence Shares, SIX THOUSAND ONE HUNDRED EIGHTY THREE (6,183) Class H Preference Shares, SIX THOUSAND
ONE HUNDRED EIGHTY THREE (6,183) Class I Preference Shares, all with a par value of Twenty-Five Euros (EUR 25)
and all fully subscribed and entirely paid UP.

At the moment and as long as all the Shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

("société unipersonnelle") in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately two thousand-
euros.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le huit mai.
Par-devant, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

ONT COMPARU:

87715

1. Industri Kapital Europa B.V., une société de droit de néerlandais, ayant son siège social à Claude Debussylaan 44,

1082 MD Amsterdam, Pays-Bas;

2. Brialmont AB, ayant son siège social à Cardellgatan 3, 11436 Stockholm, Suède;
3. Kalexa Förvaltning AB, ayant son siège social à Odenvagen 18, 13338 Saltsjobaden, Suède;
4. Mikaros AB, ayant son siège social à Osterangsvagen 46B, 18247 Enebyberg, Suède;
5. Monsieur Christopher Masek, demeurant au Flat 4, 3 Palace Gate, Londres, W8 5LS, Royaume Uni;
6. Monsieur Mads Ryum Larsen, demeurant à 41 Bradbourne Street, Londres, SW6 3TF, Royaume Uni;
7. SoMaLo AB, ayant son siège social à Grönviksvägen 141, 167 76 Bromma, Suède;
8. Ricks Holding Limited, ayant son siège social à Libra Tower, 23, Olympian Street, 3605 Limassol;
9. Monsieur James Yates, demeurant à 20 Onslow Avenue, Richmond, TW10 6QB, Royaume Uni;
10. Monsieur Kristiaan Nieuwenburg, demeurant à 92 Ifield Road, Londres, SW10 9AD, Royaume Uni;
11. MAJA Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH, ayant son siège social à Parkllee, 9620144 Hamburg, Allemagne;
12. IK Investment Partners Sàrl, ayant son siège social à 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Ici représentés par Madame Delphine Tempe, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu de douze

procurations datées de mai 2008. Lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des com-
parants et le notaire soussigné, resteront annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Les comparants, représentés comme dit avant, ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
Qu'ils sont les associés actuels de «IK INVESTMENT PARTNERS Sàrl», une société à responsabilité limitée, ayant son

siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire Joseph Elvinger, demeurant à Luxembourg, le 31 décembre
2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 316 du 19 mars 2004, les statuts ayant été modifiés
pour la dernière fois selon un acte du notaire soussigné, le 30 avril 2008, non encore publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.

Que suivant un contrat de rachat de parts sociales en date du 8 mai 2008, la Société a racheté 6.183 parts sociales

Préférentielles de classe E, représentant toutes les parts sociales Préférentielles de classe E émises par la Société.

Les comparants détenant 100% du capital social de IK INVESTMENT PARTNERS Sàrl, ont immédiatement procédé à

l'assemblée générale extraordinaire et ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I.- L'agenda de l'assemblée est le suivant:
1. Décision de retirer toutes les SIX MILLE CENT QUATRE VINGT TROIS (6.183) parts sociales préférentielles de

classe E et de réduire en conséquence le capital souscrit de la société d'un montant de CENT CINQUANTE QUATRE
MILLE  CINQ  CENT  SOIXANTE  QUINZE  EUROS  (EUR  154.575)  de  façon  à  ramener  le  capital  souscrit  de  DEUX
MILLIONS TROIS CENT QUATRE VINGT DIX MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS (EUR 2.390.525) à DEUX
MILLIONS DEUX CENT TRENTE CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (EUR 2.235.950) par annulation
des SIX MILLE CENT QUATRE VINGT TROIS (6.183) parts sociales Préférentielles de classe E.

2. Modification de l'article 7.1. (Capital souscrit et libéré) des statuts de la Société suite à la réduction du capital social;
3. Modification des statuts de la Société afin d'éliminer les références aux actions préférentielles de la classe E;
4. Divers.
Après approbation de ce qui précède, l'assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social d'un montant de CENT CINQUANTE QUATRE MILLE CINQ

CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (EUR 154.575) de façon à ramener le capital souscrit de DEUX MILLIONS TROIS
CENT QUATRE VINGT DIX MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS (EUR 2.390.525) à DEUX MILLIONS DEUX
CENT TRENTE CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (EUR 2.235.950) par annulation des SIX MILLE CENT
QUATRE VINGT TROIS (6.183) d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25) chacune, détenues en nom
propre par la Société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 7.1 des statuts

« 7.1.Capital souscrit et libéré. Le capital social de la Société est fixé à DEUX MILLIONS DEUX CENT TRENTE CINQ

MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (EUR 2.235.950) représenté par Soixante Quatre Mille Sept Cent Six (64.706)
Parts Sociales Ordinaires de Classe A, Six Mille Cent Quatre Vingt Trois (6.183) Parts Sociales Préférentielles de Classe
F, Six Mille Cent Quatre Vingt Trois (6.183) Parts Sociales Préférentielles de Classe G, Six Mille Cent Quatre Vingt Trois
(6.183) Parts Sociales Préférentielles de Classe H, Six Mille Cent Quatre Vingt Trois (6.183) Parts Sociales Préférentielles
de Classe I, chacune ayant une valeur nominale de Vingt Cinq Euros (EUR 25) et toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi sur les Sociétés. Dans la mesure où les articles 200-1 et
200-2 de la Loi sur les Sociétés trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre
lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.»

87716

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes est estimé à environ deux mille Euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande de la comparante et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: D. TEMPE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 mai 2008. Relation: LAC/2008/19444. — Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE conforme à l'original, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008088524/211/158.
(080101957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Kaytwo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 130.000.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 25 avril 2008

1. L'associé unique prend acte de la démission de:
- Monsieur Olivier Gaston-Braud, né le 22 Mai 1974, à Bois-Bernard (France), demeurant 2, rue Heldenstein, L-1723

Luxembourg,

de ses fonctions de gérant de la Société, avec effet au 25 Avril 2008.
2. Et de la nomination de:
- Madame Lara Schweiger, née le 19 Mars 1974, à Belfast (Irlande du Nord), demeurant 8, rue Fernand Mertens, L-2148

Luxembourg

à la fonction de gérant de la Société, avec effet au 25 Avril 2008.
3. Et comme commissaire aux comptes KPMG Audit Sàrl, 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 Avril 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008088454/1021/22.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2008, réf. LSO-CQ00292. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080100750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

T.O.Summit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 60.499.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 14 mai 2008

- Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Andréa GHIRINGHELLI, Avocat, demeurant professionnellement au 38,

Via Nassa, CH-6900 Lugano, de Monsieur Christian FRANÇOIS, employé privé, demeurant professionnellement au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Stéphane BAERT, employé privé, demeurant professionnellement
au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à
l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège

social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à
l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

87717

Certifié sincère et conforme
<i>T.O. SUMMIT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008088248/795/22.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS03869. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Carib Power Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 160.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 98.999.

Il est porté à la connaissance des tiers que l'adresse professionnelle du gérant, Monsieur Luc SUNNEN, est dorénavant

à inscrire au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008088442/799/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS03979. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080100712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Financière du Fruit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 93.135.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur Christian FRANÇOIS. Ce dernier
assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2014.

Luxembourg, le 17 juin 2008.

<i>FINANCIERE DU FRUIT S.A.
O. OUDIN / C. FRANCOIS
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2008088247/795/17.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS03870. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Losty S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 44.351.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2008

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de la société Lux Business Management Sàrl, ayant son siège
social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social au 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Co-Ventures S.A., avec siège
social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les
comptes de l'exercice 2008.

87718

Luxembourg, le 27 juin 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008088242/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03145. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Van Kanten S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 64.737.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2008

L'Assemblée  renouvelle  les  mandats  d'administrateur  de  Monsieur  Gilles  JACQUET,  employé  privé,  avec  adresse

professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de la société Lux Business Management S.àr.L, ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société Lux Konzern S.àr.L, ayant son siège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A.,
ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera
sur les comptes de l'exercice 2008.

Luxembourg, le 27 juin 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008088243/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03142. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Ophelius S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 72.882.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2008

L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse profes-

sionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de la société Lux Business Management Sàrl, avec siège social
au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société Lux Konzern Sàrl, avec siège social au 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Co-Ventures S.A., ayant son siège
social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les
comptes de l'exercice 2008.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008088244/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03125. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

87719

Mamm'out Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9670 Merkholtz, In den Sangen.

R.C.S. Luxembourg B 91.712.

Par cette lettre je donne ma démission en tant que responsable de Mamm'out Luxembourg. La démission est à partir

du 30 juin 2008.

Mortsel, le 1 

er

 juillet 2008.

An Jespers.

Référence de publication: 2008088229/553/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS03983. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080101000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Rolic Invest S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 111.695.

EXTRAIT

1. Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 30 juin 2008 que les gérants suivants

ont démissionné avec effet immédiat:

- Monsieur François Pfister;
- Monsieur Stef Oostvogels.
2. Il résulte de ces mêmes résolutions que les gérants suivants ont été nommés en remplacement des gérants démis-

sionnaires avec effet immédiat:

- Monsieur Alberto Morandini, né le 6 février 1968 à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant profession-

nellement au 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

- Monsieur Alain Blondlet, né le 27 mars 1966 à Longlier (Belgique), demeurant professionnellement au 41, boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008088230/1035/26.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03595. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 16.758.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 21 mai 2008 à

Bascharage que les résolutions suivantes ont été adoptées:

1. Le mandat du réviseur d'entreprise suivant est renouvelé avec effet immédiat pour une période de un an:
- La société Ernst &amp; Young Luxembourg S.A., avec siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, dont le

numéro d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés est le B 88.019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

87720

Fait à Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008088233/1035/19.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03513. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Brixton Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.813.

In the year two thousand and eight, on the ninth day of May.
Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BRIXTON HOLDING S.A., a company limited by

shares, having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, incorporated by deed of the under-
signed notary, on November 16, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of December
19, 2007, number 2953, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 133813.

The meeting is presided by Mr Jean Michel Merienne, private employee, residing professionally in Senningerberg.
who appointed as secretary Mrs Sophie Mathot, private employee, residing professionally in Senningerberg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Dorothée Schulz, private employee, residing professionally in L-1855 Luxem-

bourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. - To increase the subscribed share capital of the Company by an amount of five million nine hundred thousand Euros

(EUR 5,900,000) so as to raise the subscribed capital from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000)
divided into three million one hundred thousand (3,100,000) shares with a par value of one Cent (0.01- EUR) per share
to an amount of five million nine hundred thirty-one thousand Euros (5,931,000) to be finally divided into five hundred
ninety-three million one hundred thousand (593,100,000) shares having each a par value of one Cent (0.01 EUR) by the
creation of and issue of five hundred ninety million (590,000,000) new additional shares, each with a par value of one
Cent (0.01 EUR) and issued with the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as form
the day of the extraordinary shareholders' meeting on, against contributions in cash;

2. - To have all the shares subscribed by the current shareholder of the Company, being Calster Capital Ltd, a company

duly incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands, with registered office at Palm Grove House,
PO Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3. - To amend Article 5 (5) paragraph five point one (5.1.) of the Company's Articles of Incorporation so as to reflect

the capital increase and to give it then henceforth the following wording:

Art. 5.1. The Corporate capital is set at five million nine hundred thirty-one thousand Euros (5,931,000) divided into

five hundred ninety-three million one hundred thousand (593,100,000) shares having a nominal value of one Cent (0.01
EUR) each."

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the
proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed

to the present deed.

III.- That the present meeting, representing one hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and

may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general shareholders' meeting unanimously resolves to increase the subscribed share capital of the Company by

an amount of five million nine hundred thousand Euros (EUR 5,900,000) so as to raise the subscribed capital from its
present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) divided into three million one hundred thousand (3,100,000)
shares with a par value of one Cent (0.01- EUR) per share to an amount of five million nine hundred thirty-one thousand
Euros (5,931,000) to be finally divided into five hundred ninety-three million one hundred thousand (593,100,000) shares
having each a par value of one Cent (0.01- EUR) by the creation of and issue of five hundred ninety million (590,000,000)
new additional shares, each with a par value of one Cent (0.01- EUR) and issued with the same rights and privileges as

87721

the existing shares and entitling to dividends as form the day of the extraordinary shareholders' meeting on, against
contributions in cash.

<i>Subscription - payment

The total of the new shares is then subscribed, by the sole shareholder:
Calster Capital Ltd, a company duly incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands, with regis-

tered office at Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, here represented by Mrs
Dorothée Schulz, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal as mentioned hereabove, which declares to
subscribe for the five hundred ninety million (590,000,000) new additional shares by contribution in cash amounting to
five million nine hundred thousand Euros (EUR 5,900,000).

All the shares have been fully paid-up in cash, so that the amount of five million nine hundred thousand Euros (EUR

5,900,000) is from now at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by
a bank certificate.

<i>Second resolution

As a result of the first resolution, the general shareholders' meeting unanimously resolves to amend paragraph 5.1 of

Article 5 of the Company's statutes to be read as follows:

Art.5. Share Capital.
5.1. The Corporate capital is set at five million nine hundred thirty-one thousand Euros (5,931,000) divided into five

hundred ninety-three million one hundred thousand (593,100,000) shares having a nominal value of one Cent (0.01- EUR)
each (the "Shares")."

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Declaration

The undersigned notary states in compliance with Article 32-1 of company law, as modified, that the conditions of

Article 26 of this law have been observed.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about thirty-three thousand Euros (EUR 33,000).

Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in English

followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English and
the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit le neuf mai.
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRIXTON HOLDING S.A. avec siège

social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 16 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2953 du 19 décembre 2007,
immatriculée au registre de commerce et des société de Luxembourg sous le numéro B 133813.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Merienne, employé privé, demeurant profes-

sionnellement à Senningerberg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Sennin-

gerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Dorothée Schulz, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. - Augmentation du capital souscrit de la Société d'un montant de cinq millions neuf cent mille Euros (EUR 5.900.000,-)

pour porter le montant de son capital souscrit de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trois millions
cent mille (3.100.000) actions, ayant une valeur nominale de un Cent (EUR 0,01) chacune au montant de cinq millions
neuf cent trente et un mille Euros (EUR 5.931.000,-) représenté finalement par cinq cent quatre-vingt-treize millions cent
mille  (593.100.000)  actions  de  un  Cent  (EUR  0,01)  chacune  par  l'émission  de  cinq  cent  quatre-vingt-dix  millions

87722

(590.000.000) nouvelles actions, d'une valeur nominale de un Cent (EUR 0,01) chacune, investies des mêmes droits et
privilèges que les actions existantes et donnant droit aux dividendes à partir du jour de la tenue de la présente assemblée
générale extraordinaire, par apport en espèces;

2. - Souscription de toutes les nouvelles actions par l'actionnaire existant, Calster Capital Ltd, une société constituée

et régie par le droit des îles Vierges Britanniques, avec siège social à Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola,
Iles Vierges Britanniques;

3. - Modification de l'article 5 paragraphe 5.1 des statuts de la Société en vue de refléter l'augmentation de capital qui

aura  la  teneur  suivante:  «Art.  5.1.  Le  capital  social  est  fixé  à  cinq  millions  neuf  cent  trente  et  un  mille  Euros  (EUR
5.931.000,-) divisé en cinq cent quatre-vingt-treize millions cent mille (593.100.000) actions, ayant une valeur nominale
de un Cent (EUR 0,01) chacune (les «Actions»)».

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

„ne varietur" par les comparants.

III.-  Que  la  présente  assemblée,  réunissant  cent  pour  cent  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut

délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide à l'unanimité d'augmenter le capital souscrit de la société d'un montant de cinq millions

neuf cent mille Euros (EUR 5.900.000,-) pour porter le montant de son capital souscrit de trente et un mille Euros (EUR
31.000,-) représenté par trois millions cent mille (3.100.000) actions, ayant une valeur nominale de un Cent (EUR 0,01)
chacune au montant de cinq millions neuf cent trente et un mille Euros (EUR 5.931.000,-) représenté finalement par cinq
cent quatre-vingt-treize millions cent mille (593.100.000) actions de un Cent (EUR 0,01) chacune par l'émission de cinq
cent quatre-vingt-dix millions (590.000.000) nouvelles actions, d'une valeur nominale de un Cent (EUR 0,01) chacune,
investies des mêmes droits et privilèges que les actions existantes et donnant droit aux dividendes à partir du jour de la
tenue de la présente assemblée générale extraordinaire, par apport en espèces.

<i>Souscription - libération

Toutes les nouvelles actions sont souscrites à l'instant par l'actionnaire unique:
Calster Capital Ltd, une société constituée et régie par le droit des îles Vierges Britanniques, avec siège social à Palm

Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques ici représentée par Madame Dorothée Schulz,
précité, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé comme indiqué ci-dessus, qui déclare souscrire les cinq cent
quatre-vingt-dix millions (590.000.000) actions nouvellement émises et les libérer par un apport en espèces s'élevant à
cinq millions neuf cent mille Euros (EUR 5.900.000,-).

Toutes les actions sont libérées en espèces de sorte que le montant de cinq millions neuf cent mille Euros (EUR

5.900.000,-) est à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat
bancaire.

<i>Seconde résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le paragraphe 1 

er

 de l'Article 5 des

statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à cinq millions neuf cent trente et un mille Euros (EUR 5.931.000,-) divisé en cinq cent

quatre-vingt-treize millions cent mille (593.100.000) actions, ayant une valeur nominale de un Cent (EUR 0,01) chacune
(les «Actions»)».

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'Article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'Article 26, ont été remplies.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de trente-trois mille Euros (EUR 33.000,-).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.

87723

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: Jean Michel Merienne, Sophie Mathot, Dorothée Schulz, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 19 mai 2008, LAC/2008/ 19979. - Reçu à 0,50%: vingt-neuf mille cinq cents euros

(€ 29.500,-).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 3 juillet 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008088526/202/171.
(080101661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

C71, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 114.205.

Il est porté à la connaissance des tiers que l'adresse professionnelle des gérants, Messieurs Luc SUNNEN et Christophe

FENDER, est dorénavant à inscrire au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008088443/799/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS03984. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080100714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Apone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 53.643.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2008

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Serguei ARSHINOV, administrateur de sociétés,

demeurant 34, rue des Fraises à L-7321 Steinsel, de Madame Christel GIRARDEAUX, employée privée, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Business Management S.à.r.l., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES
S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui
statuera sur les comptes de l'exercice 2008.

Luxembourg, le 27 juin 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008088245/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02162. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

87724

Compagnie de Banque Privée, Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 117.963.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2008

En date du 25 juin 2008 l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
De nommer Administrateurs M. Edio Delcò, domicilié Via Co'd'Denta 46, CH-6808 Torricella, pour une durée expirant

lors de l'Assemblée Générale appelée à délibérer sur les comptes de la Banque au 31 mars 2010.

Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Pour extrait sincère et conforme
S. Harmel
<i>Secrétaire du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2008088238/7989/17.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04758. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080101238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 16.758.

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration tenu en date du 21 mai 2008 à Bascharage que:
Le mandat de l'administrateur délégué suivant est renouvelé avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale des

actionnaires qui se tiendra en 2009 et approuvant les comptes annuels 2008 de la Société:

- Monsieur Steven Kiefer, né le 12 juillet 1963 à Michigan, USA, demeurant au 2, rue de l'Egalité, L-8319 Olm.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008088234/1035/18.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03511. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Axess Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 125.808.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 125808, ici représentée par son Directeur Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse
professionnelle à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La société anonyme AXESS INVEST S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, a été

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 8 mars 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1052 du 4 juin 2007.

- La société a actuellement un capital social de EUR 100.000.- (cent mille euros) représenté par 100 (cent) actions sans

désignation de valeur nominale.

87725

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, savoir la société

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A..

- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société AXESS INVEST S.A.. Il assume la fonction de

liquidateur.

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société AXESS

INVEST S.A..

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.
- L'actionnaire unique est investi de tous les actifs de la Société et se chargera en sa qualité de liquidateur de l'apurement

du passif de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'ac-
tionnaire unique. Il répondra de tous les engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle et réglera également
les frais des présentes.

- Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société AXESS INVEST S.A.
- Les livres et documents comptables de la Société demeureront conservés pendant cinq ans à l'ancien social de la

société dissoute à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure,

le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. RECKINGER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juin 2008. Relation: LAC/2008/26389. — Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008088521/242/43.
(080101759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Samson International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 57.151.

Im Jahre zwei tausend acht, den fünfundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.

Versammelten sich in einer außerordentlichen Generalversammlung die Anteilseigner der Aktiengesellschaft SAMSON

INTERNATIONAL HOLDING S.A., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare, eingetragen beim Handels- und
Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 57.151 (NIN 1996 2219 821),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 9. Dezember 1996, veröffentlicht im

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 90 vom 26. Februar 1997, und deren Statuten abgeändert
wurden wie folgt:

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 10. März 1997, veröffentlicht im Mémorial C Recueil

des Sociétés et Associations Nummer 332 vom 28. Juni 1997;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Alphonse LENTZ, mit dem damaligen Amtssitze in Remich, am 19.

Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 544 vom 18. Juli 2001;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Alphonse LENTZ, am 20. Dezember 2000, veröffentlicht im

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 544 vom 18. Juli 2001.

Das Gesellschaftskapital wurde in Euro umgewandelt gemäss Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung

vom 22. Oktober 2001, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 373 vom 7. März
2002.

Die Statuten wurden alsdann wie folgt abgeändert:
- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Alphonse LENTZ, am 10. Juni 2002, veröffentlicht im Mé-

morial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1253 vom 28. August 2002;

- zufolge zweier Urkunden aufgenommen durch denselben Notar Alphonse LENTZ, am 18. Dezember 2002, veröf-

fentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 121 vom 6. Februar 2003;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Alphonse LENTZ, am 26. November 2003, veröffentlicht im

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 105 vom 27. Januar 2004;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Alphonse LENTZ, am 11. März 2005, veröffentlicht im Mé-

morial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 741 vom 26. Juli 2005;

87726

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 20. Oktober 2006, veröffentlicht im Mémorial C

Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2374 vom 20. Dezember 2006.

Das Gesellschaftskapital beträgt DREIUNDSECHZIG MILLIONEN FÜNF HUNDERT FÜNF TAUSEND ZWEI HUN-

DERT EURO (€ 63.505.200,-), eingeteilt in zwölf Millionen sieben hundert ein tausend vierzig (12.701.040) Aktien mit
einem Nominalwert von je FÜNF EURO (€ 5,-).

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr René FALTZ, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in L-1720 Luxemburg,

6, rue Heine.

Er beruft zum Schriftführer Herrn René SCHAWEL, Jurist, beruflich ansässig in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine,
und zum Stimmzähler Herrn Nico KRUCHTEN, Direktor, beruflich ansässig in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine.
Die Vorsitzende eröffnet die Versammlung und bittet den amtierenden Notar zu beurkunden, dass:
I) Die Tagesordnung der Generalversammlung folgende Punkte begreift:
1.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um ACHTUNDDREISSIG MILLIONEN EURO (€ 38.000.000,-) um es von sei-

nem jetzigen Betrag von DREIUNDSECHZIG MILLIONEN FÜNF HUNDERT FÜNF TAUSEND ZWEI HUNDERT EURO
(€ 63.505.200,-) auf den Betrag von EIN HUNDERT UND EINE MILLION FÜNF HUNDERT FÜNF TAUSEND ZWEI
HUNDERT EURO (€ 101.505.200,-) zu bringen, durch Ausgabe von sieben Millionen sechs hundert tausend (7.600.000)
neuen Aktien mit einem Nominalwert von je FÜNF EURO (€ 5,-).

2.- Zeichnung und Einzahlung der sieben Millionen sechs hundert tausend (7.600.000) neu geschaffenen Aktien seitens

des einziges Aktionärs, die Gesellschaft SAMSON A.G., mit Sitz in D-60314 Frankfurt am Main, Weismüllerstraße, 3,
mittels Einbringen von ein hundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals der privaten Gesellschaft mit beschränkter
Haftung KOSMOS FINANCE LTD., mit Sitz in 12 York Gate, Regents Park, London NW1 4QS, eingetragen im Companies
House unter der Nummer 03143292.

3.- Aufhebung des genehmigten Kapitals.
4.- Abänderung von Artikel 3 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EIN HUNDERT UND EINE MILLION FÜNF HUNDERT FÜNF TAU-

SEND  ZWEI  HUNDERT  EURO  (€  101.505.200,-),  eingeteilt  in  zwanzig  Millionen  drei  hundert  ein  tausend  vierzig
(20.301.040) Aktien mit einem Nominalwert von je FÜNF EURO (€ 5,-).

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluß der General-

versammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

5.- Mandat an den Verwaltungsrat vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
II) Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch den Gesellschafter oder dessen Beauftragten vertreten sind, waren

Einberufungsschreiben hin- fällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III) Gegenwärtigem Protokoll liegt eine Präsenzliste, mit Verzeichnis der Anteile und der Gesellschafter bei; welche

Liste von dem Gesellschafter, beziehungsweise dessen Vertreter, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem am-
tierenden Notar unterzeichnet ist.

IV) Die von dem Gesellschafter ausgestellte Vollmacht wird, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung "ne

varietur" unterschrieben wurden, diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben einregistriert zu werden.

V) Aus der vorerwähnten Präsenzliste geht hervor, dass alle ausgegebenen Aktien bei gegenwärtiger Versammlung

anwesend oder vertreten sind und dass somit die Versammlung rechtsgültig beschliessen kann.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um den Betrag von ACHTUNDDREISSIG MILLIONEN

EURO  (€  38.000.000,-)  zu  erhöhen  um  es  von  seinem  jetzigen  Betrag  von  DREIUNDSECHZIG  MILLIONEN  FÜNF
HUNDERT FÜNF TAUSEND ZWEI HUNDERT EURO (€ 63.505.200,-) auf den Betrag von EIN HUNDERT UND EINE
MILLION FÜNF HUNDERT FÜNF TAUSEND ZWEI HUNDERT EURO (€ 101.505.200,-) zu bringen, durch Ausgabe
von sieben Millionen sechs hundert tausend (7.600.000) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je FÜNF EURO (€
5,-).

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass die sieben Millionen sechs hundert tausend (7.600.000) neu geschaffenen

Aktien  seitens  des  einziges  Aktionärs,  die  Gesellschaft  SAMSON  A.G.,  mit  Sitz  in  D-60314  Frankfurt  am  Main,
Weismüllerstraße, 3, gezeichnet wurden.

Die sieben Millionen sechs hundert tausend (7.600.000) neu geschaffenen Aktien wurden eingezahlt mittels Einbringen

von ein hundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals der privaten Gesellschaft mit beschränkter Haftung KOSMOS
FINANCE LTD, mit Sitz in 12 York Gate, Regents Park, London NW1 4QS, eingetragen im Companies House unter der
Nummer 03143292.

Die Gesellschaft SAMSON A.G. ist hier vertreten durch Herrn Josef TONUS,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 12. Juni 2008,

87727

welche Vollmacht, von den Komparenten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Gesellschaft SAMSON A.G., vertreten wie vorerwähnt, erklärt dass die Aktien der Gesellschaft KOSMOS FI-

NANCE LTD nicht verpfändet sind, und dass sie frei über dieselben verfügen kann.

Da die Kapitalerhöhung mittels Sacheinlage eingezahlt wurde, wurde ein Revisionsbericht von dem Wirtschaftsprüfer

EWA REVISION S.A., mit Sitz in L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy, erstellt, welcher folgende Schlussfolgerung
enthält:

Auf Grundlage der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und Nachweise sind uns keine Sachverhalte bekannt ge-

worden,  die  uns  zur  Annahme  veranlassen,  dass  der  gesamte  Wert  der  Sacheinlage  nicht  der  Anzahl  sowie  dem
Nominalwert resp. dem Buchwert der neu auszugebenen Aktien entsprechen würde.

Der  vorerwähnte  Bericht  bleibt,  nachdem  er  durch  die  Komparenten  und  dem  amtierenden  Notar  "ne  varietur"

unterzeichnet wurde, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Aufhebung des genehmigten Kapitals.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 3 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EIN HUNDERT UND EINE MILLION FÜNF HUNDERT FÜNF TAU-

SEND ZWEI HUNDERT EURO (€ 101.505.200,-), eingeteilt in zwanzig Millionen drei hundert ein tausend vierzig (20.301 .
040) Aktien mit einem Nominalwert von je FÜNF EURO (€ 5,-).

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-

ralversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

<i>Fünfter Beschluss

Dem Verwaltungsrat wird Mandat erteilt vorhergehende Beschlüsse auszuführen und insbesondere die Überschreibung

respektive die Übertragung der neuen Aktien auf die SAMSON A.G.

<i>Erklärung

Zwecks Berechnung der Einregistrierungsgebühren beantragen die Unterzeichneten Anwendung von Artikel 2-4 des

Gesetzes vom 29. Dezember 1971.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. FALTZ, R. SCHAWEL, N. KRUCHTEN, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 30 juin 2008. Relation: ECH/2008/879. — Reçu douze euros € 12,00.

<i>Le Receveur (signé): MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Echternach, den 10. Juli 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008088528/201/127.

(080101729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Société d'Etudes pour Travaux et Participations, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 6.363.

Les comptes annuels au 31.12.2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

87728

Luxembourg, le 11 juillet 2008.

<i>Pour SOCIETE D'ETUDES POUR TRAVAUX ET PARTICIPATIONS S.A., société anonyme holding
Experta Luxembourg, société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2008088546/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS04160. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Latincom S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 82.203.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008088566/506/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS04011. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

World Trade Stones s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4761 Pétange, 63, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 125.669.

Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 14 juillet 2008

Signature.

Référence de publication: 2008088558/1399/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2008, réf. LSO-CQ02956. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Svendborg Brakes International S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 139.836.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-forth of June.
Before Ms Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) Industri Kapital 2007 Limited Partnership I, with registered office at 30-32 New Jersey Street, St Helier, Jersey, JE2

3RA Channel Islands and registered with the Register of Commerce under number LP12080;

2) Industri Kapital 2007 Limited Partnership II, with registered office at 30-32 New Jersey Street, St Helier, Jersey, JE2

3RA Channel Islands and registered with the Register of Commerce under number LP12079;

3) Industri Kapital 2007 Limited Partnership III, with registered office at 30-32 New Jersey Street, St Helier, Jersey,

JE2 3RA Channel Islands and registered with the Register of Commerce under number LP12077;

4) Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV, with registered office at 30-32 New Jersey Street, St Helier, Jersey,

JE2 3RA Channel Islands and registered with the Register of Commerce under number LP12078;

5) IK 2007 IAB Co-Investment AB, with registered office at Drottninggatau 25, PO Box 162 85, SE 103 25 Stockholm,

Sweden and registered with the Register of Commerce under number 556705-2971.

The founders are here represented by Mrs Corinne Peyron, with professional address at 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.

87729

The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such parties have requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" ("the

Company") which they declare to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company, governed by the present

articles  of  incorporation  and  by  current  Luxembourg  laws,  especially  the  laws  of  August  10th,  1915  on  commercial
companies on "sociétés à responsabilité limitée", as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

Art. 2. The Company's name is "Svendborg Brakes International S. à r.l.".

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed, including authorising its subsidiaries to do
the same; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking
advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8.
8.1. The Company's capital is set at EUR 12.500,- (twelve thousand and five hundred euro), represented by 12,500

(twelve thousand and five hundred) shares of EUR 1,- (one Euro) each.

8.2. The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the sole shareholder or, as the case may

be, by decision of the shareholders' meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the articles of
association.

8.3. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is further authorised and empowered to

issue convertible bonds or not, or assimilated instruments or bonds with subscription rights or to issue any debt financial
instruments convertible or not, into shares under the conditions to be set by the manager or, in case of plurality of
managers, the board of managers, provided however that, in case of convertible bonds or assimilated instruments, these

87730

bonds or instruments are not be issued to the public and that upon conversion, article 189 of the law of 10th August
1915, as amended, on commercial companies, will be complied with.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of the

corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers either shareholders or not, appointed by the shareholders

with or without limitation of their period of office.

The manager(s) may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority

of votes.

The powers and the remuneration of any managers possibly appointed to or in place of the first managers will be

determined in the act of nomination.

In the case of one sole manager, the sole signature of this manager shall bind the Company.
In case of plurality of managers, the Company will be bound by the joint-signature of any two managers.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,

compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Meeting of the boards of managers will be validly held provided that there are less managers in attendance in the United

Kingdom than managers in attendance in Luxembourg, present or represented. Regardless of the number of managers
present, a quorum of managers residing in the United Kingdom cannot be made at any time.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another

manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted

by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Art. 14. Each shareholder shall have the right to appoint a representative to attend as an observer each and every

meeting of the Board of managers, and each and every meeting of any committee of such boards. The appointment and
removal of such a representative shall be by written notice from the shareholder -who has appoint, in the case of a
removal, or willing to appoint an observer- to the Company and shall take effect upon the delivery thereof at the Com-
pany's registered office or at any meeting of the Board of managers or any committee thereof.

Shareholders decisions

Art. 15. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 16. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of

shareholders representing the three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

87731

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 18. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting

of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 20. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Interim dividend

Art. 21. Notwithstanding the provisions of the article twenty, the general meeting of partners of the Company, by the

majority vote determined by the Law for payment of dividend, upon proposal of the board of managers or the sole
manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the
basis of a recent interim statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager itself (as the case
may be), and showing that sufficient reserves are available for distribution, it being understood that the amount to be
distributed may not exceed realised profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts
have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses
carried forward and any sums to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 22. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 23. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2008.

<i>Subscription - Payment

1) Industri Kapital 2007 Limited Partnership I, represented as stated above, subscribes to two thousand nine hundred

and eighty-seven (2,987) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them
in full by a contribution in cash in the amount of two thousand nine hundred and eighty-seven euro (EUR 2,987);

2) Industri Kapital 2007 Limited Partnership II, represented as stated above, subscribes to two thousand eight hundred

and eighteen (2,818) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full
by a contribution in cash in the amount of two thousand eight hundred and eighteen euro (EUR 2,818);

3) Industri Kapital 2007 Limited Partnership III, represented as stated above, subscribes to three thousand one hundred

and forty (3,140) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by
a contribution in cash in the amount of three thousand one hundred and forty euro (EUR 3,140);

4) Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV, represented as stated above, subscribes to three thousand five hundred

and eighteen (3,518) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full
by a contribution in cash in the amount of three thousand five hundred and eighteen euro (EUR 3,518); and

87732

5) IK 2007 IAB Co-Investment AB, represented as stated above, subscribes to thirty-seven (37) shares in registered

form, with a par value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount
of thirty-seven euro (EUR 37).

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred euro (EUR
1,500).

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as manager for an undetermined duration of the Company:
- Mr James Yates, with professional address at Brettenham House, 5, Lancaster Place, London WC2E 7EN, United

Kingdom, born on the 22nd of June 1972 in Chelmsford, England;

- Mr Andrew Townend, with professional address at Brettenham House, 5, Lancaster Place, London WC2E 7EN,

United Kingdom, born on the 31st of December 1971 in Mirfield, England;

- Mr Xavier Pauwels, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, born on the 21st of

December 1971 in Brussels, Belgium;

- Mr Philippe Leclercq, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, born on the 18th of

May 1968 in Liège, Belgium.

The Company shall be bound in accordance with article eleven of the By-Laws.
2) The Company shall have its registered office at L-1882, 5, rue Guillaume Kroll.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

ONT COMPARU:

1) Industri Kapital 2007 Limited Partnership I, ayant son siège social au 30-32 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA,

Channel Islands et immatriculée auprès du Registre de Commerce sous le numéro LP12080;

2) Industri Kapital 2007 Limited Partnership II, ayant son siège social au 30-32 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA,

Channel Islands et immatriculée auprès du Registre de Commerce sous le numéro LP12079;

3) Industri Kapital 2007 Limited Partnership III, ayant son siège social au 30-32 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA,

Channel Islands et immatriculée auprès du Registre de Commerce sous le numéro LP12077;

4) Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV, ayant son siège social au 30-32 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA,

Channel Islands et immatriculée auprès du Registre de Commerce sous le numéro LP12078;

5) IK 2007 IAB Co-Investment AB, ayant son siège social au Drottinggatau 25, PO Box 162 85, SE 103 25 Stockholm,

Suède et immatriculée auprès du Registre de Commerce sous le numéro 556705-2971.

Fondateurs ici représentés par Madame Corinne Peyron, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée (la "Société")

qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur les
sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

87733

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera "Svendborg Brakes International S. à r.l.".

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie de parts sociales ou de titres
de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales
ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou
d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier
direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que
ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée, incluant des autorisations à ses filiales pour faire la
même chose; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature

à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert
du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8.
8.1 Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros), représenté par 12,500 (douze mille cinq

cent) parts sociales de EUR 1 (un euro) chacune.

8.2 Le capital souscrit peut être modifié sur décision de l'associé unique ou, comme cela peut être le cas, par décision

de l'assemblée des associés statuant de la même manière que pour une modification des statuts.

8.3 Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance seront de plus autorisés et habilités à émettre

des  obligations  convertibles  ou  non,  ou  des  instruments  assimilés  ou  des  obligations  avec  droits  de  souscription  ou
d'émettre tous instruments financiers convertibles ou non, en parts sociales à des conditions établies par le gérant ou,
en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance, pour autant cependant que ces obligations ou instruments ne
soient pas émis au public et que, dans le cas d'obligations convertibles ou instruments assimilés, au moment de la con-
version, l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifié, soit respecté.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou sans

limitation de leur mandat.

87734

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des

premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la société sera valablement engagée à l'égard des tiers par la seule signature d'un gérant

unique.

En cas de pluralité de gérants, la société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous

frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire/associée ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où
ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas
d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel
et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué
à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres
droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement qu'autant que le nombre de gérants assistant du Royaume-

Uni soit inférieur au nombre de gérants présents au Luxembourg, présents ou représentés. Indépendamment du nombre
des gérants présents, un quorum de gérants résidant au Royaume-Uni ne peut être réuni à chaque conseil.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Art. 14. Chaque associé a le droit de nommer un représentant pour assister en tant qu'observateur à chaque conseil

de gérance et à chaque réunion, ou chaque comité lié à ces conseils de gérance. La nomination et révocation d'un tel
représentant devront être notifiée par écrit à la Société -ayant nommé, dans le cas d'une révocation, ou voulant nommer
un observateur- par l'associé et prendront effet dès réception de la notification au siège social de la Société ou à toute
réunion du conseil de gérance ou tout comité lié.

Décisions des associés

Art. 15. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément

formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 16. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

87735

Art. 18. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de

la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec

le bilan.

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 20. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dividendes intérimaires

Art. 21. Nonobstant les dispositions de l'article 20, l'assemblée générale des associés de la Société, par le vote majo-

ritaire déterminé par la loi sur le paiement des dividendes, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (le
cas échéant) peut décider de payer des dividendes intérimaires avant la fin de l'exercice social en cours, sur base d'un
récent état intérimaire des comptes préparé par e conseil de gérance ou le gérant unique lui-même (le cas échéant), et
laissant apparaître que les fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer
ne saurait excéder les profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social pour lesquels les comptes annuels ont été
approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles et diminué
des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire".

Dissolution - Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le

capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à

sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 23. Les lois mentionnées à l'article 1 

er

 , ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application

partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2008.

<i>Souscription - Libération

1) Industri Kapital 2007 Limited Partnership I, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à deux mille neuf

cent quatre-vingt-sept (2.987) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune,
et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de deux mille neuf cent quatre-vingt-sept euros
(EUR 2.987);

2) Industri Kapital 2007 Limited Partnership II, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à deux mille

huit cent dix-huit (2.818) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, et
de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de deux mille huit cent dix-huit euros (EUR 2.818);

3) Industri Kapital 2007 Limited Partnership III, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trois mille

cent quarante (3.140) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, et de
les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de trois mille cent quarante euros (EUR 3.140);

4) Industri Kapital 2007 Limited Partnership IV, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trois mille

cinq cent dix-huit (3.518) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, et
de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de trois mille cinq cent dix-huit euros (EUR 3.140);

5) IK 2007 IAB Co-Investment AB, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trente-sept (37) parts

sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, et de les libérer intégralement par
un apport en numéraire d'un montant de trente-sept euros (EUR 37).

87736

Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au

notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérant pour une durée indéterminée:
- Monsieur James Yates, avec adresse professionnelle au 5, Brettenham House, Lancaster Place, London WC2E 7EN,

né le 22 juin 1972 à Chelmsford, Angleterre;

- Monsieur Andrew Townend, avec adresse professionnelle 5, Brettenham House, Lancaster Place, London WC2E

7EN, né le 31 décembre 1971 à Mirfield, Angleterre;

- Monsieur Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, né le 21

décembre 1971 à Bruxelles, Belgique;

- Monsieur Philippe Leclercq, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, né le 18

mai 1968 à Liège, Belgique.

La Société se trouvera engagée conformément à l'article 11 des statuts.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante

les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 27 juin 2008, LAC/2008/26233. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents Eur

0,5% = 62,50.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008088501/5770/436.
(080100716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Asset Finance Management Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 74.093.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008088592/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03221. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Plastichem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 47.457.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires

<i>et par le conseil d'administration en date du 12 juin 2008

1. MM. Gérard BIRCHEN et Sinan SAR ont été reconduits dans leur mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'as-

semblée générale statutaire de 2014.

87737

2. Le mandat d'administrateur, venu à échéance, de Mme Monique JUNCKER, n'a pas été renouvelé et décharge lui a

été donnée pour l'exercice de son mandat.

3. M. Cornelius Martin BECHTEL, administrateur de sociétés, né à Emmerich (Allemagne), le 11 mars 1968, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

4. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire aux

comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

5. M. Cornelius Martin BECHTEL, pré-nommé, a été nommé comme président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 24.6.2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PLASTICHEM S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008088132/29/26.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR11108. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080100885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Laumor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 109.554.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des associés de la Société a décidé, en date du 19 mai 2008:
- d'accepter la démission de Madame Marina Mottura comme gérant de la Société;
- de nommer avec effet immédiat et pour une durée illimitée, Monsieur Matthijs Bogers, né le 24 novembre 1966 à

Amsterdam aux Pays-Bas, ayant pour adresse professionnelle 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, gérant de la
Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Laumor Holdings S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008088148/2460/19.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS03900. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Lindinger Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5416 Ehnen, 127, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 36.197.

<i>Extrait des délibérations prises lors de assemblée générale ordinaire

<i>tenue le 7 mai 2007

L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire à tenir en l'an 2012 comme suit:

Administrateur: Monsieur Kim LINDINGER, directeur de société demeurant professionnellement au 127, route du

Vin L-5416 EHNEN

Administrateur: Madame Viviane KORONOWSKI, employée privée, demeurant professionnellement au 127, route

du Vin L-5416 EHNEN

Administrateur: Madame Morgane DETRAIT, employée privée, demeurant professionnellement au 127, route du Vin

L-5416 EHNEN

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

87738

Luxembourg, le 13 mai 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008088149/1134/25.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2008, réf. LSO-CQ02916. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080100873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Lindinger Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5416 Ehnen, 127, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 36.197.

<i>Extrait des délibérations prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 7 mai 2007

Le conseil d'administration renouvelle les mandats de Monsieur Kim LINDINGER, directeur de société, demeurant

professionnellement au 127, route du Vin, L-5416 EHNEN aux fonctions de Président du Conseil d'administration et
d'administrateur délégué pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2012.

Monsieur Kim LINDINGER aura en sa qualité d'administrateur délégué, tous pouvoirs de signature individuelle dans

le cadre de la gestion journalière de la société ainsi que dans la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion journalière, pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2012.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 13 mai 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008088150/1134/22.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2008, réf. LSO-CQ02913. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080100873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Sustainable Energy Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 129.730.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 2 juin 2008

1. M. Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né le 20 avril 1963 à Luxembourg, domicilié professionnellement à

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé en tant que gérant de catégorie A pour
une durée indéterminée.

2. M. Hansruedi SCHENK, administrateur de sociétés, né le 2 septembre 1952 à CH-Berne, domicilié professionnel-

lement  à  CH-6901  Lugano,  25,  Corso  Elvezia,  a  été  nommé  en  tant  que  gérant  de  catégorie  A  pour  une  durée
indéterminée.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008088162/6341/21.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS04086. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080100936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

87739

Dograd Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 31.343.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 10/06/2008 que:
- l'assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir:
- Van Lanschot Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer;
- Van Lanschot Corporate Services S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer;
- Harbour Trust and Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer;
et ceci jusqu'à l'assemblée approuvant les comptes 2013;
- l'assemblée renomme AACO S.à r.l., Réviseur d'Entreprises, 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, comme commis-

saire aux comptes, et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2008.

Mamer, le 10.06.2008.

Van Lanschot Management S.A. / Van Lanschot Corporate Services S.A.
Signatures / Signatures

Référence de publication: 2008088211/695/21.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2008, réf. LSO-CS03740. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080100699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

PGF III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 138.531.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'administration de la Société en date du 9 juin 2008

Monsieur Mark CRADER, administrateur de la société, né le 25 juillet 1962 à Londres, demeurant The Wall House,

Boundway Hill, GB-SO41 6EN Sway, est nommé en qualité de Président du Conseil d'administration de la Société pour
la durée de son mandat d'administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008088220/280/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2008, réf. LSO-CR10462. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080100828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

PGF III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 138.531.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 16 juin 2008

1. L'associé unique décide d'augmenter le nombre des administrateurs de la Société de trois à quatre.
2. L'associé unique nomme Monsieur Robert HASSETT, né à Dublin (Irlande) le 10 mai 1970, demeurant profession-

nellement 23, Cloister Way, Carysfort Avenue, Blackrock, Co. Dublin (Irlande), en qualité d'administrateur de la Société
avec effet au 16 juin 2008. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008088222/280/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2008, réf. LSO-CR10464. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080100847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

87740

Parker Hannifin Luxembourg Investments 1 S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 134.918.

In the year two thousand and eight, on the nineteenth day of June.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED

PARKER HANNIFIN GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT, a 'société a responsabilité limitée' with registered office

at 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the
number B 113.372,

here represented by Marie-Claude FRANK, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given on June 11, 2008.

Which proxy shall be signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary and shall be attached to

the present deed to be filed at the same time.

The prenamed is the sole shareholder of PARKER HANNIFIN LUXEMBOURG INVESTMENTS 1, S. á r.l., a 'société

á responsabilité limitée' with registered office at 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under number B 134.918, incorporated by deed of the undersigned notary, on December
12, 2007, published in the Memorial C number 242 of January 30, 2008 (the "Company").

Which appearing person, acting in its above-mentioned capacity, requested the undersigned notary to draw up as

follows:

I) The agenda of the present extraordinary general meeting is the following:
1. Decision to increase the capital of the Company by seven hundred fifty four thousand four hundred twenty-four

euro (€ 754,424.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (€ 12,500.-) to seven
hundred sixty-six thousand nine hundred and twenty-four euro (6 766,924.-) by the issue of seven hundred fifty-four
thousand four hundred twenty-four (754,424) new parts, having a par value of one euro (€ 1.-) each, at a total subscription
price of seven hundred and fifty-four thousand four hundred and twenty-four euro (€ 754,424.-), this capital increase
occurring by a contribution in cash of the existing sole shareholder of the Company,

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company to reflect the above capital increase so as to

read:

Art. 6. Share capital. The capital is fixed at seven hundred sixty-six thousand nine hundred and twenty-four euro (€

766,924.-) represented by seven hundred sixty-six thousand nine hundred and twenty-four (766,924) parts with a nominal
value of one euro (€ 1.-) each, entirely subscribed and fully paid up."

II) That the sole shareholder of the Company has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder of the Company has decided to increase the capital of the Company by seven hundred fifty-four

thousand four hundred twenty-four euro (€ 754,424.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five
hundred euro (€ 12,500.-) to seven hundred sixty-six thousand nine hundred and twenty-four euro (€ 766,924.-) by the
issue of seven hundred fifty-four thousand four hundred twenty-four (754,424) new parts, having a par value of one Euro
(€ 1.-) each.

<i>Subscription and payment

The seven hundred and fifty-four thousand four hundred and twenty-four (754,424) new parts of the Company are

subscribed for and fully paid in by the current sole shareholder of the Company at an aggregate subscription price of
seven hundred and fifty-four thousand four hundred and twenty-four euro (€ 754,424.-), all of which represent the par
value of the seven hundred and fifty-four thousand four hundred and twenty-four (754,424) newly issued parts, through
a contribution in cash of the current sole shareholder of the Company.

Proof of the existence and value of the contribution for an amount of seven hundred and fifty-four thousand four

hundred and twenty-four euro (€ 754,424.-) has been given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company has resolved to amend article 6 of the articles of association of the Company

so as to reflect the above capital increase as follows:

Art. 6. Share capital. The capital is fixed at seven hundred sixty-six thousand nine hundred and twenty-four euro (€

766,924.-) represented by seven hundred sixty-six thousand nine hundred and twenty-four (766,924) parts with a nominal
value of one euro (€ 1.-) each, entirely subscribed and fully paid up."

87741

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present capital increase, have been estimated at about 6,000.-€.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille huit, le dix-neuf juin.
Par devant Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg,

A COMPARU

PARKER HANNIFIN GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social

à 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 113.372,

ici représentée par Marie-Claude FRANK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration délivrée en date du 11 juin 2008.

Ladite procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Le comparant prénommé est l'associé unique de PARKER HANNIFIN LUXEMBOURG INVESTMENTS 1, S.à r.l., une

société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.918, constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentaire, en date du 12 décembre 2007, publié au Mémorial C, numéro 242 du 30 janvier 2008 (la „Société").

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I) Que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:
1. Décision d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de sept cent cinquante-quatre mille

quatre cent vingt-quatre euros (€ 754.424,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (€
12.500,-) à sept cent soixante-six mille neuf cent vingt-quatre euros (€ 766.924,-) par l'émission de sept cent cinquante-
quatre mille quatre cent vingt-quatre (754.424) parts sociales nouvelles, d'une valeur nominale d'un euro (€ 1,-) chacune,
à un prix d'émission total de sept cent cinquante-quatre mille quatre cent vingt-quatre euros (€ 754.424,-), cette aug-
mentation de capital étant réalisée moyennant apport en espèces de l'associé unique de la Société.

2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital ci-dessus

comme suit:

« Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à sept cent soixante-six mille neuf cent vingt-quatre euros (€ 766.924,-),

divisé en sept cent soixante-six mille neuf cent vingt-quatre (766.924) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro
(€ 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.»

II. Que l'associé unique de la Société a pris les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique de la Société a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de sept

cent cinquante-quatre mille quatre cent vingt-quatre euros (€ 754.424,-) pour le porter de son montant actuel de douze
mille cinq cents euros (€ 12.500,-) à sept cent soixante-six mille neuf cent vingt-quatre euros (€ 766.924,-) par l'émission
de sept cent cinquante-quatre mille quatre cent vingt-quatre (754.424) parts sociales nouvelles, d'une valeur nominale
d'un euro (€ 1,-) chacune.

<i>Souscription et libération

Les sept cent cinquante-quatre mille quatre cent vingt-quatre (754.424) parts sociales nouvelles ont été entièrement

souscrites et intégralement libérées par l'associé unique actuel de la Société à un prix d'émission total de sept cent
cinquante-quatre mille quatre cent vingt-quatre euros (€ 754.424,-), dont la totalité représente la valeur nominale des
sept cent cinquante-quatre mille quatre cent vingt-quatre (754.424) parts sociales nouvellement émises, moyennant apport
en espèces de la part de l'associé unique actuel de la Société.

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport d'un montant de sept cent cinquante-quatre mille quatre cent vingt-

quatre euros (€ 754.424,-) a été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

87742

<i>Deuxième résolution

L'associé unique de la Société a décidé de modifier en conséquence l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter

l'augmentation de capital ci-dessus comme suit:

« Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à sept cent soixante-six mille neuf cent vingt-quatre euros (€ 766.924,-) divisé

en sept cent soixante-six mille neuf cent vingt-quatre (766.924) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (€ 1,-)
chacune, entièrement souscrites et libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que soit, qui incombent à la Société ou qui doivent

être pris en charge par elle en relation avec l'augmentation de capital ci-dessus, sont évalués approximativement à 6.000.-6.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom,

état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.-Cl. Frank, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 JUIN 2008. Relation: LAC / 2008 / 25593. - Reçu à 0,50%: trois mille sept cent

soixante-douze euros douze cents (€3.772,12).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008088769/212/133.
(080101699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Eadred International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 67.130.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le vingt juin.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CINTALIA HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Afroditis 25, 2413 Nicosia, Cyprus, registred in Cyprus

under N 

o

 175837.

ici représentée par Monsieur Jorrit CROMPVOETS, juriste, domicilié professionnellement au 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 4 juin 2008.
Ladite procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:
- La société anonyme "EADRED INTERNATIONAL S.A.'', R.C.S. Luxembourg N 

o

 B 67 130, fut constituée par le

notaire Gérard LECUIT, alors de résidence à Hesperange, en date du 30 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 54 du 30 janvier 1999;

- Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte sous seing privé en date du 4 décembre 2001, dont un

extrait a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 995 du 29 juin 2002;

- La société a actuellement un capital de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) représenté par

mille deux cent cinquante (1.250) actions avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement
libérées;

- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société ''EADRED INTER-

NATIONAL S.A.''.

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la société ''EADRED IN-

TERNATIONAL S.A.'' avec effet immédiat.

87743

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société ''EADRED INTERNATIONAL S.A.'' déclare que l'activité de

la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné;

- L'actionnaire unique s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister

à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société
est à considérer comme faite et clôturée.

- la comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuver un bilan de clôture daté de ce jour;

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu'à

ce jour;

- les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au 12, rue Léon Thyes, L-2636

Luxembourg;

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents lequel

a été immédiatement lacéré.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société ''EADRED INTERNATIONAL S.A.''.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous notaire la présente

minute.

Signé: J. Crompvoets et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 27 juin 2008. LAC/2008/26207. — Reçu douze euros Eur 12.-.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008088522/5770/53.

(080101773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Valbay International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 101.930.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 10 juillet 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008088729/239/12.

(080101587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Morgan Stanley Infrastructure S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 137.610.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 10 juillet 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008088730/239/12.

(080101551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

87744


Document Outline

Apone S.A.

Asset Finance Management Holding S.A.

Axess Invest S.A.

Baki-Paysage S.à.r.l.

Baya S.àr.l.

Beau Soleil Invest S.A.

Brixton Holding S.A.

C71

Carib Power Lux S.à r.l.

Cetrel Securities S.A.

Cocteau S.A.-SPF

Compagnie de Banque Privée

Connecting You Sàrl

Datheda Investment S.A.

Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.

Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.

Dograd Holding S.A.

Eadred International S.A.

FCM Finance S.A.H.

Financière Centuria Luxembourg S.A.

Financière du Fruit S.A.

Hellenger Café

IK Investment Partners S.à r.l.

Indian Investment S.A.

Industri Kapital Luxembourg S.à r.l.

Inofinance S.A. Holding

Kaytwo S.à r.l.

Latincom S.A.

Laumor Holdings S.à r.l.

Lindinger Management Services S.A.

Lindinger Management Services S.A.

Losty S.A.

Mamm'out Luxembourg S.à.r.l.

Martine S.à r.l.

Morgan Stanley Infrastructure S.A.

Ophelius S.A.

Parker Hannifin Luxembourg Investments 1 S.à. r.l.

PGF III S.A.

PGF III S.A.

Planetarium Advisor S.A.

Plastichem S.A.

P.T.R. Finances S.A.

Rolic Invest S.àr.l.

Rolly Real Estate S.A.

ROMAKA, société à responsabilité limitée &amp; Cie

Safeharbor S.A. Holding

Samson International Holding S.A.

Société d'Etudes pour Travaux et Participations

Sustainable Energy Solutions S.à r.l.

Svendborg Brakes International S. à r.l.

T.O.Summit S.A.

Valbay International S.A.

Van Kanten S.A.

World Trade Stones s.à r.l.