This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1776
18 juillet 2008
SOMMAIRE
AMB Le Grand Roissy Holding 1 S.à r.l. . .
85236
AMB Le Grand Roissy Holding 2 S.à r.l. . .
85232
Ateliers VVYNGLA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
85212
Audit-Gestion-Management Luxembourg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85212
Bifico S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85214
Boutique Pour Elle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85213
Business Contact Holding S.A. . . . . . . . . . .
85208
Cebeus Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85218
CIL-Centuria Invest Luxembourg S.A. . . .
85207
Cliveden S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85206
Colombage S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85202
Dal Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85210
Dal Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85211
Downington Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85209
Eclaircie s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85214
Electrofin S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85232
Euroliberty-Lease S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85212
European Consent AG . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85213
European Opticians S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
85248
Famper S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85204
Felix.Joe.Resto S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85210
Financière d'Ancône . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85204
FinForce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85211
Forchim S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85205
Fortis L Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85203
Glancia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85210
Grandica du Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .
85209
GVP Immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85208
Hama Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85204
High Pressure Investments S.A. . . . . . . . . .
85225
I C T C S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85209
IFE II Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85207
IFE II Gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85206
International Finance Development Com-
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85213
Kipling Luxembourg S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
85215
L'Amphitryon Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85218
La Racchetta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85208
Le Fou du Roi Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85211
LEICo (Luxembourg-England Investment
Company) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85205
Luxlait-Expansion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85248
Maecolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85235
M. Pletschette S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85205
Ostonian Enterprises S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
85203
Patrilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85209
Performance Partner S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
85207
Promo Bous S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85202
Rosneft Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85202
Royal Eight Ball S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85213
S.A.F. Services Anti-Feu . . . . . . . . . . . . . . . .
85239
Sal. Oppenheim Special Situations S.A. . .
85235
Samart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85214
Seals Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85212
Segepi Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85208
Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care
III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85225
Société Générale de Consultance S.A. . . .
85210
StaGe Mezzanine Société en Commandite
Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85204
Stone Leaf Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
85240
Sunshine S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85207
Technical Supply Company . . . . . . . . . . . . .
85203
Tipi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85206
Troisième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85206
T.W. Logistics S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85214
Van Der Beek I.T. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
85205
Webfinance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85211
85201
Rosneft Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 128.487.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2008i>
- Est nommée administrateur de la société Mme Heike Kubica, employée privée, résidant professionnellement au 2,
boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du administrateur démissionnaire M. Olivier Jarny.
- Le mandat de nouveau administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant
sur les comptes annuels de 2012
Luxembourg, le 13 juin 2008.
<i>Pour le conseil d'administration
i>Signature
Référence de publication: 2008085026/1463/17.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR09606. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080097103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Promo Bous S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 132.195.
Il résulte des actes de cession des parts sociales intervenus en date du 16 juin 2008 que la répartition du capital est
dorénavant la suivante:
Rosa FIRULLI, née le 11 juillet 1960, demeurant au 31, rue T. Aubart à L-4907 Bascharage . . . . . . . . . . . . 55 parts
WATT LUX S.A., ayant son siège social 27, rue Glück à L-1632 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008085029/5863/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2008, réf. LSO-CR10396. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Colombage S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 112.578.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Suite à une assemblée générale extraordinaire enregistrée à Luxembourg, actes civils le 5 juin 2008, LAC/2008/22787
et reçue par devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg en date du 30 mai 2008, acte n
o
283,
il a été prononcé la clôture de la liquidation de la société COLOMBAGE S.A., qui cessera d'exister.
L'assemblée a décidé que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 48, boulevard
Grande Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg.
Pour mention, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 25 June 2008.
Jacques DELVAUX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008085738/208/19.
(080097824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
85202
Ostonian Enterprises S.A., Société Anonyme.
Siège de direction effectif: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 95.451.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Suite à une assemblée générale extraordinaire enregistrée à Luxembourg, actes civils le 12 juin 2008, LAC/2008/23860
et reçue par devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg en date du 6 juin 2008, acte n
o
299,
il a été prononcé la clôture de la liquidation de la société OSTONIAN ENTERPRISES S.A., qui cessera d'exister.
L'assemblée a décidé que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 19-21, bvd du
Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
Pour mention, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 26 June 2008.
Jacques DELVAUX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008085740/208/19.
(080097826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Fortis L Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 32.327.
Le bilan au 31/12/2007 ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS L FUND
i>Fortis Investment Management Luxembourg S.A.
Didier LAMBERT
Référence de publication: 2008085283/755/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01626. - Reçu 912,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
TECSUCO S.A., Technical Supply Company, Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 96.208.
Vu que l'Administration Communale de Weiswampach a décidé de modifier la dénomination des rues, il y a lieu de
noter que l'adresse du siège de Tecsuco Sa a été changé:
ancienne dénomination:
L-9991 WEISWAMPACH Maison 150
nouvelle dénomination:
L-9991 WEISWAMPACH Am Hock 2
20.06.2008.
Pour extrait
Signature
Référence de publication: 2008085539/557/18.
Enregistré à Diekirch, le 24 juin 2008, réf. DSO-CR00308. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080097880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
85203
Financière d'Ancône, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 33.608.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008085453/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS01041. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080096979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Famper S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 35.531.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2008.
<i>Pour FAMPER S.A., société anonyme holding
i>Experta Luxembourg, société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS
Référence de publication: 2008086023/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01763. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Hama Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 11.521.
Les comptes annuels au 31.03.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2008.
<i>Pour HAMA HOLDING S.A., société anonyme holding
i>Experta Luxembourg, société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS
Référence de publication: 2008086021/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01760. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
StaGe Mezzanine Société en Commandite Simple.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 111.962.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2008085997/1955/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS01081. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
85204
LEICo (Luxembourg-England Investment Company), Société Anonyme.
Siège social: L-7634 Heffingen, Scherfenhof, La Grange.
R.C.S. Luxembourg B 95.515.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2008.
<i>Pour LEICO (Luxembourg-England Investment Company) S.A., société anonyme
i>Experta Luxembourg, société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS
Référence de publication: 2008086006/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01775. - Reçu 34,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080098770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Van Der Beek I.T. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6113 Junglinster, 2, rue des Cerises.
R.C.S. Luxembourg B 87.974.
Die verkürze Bilanz zum 31. Dezember 2007 wurde hinterlegt im Handelsregister.
Zum Vermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Unterschrift.
Référence de publication: 2008085996/8479/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02701. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Forchim S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 6.398.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2008.
<i>Pour FORCHIM S.A., société anonyme holding
i>Experta Luxembourg, société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS
Référence de publication: 2008086009/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01781. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
M. Pletschette S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9155 Grosbous, 15, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 109.833.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008085993/8479/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02698. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
85205
Tipi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 73.930.
Le bilan au 31/03/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008085448/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS01050. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080096974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
IFE II Gestion, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 109.767.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2008.
<i>Pour IFE II GESTION S.A., société anonyme
i>Experta Luxembourg, société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS
Référence de publication: 2008086012/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01785. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Cliveden S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 61.486.
Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2008.
<i>Pour CLIVEDEN S.A., société anonyme
i>Experta Luxembourg, société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS
Référence de publication: 2008086013/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01786. - Reçu 40,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Troisième, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5752 Frisange, 11, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 133.322.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008085989/8479/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02695. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
85206
CIL-Centuria Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 90.451.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2008.
<i>Pour CIL-CENTURIA INVEST LUXEMBOURG S.A., société anonyme
i>Experta Luxembourg, société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS
Référence de publication: 2008086027/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01771. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080098762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
IFE II Capital, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 129.428.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2008.
<i>Pour IFE II CAPITAL S.A.R.L., société à responsabilité limitée
i>Experta Luxembourg, société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS
Référence de publication: 2008086026/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01769. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Sunshine S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2269 Luxembourg, 4, rue Origer.
R.C.S. Luxembourg B 125.473.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008085991/8479/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02703. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Performance Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 29, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 92.040.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008085994/8479/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02692. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
85207
Business Contact Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 98.253.
Le bilan de la société au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08/07/08.
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008085995/1212/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01491. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080098797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Segepi Lux, Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 128.913.
Le bilan de la société au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08/07/08.
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008085992/1212/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01484. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
La Racchetta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8051 Bertrange, 15, rue Atert.
R.C.S. Luxembourg B 79.636.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Strassen, le 07 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008085660/670/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007, réf. LSO-CL07311. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
GVP Immobilier, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 135.661.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
CAPELLEN, le 04/07/2008.
Signature.
Référence de publication: 2008085663/825/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00635. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
85208
Grandica du Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 12, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 40.566.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Strassen, le 07 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008085664/670/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007, réf. LSO-CL07323. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080097324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Downington Holding, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 115.601.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
CAPELLEN, le 04/07/2008.
Signature.
Référence de publication: 2008085665/825/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00633. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Patrilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 30.409.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2008.
<i>Pour PATRILUX S.A., société anonyme
i>Experta Luxembourg, société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS
Référence de publication: 2008086024/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01765. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
I C T C S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 53.858.
Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2008.
<i>Pour ICTC S.A., société anonyme
i>Experta Luxembourg, société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS
Référence de publication: 2008086019/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01753. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
85209
Dal Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 58.107.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2008.
<i>Pour DAL FINANCIERE S.A., société anonyme
i>Experta Luxembourg, société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS
Référence de publication: 2008086010/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01782. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080098789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Glancia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 123.607.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2008.
<i>Pour GLANCIA S.A., société anonyme
i>Experta Luxembourg, société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS
Référence de publication: 2008086008/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01779. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Société Générale de Consultance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 87.044.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4.07.08.
Signature.
Référence de publication: 2008085614/318/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06723. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Felix.Joe.Resto S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5754 Frisange, 6, Am Pesch.
R.C.S. Luxembourg B 101.218.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 07 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008085577/670/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007, réf. LSO-CL07294. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
85210
Webfinance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 77.517.
Le bilan au 31 décembre 2006 et annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4/7/08.
Signature.
Référence de publication: 2008085624/317/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01503. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080097541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Le Fou du Roi Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 6, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 68.679.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 07 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008085576/670/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007, réf. LSO-CL07289. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Dal Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 58.107.
Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2008.
<i>Pour DAL FINANCIERE S.A., société anonyme
i>Experta Luxembourg, société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS
Référence de publication: 2008086011/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01784. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
FinForce, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 80.919.
Le bilan de la société au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08/07/08.
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008085988/1212/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01480. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
85211
Euroliberty-Lease S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 2, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 118.211.
Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 8 juillet 2008.
Fiduiciare COFIGEST S.A R.L.
Platinerei, 8, L-8552 OBERPALLEN
Isabelle PHILIPIN
Référence de publication: 2008085983/2631/15.
Enregistré à Diekirch, le 26 mai 2008, réf. DSO-CQ00194. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(080098788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Seals Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 87.215.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2008.
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2008085982/805/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02041. - Reçu 40,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Audit-Gestion-Management Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 107.506.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008085565/2980/12.
Enregistré à Diekirch, le 27 juin 2008, réf. DSO-CR00360. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080097430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Ateliers VVYNGLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 128.105.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008085567/2980/12.
Enregistré à Diekirch, le 27 juin 2008, réf. DSO-CR00347. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080097434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
85212
Boutique Pour Elle, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 19-23, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 7.471.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 07 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008085570/670/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007, réf. LSO-CL07342. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080097357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Royal Eight Ball S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1531 Luxembourg, 16, rue de la Fonderie.
R.C.S. Luxembourg B 41.433.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 07 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008085572/670/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007, réf. LSO-CL07344. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
International Finance Development Company, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 21.124.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2008.
<i>Pour INTERNATIONAL FINANCE DEVELOPMENT COMPANY S.A., société anonyme holding
i>Experta Luxembourg, société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS
Référence de publication: 2008086028/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01773. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
European Consent AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 97.062.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2008.
<i>Pour EUROPEAN CONSENT A.G., société anonyme
i>Experta Luxembourg, société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS
Référence de publication: 2008086022/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01761. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
85213
Bifico S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 114.469.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juillet 2008.
<i>Pour BIFICO S.A., société anonyme
i>Experta Luxembourg, société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS
Référence de publication: 2008086025/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01767. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080098758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Eclaircie s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 121.861.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 8 juillet 2008.
Fiduciaire COFIGEST S.A R.L.
Platinerei, 8, L-8552 OBERPALLEN
Isabelle PHILIPIN
Référence de publication: 2008085979/2631/15.
Enregistré à Diekirch, le 16 juin 2008, réf. DSO-CR00194. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080098799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
T.W. Logistics S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7260 Bereldange, 12, rue Adolphe Weis.
R.C.S. Luxembourg B 94.662.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008085545/2980/12.
Enregistré à Diekirch, le 27 juin 2008, réf. DSO-CR00346. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080097292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Samart S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 101.391.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008085551/2980/12.
Enregistré à Diekirch, le 27 juin 2008, réf. DSO-CR00348. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080097307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
85214
Kipling Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 26.782.150,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 116.339.
In the year two thousand and eight, on the fifth day of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN BOARD, a corporation organised under the laws of the Province of Ontario,
with registered office at 5650 Yonge Street, 4th Floor, Toronto, Ontario, M2M 4H5, Canada, registered with the Ministry
of Consumer and Business Services of Ontario under the number 000950645,
here represented by Mrs. Elisabeth Maas, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on March
5th, 2008,
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- Ontario Teachers' Pension Plan Board is the sole shareholder of Kipling Luxembourg S.àr.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître Tom Metzler, notary residing in
Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duchy of Luxembourg, on May 5, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n
o
1368 on July 15, 2006 (the Company).
- The articles of association of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary dated October 16, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
o
15 of January 4,
2008.
- The Company's share capital is presently set at twenty-five million one hundred fifty-six thousand seven hundred
euro (EUR 25,156,700) represented by five hundred (500) ordinary shares and one million five thousand seven hundred
sixty-eight (1,005,768) preferred equity stock certificates (the PESCs), with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Ontario Teachers' Pension Plan Board, in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to increase the
subscribed share capital by an amount of one million six hundred twenty-five thousand four hundred and fifty euro (EUR
1,625,450) to bring it from its present amount of twenty-five million one hundred fifty-six thousand seven hundred euro
(EUR 25,156,700) to twenty-six million seven hundred eighty-two thousand one hundred and fifty euro (EUR 26,782,150)
by the issuance of sixty-five thousand and eighteen (65,018) new PESCs, having the same rights and obligations as the
already existing PESCs.
<i>Intervention - subscription - paymenti>
Thereupon, Ontario Teachers' Pension Plan Board, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe
to the new sixty-five thousand and eighteen (65,018) PESCs and to have them fully paid up by way of a contribution in
kind consisting of one hundred forty-five thousand one seven hundred sixty-nine (145,769) shares without nominal value,
and with an accounting par value of eleven euro fifteen eurocent (EUR 11.15) rounded off downwards (the Belgian Shares)
of Kipling Investment Belgium N.V., a public limited company incorporated and organised under the laws of Belgium, with
registered office at Koningsstraat 97, 1000 Brussels, Belgium, registered with the Belgian Crossroadbank for Enterprises
under number 0877.940.268, having a share capital of twenty-six million seven hundred eighty-two thousand two hundred
and fifteen euro and one ninety-three eurocents (EUR 26,782,215.93) represented by two million four hundred and one
thousand and seven hundred eighty-eight (2,401,788) shares without nominal value (Kipling Belgium).
It results from a certificate issued on the date hereof by the management of Kipling Belgium that, as of the date of such
certificate:
- Ontario Teachers' Pension Plan Board is the full owner of the Belgian Shares;
- The Belgian Shares are fully paid-up and represent 6.06 % of the issued share capital of Kipling Belgium;
- Ontario Teachers' Pension Plan is solely entitled to the Belgian Shares and possesses the power to dispose of the
Belgian Shares;
- none of the Belgian Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge
or usufruct on the Belgian Shares and the Belgian Shares are not subject to any attachment;
- there exists no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that
the Belgian Shares be transferred to him;
85215
- according to the laws of Belgium and the articles of association of Kipling Belgium, the Belgian Shares are freely
transferable;
- on the date hereof, the Belgian Shares are worth at least one million six hundred twenty-five thousand four hundred
sixty-one euro and seventy-seven eurocents (EUR 1,625,461.77), this estimation being based on generally accepted ac-
countancy principles.
The contribution in kind is made for an aggregate amount of one million six hundred twenty-five thousand four hundred
sixty-one euro and seventy-seven eurocents (EUR 1,625,461.77) out of which eleven euro seventy-seven eurocents (EUR
11.77) shall be allocated to the share premium reserve account of the Company and one million six hundred twenty-five
thousand four hundred and fifty euro (EUR 1,625,450) shall be allocated to the share capital account of the Company.
Such certificate and a copy of the balance sheet of Kipling Belgium dated as per the date hereof, after signature "ne
varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed
to be filed with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder of the Company decides to amend articles 5.2.
and 5.3. of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:
5.2. The Company's corporate capital is also represented by one million seventy thousand seven hundred eighty-six
euro (EUR 1,070,786) preferred equity stock certificates with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each (the PESCs),
which are redeemable in accordance with these Articles. The holder(s) of PESCs are hereinafter individually referred to
as a PESC Partner and collectively to as the PESC Partners.
5.3. The entire corporate capital thus amounts to twenty-six million seven hundred eighty-two thousand one hundred
and fifty euro (EUR 26,782,150).
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately 2,800.- Euros.
Insofar as the contribution in kind results in the Company owning more than 65 % of the share capital of Kipling
Belgium, a company incorporated in Belgium, Member State of the European Union, the Company refers to article 4-2
of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.
The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the
present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le cinquième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN BOARD, une société de droit de La Province d'Ontario, avec siège social
au 5650 Yonge Street, 4th Floor, Toronto, Ontario, M2M 4H5, Canada, immatriculée au "Ministry of Consumer and
Business Services of Ontario" sous le numéro 000950645,
représentée par Maître Elisabeth Maas, Avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 5 mars
2008,
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Ontario Teachers' Pension Plan Board est l'associé unique de Kipling Luxembourg S.àr.l., une société à responsabilité
limitée constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 5 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
o
1368 du
15 juillet 2006 (la Société).
- Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le Notaire soussigné en date du
15 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
o
15 du 4 janvier 2008.
- Le capital social de la Société est actuellement fixé à vingt-cinq millions cent cinquante-six mille sept cents euros
(EUR 25.156.700) représenté par cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25) chacune
et par un million cinq mille sept cent soixante-huit (1,005,768) certificats de parts privilégiées d'une valeur nominale de
vingt-cinq (EUR 25).
85216
La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Ontario Teachers' Pension Plan Board, en sa qualité d'associé unique de la Société, décide d'augmenter le capital social
souscrit par un montant de un million six cent vingt-cinq mille quatre cent cinquante euros (EUR 1.625.450) pour le porter
de son montant actuel de vingt-cinq millions cent cinquante-six mille sept cents euros (EUR 25.156.700) à vingt-six millions
sept cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante euros (EUR 26.782.150) par l'émission de soixante-cinq mille dix-huit
(65.018) certificats de parts privilégiées d'une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25) chacune (les PESCs), ayant les
mêmes droits et obligations que les PESCs déjà existant.
<i>Intervention - souscription - libérationi>
Ces faits exposés, Ontario Teachers' Pension Plan Board, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare
souscrire aux nouveaux PESCs et les libérer entièrement par un apport en nature consistant en cent quarante-cinq mille
sept cent soixante-neuf (145.769) parts sociales sans valeur nominale, ayant une valeur comptable réelle de onze euros
et quinze centimes (EUR 11,15) chacune, arrondis en dessous (les Parts Sociales Belges) de Kipling Investment Belgium
N.V., une société anonyme de droit belge, ayant son siège social à Koningsstraat 97, 1000 Bruxelles, Belgique, inscrite
auprès du Registre de Commerce de Bruxelles sous le numéro 0877.940.268, ayant un capital social de vingt-six millions
sept cent quatre-vingt-deux mille deux cent quinze euros et quatre-vingt-treize centimes (EUR 26.782.215,93), représenté
par deux millions quatre cent et un mille sept cent quatre-vingt-huit (2.401.788) parts sociales sans une valeur nominale
individuelle (Kipling Belgique).
Il résulte d'un certificat délivré par la gérance de Kipling Belgique, en date de ce jour, que:
- Ontario Teachers' Pension Plan Board est le propriétaire unique des Parts Sociales Belges;
- les Parts Sociales Belges sont entièrement libérées et représentent 6,06% du capital social émis par Kipling Belgique;
- Ontario Teachers' Pension Plan Board est la seule titulaire des droits sur les Parts Sociales Belges et possède le
pouvoir de céder les Parts Sociales Belges;
- aucune Part Sociale Belge n'est grevée d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un
nantissement ou un usufruit sur les Parts Sociales Belges et aucune Part Sociale Belge ne sont sujets à une telle opération;
- il n'existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander
qu'une ou plusieurs Parts Sociales Belges lui soit cédé;
- conformément aux lois de Belgique et aux statuts de Kipling Belgique, les Parts Sociales Belges sont librement cessibles.
- à la date des présentes, la valeur nominale totale des Parts Sociales Belges est évaluée à au moins un million six cent
vingt-cinq mille quatre cent soixante-et-un euros et soixante-dix-sept centimes (EUR 1.625.461,77), cette estimation
correspondant aux principes comptables généralement admis.
L'apport en nature étant effectué pour un montant total de un million six cent vingt-cinq mille quatre cent soixante-
et-un euros et soixante-dix-sept centimes (EUR 1.625.461,77) fait à la Société, onze euros soixante-dix-sept centimes
(EUR 11,77) seront affectés au compte de réserve de prime d'émission et un million six cent vingt-cinq mille quatre cent
cinquante euros (EUR 1.625.450) seront affectés au capital de la Société.
Ledit certificat et une copie du bilan de Kipling Belgique daté du 31 janvier 2007, après signature ne varietur par le
mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec
lui aux formalités de l'enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique de la Société décide de modifier les articles 5.2. et 5.3.
des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
5.2. Le capital social est aussi représenté par un million soixante-dix mille sept cent quatre-vingt-six (1.070.786) cer-
tificats de parts privilégiées d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacun (les PESCs), rachetables
conformément aux présents Statuts. Le(s) détenteur(s) de PESCs est/sont défini(s) ci-après, individuellement l'Associé
PESC et collectivement les Associés PESC.
5.3. La totalité du capital social s'élève à vingt-six millions sept cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante euros (EUR
26.782.150).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital à environ 2.800.- Euros.
Dans la mesure où il résulte de l'apport en nature que la Société possède plus de 65 % du capital social de Kipling
Belgium, une société de droit belge, Etat Membre de l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du
29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties
comparantes l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
85217
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date d'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: E. MAAS, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 07 mai 2008. Relation: LAC/2008/18541. - Reçu douze euros (12. - €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE conforme à l'original, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2008.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2008085786/211/179.
(080098410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
L'Amphitryon Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 22, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 86.920.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Strassen, le 07 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008085672/670/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007, réf. LSO-CL07334. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Cebeus Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.
R.C.S. Luxembourg B 139.722.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendacht, am siebzehnten Juni
Vor dem unterzeichneten Notar Anja HOLTZ, mit Amtssitz in Wiltz.
Sind erschienen:
1.- Herr Joël, René, Gaston REBUFFAT, geboren in Paris am 5. Februar 1952, wohnhaft in CH-1287 Laconnex (CH),
10, rue de la Maison-Forte,
2.- Frau Edith, Messaouda, Haia BELLAICHE, geboren am 4. Mai 1946 in Beja, Tunesien, wohnhaft in 28, rue de la
Fontarabie, F-75020 Paris 20
e
.
3.- Herr Dr Elmar Michael SPRANGER, geboren in Ingolstadt am 27. Mai 1956, wohnhaft in Ingolstadt (D), Barellistraße
12,
hier vertreten durch Herrn Joël REBUFFAT, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift erteilt in Genf
(CH), am 12. Juni 2008
4.- Herr Gerd SEEFRIED, geboren in Wemding (D) am 18. Juli 1963, wohnhaft in Wemding (D), Wimburggasse 4,
hier vertreten durch Herrn Joël REBUFFAT, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift erteilt in Genf
(CH), am 12. Juni 2008
Beide Vollmachten bleiben nach gehöriger „ne varietur" durch die erschienenen Parteien und den verhandelnden Notar
bei gegenwärtiger Urkunde als Anlage um mit ihr einregistriert zu werden.
Die erschienenen Parteien, handelnd wie vorerwähnt, ersuchen den verhandelnden Notar, die Satzungen einer von
ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:
Gesellschaftsname - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Zwischen den erschienenen Parteien und allen Personen, die später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung „CEBEUS HOLDING SA".
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Winseler/Doncols.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl
im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die normale Geschäftstätigkeit
am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes im Ausland gefährden oder
85218
unmittelbar bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Einstellung dieser unge-
wöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden, ohne dass jedoch diese Maßnahme eine Wirkung auf die Staatszuge-
hörigkeit der Gesellschaft hat, welche unbeschadet der provisorischen Verlegung des Sitzes luxemburgisch bleiben wird.
Eine solche Sitzverlegungserklärung wird gemacht sowie Dritten zur Kenntnis gegeben durch einen der ausführenden
Organe der Gesellschaft, welcher die Befugnis besitzt, die tägliche Geschäftsführung auszuüben.
Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung, jedweder Art, an anderen Gesellschaften mit Sitz im Großher-
zogtum Luxemburg oder im Ausland, die Kontrolle und Verwaltung dieser Beteiligungen sowie deren Geltendmachung.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,
Kauf oder jede andere Transaktion oder Maßnahme. Sie kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder
auf jede andere Art und Weise veräußern. Sie kann sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle von Gesellschaften
und Unternehmen beteiligen und diese unterstützen.
Die Gesellschaft kann auch Patente, Warenzeichen, Lizenzen und andere Rechte erwerben, veräußern und verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen, sowie den Gesellschaften und Unternehmen an welchen sie sich beteiligt,
Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.
Die Gesellschaft kann im allgemeinen alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, die mit-
telbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes
beitragen könnten.
Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Gesellschaftskapital - Aktien
Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000.- EUR) eingeteilt in vier Aktien (4) mit einem
Nennwert von siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro (7.750.- EUR) pro Aktie.
Art. 6. Die Aktien sind je nach Wunsch des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.
Verwaltung - Aufsicht
Art. 7. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern die Aktionäre
sein können.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung ernannt.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder kann eine Dauer von sechs Jahren nicht überschreiten. Sie sind wieder-
wählbar, können jedoch jederzeit durch die Generalversammlung abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrats ermächtigt die vorläufige Besetzung des freigewordenen Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. Die
nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 8. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bezeichnen; in dessen Abwesenheit wird der
Vorsitz einem Verwaltungsratsmitglied übertragen, das zu diesem Zweck von den anwesenden Mitgliedern ernannt wird.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Ein
Mandat zwischen Verwaltungsräten ist zulässig, ohne dass jedoch ein Verwaltungsratsmitglied mehr als einen seiner Kol-
legen vertreten kann.
Die Vollmacht zur Vertretung eines verhinderten Verwaltungsratsmitgliedes kann durch Brief, Fax, Telegramm, Fern-
schreiben erteilt werden.
Art. 9. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Art. 10. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmit-
gliedern unterschrieben.
Abschriften oder Auszüge der Protokolle werden für gleichlautend vom Vorsitzenden oder einem Bevollmächtigten
bescheinigt. Die Vollmachten bleiben den Protokollen beigefügt.
Art. 11. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur Verwirklichung
des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, soweit dieselben nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen
Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
Art. 12. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbe-
zügliche Vertretung der Gesellschaft ganz oder teilweise an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren,
Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die nicht Aktionäre zu sein brauchen.
Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied unterliegt der vorherigen Genehmi-
gung der Generalversammlung.
Es steht dem Verwaltungsrat zu, Spezialvollmachten zu erteilen für Rechtsgeschäfte, zu denen er selbst befugt ist.
85219
Art. 13. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet durch die Unterschrift des Verwal-
tungsratsdelegierten oder gegebenenfalls durch die gemeinschaftliche Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates
und des Verwaltungsratsdelegierten.
Art. 14. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche Aktionäre sein können. Der
oder die Kommissare werden ernannt für die Dauer von höchstens sechs Jahren gerechnet von der Generalversammlung
an. Die Generalversammlung legt ihre Anzahl und Bezüge fest. Sie sind wiederwählbar.
Gesellschafterversammlung
Art. 15. Die Gesellschafterversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.
Sie hat die weitestgehenden Befugnisse in Bezug auf alle Gesellschaftsangelegenheiten.
Art. 16. Die jährliche ordentliche Generalversammlung findet rechtens statt am Gesellschaftssitz oder an dem im
Einberufungsschreiben angegebenen Ort, jeweils am ersten Freitag des Monats Juni und zum ersten Mal im Jahr 2009.
Sofern dieser Tag auf einen Feiertag fällt, findet sie am ersten drauffolgenden Werktag statt.
Art. 17. Eine außerordentliche Generalversammlung kann durch den Verwaltungsrat oder durch den oder die Kom-
missare einberufen werden.
Die Einberufung kann auch auf schriftliche Anfrage von Aktionären, die mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals
vertreten, gefordert werden.
Art. 18. Die Einberufung der Gesellschafterversammlungen erfolgt gemäss der im Gesetz vorgeschriebenen Formen
und Fristen.
Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einberufung von Generalversammlungen kann abgesehen wer-
den, wenn sämtliche Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und erklären den Inhalt der
Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Art. 19. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; falls
eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, die mit dieser
Aktie verbunden sind, solange zu suspendieren bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.
Geschäftsführung - Gewinnverteilung
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt die jährliche Bilanz.
Er übergibt dem oder den Kommissaren wenigstens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung die Unterlagen
nebst einem Tätigkeitsbericht.
Art. 21. Vom Nettogewinn werden mindestens fünf Prozent (5%) einbehalten zwecks Bildung der gesetzlichen Rück-
lage; diese obligatorische Vorwegnahme entfällt sobald und solange die Rücklage ein Zehntel des Gesellschaftskapitals
erreicht.
Das Saldo steht der Generalversammlung zur Verfügung.
Der Verwaltungsrat kann mit Zustimmung des oder der Kommissare und unter Berücksichtigung der diesbezüglichen
Vorschriften Anzahlungen auf Dividende vornehmen.
Auflösung - Liquidation
Art. 22. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung, die gemäss den für die Satzungsänderung
vorgesehenen Bestimmungen befindet, vorzeitig aufgelöst werden.
Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Liquidatoren. Diese werden von der Gesellschaf-
terversammlung ernannt, die ihre Befugnisse und Bezüge festlegt.
Gesetzgebung
Art. 23. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 in seiner gegenwärtigen Form über die Handelsgesell-
schaften finden ihre Anwendung in allen Fällen finden, wo nicht anders durch die gegenwärtige Satzung bestimmt wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2008.
Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahr 2009 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlung des Kapitalsi>
Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:
Aktien
1) Herr Joël REBUFFAT, vorbenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2) Frau Edith BELLAICHE, vorbenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3) Herr Dr. Elmar SPRANGER, vorbenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
85220
4) Herr Gerd SEFFRIED, vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
TOTAL: vier Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Alle Aktien sind ganz in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von einunddreißigtausend Euro
(31.000.- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich
bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen gegenwärtiger Urkunde beläuft sich auf ungefähr
2.000.- €.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann sind die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen
Generalversammlung zusammen-gekommen und haben nach Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Zu-
sammensetzung dieser Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf vier, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats ernannt. Ihre Mandate erlöschen am Ende der ordentlichen Gene-
ralversammlung des Jahres 2014:
a) Herr Joël, René, Gaston REBUFFAT,
b) Frau Edith, Messaouda, Haia BELLAICHE
c) Herr Dr Elmar Michael SPRANGER,
d) Herr Gerd SEEFRIED,
Alle vorbezeichnet
3) Zum Kommissar mit Wirkung bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2014: wird ernannt:
Die Gesellschaft COMPTAPHI S.A., mit Sitz in L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers, engetragen im Gesell-
schafts- und Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 115.282.
4) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers
5) Gemäss der gegenwärtigen Satzung und des Gesetzes ermächtigt die Gesellschafterversammlung den Verwaltungs-
rat, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäfts-
führung an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates zu übertragen.
<i>Versammlung des Verwaltungsratesi>
Sind erschienen:
Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft „CEBEUS HOLDING SA"
a) Herr Joël, René, Gaston REBUFFAT, vorgenannt,
b) Frau Edith, Messaouda, Haia BELLAICHE, vorgenannt,
c) Herr Dr Elmar Michael SPRANGER,vorgenannt, hier vertreten wie vorerwähnt,
d) Herr Gerd SEEFRIED, vorgenannt, hier vertreten wie vorerwähnt
Die hier anwesenden Verwaltungsratsmitglieder bestimmen zu Verwaltungsratsdelegierten Herr Joël REBUFFAT und
Herrn Gerd SEEFRIED, vorgenannt.
Die beiden Verwaltungsratsdelegierten vertreten die Gesellschaft rechtsgültig durch ihre gemeinsame Unterschrift.
Der unterzeichnete Notar, der Deutsch und Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, daß auf Anfrage der er-
schienen Partei dieser Urkunde eine englische Übersetzung folgt, und daß im Falle irgendwelcher Abweichungen zwischen
deutschem und englischem Text die deutsche Version vorherrscht.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Wiltz in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die erschienenen Parteien, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben sie mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Es folgt die englische Übersetzung des vorstehenden Textes:
In the year two thousand eight, on
Before us, Maître Anja HOLTZ, notary residing in Wiltz,
there appears:
1.- Mr Joël, René, Gaston REBUFFAT, born to Paris on the 5th of February 1952, residing in CH-1287 Laconnex (CH),
10, rue de la Maison Forte
85221
2.- Misses Edith, Messaouda, Haia BELLAICHE, born to Beja (Tunisia) on the 4th of May 1946, residing in 28, rue de
la Fontarabie, F-75020 Paris 20
e
.
3.- Mr. Dr. Elmar Michael SPRANGER, born to Ingolstadt (D) on the 27th of May 1956, residing in Ingolstadt (D),
Barellistraße 12
here represented by Mr. Joël REBUFFAT, prenamed, by virtue of a proxy given in Geneva on the 12th of June 2008.
4.- Mr. Gerd SEEFRIED, born to Wemding (D), on the 18th of July, residing in Wemding (D), Wimburggasse 4,
here represented by Mr. Joël REBUFFAT, prenamed, by virtue of a proxy given in Geneva on the 12th of June 2008.
both prenamed proxies, after having been signed „ne varietur" by all the appearing parties and the notary executing
remains annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the here above stated capacities, have drawn up the following articles of a public
limited liability Company which they intend to organize among themselves.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Between the appearing parties and all those that might become owners of the shares created hereafter, a public
limited liability Company is herewith formed under the name of „CEBEUS HOLDING SA".
Art. 2. The registered office is established in Winseler / Doncols.
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies and administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a resolution of the board of directors.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the provisional
transfer of is registered office, shall remain a Luxembourg Company.
The board of directors shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Lux-
embourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The company may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,
option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer exchange or otherwise. The company can par-
ticipate in the establishment, development and control of companies and support these.
The company may also acquire and manage all patents, trademarks, licences and other rights.
The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct
and substantial interest.
The company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions and in general all transactions
which are necessary or useful to fulfil its corporate object.
Art. 4. The Company is established for an unlimited period.
Capital - Shares
Art. 5. The share capital of the Company is fixed at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31.000.- EUR) divided into
FOUR (4) shares with a par value of SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY (7.750.- EUR) each.
Art. 6. The shares of the company may be in registered or in bearer form at the option of the shareholders.
Board of directors - Statutory auditors
Art. 7. The Company is managed by a board of directors of not less than three members, shareholders or not, who
are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed
at any time by the general meeting.
If the port of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally fill the vacancy by electing a Director. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 8. The board of directors could choose among its members a chairman. If the chairman is unable to be present,
his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The board of directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented by
proxies. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy.
Votes may also be cast by letter, fax, telegram, or telex.
Art. 9. All decisions by the board of directors require a simple majority of votes cast. In case of an equality of votes,
the chairman has a casting vote.
Art. 10. The minutes of meetings of the board of directors shall be signed by the chairman or of two of the directors.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy. The proxies remains annexed to the minutes
of meetings.
85222
Art. 11. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholder's meeting by the Law or by the
present Articles, fall within the competence of the board of directors.
Art. 12. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to directors, manager or proxyholder, who need not be shareholders of the Company.
The delegation of the daily management to a member of the board is subject to a previous authorization of the general
meeting of shareholders.
The board of directors may also confer special mandates for legal transactions.
Art. 13. Towards third parties, the Company is in all circumstances committed either by the joint signatures of the
chairman and a director or by the single signature of the chairman.
Art. 14. The Company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by
the general meeting, which determines their number and their remuneration. The term of the mandate of the statutory
auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years. The auditors can be re-
elected.
General meeting
Art. 15. The general meeting represents the whole body of shareholders.
It has the most extensive powers to carry out or ratify acts relating to the Company.
Art. 16. The annual general meeting will be held in the registered office or at the place specified in the convening notice,
on the first Friday of the month of June and for the first time in the year 2009.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 17. The board of directors or the auditors may convene a general meeting of the shareholders.
It must be convened at the written request of shareholders representing twenty percent of the Company's share
capital.
Art. 18. Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder in
compliance with the law.
In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the
agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.
Art. 19. Each share entitles to the casting of one vote. The Company will recognize only one holder for each share.
The corporation will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the
corporation has the right to suspend the exercise of all right attached to the share until one person has been appointed
as the sale owner in relation to the corporation.
Management - Distribution of profits
Art. 20. The business year begins on the 1st of January and ends on the 31st December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the Company's activities to the statutory auditor(s) at least one month
before the statutory general meeting.
Art. 21. At least five percent (5%) of the net profit fort he financial year have to be allocated to the legal reserve fund.
Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
Dissolution - Liquidation
Art. 22. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the articles of incorporation.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, appointed by the
general meeting which will specify their powers and remunerations.
Legislation
Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law
of August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on the 31st of December 2008.
The first annual general meeting shall be held in 2009.
85223
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed to as follows:
Shares
1) Mr. Joël REBUFFAT, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2) Miss Edith BELLAICHE, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3) Mr. Dr Elmar SPRANGER, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4) Mr Gerd SEEFRIED, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
TOTAL: four shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of
THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31.000.- €) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the Law have been fulfilled and
expressly bears witness to their fulfillment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the Company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one
two thousand euro (2.000.- €)
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:
1) The number of directors is fixed at four, and the number of auditor is fixed at one.
2) The following have been elected as directors for duration ending at the annual general meeting of 2014:
a) Mr Joël, René, Gaston REBUFFAT,
b) Miss Edith, Messaouda, Haia BELLAICHE,
c) Mr Dr Elmar SPRANGER,
d) Mr Gerd SEEFRIED.
3) The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2014:
The company COMPTAPHI S.A., having its registered office in L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers, registered
in the Luxembourg's trade register under the number B115.282.
4)The company's registered office is located at L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers,
5) The board of directors is authorized to delegate the daily management to one or several of its members.
<i>Meeting of the board of directorsi>
There appeared the board of directors of the company „CEBEUS HOLDING SA"
a) Mr Joël, René, Gaston REBUFFAT, prenamed
b) Miss Edith, Messaouda, Haia BELLAICHE, prenamed
c) Mr Dr Elmar SPRANGER, prenamed, here represented as mentioned
d) Mr Gerd SEEFRIED, prenamed, here represented as mentioned.
They appoint chairman Mr Joël REBUFFAT and Mr Gerd SEEFRIED.
Both chairmans represent the company in all circumstances by their joint signatures.
The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that upon request of the
above appearing persons, this deed is followed by an English translation, and that in case of any divergences between
German and English text, the German version shall be prevailing
Whereof the present notarial deed was drawn up in Wiltz, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,
surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary the present original
deed.
Signed: Rebuffat, Bellaiche, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 18 juin 2008, Relation: WILL/2008/555. — Reçu cent cinquante-cinq euros 31000*0.5% = 155
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Pletschette.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG der Gesellschaft auf Begehr erteilt auf stempelfreien Papier zwecks
Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
85224
Wiltz, den 24. Juni 2008.
Anja HOLTZ.
Référence de publication: 2008085861/2724/349.
(080098144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
High Pressure Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 87.334.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008085445/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS01056. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080096971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 139.725.
STATUTES
In the year two thousand and eight, on the third of July.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
APPEARED:
"Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS", a company incorporated and organised under the laws of Luxembourg with
registered office is 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,
represented by Mrs Linda FUNCK, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal on 2nd
of July 2008.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée).
Chapter I.- Form, name, registered office, object, duration
Art. 1. Form, Corporate Name. Hereby is formed under the name of "Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care III
S.à r.l." a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws pertaining
to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies
as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The board
of managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory registered office.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect
on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a
Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of
managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 3. Corporate Objectives. The Company's object is to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in other
Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
The Company may further use its funds for the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease
of real estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as for any other operations relating to real
estate. In particular, the Company may have direct or indirect shareholdings in companies and participations in limited
85225
partnerships or other legal entities in whatever form and based in Luxembourg or abroad, the principal object of which
is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate, including real estate located
abroad.
The Company may also enter into the following transactions:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect
interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect unitholder of the Company or any company
belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies" and each as a
"Connected Company").
For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same "group" as the Company if such other
company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another
company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the
company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether
through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company, or any directors or officers of the Company, or any of the
Connected Companies and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;
it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a banking activity.
The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all
transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its object in all areas described above.
Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II.- capital, units
Art. 5. Corporate Capital. The unit capital is fixed at thirty five thousand Euro (35,000.- EUR), represented by three
hundred and fifty (350) units of hundred Euro (100.-EUR) each.
Art. 6. Capital Amendment. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where there
is only one unitholder) or by a decision of the unitholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.
Art. 7. Distribution Right of Units. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and
profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.
Art. 8. Units Indivisibility. Towards the Company, the Company's units are indivisible, since only one owner is admitted
per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of Units. In case of a single unitholder, the Company's units held by the single unitholder are freely
transferable.
In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of units without the prior consent of
the majority of the unitholders owning at least three-quarter of the Company's unit capital.
Chapter III.- Management
Art. 10. Management. A board of managers composed of at least three members manages the Company. The managers
need not to be unitholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of
unitholders holding a majority of votes.
The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram or telefax or
email or letter another manager as his proxy. A meeting of the board of managers can only be held if two managers are
present in person, by conference call or by video conference.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating manager
is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each
participating manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
Written resolutions of the board of managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the members
of the board of managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by mail, fax, e-mail,
telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the board of managers' meetings,
physically held.
85226
Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is
confirmed in writing.
Art. 11. Powers of the manager. In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of
the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
objects and provided the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the
competence of the board of managers. The board of managers, may, in particular, enter into investment advisory agree-
ments and administration agreements such as e.g. real estate agent or property management agreements.
Art. 12. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of any member of the
board of managers.
Art. 13. Sub-Delegation and Agent of the manager. Any members of the board of managers may sub-delegate his
powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
Any members of the board of managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the
duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
Art. 14. Remuneration of the manager. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later
date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 15. Liabilities of the manager. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no
personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.
Chapter IV.- General meeting of unitholders
Art. 16. Powers of the General Meeting of Unitholder(s). The single unitholder assumes all powers conferred to the
general unitholders' meeting.
In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding.
A unitholder may act at any general meeting of unitholders by appointing (or, if the unitholder is a legal entity, its legal
representative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, email as his proxy another person who need not be a
unitholder himself.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the unit
capital. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least
three-quarter of the Company's unit capital, subject to the provisions of the Law.
Chapter V.- Business year - balance sheet
Art. 17. Business Year. The Company's financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each
year.
At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the board of managers prepares an
inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each unitholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Allocation and Distribution of the Profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts,
after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per
cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent
(10%) of the Company's unit capital.
The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the
Company.
Chapter VI.- Dissolution - liquidation
Art. 19. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.
Art. 20. Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.
A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Chapter VII.- Applicable law
Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
85227
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 31 De-
cember 2008.
<i>Subscription - paymenti>
All the three hundred and fifty (350) units representing the entire capital have been entirely subscribed by "Sireo
Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS", prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of thirty five thousand Euro
(EUR 35,000.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about three thousand euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as managers for an undetermined period:
a. Mr Wolfgang A. BAERTZ, Senior Consultant, L-8123 Bridel, Grand Duchy of Luxembourg;
b. Mr Detlef NIEZGODKA, Senior Consultant Sireo, D-50259 Pulheim, Germany;
c. Dr. Bernd WIEBERNEIT, Executive Director, Corpus Sireo Asset Management GmbH, D-63150 Heusenstamm,
Germany;
d. Mr Jost-Albrecht NIES, Director, Corpus Sireo Investment Management S.à r.l., L-1246 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg;
e. Dr. Hilmar FRIEDRICH-RUST, Senior Consultant Sireo, D-61476 Kronberg im Taunus, Germany;
f. Dr. Rolf SUTTER, Senior Consultant, Laan van Ypenhof 164, NL-3062 ZN Rotterdam, The Netherlands.
In accordance with article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the sole signature of any member of the
board of managers.
2) The Company shall have its registered office at 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
3) "Deloitte S.A.", société anonyme, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg is ap-
pointed as auditor of the Company for an undetermined period of time.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le trois juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
«Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS», une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg,
représentée par Madame Linda FUNCK, avocat, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé le 2 juillet 2008.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Chapitre I
er
.- Forme, nom, siège social, objet, durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Par la présente, il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination
de «Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care III S.à r.l.» qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la
"Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"),
ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts").
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil de gérance est
autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur de la Ville du siège statutaire.
85228
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant de la même manière que pour une modification des Statuts.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre
l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire
n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera
luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce soit,
dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie entre autres de participation, d'apport, de souscri-
ption, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments financiers
de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.
La Société peut également utiliser ses fonds en vue de l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion
et/ou la location de biens immobiliers au Grand-duché du Luxembourg ou à l'étranger ainsi que toutes autres opérations
ayant trait à l'immobilier. En particulier, la Société peut détenir directement ou indirectement des actions dans des sociétés
et des participations dans des sociétés à responsabilité limitée (limited partnership) ou toutes autres entités juridiques
quelle que soit leur forme et basés soit Luxembourg ou à l'étranger ayant pour objet principal l'acquisition, le dévelop-
pement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers, y compris de biens immobiliers situés à
l'étranger.
La Société pourra également, être engagée dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt
direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société,
ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les «Sociétés Apparentées» et chacune
une «Société Apparentée»);
Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre
société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société,
que ce soit comme détenteur ultime, trustée ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme con-
trôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du
capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance
aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;
il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités
pouvant être considérées comme une activité bancaire.
La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes
opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs pré-décrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci-
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II.- Capital, parts
Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à trente cinq mille Euros (35.000 EUR,-), représenté par trois cent
cinquante (350) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Art. 6. Modification du Capital. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique (quand
il y a un seul associé) ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 16 des présents
Statuts.
Art. 7. Droit de Distribution des Parts. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et
bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 8. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par
part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la
Société.
Art. 9. Transfert des parts. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont
librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
85229
Chaque associé s'engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les parts qu'il détient sans le consen-
tement préalable de la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social de la Société.
Chapitre III.- Gérance
Art. 10. Gérance. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins trois membres. Les gérants ne
sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une
résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du conseil de gérance par un autre gérant, pour
autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre.
Un conseil de gérance peut uniquement être tenu si deux gérants sont présents en personne, par conférence téléphonique
ou par vidéo conférence.
L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure
d'entendre et d'être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
Des résolutions du conseil de gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et
approuvées par écrit par tous les membres du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de
plusieurs documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même effet et la
même validité que des décisions votées lors d'une réunion du conseil de gérance physiquement tenue.
Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tel que fax, e-mail, télé-
gramme ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.
Art. 11. Pouvoirs du Gérant. Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom de
la Société et pour effectuer et approuver tout acte et opération conformément à l'objet social et pourvu que les termes
du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut, en particulier, conclure des contrats de conseil en
investissement et des contrats d'administration, par exemple des real estate agent's agreements et des property mana-
gement agreements.
Art. 12. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par la seule signature d'un des membres du
conseil de gérance.
Art. 13. Sub-délégation et Agent du Gérant. Tout membre du conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses
pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Tout membre du conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de ces
agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Art. 14. Rémunération du Gérant. Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieure-
ment en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 15. Responsabilités du Gérant. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction,
aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Chapitre IV.- Assemblée générale des associés
Art. 16. Pouvoirs de l'Assemblée Générale de l'Associé (des Associés). L'associé unique exerce tous pouvoirs qui sont
conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.
Un associé est autorisé à se faire représenter à toute assemblée des associés par un mandataire qui ne doit pas
nécessairement être associé lui-même, pour autant que ce dernier ait été nommé à cet égard par une procuration écrite,
par fax, câble, télégramme ou par e-mail.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés
que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de
la Loi.
Chapitre V.- Exercice social - comptes annuels
Art. 17. Exercice Social. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance prépare un
inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé aura le droit de prendre connaissance des livres de la Société, desdits inventaires et bilan au siège social.
85230
Art. 18. Réserve Légale et Distribution du Bénéfice. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels,
après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est
prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%)
du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Chapitre VI.- Dissolution - liquidation
Art. 19. Causes de Dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits
civils, d'insolvabilité, de faillite de son associé unique ou de l'un des associés.
Art. 20. Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liqui-
dateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, en prenant personnellement
en charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Chapitre VII.- Loi applicable
Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.
<i>Souscription - libérationi>
Les trois cent cinquante (350) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par
«Sireo Immobilienfonds No. 5 Sicav FIS», prénommée, et intégralement libérées par des versements en numéraire, de
sorte que la somme de trente-cinq mille Euros (EUR 35.000.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ trois mille euros.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
a. Monsieur Wolfgang A. BAERTZ, Senior Consultant, L-8123 Bridel, Grand-Duché de Luxembourg;
b. Monsieur Detlef NIEZGODKA, Senior Consultant Sireo, D-50259 Pulheim, Allemagne;
c. Dr. Bernd WIEBERNEIT, Executive Director, Corpus Sireo Asset Management GmbH, D-63150 Heusenstamm,
Allemagne;
d. Monsieur Jost-Albrecht NIES, Director, Corpus Sireo Investment Management S.à r.l., L-1246 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg;
e. Dr. Hilmar FRIEDRICH-RUST, Senior Consultant Sireo, D-61476 Kronberg im Taunus, Allemagne;
f. Dr. Rolf SUTTER, Senior Consultant, Laan van Ypenhof 164, NL-3062 ZN Rotterdam, Pays-Bas.
Conformément à l'article 12 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature d'un des membres du
conseil de gérance.
2) Le siège social de la Société est établi au 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
3) «Deloitte S.A.», société anonyme, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg est
désignée comme étant réviseur d'entreprises de la Société pour une période illimitée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: L. FUNCK, J.-J. WAGNER.
Enregistré Esch-sur-Alzette A.C., le 4 juillet 2008. Relation: EAC/2008/8914. - Reçu cent soixante-quinze Euros
(35.000.- à 0,5 % = 175.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
85231
Belvaux, le 4 juillet 2008.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2008085866/239/366.
(080098176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Electrofin S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 40.053.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008085444/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS01058. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080096970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
AMB Le Grand Roissy Holding 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 115.810.
In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth of June.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
AMB Le Grand Roissy Holding 1 S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorpo-
rated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 115.809,
in its capacity of sole partner of AMB Le Grand Roissy Holding 2 S. à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée), incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its regis-
tered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 115.810, incorporated on 18 April 2006 pursuant to a deed of notary André-Jean-Joseph Schwachtgen,
published on 29 June 2006 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1255 (the "Company"),
here represented by Mrs Barbara MALANIUK, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given
in Luxembourg on June 18th, 2008.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the undersigned notary and the proxyholder acting on behalf of
the appearing party, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. AMB Le Grand Roissy Holding 1 S. à r.l., is the sole partner (the "Sole Partner") of the Company;
II. The Company's share capital is presently set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) divided into
five hundred (500) shares each having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-).
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Partner resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of twenty-five euro
(EUR 25.-) so as to bring the Company's share capital from its current amount of twelve thousand and five hundred euro
(EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR
25.-) each, to an amount of twelve thousand five hundred and twenty-five euro (EUR 12,525.-), by the issuance of one
new share in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-), having the same characteristics and entitling
to the same rights as the five hundred (500) existing shares of the Company (the "Shares").
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Partner, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for one new share of
the Company, in registered form and with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-), and to have it fully paid up by a
contribution in kind to the Company consisting of the following assets (the "Claims"):
1. a receivable which was lent by the Sole Partner to the Company in relation to transaction called "SCI AMB Gonesse
Distribution Center 3" (the Claim 1);
85232
2. a receivable which was lent by the Sole Partner to the Company in relation to transaction called "SCI AMB Gonesse
Distribution Center 4" (the Claim 2);
3. a receivable which was lent by the Sole Partner to the Company in relation to transaction called "AMB Lille Holding
1 SAS" (the Claim 3); and
4. a receivable which was lent by the Sole Partner to the Company in relation to transaction called "SCI AMB Orléans
Distribution Center 1" (the Claim 4).
The contribution in kind in an aggregate amount of three million nine hundred ninety-nine thousand six hundred and
fifty euro (EUR 3,999,650.-) is to be allocated as follows:
- an amount of twenty-five euro (EUR 25.-) is to be allocated to the corporate capital account of the Company;
- an amount of three million nine hundred ninety-nine thousand six hundred and twenty-five euro (EUR 3,999,625.-)
is to be allocated to the share premium account of the Company.
It further results from a declaration issued on June 18th, 2008 by the Sole Partner (the "Declaration") that:
- based on generally accepted accounting principles, the net worth of the Claims to be contributed to the Company
is valued at three million nine hundred ninety-nine thousand six hundred and fifty euro (EUR 3,999,650.-) and since the
date of the Declaration no material changes have occurred which would have depreciated the contribution to be made
to the Company;
- the Claims to be contributed to the Company are freely transferable by the Sole Partner and they are not subject
to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value; and
- all formalities for the transfer of the legal ownership of the Claims to be contributed to the Company have been or
will be accomplished by the Sole Partner in cooperation with the Company.
It further results from a certificate issued on June 18th, 2008 by the Company (the "Certificate'') that:
- based on generally accepted accounting principles, the net worth of the Claims to be contributed to the Company
is valued at three million nine hundred ninety-nine thousand six hundred and fifty euro (EUR 3,999,650.-) and since the
date of the Certificate no material changes have occurred which would have depreciated the contribution to be made to
the Company; and
- all formalities for the transfer of the legal ownership of the Claims to be contributed to the Company have been or
will be accomplished by the Company in cooperation with the Sole Partner.
Such Declaration and the Certificate, after signature "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Partner resolves to amend article 5, first paragraph, of the articles
of association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:
"5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred and twenty-five euro (EUR 12,525.-),
represented by five hundred and one (501) share in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each,
all subscribed and fully paid-up".
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be
borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
twenty-three thousand euro (EUR 23,000).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancies between the English
version and the French version, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing party, the proxyholder signed
together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
En l'an deux mille huit, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
AMB Le Grand Roissy Holding 1 S. à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.809,
en sa capacité d'associé unique d'AMB Le Grand Roissy 2 S. à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, im-
85233
matriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.810, constituée le 18 avril
2006 en vertu d'un acte notarié du notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, publié le 29 juin 2006 au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations sous le numéro 1255 (la "Société"),
ici représentée par Madame Barbara MALANIUK, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à Luxembourg le 18 juin 2008.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire soussigné et le mandataire agissant pour le
compte de la partie comparante, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregis-
trement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. AMB Le Grand Roissy 1 S. à r.l., est l'associé unique ("l'Associé Unique") de la Société;
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) divisé en cinq cents
(500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.
Sur ceci, la partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première décisioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de vingt-cinq euros (EUR
25.-) aux fins de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-)
représenté par cinq cents (500) parts sociales, sous forme nominative, ayant une valeur comptable de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, à un montant de douze mille vingt-cinq euros (EUR 12.025,-) par l'émission d'une (1) nouvelle part
sociale, sous forme nominative, ayant une valeur comptable de vingt-cinq euros (EUR 25,-), ayant les mêmes caractéris-
tiques et attribuant les mêmes droits que le cinq cents (500) parts sociales existantes de la Société.
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits étant exposés, l'Associé Unique, prédésigné et représenté comme ci-dessus, déclare souscrire une (1) nou-
velle part sociale de la Société, sous forme nominative et ayant une valeur comptable de vingt-cinq euros (EUR 25,-), et
la libérer entièrement par un apport en nature à la Société consistant dans les actifs suivants (les "Créances"):
1. une créance qui a été prêtée par l'Associé Unique à la Société dans le cadre de la transaction dénommée "SCI AMB
Gonesse Distribution Center 3" (la Créance 1);
2. une créance qui a été prêtée par l'Associé Unique à la Société dans le cadre de la transaction dénommée "SCI AMB
Gonesse Distribution Center 4" (la Créance 2);
3. une créance qui a été prêtée par l'Associé Unique à la Société dans le cadre de la transaction dénommée "AMB Lille
Holding 1 SAS" (la Créance 3); et
4. une créance qui a été prêtée par l'Associé Unique à la Société dans le cadre de la transaction dénommée "SCI AMB
Orléans Distribution Center 1" (la Créance 4).
L'apport en nature d'un montant total de trois millions neuf cent quatre-vingt-diy-neuf mille six cent cinquante euros
(EUR 3.999.650.-) est à allouer comme suit:
- un montant de vingt-cent euros (EUR 25,-) est à allouer au compte capital social de la Société;
- un montant de trois million neuf cents quatre-vingt-dix-neuf mille six cent vingt-cinq euros (EUR 3.999.625.-) est à
allouer au compte prime d'émission de la Société.
De plus, il ressort d'une déclaration émise par la gérance de l'Associé Unique à la date du 18 juin 2008 (la "Déclaration")
que:
- conformément aux principes comptables généralement admis, la valeur nette des Créances devant être apportées à
la Société est estimée à trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent cinquante euros (EUR 3.999.650.-) et
depuis la date de la Déclaration il n'y a pas eu de changement matériel, qui aurait déprécié l'apport devant être fait à la
Société;
- les Créances devant être apportées à la Société sont librement cessibles par l'Associé Unique et ne sont pas soumises
à des restrictions ou grevées d'un nantissement ou d'un droit de gage limitant leur transmissibilité ou diminuant leur
valeur; et
- toutes les formalités pour le transfert de la possession des Créances devant être apportées à la Société ont été ou
seront accomplisses par l'Associé Unique en coopération avec la Société.
De plus, il ressort d'un certificat émis par la gérance de la Société à la date du 18 juin 2008 (le "Certificat") que:
- conformément aux principes comptables généralement admis, la valeur nette des Créances devant être apportées à
la Société est estimée à trois million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent cinquante euros (EUR 3.999.650.-) et
depuis la date du Certificat il n'y a pas eu de changement matériel, qui aurait déprécié l'apport devant être fait à la Société;
et
- toutes les formalités pour le transfert de la possession des Créances devant être apportées à la Société ont été ou
seront accomplisses par la Société en coopération avec l'Associé Unique.
85234
Ladite Déclaration et le Certificat, après signature "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
<i>Deuxième décisioni>
En conséquence de la décision ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5, premier paragraphe, des statuts
de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
"5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 12.525,-) représenté par mille
cinq cent et une (501) parts sociales, sous forme nominative, ayant une valeur comptable de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant total des frais, charges, rémunérations ou dépenses, sous toute forme qu'ils soient, qui incombent à la
Société ou qui seront facturés à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à vingt-trois mille
euros (EUR 23.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence entre la version en anglais et la version en français,
la version en anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête du présent acte.
Le document ayant été lu au mandataire agissant pour le compte de la partie comparante, le mandataire a signé le
présent acte original avec le notaire.
Signé: B. Malaniuk et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juin 2008, LAC/2008/26421. — Reçu dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-
huit euros vingt-cinq cents. Eur 0,50% = 19.998,25.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008085792/5770/179.
(080098336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Maecolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 108.632.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 juin 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008085557/2980/12.
Enregistré à Diekirch, le 27 juin 2008, réf. DSO-CR00353. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080097326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Sal. Oppenheim Special Situations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 130.099.
<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of June 30th, 2008i>
- The resignation of Mrs Ulrike Sachs and Mr Carlo Schlesser for personal reasons as directors, are accepted.
- The following are appointed as new Directors:
* Mr Friedrich Carl Janssen, Personal Liable Partner, professionally residing in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
* Mr Dieter Pfundt, Personal Liable Partner, professionally residing in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
* Mr Freiherr Christopher von Oppenheim, Personal Liable Partner, professionally residing in 4, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg
Their mandates will lapse at the Annual General Meeting of 2009.
85235
<i>Auszug aus der Beschlussfassung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2008i>
- Die Rücktritte von Frau Ulrike Sachs, geschäftsansässig in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg und von Herrn
Carlo Schlesser, geschäftsansässig in 23, avenue Monterey, L-2086 Luxemburg, als Verwaltungsratsmitglieder der Gesell-
schaft werden angenommen.
- Folgende Personen erhalten ein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft:
* M. Friedrich Carl Janssen, Personal Liable Partner, geschäftsansässig in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
* M. Dieter Pfundt, Personal Liable Partner, geschäftsansässig in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
* M. Freiherr Christopher von Oppenheim, Personal Liable Partner, geschäftsansässig in 4, rue Jean Monnet, L-2180
Luxemburg
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder laufen somit anlässlich der ordentlichen Generalversammlung des Jahres
2009 aus.
Luxemburg, den 30. Juni 2008.
For true copy / Für beglaubigten Auszug
<i>SAL. OPPENHEIM SPECIAL SITUATIONS S.A.
i>SGG IN DER EIGENSCHAFT ALS DOMIZILIERUNGSGESELLSCHAFT
Unterschriften
Référence de publication: 2008085043/795/33.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02234. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080097981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
AMB Le Grand Roissy Holding 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.025,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 115.809.
In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth of June.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
AMB Dutch Holding B.V., a private limited liability company under Dutch law (besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid), having its registered offices in Amsterdam, the Netherlands and its office address at Zuidplein 108,
Tower H-13, 1077 XV Amsterdam, the Netherlands, registered with the Trade Register of the Amsterdam Chamber of
Commerce under number 34188102,
in its capacity of sole partner of AMB Le Grand Roissy Holding 1 S. à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée), incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its regis-
tered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 115.809, incorporated on 18 April 2006 pursuant to a deed of notary André-Jean-Joseph Schwachtgen,
published on 29 June 2006 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1257 (the "Company"),
here represented by Mrs Barbara MALANIUK, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given
in Amsterdam (NL) on June 12th, 2008.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the undersigned notary and the proxyholder acting on behalf of
the appearing party, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. AMB Dutch Holding B.V., is the sole partner (the "Sole Partner") of the Company;
II. The Company's share capital is presently set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) divided into one thousand
(1,000) shares each having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-).
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Partner resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of twenty-five euro
(EUR 25.-) so as to bring the Company's share capital from its current amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-)
represented by one thousand (1,000) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to
an amount of twenty-five thousand and twenty-five euro (EUR 25,025.-), by the issuance of one new share in registered
form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-), having the same characteristics and entitling to the same rights as
the one thousand (1,000) existing shares of the Company (the "Shares").
85236
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Partner, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for one new share of
the Company, in registered form and with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-), and to have it fully paid up by a
contribution in kind to the Company consisting of the following assets (the ''Claims''):
1. a receivable which was lent by the Sole Partner to the Company in relation to transaction called "SCI AMB Gonesse
Distribution Center 3" (the Claim 1);
2. a receivable which was lent by the Sole Partner to the Company in relation to transaction called "SCI AMB Gonesse
Distribution Center 4" (the Claim 2);
3. a receivable which was lent by the Sole Partner to the Company in relation to transaction called "AMB Lille Holding
1 SAS" (the Claim 3); and
4. a receivable which was lent by the Sole Partner to the Company in relation to transaction called "SCI AMB Orléans
Distribution Center 1" (the Claim 4).
The contribution in kind in an aggregate amount of three million nine hundred ninety-nine thousand six hundred and
fifty euro (EUR 3,999,650.-) is to be allocated as follows:
- an amount of twenty-five euro (EUR 25.-) is to be allocated to the corporate capital account of the Company;
- an amount of three million nine hundred ninety-nine thousand six hundred and twenty-five euro (EUR 3,999,625.-)
is to be allocated to the share premium account of the Company.
It further results from a declaration issued on June 12th, 2008 by the Sole Partner (the ''Declaration'') that:
- based on generally accepted accounting principles, the net worth of the Claims to be contributed to the Company
is valued at three million nine hundred ninety-nine thousand six hundred and fifty euro (EUR 3,999,650.-) and since the
date of the Declaration no material changes have occurred which would have depreciated the contribution to be made
to the Company;
- the Claims to be contributed to the Company are freely transferable by the Sole Partner and they are not subject
to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value; and
- all formalities for the transfer of the legal ownership of the Claims to be contributed to the Company have been or
will be accomplished by the Sole Partner in cooperation with the Company.
It further results from a certificate issued on June 18th, 2008 by the Company (the ''Certificate'') that:
- based on generally accepted accounting principles, the net worth of the Claims to be contributed to the Company
is valued at three million nine hundred ninety-nine thousand six hundred and fifty euro (EUR 3,999,650.-) and since the
date of the Certificate no material changes have occurred which would have depreciated the contribution to be made to
the Company; and
- all formalities for the transfer of the legal ownership of the Claims to be contributed to the Company have been or
will be accomplished by the Company in cooperation with the Sole Partner.
Such Declaration and the Certificate, after signature "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Partner resolves to amend article 5, first paragraph, of the articles
of association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:
"5.1. The Company's corporate capital is fixed at twenty-five thousand and twenty-five euro (EUR 25,025.-), repre-
sented by one thousand and one (1,001) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each,
all subscribed and fully paid-up".
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be
borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
twenty-three thousand euro (EUR 23,000).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancies between the English
version and the French version, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing party, the proxyholder signed
together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
En l'an deux mille huit, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
85237
A COMPARU:
AMB Dutch Holding B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais, ayant son siège social au Zuidplein
108 Tower H-13, 1077XV Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au Registre de la Chambre du Commerce et de l'Industrie
d'Amsterdam sous le numéro 34188102,
en sa capacité d'associé unique d'AMB Le Grand Roissy 1 S. à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, im-
matriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.809, constituée le 18 avril
2006 en vertu d'un acte notarié du notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, publié le 29 juin 2006 au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations sous le numéro 1257 (la "Société"),
ici représentée par Madame Barbara MALANIUK, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à Amsterdam (NL) le 12 juin 2008.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire soussigné et le mandataire agissant pour le
compte de la partie comparante, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregis-
trement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. AMB Dutch Holding B.V., est l'associé unique ("l'Associé Unique") de la Société;
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000.-) divisé en mille (1.000)
parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.
Sur ceci, la partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première décisioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de vingt-cinq euros (EUR
25.-) aux fins de porter le capital social de la Société de son montant actuel de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000.-)
représenté par mille (1.000) parts sociales, sous forme nominative, ayant une valeur comptable de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, à un montant de vingt-cinq mille vingt-cinq euros (EUR 25.025,-) par l'émission d'une (1) nouvelle part
sociale, sous forme nominative, ayant une valeur comptable de vingt-cinq euros (EUR 25,-), ayant les mêmes caractéris-
tiques et attribuant les mêmes droits que le mille (1.000) parts sociales existantes de la Société.
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits étant exposés, l'Associé Unique, prédésigné et représenté comme ci-dessus, déclare souscrire une (1) nou-
velle part sociale de la Société, sous forme nominative et ayant une valeur comptable de vingt-cinq euros (EUR 25,-), et
la libérer entièrement par un apport en nature à la Société consistant dans les actifs suivants (les "Créances"):
1. une créance qui a été prêtée par l'Associé Unique à la Société dans le cadre de la transaction dénommée "SCI AMB
Gonesse Distribution Center 3" (la Créance 1);
2. une créance qui a été prêtée par l'Associé Unique à la Société dans le cadre de la transaction dénommée "SCI AMB
Gonesse Distribution Center 4" (la Créance 2);
3. une créance qui a été prêtée par l'Associé Unique à la Société dans le cadre de la transaction dénommée "AMB Lille
Holding 1 SAS" (la Créance 3); et
4. une créance qui a été prêtée par l'Associé Unique à la Société dans le cadre de la transaction dénommée "SCI AMB
Orléans Distribution Center 1" (la Créance 4).
L'apport en nature d'un montant total de trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent cinquante euros
(EUR 3.999.650.-) est à allouer comme suit:
- un montant de vingt-cent euros (EUR 25,-) est à allouer au compte capital social de la Société;
- un montant de trois million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent vingt-cinq euros (EUR 3.999.625.-) est à
allouer au compte prime d'émission de la Société.
De plus, il ressort d'une déclaration émise par la gérance de l'Associé Unique à la date du 12 juin 2008 (la "Déclaration")
que:
- conformément aux principes comptables généralement admis, la valeur nette des Créances devant être apportées à
la Société est estimée à trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent cinquante euros (EUR 3.999.650.-) et
depuis la date de la Déclaration il n'y a pas eu de changements matériels, qui aurait déprécié l'apport devant être fait à la
Société;
- les Créances devant être apportées à la Société sont librement cessibles par l'Associé Unique et ne sont pas soumises
à des restrictions ou grevées d'un nantissement ou d'un droit de gage limitant leur transmissibilité ou diminuant leur
valeur; et
- toutes les formalités pour le transfert de la possession des Créances devant être apportées à la Société ont été ou
seront accomplisses par l'Associé Unique en coopération avec la Société.
De plus, il ressort d'un certificat émis par la gérance de la Société à la date du 18 juin 2008 (le "Certificat") que:
85238
- conformément aux principes comptables généralement admis, la valeur nette des Créances devant être apportées à
la Société est estimée à trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent cinquante euros (EUR 3.999.650.-) et
depuis la date du Certificat il n'y a pas eu de changement matériel, qui aurait déprécié l'apport devant être fait à la Société;
et
- toutes les formalités pour le transfert de la possession des Créances devant être apportées à la Société ont été ou
seront accomplisses par la Société en coopération avec l'Associé Unique.
Ladite Déclaration et le Certificat, après signature "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
<i>Deuxième décisioni>
En conséquence de la décision ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5, premier paragraphe, des statuts
de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
"5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille vingt-cinq euros (EUR 25.025,-) représenté par mille et
une (1.001) parts sociales, sous forme nominative, ayant une valeur comptable de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées."
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant total des frais, charges, rémunérations ou dépenses, sous toute forme qu'ils soient, qui incombent à la
Société ou qui seront facturés à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à vingt-trois mille
euros (EUR 23.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence entre la version en anglais et la version en français,
la version en anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête du présent acte.
Le document ayant été lu au mandataire agissant pour le compte de la partie comparante, le mandataire a signé le
présent acte original avec le notaire.
Signé: B. Malaniuk et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juin 2008, LAC/2008/26420. — Reçu dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-
huit euros vingt-cinq cents Eur 0,50% = 19.998,25.
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008085791/5770/180.
(080098317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
S.A.F. Services Anti-Feu, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6691 Moersdorf, 4, Um Kiesel.
R.C.S. Luxembourg B 128.243.
Im Jahre zweitausendacht, den ersten Juli.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche MOUTRIER, mit Amtssitz in Esch/Alzette.
SIND ERSCHIENEN:
1.- Herr Rudi MICHELS, Kaufmann, geboren am 20. Oktober 1953 zu Prüm (D), wohnhaft in L-6691 Moersdorf, 4,
Um Kiesel.
2.- Herr Udo KOHLHAAS, Brandschutztechniker, geboren am 2. November 1963 zu Damflos (D), wohnhaft in
D-54346 Mehring, Im Weierfeld 10.
handelnd in ihrer Eigenschaft als alleiniger Anteilseigner der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "S.A.F. Services
Anti-Feu", mit Sitz in L-6947 Niederanven, 3, Zone Industrielle Bombicht, eingetragen im Handelregister Luxemburg unter
der Nummer B 128.243,
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch die amtierende Notarin, am 4. Juni 2007, veröffentlicht im Mémorial
C Nummer 1451 vom 13. Juli 2007.
Sodann ersuchten die Komparenten die amtierende Notarin, folgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von L-6947 Niederanven, 3, Zone Industrielle Bombicht nach
L-6691 Moersdorf, 4, Um Kiesel zu verlegen.
85239
<i>Zweiter Beschlussi>
Durch den vorhergehenden Beschluss, beschliessen die Gesellschafter den ersten (1.) Absatz des zweiten (2.) Artikels
der Satzung wie folgt abzuändern:
"Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Moersdorf (Gemeinde Mompach)."
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde entstehen, gehen zu Lasten der Gesellschaft.
WORÜBER PROTOKOLL, aufgenommen in Esch/Alzette, in der Amtsstube der amtierenden Notarin, Datum wie
Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: R. Michels, U. Kohlhaas, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 2 JUILLET 2008. Relation: EAC/2008/8797. — Reçu douze euros 12,- €.
<i>Le Receveuri>
(signé): A. Santioni.
POUR COPIE CONFORME, délivréea aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 7 juillet 2008.
BLANCHE MOUTRIER.
Référence de publication: 2008085826/272/38.
(080098390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Stone Leaf Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.
R.C.S. Luxembourg B 139.724.
STATUTES
In the year two thousand eight, on the seventeenth of June
Before us Maître Anja HOLTZ, notary residing in Wiltz (Luxembourg),
There appeared
1. Mister Joël René Gaston REBUFFAT, born to Paris (France), on the 05 of February 1952, residing to CH-1287
Laconnex, 10, rue de la Maison Forte
2. Madam Edith Messaouda Haïa BELLAICHE marry DANAN, born to Beja (Tunisia), on the 04 of May 1946, residing
to residing in 28, rue de la Fontarabie, F-75020 Paris 20
e
.
The appearing party, acting in the here above stated capacities, has drawn up the following articles of a public limited
liability Company which she intends to organize.
Name - registered office - duration - object - capital
Art. 1. The above-mentioned person and all those that might become owners of the shares created hereafter, herewith
forms a limited Company (société anonyme) under the name of STONE LEAF HOLDING S.A., which shall be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on
commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter
the «Articles»).
Art. 2. The registered office is established in the municipality of Winseler / Doncols.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a
resolution of the board of directors.
It may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary
general meeting of the shareholders.
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a resolution of the board of directors.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg Company.
The board of directors shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a resolution of the board of directors.
Art. 3. The Company is established for an unlimited period.
85240
Art. 4. The Company's object is to acquire and hold interests in any form whatsoever, in any other Luxembourg or
foreign, commercial, industrial or financial entities, by way of, among others, the subscription or acquisition of any se-
curities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other
way, or financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of
interests.
The Company may in particular enter into the following transactions:
- borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited
to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other equity instruments or debt instruments, convertible
or not into shares of the Company, the use of financial derivatives or otherwise;
- advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect
interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company
belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies" and each as a
"Connected Company") through, including but not limited to, the subscription to bonds, notes, certificates and other
equity instruments or debt instruments, convertible or not into shares of any Connected Company.
For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same "group" as the Company if such other
company directly or indirectly owns, is owned by, is in control of, is controlled by, or is under common control with, or
is controlled by a shareholder of, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary.
A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all
or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management
or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.
- enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods,
for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any
director, director or other agent of the Company or any of the Connected Companies, and to render any assistance to
the Connected Companies, within the limits of the laws of Luxembourg; and
- enter into any agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, marketing
agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other services contracts,
selling agreements, connected directly or indirectly to the areas described above;
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions and,
in general, all transactions which are necessary or useful to fulfill its corporate object as well as all transactions directly
or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object
in all areas described above.
Art. 5. The share capital of the Company is fixed at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (EUR 31,000.-) divided into
hundred (100.-) shares with a par value of three hundred and ten (310) euro each:
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by
law.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
Bonds, notes and other debt instruments
Art. 6. The Company may issue bonds, notes or other debt instruments convertible or not, under registered or bearer
form. Bonds, notes or other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted into bearer
form.
Board of directors and statutory auditors
Art. 7. The Company is managed by a board of directors of not less than three members, shareholders or not, who
are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed
at any time by the general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally fill the vacancy by electing a Director by majority vote. In this case, the next general meeting will proceed
to the final election.
If the company is owned by a single shareholder the board of directors may be replaced by a single managing director.
Art. 8. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any director.
The board of directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented by
proxies. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing another director as his
85241
proxy. A director may also appoint another director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later
stage.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating director
being able to hear and to be heard by all other participating directors using this technology shall be deemed to be present
and shall be authorized to vote by video or by telephone.
Circular resolutions of the board of directors can be validly taken if approved in writing and signed by all of them in
person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions shall
have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings, duly convened.
Votes may also be cast by fax, e-mail or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.
Art. 9. All decisions by the board of directors require a simple majority of votes cast. In case of an equality of votes,
the chairman has a casting vote.
Art. 10. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 11. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the Law or by the
present Articles, fall within the competence of the board of directors.
Art. 12. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons who need not be shareholders of the Company. The delegation of the day-to-day
management to a member of the board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.
The board of directors may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be a Director,
appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
If a single managing director is appointed he is vested with the broadest powers to perform all acts of administration
and disposition in the Company's interest.
Art. 13. Towards third parties, the Company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any
two directors or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two
directors of the Company.
If a single managing director is appointed the Company is in all circumstances committed by his signature.
Art. 14. The Company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by
the general meeting, which determines their number and their remuneration.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years.
General meeting
Art. 15. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry
out or ratify acts relating to the Company.
If the company is owned by a single shareholder he has the most extensive powers to carry out or ratify acts relating
to the Company.
Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder in compliance
with the Law. In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed
of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.
Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of share-
holders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.
An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless
at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the
first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or
by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting.
The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings,
resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the shareholders present or represented.
However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased
only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Art. 16. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the
convening notice on the 1st Friday of the month of June at 5 p.m.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
85242
Art. 17. The board of directors, the auditor(s) or the single managing director may convene a general meeting of the
shareholders. It must be convened at the written request of shareholders representing twenty percent of the Company's
share capital.
Art. 18. Each share entitles to the casting of one vote. The Company will recognize only one holder for each share.
A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of shareholders, by appointing another
person as his proxy in writing.
Business year - distribution of profits
Art. 19. The business year begins on the 1st of January and ends on the 31st December of each year.
The board of directors or the single managing director draw up the annual accounts according to the legal requirements.
They submit these documents with a report of the Company's activities to the statutory auditor(s) at least one month
before the statutory general meeting.
Art. 20. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such
contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
Dissolution - liquidation
Art. 21. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the articles of incorporation.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations
<i>Transitory dispositionsi>
1) The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on the 31st of December 2008.
2) The first annual general meeting shall be held in 2009.
<i>Subscription and paymenti>
The shares all have been subscribed to by:
- Mister REBUFFART, fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
- Madam BELLAICHE, fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
TOTALITY, hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of
THIRTY-ONE THOUSAND EURO (EUR 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the Law have been fulfilled and
expressly bears witness to their fulfillment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the Company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two
thousand Euro (EUR 2,000.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named partie, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and passed the following reso-
lutions:
<i>First resolutioni>
1. -The number of directors is fixed at three. The following has been elected as directors for duration ending at the
annual general meeting of 2014:
1. Mister Joël René Gaston REBUFFAT, born to Paris (France), on the 05 of February 1952, residing to CH-1287
Laconnex, 10, rue de la Maison Forte
2. Madam Edith Messaouda Haïa BELLAICHE marry DANAN, born to Beja (Tunisia), on the 04 of May 1946, residing
to residing in 28, rue de la Fontarabie, F-75020 Paris 20
e
.
3. Mister Philippe HOGE, born to Waremme (Belgium), on the 09 August 1961, residing in Doncols, 14, Chemin des
Douaniers.
<i>Second resolutioni>
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2014.
85243
COMPTAPHI S. A., limited company having its registered office in L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers, reg-
istered in the Luxembourg's trade register under the number B 115.282.
<i>Third resolutioni>
The company's registered office is located at L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers
<i>Fourth resolutioni>
The board of directors is authorized to delegate the daily management to one or several of its members.
<i>Meeting of the board of directorsi>
There appeared the board of directors of the company „STONE LEAF HOLDING SA"
a) Mister Joël René Gaston REBUFFAT prenamed
b) Miss Edith, Messaouda, Haia BELLAICHE, prenamed
c) Mister Philippe HOGE prenamed
They appoint chairmen Mr Joël René Gaston REBUFFAT, Mr Philippe HOGE and Miss Edith, Messaouda, Haia BEL-
LAICHE.
Both chairmen represent the company in all circumstances by their joint signatures.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Wiltz, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,
surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le
Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz (Luxembourg),
a comparu:
1. Monsieur Joël René Gaston REBUFFAT, né à Paris (France), le 05 février 1952, demeurant à CH- 1287 Laconnex,
10, rue de la Maison Forte
2. Madame Edith Messaouda Haïa BELLAICHE épouse DANAN, née à Beja (Tunisie), le 04 mai 1946, demeurant à 28,
rue de la Fontarabie, F-75020 Paris 20
e
.
Le comparant, ès-qualités qu'il agit, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils va constituer.
Dénomination - siège - durée - objet - capital
Art. 1
er
. La personne ci-avant désignée et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions ci-
après créées, forment une société anonyme sous la dénomination de STONE LEAF HOLDING S.A. qui sera régie par
les lois se rapportant à une telle société (dénommée ci-après la «Société») et en particulier la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifié (dénommée ci-après la «Loi»), ainsi que les présents statuts de
constitution (dénommés ci-après «Statuts»).
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Winseler.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. L'objet de la Société est d'acquérir et de détenir tous intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
autres entités luxembourgeoises ou étrangères, commerciales, industrielles ou financières, notamment par voie de sou-
85244
scription ou d'acquisition de toute valeur mobilière ou de droits au travers de participation, d'apport, de prise ferme ou
d'option, de négociation ou de toute autre manière, ou d'instruments financiers de dette, sous quelque forme que ce soit,
ainsi que d'administrer, de développer et de gérer ces intérêts.
La Société pourra notamment conclure les transactions suivantes:
- emprunter sous toute forme ou obtenir toutes formes de crédit et lever des fonds, notamment, par l'émission
d'obligations, de titres de dettes (notes), de billets à ordre (promissory notes), certificats (certificates) et autres instru-
ments de dette ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou accorder des crédits à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un
intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit nécessairement substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires,
directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après
reprises comme les «Sociétés Apparentées», chacune une «Société Apparentée»
- Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société
si cette autre société, d'une manière directe ou indirecte, détient, est détenue par, contrôle, est contrôlé par ou est sous
le contrôle commun avec, ou est contrôlée par un associé ou un actionnaire de, la Société, que ce soit comme bénéficiaire
ou trustée, gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient,
directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle du capital social de la société ou dispose du pouvoir de
diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres
permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou par tout autre moyen.
- accorder toutes garanties, mettre en gage ou fournir toutes autres formes de sûretés, que ce soit par engagement
personnel ou par hypothèque ou charge (charge) sur tout ou partie des actifs (présents ou futurs) de l'entreprise, ou par
l'une ou l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de toute Société
Apparentée, ou de tout administrateur, gérant ou autre mandataire de la Société ou de toute Société Apparentée, et
apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites de la loi luxembourgeoise; et
- conclure tous contrats, et notamment, des contrats d'association, des contrats de souscription, des accords de
distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration et autres contrats de services,
des contrats de vente, en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus;
étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités
pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.
Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et,
en général, toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) représenté par cent (100.-) actions
d'une valeur nominale de trois cent dix (310) euros chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire sous réserve de restriction prévue par le loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Obligations billets et autres instruments de crédit
Art. 6. La société peut émettre des obligations, billets ou toute autres instruments de crédit convertible ou pas, sous
forme nominative ou au porteur. Les obligations, les billets et tout autre instrument sous forme nominative ne seront
pas échangés ou convertis en titre au porteur.
Administration - surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restant ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement en élisant un administrateur par vote majoritaire. Dans ce cas, l'as-
semblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.
Si la société est constitué par un seul actionnaire, un administrateur unique peut être nommé.
Art. 8. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou d'un des administrateurs.
Le conseil d'administration ne pourra valablement se réunir et prendre des décisions que si la majorité de ses membre
sont présent ou représentée par procuration.
Tout directeur pourra agir à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit un autre directeur comme
son représentant. Un directeur pourra également désigner un autre directeur pour le représenter par téléphone, cela
sera confirmé par écrit par la suite.
Le recours à la vidéoconférence et à la conférence call est permis à condition que tous les directeurs participant soient
en mesure d'entendre et d'être entendus par tous les autres directeurs participant utilisant cette technologie, qu'ils soit
présent ou autorisés à voter par vidéo ou par téléphone.
85245
Les circulaires résolutions du conseil d'administration pourront être valablement prises à condition qu'elles soient
approuvées par écrit et signées par chacun d'eux. Tel accord pourra être envoyé en un ou en plusieurs documents séparés
par fax ou par courriel. Telle résolution aura le même effet que les résolutions votées en assemblée des administrateurs,
dûment convoquée.
Les votes pourront être pris par fax, par courriel ou par téléphone, les votes ainsi obtenus seront confirmés par écrits.
Art. 9. Toutes décisions du conseil d'administration requièrent la majorité simple des votes exprimés. En cas de partage,
la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 10. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration
et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs
ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.
Art. 12. Le conseil d'administration peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes,
qui ne doivent pas nécessaire-ment être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés et fixer leurs
émoluments.
Si la société est administrée par un administrateur unique ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour
faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.
Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-
nistrateurs ou par la signature individuelle de toute personne à qui tel pouvoir de signature pourra être conféré par deux
administrateurs de la Société.
L'administrateur unique engage valablement la société par sa seule signature.
Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 15. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales.
Si la société est constituée par un seul actionnaire ce dernier exerce les pouvoirs de l'assemblée générale.
Tout assemblée générale sera convoquée au moyen d'une convocation écrite envoyé à tous les actionnaires figurant
au registre conformément à la Loi. Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils confirme
avoir été informé de l'agenda de la réunion, ils pourront renoncer à toutes les exigences de convocation et formalités de
publication.
A moins que la loi et les statut n'en disposent autrement, toutes décisions prises en assemblée générale annuel et
ordinaire des actionnaires pourront être prises à la majorité simples des votes, sans qu'il soit tenu compte de la proportion
du capital représenté.
Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour amender les article des Statuts ne pourra valablement déli-
bérée à moins qu'une moitié au moins du capital ne soit représentée et que l'agenda n'indique les amendements proposés
aux Statuts. Si la première de ces conditions n'est pas satisfaite, une seconde assemblée sera convoquée, conformément
à ce que les Statuts ou la loi prévoit. Une telle convocation reproduira l'agenda et indiquera la date et les résultats de
l'assemblée précédente. La seconde assemblée délibérera valablement sans tenir compte de la proportion du capital
représentée. A ces deux réunions, des résolutions, pour être adoptées, devront être adoptée par une majorité de deux
tiers des actionnaires présents ou représentés.
Cependant, la nationalité de la Société ne pourra être changée et les engagements des actionnaires ne pourront être
augmentés qu'avec le consentement unanime de tout les actionnaires et dans le respect de toutes autres prescriptions
légales.
Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le premier vendredi du mois de juin à 17.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration, l'administrateur
unique ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cin-
quième du capital social.
85246
Art. 18. Chaque action donne droit à une voix. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Un actionnaire
pourra agir à toute assemblée générale, même lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, en désignant une
autre personne par écrit en qualité de représentant.-
Année sociale - répartition des bénéfices
Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établissent les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Ils remettent ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 20. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
Dissolution - liquidation
Art. 21. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2008.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites par
- Monsieur REBUFFART, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
- Madame BELLAICHE, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
TOTAL, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de TRENTE ET UN
MILLE EUROS (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille Euros (2.000.-
€).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant la comparante, ès-qualités qu'elle agit, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire à laquelle
elle se reconnaît dûment convoquée et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, a, à l'unanimité
des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Est appelé aux fonctions d'administrateur, le mandat expirant à l'assemblée générale annuelle de 2014:
1. Monsieur Joël René Gaston REBUFFAT, demeurant à CH-Laconnex, 10, rue de la Maison Forte
2. Madame Edith Messaouda Haïa BELLAICHE épouse DANAN, demeurant à 28, rue de la Fontarabie, F-75020 Paris
20
e
.
3. Monsieur Philippe HOGE, né à Waremme (Belgium), le 09 août 1961, demeurant à 14, Chemin des Douaniers,
Doncols.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale annuelle de 2014.
La société COMPTAPHI S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 115.282.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.
85247
<i>Quatrième résolutioni>
Le Conseil d'Administration est autorisé à déléguer la gestion des affaires journalières de la société à un ou plusieurs
de ses membres.
<i>Réunion du conseil d'administrationi>
Se sont réunis les membres du conseil d'administration de la société «STONE LEAF HOLDING»
1. Monsieur Joël René Gaston REBUFFAT
2. Mlle Edith Messaouda Haia BELLAICHE
3. Monsieur Philippe HOGE prenamed
Lesquels nomment les prénommés M. Joël René Gaston REBUFFAT de Président, M. Philippe HOGE et Mlle Edith,
Messaouda, Haia BELLAICHE tous trois administrateurs délégués.
Deux administrateurs délégués représentent la compagnie dans toutes les circonstances par leurs signatures commu-
nes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états
et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Rebuffat, Bellaiche, Hoge, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 18 juin 2008. Relation: WIL/2008/556. — Reçu cent cinquante-cinq euros 31000*0,5= 155 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Pletschette.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 24 juin 2008.
Anja HOLTZ.
Référence de publication: 2008085869/2724/438.
(080098160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
European Opticians S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 114.902.
Dépôt des comptes annuels au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Halsey Group S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2008085932/6762/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02329. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Luxlait-Expansion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1311 Luxembourg, 27, boulevard Marcel Cahen.
R.C.S. Luxembourg B 33.959.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008085685/1510/13.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2008, réf. LSO-CS00073. - Reçu 50,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
85248
AMB Le Grand Roissy Holding 1 S.à r.l.
AMB Le Grand Roissy Holding 2 S.à r.l.
Ateliers VVYNGLA S.A.
Audit-Gestion-Management Luxembourg
Bifico S.A.
Boutique Pour Elle
Business Contact Holding S.A.
Cebeus Holding SA
CIL-Centuria Invest Luxembourg S.A.
Cliveden S.A.
Colombage S.A.
Dal Financière S.A.
Dal Financière S.A.
Downington Holding
Eclaircie s.à.r.l.
Electrofin S.A.H.
Euroliberty-Lease S.A.
European Consent AG
European Opticians S.àr.l.
Famper S.A.
Felix.Joe.Resto S.à.r.l.
Financière d'Ancône
FinForce
Forchim S.A.H.
Fortis L Fund
Glancia S.A.
Grandica du Luxembourg S.A.
GVP Immobilier
Hama Holding S.A.
High Pressure Investments S.A.
I C T C S.A.
IFE II Capital
IFE II Gestion
International Finance Development Company
Kipling Luxembourg S.àr.l.
L'Amphitryon Sàrl
La Racchetta S.à r.l.
Le Fou du Roi Sàrl
LEICo (Luxembourg-England Investment Company)
Luxlait-Expansion S.A.
Maecolux S.A.
M. Pletschette S.à r.l.
Ostonian Enterprises S.A.
Patrilux S.A.
Performance Partner S.à r.l.
Promo Bous S.à r.l.
Rosneft Capital S.A.
Royal Eight Ball S.à r.l.
S.A.F. Services Anti-Feu
Sal. Oppenheim Special Situations S.A.
Samart S.A.
Seals Finance S.A.
Segepi Lux
Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care III S.à r.l.
Société Générale de Consultance S.A.
StaGe Mezzanine Société en Commandite Simple
Stone Leaf Holding S.A.
Sunshine S. à r.l.
Technical Supply Company
Tipi S.A.
Troisième
T.W. Logistics S.A.
Van Der Beek I.T. S.à r.l.
Webfinance S.A.