This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1773
18 juillet 2008
SOMMAIRE
Aberdeen Property Funds SICAV . . . . . . .
85081
Aberdeen Property Funds SICAV-FIS . . . .
85081
ADT Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85072
AKT Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
85060
AMB Le Havre Holding S.à r.l. . . . . . . . . . .
85086
Atelier Pia Mai GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85095
Belron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85062
BERGER TRUST Luxembourg HOLDING
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85092
CEREP Pic Place S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
85097
CEREP Vivienne S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
85065
City's S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85068
DREYER RUPPERT REAL ESTATE S.A.
Development & Investment . . . . . . . . . . . .
85094
Epicea Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85064
EPI Highgate GP 2 S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
85063
EPI Highgate GP 3 S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
85063
EPI Highgate GP 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
85062
Equity Trust (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . .
85065
E.S.T.I.M. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85059
Ets Jos Mosar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85066
Euro-Gate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85070
Euronav Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
85070
Europ Continents Holding . . . . . . . . . . . . . .
85104
Europ Continents Holding . . . . . . . . . . . . . .
85074
Everest Investors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85104
Evolia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85058
Excell Life International S.A. . . . . . . . . . . . .
85069
FINAGEL S.A., société de gestion de patri-
moine familial (SPF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85072
Fortis L FoF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85061
Fundtrust Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
85092
Gia Abanico S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85062
Goodyear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85060
Goodyear Luxembourg Tires S.A. . . . . . . .
85060
Haas & Knaf, Succ. Jos Mosar . . . . . . . . . . . .
85066
Interflog S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85089
Investment 2000 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85061
Invista European Real Estate Finance S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85065
Just Move S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85069
Kamps Food Retail Investments S.A. . . . . .
85068
Karma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85058
Laudamar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85066
Locent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85064
Lux - Beauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85058
Maison Josy Juckem S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
85073
Mascagna Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
85071
Metros Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85091
MGP Asia (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
85068
Mitte Holdings Management S.A. . . . . . . . .
85073
Mitte Holdings Management S.C.A. . . . . . .
85073
NovEnergia 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85063
Peinture Schultze Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85067
Primera Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85061
Prologis Management Services S.à r.l. . . . .
85101
Richnou S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85059
Rocca Investments Holding S.A. . . . . . . . . .
85067
Rovi-Tech Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85068
Royalino Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
85058
Sachamadra Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
85064
S.M.M. spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85080
Sumbiosis CS S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85059
Trema Architecture Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
85059
UBI Banca International S.A. . . . . . . . . . . . .
85074
UBS (Lux) Institutional Sicav II . . . . . . . . . .
85069
Universal Wireless S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
85060
Vellemans-Vellemans-Nys-Timmermans
Société en nom collectif . . . . . . . . . . . . . . .
85085
Vodafone Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
85099
Walser Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85069
Y.E SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85071
85057
Karma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 73.101.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>KARMA S.A.
i>Pour Services Généraux de Gestion S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008081158/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2008, réf. LSO-CR08814. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080092332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2008.
Royalino Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 100.387.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2008.
CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.
P.O. Box 156, LU-2011 LUXEMBOURG, 60, Grand-Rue / Niveau 2
<i>International Tax Planners
i>Signature
Référence de publication: 2008082491/816/16.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2008, réf. LSO-CR09857. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080093872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2008.
Lux - Beauté, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 70, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 7.654.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008085318/3221/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02572. - Reçu 93,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Evolia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 234, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 99.082.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25/06/08.
Signature.
Référence de publication: 2008085300/1969/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2008, réf. LSO-CS00285. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
85058
Sumbiosis CS S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9706 Clervaux, 2A/13, route d'Eselborn.
R.C.S. Luxembourg B 128.092.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7/07/08.
Pour VO Consulting Lux S.A.
Signature
Référence de publication: 2008085297/1427/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02043. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080097954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Richnou S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 41.968.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7/07/08.
Pour VO Consulting Lux S.A.
Signature
Référence de publication: 2008085298/1427/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02054. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Trema Architecture Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4818 Rodange, 8, avenue du Docteur Gaasch.
R.C.S. Luxembourg B 118.354.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7/07/08.
Pour VO Consulting Lux S.A.
Signature
Référence de publication: 2008085296/1427/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02045. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
E.S.T.I.M. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 117.928.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25/06/08.
Signature.
Référence de publication: 2008085301/1969/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2008, réf. LSO-CS00284. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
85059
Universal Wireless S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 80.647.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7/07/08.
Pour VO Consulting Lux S.A.
Signature
Référence de publication: 2008085294/1427/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02051. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080097963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Goodyear, Société Anonyme.
Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.
R.C.S. Luxembourg B 4.441.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 26 juin 2008.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2008085293/2258/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01813. - Reçu 50,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Goodyear Luxembourg Tires S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.
R.C.S. Luxembourg B 71.219.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 26 juin 2008.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2008085292/2258/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01810. - Reçu 46,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
AKT Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 138.485.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 52179 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Joseph ELVINGER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008085348/211/12.
(080097087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
85060
Fortis L FoF, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 63.266.
Le bilan au 31/12/2007 ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS L FOF
i>Fortis Investment Management Luxembourg S.A.
Didier LAMBERT
Référence de publication: 2008085286/755/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01638. - Reçu 46,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080097376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Primera Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 107.878.
Le bilan au 31/12/2007 ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PRIMERA FUND
i>Fortis Investment Management Luxembourg S.A.
Nathalie Moroni
Référence de publication: 2008085287/755/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01667. - Reçu 50,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Investment 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 73.502.
Par décision du Conseil d'Administration tenu le 12 juin 2008 à 11.00 heures au siège social de la société, il a été
décidé:
- D'accepter, avec effet immédiat, la démission de:
Monsieur Stefano CICCARELLO, né le 16 septembre 1966 à Rome en Italie, résident professionnellement au 19/21,
boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg de sa fonction d'administrateur.
- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat
Madame Manuela D'AMORE, employée privée, née le 4 mars 1972 à Rome en Italie, résident professionnellement au
19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant comme échéance celui de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>INVESTMENT 2000 S.A., Société Anonyme
i>Signatures
Référence de publication: 2008086081/24/20.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01742. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
85061
Gia Abanico S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4807 Rodange, 118, rue Nicolas Biever.
R.C.S. Luxembourg B 63.635.
La convention de cession de parts sociales conclue en date du 15 février 2008 entre la société ALA SA et la société
LOR SECURITY S.à r.l. n'ayant pas du être publiée, celle-ci contenant des clauses suspensives au transfert de propriété,
la société ALA S.A. reste propriétaire de la totalité des parts sociales de la société GIA ABANICO S.à r.l., conformément
aux articles 4 et 6 de la Convention de cession de parts sociales du 15 février 2008 et à l'article 3 du Protocole d'Accord
du 15 février 2008.
Luxembourg, le 17 juin 2008.
ALA S.A.
24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg
<i>Associé unique
i>Signature
Référence de publication: 2008086086/1429/20.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR09638. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080098212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Belron S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 71.639.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2008i>
<i>Conseil d'Administrationi>
L'assemblée générale ordinaire a décidé de nommer comme nouvel administrateur de la société avec effet au 29 avril
2008 et ce pour une durée de 3 ans, son mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale de 2011, Monsieur
Maurice PERIER, demeurant à 4, avenue de l'Ecuyer, B-1640 Rhode-Saint-Genèse en remplacement de M. Gilbert Van
Marcke de Lummen, démissionnaire.
Pour extrait conforme
Fons MANGEN
Référence de publication: 2008086079/750/17.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02233. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
EPI Highgate GP 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 121.977.
<i>Extrait de réquisitioni>
L'Associé unique de la Société a changé sa dénomination en EPI Highgate S. àr.l. (anciennement EPI Office 1 S.à r.l.)
par acte notarié en date du 21 mars 2007.
Ainsi fait à Luxembourg, le 13 juin 2008.
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008086087/6902/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02524. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
85062
EPI Highgate GP 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 171.225,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 121.743.
<i>Extrait de réquisitioni>
L'Associé unique de la Société a changé sa dénomination en EPI Highgate S.à r.l. (anciennement EPI Office 1 S.à r.l.)
par acte notarié en date du 21 mars 2007.
Ainsi fait à Luxembourg, le 13 juin 2008.
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008086090/6902/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02491. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080098875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
EPI Highgate GP 3 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 200.150,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 121.742.
<i>Extrait de réquisitioni>
L'Associé unique de la Société a changé sa dénomination en EPI Highgate S.à r.l. (anciennement EPI Office 1 S.à r.l.)
par acte notarié en date du 21 mars 2007.
Ainsi fait à Luxembourg, le 13 juin 2008.
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008086092/6902/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02457. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
NovEnergia 2010, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 82.277.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 2008i>
En date du 11 juin 2008, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler le mandat de Monsieur Carlos Alberto Martins Pimenta en qualité d'Administrateur et de Président
pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2008
- de renouveler les mandats de Monsieur Alvaro Martins Monteiro, Monsieur Armando Manuel De Carvalho Nunes,
de Monsieur Henri Baguenier et de Monsieur Rui Fernando Da Silva Penaforte Pedroso en qualité d'Administrateurs pour
une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2008
Luxembourg, le 12 juin 2008.
Pour extrait sincère et conforme
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signatures
Référence de publication: 2008086094/1024/20.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2008, réf. LSO-CR08661. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
85063
Epicea Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 74.137.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue en date du 11 juin 2008 a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Roeland P. Pels, en tant qu'Administrateur de la société, est acceptée avec effet immédiat.
- Monsieur Frank Walenta, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg, est élu nouvel
Administrateur de la société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2010.
Luxembourg, le 11 juin 2008.
Pour extrait conforme
Roeland P. Pels
Référence de publication: 2008086110/724/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02514. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080098738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Sachamadra Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 103.199.
Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 juin 2008, Mme Catherine BARRA-
QUAND-LEGRAND, 12, chemin des Tuilières, CH-1248 Hermance, a été nommée Administrateur B et KOFFOUR S.A.,
société anonyme 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Administrateur A. Les mandats des nouveaux
Administrateurs viendront à échéance avec ceux de leurs collègues à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2011.
De ce fait, le nombre des administrateurs a été augmenté à cinq (5).
Luxembourg, le 27 JUIN 2008.
<i>Pour SACHAMADRA INVEST S.A., société anonyme
i>Experta Luxembourg, société anonyme
Catherine Day-Royemans / Mireille Wagner
<i>Vice-Présidenti>
Référence de publication: 2008086103/1017/19.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01750. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Locent, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 82.640.
Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Marthe THYES-WALCH, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 20 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 1217 du 22
décembre 2001.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2008.
LOCENT, Société à responsabilité limitée
Signature
Référence de publication: 2008085463/546/18.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS01923. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
85064
Invista European Real Estate Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 108.462.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 14 avril 2008i>
L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de:
* Monsieur Robert Kimmels, résidant professionnellement au 8, avenue Hoche, 75008 Paris, France, en tant que gérant
de la Société avec effet immédiat;
- De nommer:
* Madame Patricia Schon, résidant professionnellement au 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg, en tant que Gérante
de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.
- De renommer:
* Monsieur Michael Chidiac, résidant professionnellement au 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en tant que
Gérant de la Société avec effet rétroactif au 11 octobre 2007 pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2008.
Par Michael Chidiac / Par Patricia Schon
<i>Gérant / Gérantei>
Référence de publication: 2008084967/710/25.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2008, réf. LSO-CR08930. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
CEREP Vivienne S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 102.536.
Les comptes annuels pour la période du 1
er
janvier 2007 au 30 juin 2007 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008085273/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS01032. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Equity Trust (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 93.421.
Le bilan et l'affectation des résultats au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
i>Deirdre McCabe
<i>Risk Manager & Compliance Officeri>
Référence de publication: 2008085779/6838/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03326. - Reçu 111,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
85065
Laudamar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 101.354.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2008085744/279/13.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01478. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080097631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Ets Jos Mosar S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Haas & Knaf, Succ. Jos Mosar).
Siège social: L-2560 Luxembourg, 118, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 39.910.
Im Jahre zweitausendacht, den achtundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitze zu Niederanven,
Ist erschienen:
Herr Joseph MOSAR, Geschäftsführer, wohnhaft in D-66706 Besch, Erwin-Therre-Strasse 9 (Deutschland).
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersucht, Folgendes zu beurkunden:
Herr Joseph MOSAR, vorbenannt, ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HAAS &
KNAF, SUCC. Jos. Mosar, S.à r.l., mit Sitz in L-2560 Luxemburg, 118, rue de Strasbourg, eingetragen im Handelsregister
zu Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 39.910, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar
Jacques DELVAUX, vormals mit dem Amtssitz in Esch-sur-Alzette, am 17. März 1992, veröffentlicht im Mémorial C
Nummer 381 vom 4. September 1992. Die Statuten wurden letztmalig abgeändert durch Urkunde des unterzeichnenden
Notars vom 6. November 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1316 vom 10. Dezember 2003.
In seiner Eigenschaft als einziger Gesellschafter erklärt Herr Joseph MOSAR, vorbenannt, dem instrumentierenden
Notar, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden mit folgender Tagesordnung:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft in "Ets Jos Mosar S.à r.l.".
2.- Abänderung von Artikel 5 der Satzung.
Gemäss der Tagesordnung hat der Komparent folgende Beschlüsse gefasst.
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft von "HAAS & KNAF, SUCC. Jos. Mosar, S.à
r.l." in "Ets Jos Mosar S.à r.l." abzuändern.
<i>Zweiter und letzter Beschlussi>
Infolgedessen beschliesst der alleinige Gesellschafter Artikel 5 der Satzung wie folgt umzuändern:
" Art. 5. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung ‚Ets Jos Mosar S.à r.l.'."
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf achthundert Euro (EUR
800,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Komparenten, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: Joseph Mosar, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 2 juin 2008. LAC / 2008 / 22047. — Reçu € 12.- (douze euros).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Franck Schneider.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 3. Juli 2008.
Paul BETTINGEN.
Référence de publication: 2008085804/202/41.
(080098121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
85066
Rocca Investments Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 88.354.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Jean Wagener
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2008085741/279/13.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01502. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080097632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Peinture Schultze Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6871 Wecker, 2, Op Huefdreisch.
R.C.S. Luxembourg B 106.855.
Im Jahre zweitausendacht, den einundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtswohnsitz in Remich, handelnd in Vertretung seines verhin-
derten Kollegen, Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitz zu Niederanven.
Ist erschienen:
Herr Michael SCHULTZE, Dipl. Betriebswirt und Malermeister, geboren in Bernkastel-Kues (Deutschland), am 5. Juli
1974, wohnhaft in D-54470 Bernkastel-Kues, Siemensstrasse 2 (Deutschland).
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersucht, Folgendes zu beurkunden:
Herr Michael SCHULTZE, vorbenannt, ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
PEINTURE SCHULTZE, S.à r.l., mit Sitz in L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activités Syrdall, eingetragen im Handelsregister
zu Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 106.855, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den vorge-
nannten Notar Paul BETTINGEN am 8. März 2005, veröffentlicht im Memorial C Nummer 725 vom 21. Juli 2005.
In seiner Eigenschaft als einziger Gesellschafter erklärt Herr Michael SCHULTZE, vorbenannt, dem instrumentierenden
Notar, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden mit folgender Tagesordnung:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activités Syrdall, nach L-6871 Wecker, 2, Op
Huefdreisch.
2.- Abänderung von Artikel 2, Absatz 1, der Satzung.
Gemäss der Tagesordnung hat der Komparent folgende Beschlüsse gefasst.
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activités Syrdall, nach
L-6871 Wecker, 2, Op Huefdreisch, zu verlegen.
<i>Zweiter und letzter Beschlussi>
Infolgedessen beschliesst die Generalversammlung Artikel 2, Absatz 1, der Satzung wie folgt umzuändern:
" Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Biwer."
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf eintausend Euro (EUR
1.000,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Komparenten, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: Schultze, Patrick Serres.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 3 mars 2008. LAC / 2008 / 9179. - Reçu 12€.- (douze euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 3. Juli 2008.
Paul BETTINGEN.
Référence de publication: 2008085811/202/41.
(080098246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
85067
Kamps Food Retail Investments S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 500.000,00.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 110.174.
<i>Extrait des résolutions du Gérant Unique du 17 juin 2008i>
Il résulte de la résolution prise par le Gérant Unique de la Société le 17 juin 2008 que le siège social de la Société a
été transféré de son adresse actuelle 15, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg au 16, rue Jean-Pierre Brasseur,
L-1258 Luxembourg.
Signature
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2008081310/1459/16.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2008, réf. LSO-CR09732. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080092264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2008.
MGP Asia (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 107.241.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MGP Asia (Lux) S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2008083245/3648/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR09176. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2008.
City's S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8015 Strassen, 38, rue des Carrefours.
R.C.S. Luxembourg B 124.677.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 02 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008083246/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR09309. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2008.
Rovi-Tech Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.
R.C.S. Luxembourg B 88.508.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 02 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008083247/780/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR09302. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2008.
85068
Excell Life International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 74.132.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 30/06/08.
Signature.
Référence de publication: 2008083248/1102/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR11065. - Reçu 46,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080095211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2008.
Just Move S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 71, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 47.809.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008083249/9155/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00967. - Reçu 91,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2008.
UBS (Lux) Institutional Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 115.356.
Le bilan au 31 janvier 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2008.
<i>Pour UBS (Lux) Institutional Sicav II
i>UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Oliver Schütz / Michaela Imwinkelried
<i>Associate Director / Executive Directori>
Référence de publication: 2008083250/1360/16.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06927. - Reçu 78,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2008.
Walser Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.
R.C.S. Luxembourg B 79.320.
Le bilan au 30. Avril 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 Juillet 2008.
<i>WALSER PORTFOLIO
i>Signatures
Référence de publication: 2008085310/705/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01874. - Reçu 98,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
85069
Euro-Gate, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 92.300.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2008i>
En date du 27 juin 2008, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d'accepter la démission, avec effet au 20 décembre 2007, de Monsieur Bernard Lozé, en qualité de Président et
d'Administrateur
- de ratifier la cooptation, avec effet au 20 décembre 2007, de Monsieur Paul Henrion en qualité de Président et
d'Administrateur, en remplacement de Monsieur Bernard Lozé, démissionnaire
- d'accepter la démission, avec effet au 20 décembre 2007, de Monsieur Pierre Rochon en qualité d'Administrateur
- de ratifier la cooptation, avec effet au 20 décembre 2007, de Monsieur Marco Caldana en qualité d'Administrateur,
en remplacement de Monsieur Pierre Rochon, démissionnaire
- de renouveler le mandat de Monsieur Paul Henrion en qualité de Président et Administrateur pour une durée d'un
an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009
- de renouveler les mandats de Monsieur Marco Caldana, de Maître Pierre Delandmeter, de Monsieur Antoine Gilson
de Rouvreux et de Monsieur Vincent Marc en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2009
- de ne pas renouveler le mandat d'Ernst & Young en qualité de Réviseur d'Entreprise
- de nommer Deloitte SA, 560, rue du Neudorf, L-2220 Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprise pour une
durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009, en remplacement d'Ernst & Young.
Luxembourg, le 30 juin 2008.
Pour extrait sincère et conforme
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature
Référence de publication: 2008085015/1024/30.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS01979. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Euronav Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 51.212.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 7 avril 2008i>
- L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte de renouveler les mandats de M. Marc Saverys, M. Ludwig Criel, M.
Patrick Rodgers et M. Alexander Staring en tant qu'administrateurs pour 2 années jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle en 2010.
- L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte la nomination de M. Hugo De Stoop, employé, c/o Euronav NV, De
Gerlachekaai, 20, B-2000 Antwerpen et M. Egied Verbeeck, employé, c/o Euronav NV, De Gerlachekaai, 20, B-2000
Antwerpen en tant que nouveaux administrateurs avec effet au 7 avril 2008 jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle en 2010.
Par conséquent le nombre d'administrateurs passe de 4 à 6.
- L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte de renouveler le mandat de KPMG Audit, Luxembourg en tant que
réviseur d'entreprises pour une année jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2008.
<i>EURONAV LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008085034/1095/24.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05050. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
85070
Y.E SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 131.016.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2008 à 15 Hi>
La Société Y.E SA a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée accepte la démission de la société GL CONSULTING SA, représentée par son administrateur délégué,
Mr Jean GREFF, avec siège social à L-53-55, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce du Luxembourg sous
le numéro B 84 282, de son poste d'administrateur
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée nomme Melle Fatma TUTAN, demeurant 8, rue Alexandre Millerand F-67 170 BRUMATH au poste
d'administrateur et qui terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et
demeure, les comparants ont tous signé la présente minute.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 27/05/2008.
Mr Michel TUTAN / C. SIMON / A. BOULEAU
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Référence de publication: 2008085035/3139/24.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02960. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Mascagna Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 27.820.
<i>Extrait du proces-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 avril 2008i>
<i>Conseil d'Administration:i>
L'assemblée générale décide d'accepter la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Lorenz de HABS-
BOURG et de nommer comme nouvel administrateur Société d'Etudes Economiques avec siège social au 33, rue du
Serpentin à B-1050 Bruxelles. D'autre part, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat des autres administra-
teurs pour la durée d'un an. Suite à ces décisions le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale de
2009 est composé comme suit:
- BARRAS Chantal, Administrateur de sociétés, B-4280 Hannut, 3A, rue Georges Lambert
- BROEKHUYSE Dirk, Administrateur de sociétés, B-9830 Sint-Martens-Latem, 10 Guido Gezellestraat
- Société d'Etudes Economiques, 33, rue du Serpentin à B-1050 Bruxelles
- LAURENT JOSI Jean-Marie, Administrateur de sociétés, B-1150 Bruxelles, 42, avenue Yvan Lutens, Vice-Président
- MANGEN Fons, Réviseur d'Entreprises, L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken, Administrateur-Délégué
- SCHMITZ Alexandre, Administrateur de sociétés, B-1040 Etterbeek, 15, rue des Erables
- VARIN Christian, Administrateur de sociétés, B-1630 Linkebeek, 74 Drève des Fauvettes, Président
<i>Commissaire aux Comptes:i>
L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour la durée d'un an. Le commissaire aux
comptes en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2009 est PRICEWATERHOUSECOOPERS, L-1014 Luxembourg,
400, route d'Esch.
Pour extrait sincère et conforme
Fons MANGEN
<i>Administrateur-Déléguéi>
Référence de publication: 2008086078/750/30.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06646. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
85071
FINAGEL S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF), Société Anonyme - Société de Gestion
de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 28.619.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2008i>
<i>Conseil d'Administration:i>
D'une part, l'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Fons MANGEN,
Réviseur d'Entreprises, demeurant à 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck pour une durée de 6 ans et a accepté la
démission de tous les autres administrateurs de la société. D'autre part l'assemblée générale a décidé de nommer aux
fonctions de nouveaux administrateurs de la société pour une durée de 6 ans Monsieur Jean-Hugues ANTOINE, Admi-
nistrateur de sociétés, demeurant à 7, rue de la Sartelle, B- 6810 Izel et Madame Carine REUTER, Administrateur de
sociétés, demeurant à 5, rue des Champs, L-3332 Fennange.
Suite à ces décisions le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2014 est composé
comme suit:
- MANGEN Fons, Réviseur d'Entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck
- REUTER-BONERT Carine, Employée Privée, 5, rue des Champs, L-3332 Fennange
- ANTOINE Jean-Hugues, Comptable, 7, rue de la Sartelle, B-6810 Izel
<i>Commissaire aux Comptes:i>
L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes actuel de la société et décide de nommer en
son remplacement pour une durée de six ans, son mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle de 2014, la
société RAMLUX S.A., 9b, bd Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
Fons MANGEN
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008086080/750/30.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06642. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
ADT Finance S.A., Société Anonyme.
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 40.399.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société le 21 mai 2008i>
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires a décidé de révoquer Mr. Trevor Faure comme administrateur de la
Société à compter du 11 avril 2008.
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires a décidé de nommer Mr. Peter Schieser, Treasury Counsel and Cor-
porate Secretary, ayant pour son adresse professionnelle 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg comme
administrateur de la Société à compter du 11 avril 2008 et pour une durée indéterminée.
Suite à ces résolutions, la composition du conseil des administrateurs de la Société est désormais la suivante:
- Ms. Enrica Maccarini, administrateur demeurant a Luxembourg
- Mr. Robert Sedgley, administrateur demeurant à Londres
- Mr. Peter Schieser, administrateur demeurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>ADT Finance S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008085020/8991/24.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS01909. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
85072
Maison Josy Juckem S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Strassen, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 27.348.
EXTRAIT
Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 mai 2008,
enregistré à Luxembourg A.C., le 30 mai 2008, relation LAC/2008/21912, que suite à des cessions de parts, la répartition
des parts sociales de la société à responsabilité limitée MAISON JOSY JUCKEM S.à r.l., avec siège social à Strassen, rue
de l'Industrie, constituée suivant acte notarié du 26 janvier 1988, publié au Mémorial C, numéro 111 du 27 avril 1988,
est modifiée comme suit:
1) TOFRALUX S. à r. l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1480 Luxembourg, 6, boulevard Paul
Eyschen, quatre cent quatre-vingt-douze parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
2) Monsieur Patrick SCHLIM, directeur commercial, demeurant à L-5290 Neuhaeusgen, 43, rue Principale, cin-
quante-quatre parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3) Monsieur Romain HOUTSCH, employé privé, demeurant à L-3442 Dudelange, 197, rue des Champs, cin-
quante-quatre parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
TOTAL: six cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
et que l'assemblée générale extraordinaire des associés:
- a accepté la démission de Monsieur Josy JUCKEM, commerçant, demeurant à Steinsel, comme gérant de la société,
- a nommé en son remplacement Monsieur Thomas FRANCK, ingénieur, demeurant à L-1480 Luxembourg, 6, bou-
levard Paul Eyschen, comme gérant de la société pour une durée indéterminée,
et que par conséquent, Messieurs Thomas FRANCK, prénommé et Guy SCHWARTZ, fondé de pouvoirs, demeurant
à Huncherange, sont les seuls gérants de la société avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par leur
signature conjointe.
POUR EXTRAIT CONFORME, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2008.
Paul FRIEDERS.
Référence de publication: 2008086113/212/30.
(080098277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Mitte Holdings Management S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 78.612.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008086310/4191/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2008, réf. LSO-CR10201. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Mitte Holdings Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 78.611.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008086309/4191/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2008, réf. LSO-CR10196. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
85073
Europ Continents Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 16.913.
EXTRAIT
Lors de sa réunion à Luxembourg du 25 juin 2008, et à la suite de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de
l'exercice 2007, le Conseil d'administration de la société anonyme EUROP CONTINENTS HOLDING a confirmé Mon-
sieur Jean-Marc BEAUJOLIN dans ses fonctions de Président et d'Administrateur-délégué de la société.
Pour extrait conforme
<i>EUROP CONTINENTS HOLDING, Société anonyme
i>Signature
Référence de publication: 2008085018/546/16.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS01944. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080097772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
UBI Banca International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 61.018.
In the year two thousand and eight, on the twenty-sixth of June.
Before Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of shareholders of the company "UBI BANCA INTERNATIONAL S.A.",
a public company limited by shares, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri,
incorporated pursuant to a deed of Maître Réginald Neuman, then residing in Luxembourg, dated October 1, 1997, in
the Luxembourg Law Gazette (Mémorial C) of 1997, page number 30.248. (the "Company").
The articles of association of UBI Lux have been amended several times and for the last time by a deed number 412
of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, dated June 26, 2007.
The meeting is opened at 2.30 p.m. and is presided by Mr Massimo AMATO, bank employee, residing professionally
in Luxembourg, 47, bld du Prince Henri.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Eric COLUSSI, bank employee, residing professionally in Lux-
embourg, 47, bld du Prince Henri.
The meeting elects as scrutineer Mr Giancarlo PLEBANI, bank employee, residing professionally in Luxembourg, 47,
bld du Prince Henri.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary
to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Approval of the transfer of the German branch, located Prannerstrasse 11, Munich, Germany (the "Branch"), of
Banca Popolare di Bergamo, an Italian law public company limited by shares (società per azioni), with its registered office
at Piazza Vittorio Veneto 8, Bergamo, Italy and registered with the Bergamo Companies' Register under number
03034840169 (the "Transferring Company"), consisting in the private and corporate bank activities for companies and
private clients and, more particularly, all assets and liabilities pertaining thereto to the Company (the "Branch of Activity
Transfer") as contemplated by the transfer proposal as executed before the undersigned notary on May 16, 2008 (the
"Transfer Proposal"), filed with the Luxembourg Trade and Companies Register ("RCSL"), as published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations on 24 May 2008 (the "Mémorial") and as contemplated in the contribution agree-
ment dated 26 June 2008 (the "Contribution Agreement"), and the terms and conditions regulating the Branch of Activity
Transfer;
2. Approval of the submission of the Branch of Activity Transfer to the regime of the demergers as provided for in
articles 285 to 308 (with the exception of article 303) of the law on commercial companies dated August 10, 1915 as
amended from time to time (the "Luxembourg Company Law");
3. Confirmation of the waiver given by all the shareholders of the Company (the "Shareholders"), to waive, irrevocably
and unconditionally, in accordance with article 296 of the Luxembourg Company Law, the requirement for the explanatory
memorandum to the Transfer Proposal by the board of directors of the Company, the report of the independent expert
and for the deposit at the registered office of the Company of the explanatory memorandum to the Transfer Proposal,
of the report of the independent expert and of the provisional accounting statement with respect to the transfer to the
Company of the Branch, as expressly agreed by waiver letters dated 7 May 2008;
85074
4. Approval of the increase of the share capital of the Company and the issuance of three thousand nine hundreds and
six (3906) new shares of the Company;
5. Decision of the Shareholders to waive their preemption right to subscribe to the three thousand nine hundreds and
six (3906) newly issued shares;
6. Approval of the entry of the Transferring Company in the share capital of the Company through the subscription
of the three thousand nine hundreds and six (3906) newly issued shares in exchange of the Branch of Activity Transfer,
as contemplated in the Transfer Proposal and in the Contribution Agreement;
7. Decision of the Shareholders to modify article five (5) of the articles of association of the Company to reflect the
changes made in the number of shares of the Company pursuant to the increase of the share capital;
8. Acknowledgment of the contribution fee, representing zero point five percent (0.5%) of the valuation of the Branch,
to be paid pursuant articles 4, 6 and 8 of the law of 29th December 1971, as amended.
II. The Shareholders present or represented, their proxies and the number of shares held by each of them are shown
on an attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the chairman, the
secretary, the scrutineers and the undersigned notary. The said list shall remain annexed to the present deed to be filed
with the registration authorities.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialed "ne varietur" by the chairman, the
secretary, the scrutineers and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the
registration authorities.
The chairman acknowledges that all the Shareholders present or represented at the meeting have waived their right
to be duly convened and have been duly informed of the agenda of the meeting and have received a copy of the documents
referred to in the agenda, prior to the holding of the present meeting.
III. The chairman informed the meeting that the present general meeting will validly deliberate only if at least fifty
percent (50%) of the issued share capital is present or represented and that resolutions will be validly adopted if approved
by at least two thirds of the votes cast at the meeting.
IV. As it appears from the attendance list, from the total of eighty four thousand eight hundred and thirty eight (84,838)
shares representing the whole share capital of the Company, a total of eighty four thousand eight hundred and thirty
eight (84,838) shares are represented at the present extraordinary general meeting representing hundred percent (100%)
of the share capital. As the shares represented represent more than fifty percent (50%) of the share capital, the meeting
is thus validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items of the agenda.
V. The provisions of the Luxembourg Company Law relating to the branch of activity transfers and demergers have
been respected as follows:
1. The Transfer Proposal jointly drawn up by the boards of directors of the Company and of the Transferring Company
and executed before the undersigned notary on May 16, 2008, has been filed with the RCSL and has been published in
the Mémorial on May 24, 2008, at least one (1) month before the date of the extraordinary general meeting of shareholders
of (i) the Transferring Company convened to resolve upon the Branch of Activity Transfer and (ii) the Company at the
date hereof.
2. All the Shareholders and the sole shareholder of the Transferring Company have in accordance with article 296 of
the Luxembourg Company Law expressly waived the requirement for the establishment of an explanatory memorandum
to the Transfer Proposal by the board of directors of the Company and of the Transferring Company, of the report of
the independent expert and for the deposit at the registered office of the Company and of the Transferring Company of
the explanatory memorandum to the Transfer Proposal, of the report of the independent expert and of the provisional
accounting statement.
3. The notarised Transfer Proposal and the annual accounts including the auditors' report and the management reports
for the last three (3) financial years for respectively the Company and the Transferring Company as required pursuant
to article 295 of the Luxembourg Company Law, have been deposited at the registered office of the Company and of the
Transferring Company, for inspection by the shareholders on May 21, 2008, at least one (1) month prior to the date
hereof and the date of the resolutions of the sole shareholder of the Transferring Company. An attestation from the
Company and the Transferring Company certifying as to the availability of these documents, after having been signed "ne
varietur" by the chairman, the secretary, the scrutineers and the undersigned notary shall remain annexed to the present
deed to be filed with the registration authorities.
VI. After this had been set forth by the chairman and acknowledged by the members of the meeting, the chairman
submitted to the vote of the members of the meeting the following resolution:
<i>Resolutionsi>
The Shareholders, after having reviewed:
- the Transfer Proposal jointly drawn up by the Board of Directors of the Company and of the Transferring Company
and executed before the undersigned notary on May 16, 2008 in accordance with article 289 and article 308bis-3 of the
Luxembourg Company Law;
85075
- the annual accounts and management reports for the last three (3) financial years for respectively the Company and
the Transferring Company;
- the Contribution Agreement as executed before the undersigned notary on June 30, 2008 subject to the approval
of the Branch of Activity Transfer by the extraordinary general meeting of shareholders of the Company and the sole
shareholder of the Transferring Company;
- the approval of the Branch of Activity Transfer by the Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg
and the relevant entity in Germany,
resolve the following:
<i>First resolutioni>
The Shareholders unanimously APPROVE the Branch of Activity Transfer as contemplated by the Transfer Proposal,
filed with the RCSL, as published in the Mémorial and as contemplated in the Contribution Agreement, and the terms
and conditions regulating such Branch of Activity Transfer.
The Shareholders unanimously RESOLVE that the Branch of Activity Transfer shall become effective between the
Company and the Transferring Company on July 1, 2008 and that it shall become effective vis-à-vis third parties at the
latest on July 21, 2008.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders unanimously resolve to APPROVE the submission of the Branch of Activity Transfer to the regime
of the demergers as provided for in articles 285 to 308 (with the exception of article 303) of the Luxembourg Company
Law.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders unanimously CONFIRM their agreement to waive, irrevocably and unconditionally, in accordance
with article 296 of the Luxembourg Company Law, the requirement for the explanatory memorandum to the Transfer
Proposal by the board of directors of the Company, the report of the independent expert and for the deposit at the
registered office of the Company of the explanatory memorandum to the Transfer Proposal, of the report of the inde-
pendent expert and of the provisional accounting statement with respect to the transfer to the Company of the Branch,
as expressly agreed by waiver letters dated 7 May 2008.
The Shareholders, having acknowledge the waiver letter given by the sole shareholder of the Transferring Company,
unanimously DECLARE that all the Shareholders and the sole shareholder of the Transferring Company have therefore
in accordance with article 296 of the Luxembourg Company Law expressly waived the requirement for the establishment
of an explanatory memorandum to the Transfer Proposal by the board of directors of the Company and of the Transferring
Company, of the report of the independent expert and for the deposit at the registered office of the Company and of
the Transferring Company of the explanatory memorandum to the Transfer Proposal, of the report of the independent
expert and of the provisional accounting statement.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders unanimously RESOLVE to increase the share capital of the Company and to issue three thousand
nine hundred and six (3906) new shares of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders unanimously DECIDE to waive their preemption right to subscribe the three thousand nine hundred
and six (3906) newly issued shares.
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholders unanimously APPROVE the entry of the Transferring Company in the share capital of the Company
through the subscription of the three thousand nine hundred and six (3906) newly issued shares in exchange of the Branch
of Activity Transfer, as contemplated in the Transfer Proposal and in the Contribution Agreement.
<i>Seventh resolutioni>
As a consequence of the sixth resolution, the Shareholders unanimously RESOLVE to increase the corporate capital
by an amount of EUR 1,992,060 one million nine hundred and ninety-two thousand sixty Euros),
in order to bring it from its present amount of EUR 43,267,380 (forty-three million two hundred and sixty-seven
thousand three hundred and eighty Euros) to EUR 45,259,400 (forty-five million two hundred and fifty-nine thousand four
hundred Euros),
by the creation of 3,906 (three thousand nine hundred and six) new shares with a par value of EUR 510 (five hundred
and ten Euros) each,
and so modify article five (5) of the articles of association of the Company to reflect the changes made in the number
of shares of the Company pursuant to the increase of the share capital,
all surplus of the contribution in the amount of EUR 1,507,716 being transferred to a premium account of the Company,
the whole operation being performed without any payment to the contributing company (sans soulte).
85076
Therefore article five (5) of the articles of association of the Company will be modified as follow:
" Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 45.259.440,- (Quarante-cinq millions deux cent cinquante-neuf mille quatre
cent quarante Euros), représenté par 88.744 (Quatre-vingt-huit mille sept cent quarante-quatre) actions d'une valeur
nominale de EUR 510 (cinq cent dix Euros) chacune, toutes entièrement libérées.
Les actions sont et resteront nominatives."
The decided increase of capital being paid in by a contribution in kind, has been the object of a report of the réviseur
d'entreprises "Ernst & Young S.A.", with registered office in L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, dated June 26,
2008, that concludes as follows:
"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that
the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 3906 shares with
a nominal value of EUR 510 each to be issued with total related share premium of 1,507,716 hence total consideration
amounting to EUR 3,499,776."
Proof of the contribution in kind by the contributing company "Banca Popolare di Bergamo S.p.A." of its branch located
in Germany, has been given to the acting notary by a certificate delivered by Mr Armando SANTUS, notary residing in
Bergamo.
<i>Eighth resolutioni>
For taxation purposes, the Shareholders with the acting notary declare that the present deed is subject to the fixed
registration fee (droit fixe) in application of article 4.1 of the law of 29th December 1971, as amended.
<i>Declarationi>
In accordance with article 300 (2) of the Luxembourg Company Law, the undersigned notary declares having verified
and certifies the existence and validity of the legal acts and formalities imposed on the Company in order to realize the
Branch of Activity Transfer.
There being no further business, the meeting is terminated at 4 p.m.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French version, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this
document.
The document having been read to the meeting, the members of the bureau, known to the notary by their surnames,
given names, civil status and residences, signed together with the notary the present deed, no shareholder expressing the
wish to sign.
Follows the French version:
L'an deux mille huit, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "UBI BANCA INTERNATIONAL S.A."
une société anonyme, ayant son siège social au 47, boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg, constituée suivant
un acte reçu par Maître Réginald Neuman, alors de résidence à Luxembourg, en date du 1
er
octobre 1997, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de 1997, page 30.248 (la "Société").
Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte numéro 412 reçu par
Maître Jacques Delvaux, notaire, de résidence à Luxembourg, en date du 26 juin 2007.
La séance est ouverte à 14.30 heures sous présidence de M. Massimo AMATO, employé de banque, demeurant
professionnellement à Luxembourg, 47, bld du Prince Henri.
Le président désigne comme secrétaire de l'assemblée M. Eric COLUSSI, employé de banque, demeurant profession-
nellement à Luxembourg, 47, bld du Prince Henri.
L'assemblée choisit comme scrutateur M. Giancarlo PLEBANI, employé de banque, demeurant professionnellement à
Luxembourg, 47, bld du Prince Henri.
Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Approbation de la cession de la succursale allemande, située Prannerstrasse 11, Munich, Allemagne (la "Branche"),
de la société Banca Popolare di Bergamo, une société anonyme de droit italien (società per azioni), ayant son siège social
Piazza Vittorio Veneto 8, Bergamo, Italie et enregistrée auprès du registre du commerce de Bergamo sous le numéro
03034840169 (la "Société Cédante"), consistant en des activités bancaires de type banque privée et banque commerciale,
et plus particulièrement tous les actifs et passifs y relatifs, à la Société (la "Cession de Branche d'Activité") conformément
au projet de cession tel que signé par-devant le notaire instrumentaire le 16 mai 2008 (le "Projet de Cession"), déposé
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg ("RCSL"), tel que publié au Mémorial C, Recueil des
85077
Sociétés et Associations, le 24 mai 2008 (le "Mémorial") et conformément à l'acte de cession ("l'Acte de Cession") et aux
termes et conditions gouvernant la Cession de Branche d'Activité;
2. Approbation de la soumission de la Cession de Branche d'Activité au régime des scissions conformément aux articles
285 à 308 (hormis l'article 303) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la "Loi
Luxembourgeoise sur les Sociétés");
3. Confirmation de la renonciation donnée par tous les actionnaires de la Société (les "Actionnaires"), par laquelle ils
renoncent, expressément et inconditionnellement, en application de l'article 296 de la Loi Luxembourgeoise sur les
Sociétés, à l'établissement d'un rapport écrit détaillé sur le Projet de Cession par le conseil d'administration de la Société,
au rapport écrit de l'expert indépendant et au dépôt au siège social de la Société, du rapport écrit détaillé sur le Projet
de Cession, du rapport de l'expert indépendant et de l'état comptable intérimaire, conformément aux lettres de renon-
ciation datés du 7 mai 2008;
4. Approbation de l'augmentation du capital social de la Société et de l'émission de trois mille neuf cent six (3906)
nouvelles actions de la Société;
5. Décision des Actionnaires de renoncer à leur droit préférentiel de souscription au trois mille neuf cent six (3906)
nouvelles actions de la Société;
6. Approbation de l'entrée de la Société Cédante dans le capital social de la Société par la souscription des trois mille
neuf cent six (3906) nouvelles actions attribuées en échange de la Cession de Branche d'Activité, conformément au Projet
de Cession et à l'Acte de Cession;
7. Décision des Actionnaires de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter la modification du nombre
d'actions de la Société conformément à l'augmentation de capital social;
8. Prise en considération par la Société des droits d'apports, représentant zéro virgule cinq pourcent (0,5%) du montant
correspondant à l'évaluation de la Branche, qui doivent être payés conformément aux articles 4, 6 et 8 de la loi du 29
décembre 1971, telle que modifiée.
II. Les actionnaires présents ou représentés, leurs mandataires et le nombre d'actions détenu par chacun d'eux sont
renseignés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés,
le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire instrumentaire. Ladite liste restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations données par les actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par le président,
le secrétaire, les scrutateurs et le notaire instrumentaire resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l'enregistrement.
Le président constate que tous les actionnaires présents ou représentés ont renoncé à leur droit d'être dûment
convoqués et qu'ils ont été informés de l'agenda de l'assemblée et ont reçu une copie des documents indiqués dans
l'agenda avant la tenu de la présente assemblée.
III. Le président informe l'assemblée que la présente assemblée générale ne délibérera valablement que si au moins
cinquante pourcent (50%) du capital social émis est présent ou représenté et que les décisions ne seront valablement
adoptées que si elles sont approuvées par au moins deux tiers des votes émis à l'assemblée.
IV. Il résulte de la liste de présence, que sur les quatre-vingt-quatre mille huit cent trente-huit (84.838) actions repré-
sentant l'intégralité du capital social, un total de quatre-vingt-quatre mille huit cent trente-huit (84.838) actions sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, représentant cent pourcent (100%) du capital social. Con-
sidérant que les actions représentées représentent plus de cinquante pourcent (50%) du capital social, il apparaît que
l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.
V. Les dispositions de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés relatives aux transferts de branche d'activités et aux
scissions ont été respectées comme suit:
4. Le Projet de Cession tel qu'établi conjointement par les conseils d'administration de la Société et de la Société
Cédante et tel que signé par-devant le notaire instrumentaire le 16 mai 2008 a été déposé auprès du RCSL et a été publié
au Mémorial le 24 mai 2008, un (1) mois au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire (i) de la Société
Cédante, convoquée afin d'approuver la Cession de Branche d'Activité et (i) de la Société à la date de cet acte.
5. Tous les Actionnaires et l'actionnaire unique de la Société Cédante ont, conformément à l'article 296 de la Loi
Luxembourgeoise sur les Sociétés, expressément renoncé à l'établissement d'un rapport écrit détaillé sur le Projet de
Cession par le conseil d'administration de la Société et de la Société Cédante, au rapport écrit de l'expert indépendant
et au dépôt au siège social de la Société et de la Société Cédante, du rapport écrit détaillé sur le Projet de Cession, du
rapport de l'expert indépendant et de l'état comptable intérimaire.
6. Le Projet de Cession notarié et les comptes annuels y compris, les rapports du réviseur d'entreprises et les rapports
de gestion des trois (3) derniers exercices respectivement pour la Société et la Société Cédante tels que requis par l'article
295 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés ont été déposés au siège social de la Société et de la Société Cédante,
en vue de leur consultation par les actionnaires, en date du 21 mai 2008, un (1) mois au moins avant la date de cet acte
et avant la date de l'assemblée générale des actionnaires (i) de la Société Cédante et (ii) de la Société. Une attestation de
la Société et de la Société Cédante certifiant la disponibilité de ces documents restera, après avoir été signée "ne varietur"
85078
par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux
formalités de l'enregistrement.
VI. Ces faits ayant été exposés par le président et reconnus exacts par l'assemblée, le président met aux voix de
membres de l'assemblée la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'assemblée générale, après avoir revu:
- le Projet de Cession établi conjointement par les conseils d'administration de la Société et de la Société Cédante et
exécuté par-devant le notaire soussigné en date du 16 mai 2008 conformément à l'article 289 et à l'article 308 bis-3 de
la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés;
- les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices respectivement pour la Société et la
Société Cédante;
- l'Acte de Cession exécuté par-devant le notaire soussigné en date du 30 juin 2008 sous réserve de l'approbation de
la Cession de Branche d'Activité par l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires et par l'actionnaire unique de
la Société Cédante;
- l'approbation de la Cession de Branche d'Activité par la Commission de Surveillance du Secteur Financier à Luxem-
bourg et par l'autorité allemande compétente,
décide ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Les Actionnaires APPROUVENT à l'unanimité la Cession de Branche d'Activité telle qu'envisagée par le Projet de
Cession, enregistré auprès du RCSL, tel que publié au Mémorial et tel qu'envisagé dans l'Acte de Cession, ainsi que les
termes et conditions auxquels est soumis la Cession de Branche d'Activité.
Les Actionnaires DECIDENT à l'unanimité que la Cession de Branche d'Activité sera effective entre la Société et la
Société Cédante à la date du 1
er
juillet 2008 et vis à vis des tiers au plus tard le 21 juillet 2008.
<i>Seconde résolutioni>
Les Actionnaires APPROUVENT à l'unanimité la soumission de la Cession de Branche d'Activité au régime des scissions
conformément aux articles 285 à 308 (hormis l'article 303) de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés.
<i>Troisième résolutioni>
Les Actionnaires CONFIRMENT à l'unanimité leur consentement à renoncer, irrévocablement et inconditionnelle-
ment, en application de l'article 296 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés, à l'établissement d'un rapport écrit
détaillé sur le Projet de Cession par le conseil d'administration de la Société et de la Société Cédante, au rapport écrit
de l'expert indépendant et au dépôt au siège social de la Société et de la Société Cédante, du rapport écrit détaillé sur
le Projet de Cession, du rapport de l'expert indépendant et de l'état comptable intérimaire.
Les Actionnaires, ayant pris connaissance de la renonciation également donnée par l'actionnaire unique de la Société
Cédante, DECLARENT à l'unanimité que tous les Actionnaires et l'actionnaire unique de la Société Cédante ont, con-
formément à l'article 296 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés, expressément renoncé à l'établissement d'un
rapport écrit détaillé sur le Projet de Cession par le conseil d'administration de la Société et de la Société Cédante, au
rapport écrit de l'expert indépendant et au dépôt au siège social de la Société et de la Société Cédante du rapport écrit
détaillé sur le Projet de Cession, du rapport de l'expert indépendant et de l'état comptable intérimaire.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Actionnaires DECIDENT à l'unanimité d'augmenter le capital social de la Société et d'émettre trois mille neuf cent
six (3906) actions nouvelles de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Actionnaires DECIDENT à l'unanimité de renoncer à leur droit préférentiel de souscription aux trois mille neuf
cent six (3906) actions nouvellement émises.
<i>Sixième résolutioni>
Les Actionnaires APPROUVENT à l'unanimité l'entrée de la Société Cédante dans le capital social de la Société par la
souscription aux trois mille neuf cent six (3906) actions nouvellement émises en échange de la Cession de Branche
d'Activité, telle que décrite dans le Projet de Cession et dans l'Acte de Cession.
<i>Septième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, les Actionnaires DECIDENT d'augmenter le capital social à concurrence de EUR
1,992,060 (un million neuf cent quatre-vingt-douze mille soixante Euros,
afin de le porter de son montant actuel de EUR 43,267,380 (quarante-trois millions deux cent soixante-sept mille trios
cent quatre-vingt Euros) à EUR 45,259,400 (quarante-cinq millions deux cent cinquante-neuf mille quatre cents Euros),
par la création de 3,906 (trois mille neuf cent six ) nouvelles actions avec une valeur nominale de EUR 510 (cinq cent
dix Euros) chacune.
85079
et ainsi modifier l'article cinq (5) des statuts de la Société afin de refléter les changements intervenus dans le nombre
d'actions de la Société suite à l'augmentation du capital social.
tout excédant de l'apport, s'élevant à EUR 1.507.716 étant transféré à un compte de prime d'émission de la Société,
l'opération d'apport étant réalisé sans aucun paiement à la société apporteuse (sans soulte).
En conséquence, l'article cinq (5) des statuts de la Société sera modifié comme suit:
"Le capital social est fixé à EUR 45.259.440,- (Quarante-cinq millions deux cent cinquante-neuf mille quatre cent
quarante Euros), représenté par 88.744 (Quatre-vingt-huit mille sept cent quarante-quatre) actions d'une valeur nominale
de EUR 510 (cinq cent dix Euros) chacune, toutes entièrement libérées.
Les actions sont et resteront nominatives."
La présente augmentation de capital étant libérée par un apport en nature, celle-ci à fait l'objet d'un rapport par un
réviseur d'entreprises, savoir ERNST & YOUNG S.A., avec siège social à L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall,
lequel rapport daté du 26 juin 2008 conclut comme suit:
"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that
the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 3906 shares with
a nominal value of EUR 510 each to be issued with total related share premium of 1,507,716 hence total consideration
amounting to EUR 3,499,776."
La preuve du transfert de l'apport en nature par la société apporteuse "Banca Popolare di Bergamo S.p.A." de sa
branche sise en Allemagne à la Société a été donnée au Notaire au moyen d'un certificat délivré par Mr Armando SANTUS,
Notaire de résidence à Bergamo,
<i>Huitième résolutioni>
Pour les besoins de l'Enregistrement, les Actionnaires avec le notaire DECLARENT que le présent acte est soumis au
droit fixe en application de l'article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée.
<i>Déclarationi>
Conformément à l'article 300 (2) de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés, le notaire instrumentaire déclare avoir
vérifié et attesté l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société en vue de la réalisation de la
Cession de Branche d'Activité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée prend fin à 16.00 heures.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête de la même personne comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénoms, état et demeure,
ladite personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. AMATO, E. COLUSSI, G. PLEBANI, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 3 juillet 2008. LAC/2008/27333. — Reçu douze Euros (EUR 12.-).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/07/08.
Jacques DELVAUX.
Référence de publication: 2008085836/208/362.
(080101784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.
S.M.M. spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 38.531.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 20.06.2008 à Luxembourgi>
L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir
Messieurs GILLET Etienne, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, TORDOOR Jacques, 3B, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg, GLESENER Guy, 36, rue Frantz Seimetz, L-2531 Luxembourg, en tant qu'administra-
teurs et la société AUDITEX S.A.R.L. 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant que commissaire aux
comptes. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2014.
85080
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008085037/3842/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS01015. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Aberdeen Property Funds SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investis-
sement Spécialisé,
(anc. Aberdeen Property Funds SICAV).
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 117.474.
In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth day of June.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders ("Shareholders") of "Aberdeen Property Funds SICAV",
a Luxembourg société d'investissement à capital variable, having its registered office at 2-8, avenue Charles De Gaulle,
L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B-117.474, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 30 June 2006, published in
the Mémorial C, number 1393, on 19 July 2006 (the "Company").
The extraordinary general meeting was opened at 5 p.m. (CET) and was presided by Mr Jean-Claude MICHELS, lawyer,
residing in Luxembourg.
The extraordinary general meeting elected as secretary Mr Mathieu VOLCKRICK, lawyer, residing in Luxembourg,
and as scrutineer Mrs Marie LAMENSCH, lawyer, residing in Luxembourg.
The bureau of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested
the notary to state that:
I. The agenda of the extraordinary general meeting is as follows:
1. Amendment of the "Preliminary Title - Definitions" of the Company's articles of incorporation ("Articles"), by
(a) the deletion of the definition of the Luxembourg law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective
investment;
(b) the insertion of a definition of "Law of 2007", to read as follows: "the Luxembourg law of 13 February 2007 on
specialised investment funds, as may be amended from time to time";
(c) the amendment of the definition of "Company", to read as follows: "Aberdeen Property Funds SICAV-FIS";
(d) the amendment of the definition of "Institutional Investors", to read as follows: "has the meaning ascribed to it in
the Prospectus";
(e) the amendment of the definition of "Investor", to read as follows: "any Well-Informed Investor who has signed and
returned a Subscription Agreement (for the avoidance of doubt, the term includes, where appropriate, the Shareholders)";
(f) the replacement of the definition of "SICAV" by a definition of "SICAV-FIS", to read as follows: "société d'inves-
tissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé";
(g) the amendment of the definition of "US Person", to read as follows: "has the meaning given in Regulation S under
the United States Securities Act of 1933, as amended";
(h) the insertion of a definition of "Well-Informed Investors", to read as follows: "any investor who qualifies as a well-
informed investor in accordance with the provisions of article 2 of the Law of 2007, including in particular: a) Institutional
Investors; b) professional investors, being those investors who are, in accordance with Luxembourg laws and regulations,
deemed to have the experience, knowledge and expertise to make their own investment decisions and properly assess
the risk they incur; and c) any other well-informed investor who fulfils the following conditions: (i)declares in writing that
he adheres to the status of well-informed investor and invests a minimum of one hundred and twenty five thousand Euros
(€125,000) in the Company; or (ii) declares in writing that he adheres to the status of well-informed investor and has
obtained an assessment from a credit establishment as defined in the directive 2006/48/CE, from an investment firm as
defined in directive 2004/39/CE, or from a management company as defined in directive 2001/107/CE, certifying his/her
expertise, his/her experience and his/her knowledge to appraise in an appropriate manner an investment in the Company;
provided that US Persons qualifying as well-informed investors pursuant to the above must also be both "accredited
investors" as defined in Rule 501 (a) of Regulation D promulgated under the 1933 Act and "qualified purchasers" within
the meaning of Section 2(a)(51) of the 1940 Act";
2. Replacement, across the Articles, of all references to the "2002 Law" by references to the "2007 Law" and of any
reference to an article of the "2002 Law" by a reference to the relevant article of the "2007 Law";
85081
3. Amendment of the name of the Company from currently "Aberdeen Property Funds SICAV" into "Aberdeen Prop-
erty Funds SICAV-FIS" and corresponding amendment of article 1 of the Articles, to read as follows: "There exists among
the existing Shareholders and all those who may become owners of Shares in the future, a public limited company (société
anonyme) qualifying as an investment company with variable share capital - specialised investment fund (société d'inves-
tissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) under the name of ABERDEEN PROPERTY FUNDS SICAV-
FIS."
4. Amendment of article 5§8 of the Articles, to read as follows: "The Company shall be considered as a single legal
entity. However, the right of Shareholders and creditors relating to a particular Sub-fund or raised by the incorporation,
the operation or the liquidation of a Sub-fund are limited to the assets of such Sub-fund. The assets of a Sub-fund will be
answerable exclusively for the rights of the Shareholders relating to this Sub-fund and for those of the creditors whose
claim arose in relation to the incorporation, the operation or the liquidation of this Sub-fund. As between the Share-
holders, each Sub-fund shall be treated as a separate entity.";
5. Amendment of article 10§1 of the Articles by the addition of the following sentence: "For the avoidance of doubt,
Prohibited Person includes any person, firm or corporate body, which does not qualify as a Well-Informed Investor.".
II. The Shareholders have been duly convened pursuant to a convening notice dated 13 June 2008. Two million nine
hundred eighty-eight thousand eight hundred twenty-four (2,988,824) shares out of five million sixty-seven thousand two
hundred sixty-two point sixteen (5,067,262.16) shares in issue, i.e. 58.98% are present or duly represented. The present
extraordinary general meeting is thus regularly constituted and may validly decide on the items of its agenda.
III. An attendance list was accordingly drawn up, which remains attached to the present, together with the proxies.
The extraordinary general meeting deliberated and adopted unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting RESOLVES to amend the "Preliminary Title - Definitions" of the Articles, by
(a) the deletion of the definition of the Luxembourg law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective
investment;
(b) the insertion of a definition of "Law of 2007", to read as follows: "the Luxembourg law of 13 February 2007 on
specialised investment funds, as may be amended from time to time";
(c) the amendment of the definition of "Company", to read as follows: "Aberdeen Property Funds SICAV-FIS";
(d) the amendment of the definition of "Institutional Investors", to read as follows: "has the meaning ascribed to it in
the Prospectus";
(e) the amendment of the definition of "Investor", to read as follows: "any Well-Informed Investor who has signed and
returned a Subscription Agreement (for the avoidance of doubt, the term includes, where appropriate, the Shareholders)";
(f) the replacement of the definition of "SICAV" by a definition of "SICAV-FIS", to read as follows: "société d'inves-
tissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé";
(g) the amendment of the definition of "US Person", to read as follows: "has the meaning given in Regulation S under
the United States Securities Act of 1933, as amended";
(h) the insertion of a definition of "Well-Informed Investors", to read as follows: "any investor who qualifies as a well-
informed investor in accordance with the provisions of article 2 of the Law of 2007, including in particular: a) Institutional
Investors; b) professional investors, being those investors who are, in accordance with Luxembourg laws and regulations,
deemed to have the experience, knowledge and expertise to make their own investment decisions and properly assess
the risk they incur; and c) any other well-informed investor who fulfils the following conditions: (i) declares in writing
that he adheres to the status of well-informed investor and invests a minimum of one hundred and twenty five thousand
Euros (€ 125,000) in the Company; or (ii) declares in writing that he adheres to the status of well-informed investor and
has obtained an assessment from a credit establishment as defined in the directive 2006/48/CE, from an investment firm
as defined in directive 2004/39/CE, or from a management company as defined in directive 2001/107/CE, certifying his/
her expertise, his/her experience and his/her knowledge to appraise in an appropriate manner an investment in the
Company; provided that US Persons qualifying as well-informed investors pursuant to the above must also be both
"accredited investors" as defined in Rule 501 (a) of Regulation D promulgated under the 1933 Act and "qualified pur-
chasers" within the meaning of Section 2(a)(51) of the 1940 Act";
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting RESOLVES to replace, across the Articles, all references to the "2002 Law" by
references to the "2007 Law" and any reference to an article of the "2002 Law" by a reference to the relevant article of
the "2007 Law".
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting RESOLVES to amend the name of the Company from currently "Aberdeen Property
Funds SICAV" into "Aberdeen Property Funds SICAV-FIS" and to make the corresponding amendment of article 1 of the
Articles, to read as follows: "There exists among the existing Shareholders and all those who may become owners of
Shares in the future, a public limited company (société anonyme) qualifying as an investment company with variable share
85082
capital - specialised investment fund (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) under
the name of ABERDEEN PROPERTY FUNDS SICAV-FIS."
<i>Fourth resolutioni>
The extraordinary general meeting RESOLVES to amend article 5§8 of the Articles, to read as follows: "The Company
shall be considered as a single legal entity. However, the right of Shareholders and creditors relating to a particular Sub-
fund or raised by the incorporation, the operation or the liquidation of a Sub-fund are limited to the assets of such Sub-
fund. The assets of a Sub-fund will be answerable exclusively for the rights of the Shareholders relating to this Sub-fund
and for those of the creditors whose claim arose in relation to the incorporation, the operation or the liquidation of this
Sub-fund. As between the Shareholders, each Sub-fund shall be treated as a separate entity.";
<i>Fifth resolutioni>
The extraordinary general meeting RESOLVES to amend article 10§1 of the Articles by the addition of the following
sentence: "For the avoidance of doubt, Prohibited Person includes any person, firm or corporate body, which does not
qualify as a Well-Informed Investor.".
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, given names, civil
status and residences, the members of the bureau of the extraordinary general meeting signed together with the notary
the present deed.
Follows the French translation of the preceding text:
L'an deux mille huit, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem.
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "Aberdeen Property Funds SICAV", une société
d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B numéro 117.474, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 Juin 2006, publié au
Mémorial C, numéro 1393, en date du 19 juillet 2006 (la "Société").
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 17 heures (heure locale), présidée par Monsieur Jean-Claude MI-
CHELS, avocat, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée générale extraordinaire élit comme secrétaire Monsieur Mathieu VOLCKRICK, avocat, demeurant à Lu-
xembourg, et comme scrutateur Madame Marie LAMENSCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée générale extraordinaire ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter
que:
I. L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:
1. Amendement du "Titre Préliminaire - Définitions" des statuts de la Société ("Statuts"), par
(a) La suppression de la définition de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement
collectifs;
(b) L'insertion d'une définition de la "Loi de 2007" comme suit: "La loi luxembourgeoise du 13 février 2007 relative
aux fonds d'investissement spécialisés, telle qu'amendée";
(c) L'amendement de la définition de "Société" comme suit: "Aberdeen Property Funds SICAV-FIS";
(d) L'amendement de la définition d'"Investisseur Institutionnel", comme suit: "a la signification qui lui est accordée
dans le Prospectus";
(e) L'amendement de la définition d'"Investisseur", comme suit: "Tout Investisseur Averti qui a complété et renvoyé
un Contrat de Souscription (à toutes fins utiles, précisons que ce terme inclut, si applicable, les Actionnaires)";
(f) Le remplacement de la définition de "SICAV" par une définition de "SICAV-FIS", comme suit: "société d'investisse-
ment à capital variable - fonds d'investissement spécialisé";
(g) L'amendement de la définition de "US Person", comme suit: "a la signification qui lui est octroyée aux termes de la
Réglementation S du Securities Act américain de 1933, tel qu'amendé";
(h) L'insertion d'une définition d'"Investisseur Averti", comme suit: "tout investisseur ayant la qualité d'investisseur
averti aux termes de l'article 2 de la Loi de 2007, en ce compris, en particulier: a) les Investisseurs Institutionnels; b)
investisseurs professionnels, c'est-à-dire les investisseurs qui sont, en accord avec les termes des lois et réglementations
luxembourgeoises, considérés comme ayant l'expérience, les connaissances et l'expertise suffisante pour prendre leurs
propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques qu'ils encourent; et, c) tout autre investisseur
averti qui satisfait les conditions suivantes: (i) il a déclaré par écrit son adhésion au statut d'investisseur averti et b) (i) il
85083
investit un minimum de 125.000 euros dans le fonds d'investissement spécialisé, ou (ii) il bénéficie d'une appréciation, de
la part d'un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d'une entreprise d'investissement au sens de la
directive 2004/39/CE ou d'une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE certifiant son expertise, son ex-
périence et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans la Société; étant entendu
que les Personnes US revêtant la qualité d'investisseur avisé selon les conditions décrites ci-avant doit également revêtir
la qualité d'"investisseur accrédité" tel que ce terme est défini dans la Règle 501 (a) de la Réglementation D promulguée
dans la loi de 1933 et revête la qualité d'"acheteur avisé" aux termes de la Section 2 (a) (51) de la Loi de 1940";
2. Le remplacement, à travers l'intégralité des Statuts, de toute référence à la "Loi de 2002" par des références à la
"Loi de 2007" ainsi que de toute référence à un article de la "Loi de 2002" par des références à l'article correspondant
de la "Loi de 2007";
3. L'amendement du nom de la Société de, actuellement, "Aberdeen Property Funds SICAV" en "Aberdeen Property
Funds SICAV-FIS" et l'amendement correspondant de l'article 1
er
des Statuts, comme suit: "Il existe entre les Actionnaires
existants et tous ceux qui pourraient devenir propriétaires d'Actions dans le future, une société anonyme revêtant la
qualité de société anonyme à capital variable - fonds d'investissement spécialisé sous la dénomination de "Aberdeen
Property Funds SICAV-FIS"
4. L'amendement de l'article 5§8 des Statuts, comme suit: "La Société sera considérée comme une entité légale distincte.
Cependant, les droits des Actionnaires et des créanciers, relativement à un Sous-Fonds en particulier ou découlant de
l'incorporation, des opérations, de la liquidation d'un Sous-Fonds sont limités aux avoirs de ce Sous-Fonds. Les avoirs
d'un Sous-Fonds répondront exclusivement des droits des Actionnaires relativement à ces Sous-Fonds et pour les créan-
ciers agissant relativement à l'incorporation, les opérations ou la liquidation de ce Sous-Fonds. Concernant les relations
entre les Actionnaires, chaque Sous-Fonds sera traité comme une entité séparée".
5. L'amendement de l'article 10§1 des Statuts par l'ajout de la phrase suivante:"A toutes fins utiles, précisons que les
Personnes Interdites inclut toute personne, société ou entité incorporée qui ne revêt pas la qualité d'Investisseur Averti".
II. Les Actionnaires ont été dûment convoqués, conformément à la convocation du 13 juin 2008. Deux millions neuf
cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent vingt-quatre (2.988.824) actions des cinq millions soixante-sept mille deux cent
soixante-deux virgule seize (5.067.262,16) actions émises (càd. 58,98%) sont présentes ou dûment représentées. L'as-
semblée générale extraordinaire est donc valablement constituée et peut valablement décider sur tous les points de
l'ordre du jour.
III. Une liste de présence correspondante a été dressée, qui, avec les procurations, restera attachée aux présentes.
Après avoir délibéré, l'assemblée générale extraordinaire a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire DECIDE d'amender le "Titre Préliminaire - Définitions" des statuts de la Société
("Statuts"), par
(a) La suppression de la définition de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement
collectifs;
(b) L'insertion d'une définition de la "Loi de 2007" comme suit: "La loi luxembourgeoise du 13 février 2007 relative
aux fonds d'investissement spécialisés, telle qu'amendée";
(c) L'amendement de la définition de "Société" comme suit: "Aberdeen Property Funds SICAV-FIS";
(d) L'amendement de la définition d'"Investisseur Institutionnel", comme suit: "a la signification qui lui est accordée
dans le Prospectus";
(e) L'amendement de la définition d'"Investisseur", comme suit: "Tout Investisseur Averti qui a complété et renvoyé
un Contrat de Souscription (à toutes fins utiles, précisons que ce terme inclut, si applicable, les Actionnaires)";
(f) Le remplacement de la définition de "SICAV" par une définition de "SICAV-FIS", comme suit: "société d'investisse-
ment à capital variable - fonds d'investissement spécialisé";
(g) L'amendement de la définition de "Resortissant des Etats-Unis d'Amérique", comme suit: "a la signification qui lui
est octroyée aux termes de la Réglementation S du Securities Act américain de 1933, tel qu'amendé";
(h) L'insertion d'une définition d'"Investisseur Averti", comme suit: "tout investisseur ayant la qualité d'investisseur
averti aux termes de l'article 2 de la Loi de 2007, en ce compris, en particulier: a) les Investisseurs Institutionnels; b)
investisseurs professionnels, c'est-à-dire les investisseurs qui sont, en accord avec les termes des lois et réglementations
luxembourgeoises, considérés comme ayant l'expérience, les connaissances et l'expertise suffisante pour prendre leurs
propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques qu'ils encourent; et, c) tout autre investisseur
averti qui satisfait les conditions suivantes: (i) il a déclaré par écrit son adhésion au statut d'investisseur averti et b) (i) il
investit un minimum de 125.000 euros dans le fonds d'investissement spécialisé, ou (ii) il bénéficie d'une appréciation, de
la part d'un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d'une entreprise d'investissement au sens de la
directive 2004/39/CE ou d'une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE certifiant son expertise, son ex-
périence et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans la Société; étant entendu
que les Personnes US revêtant la qualité d'investisseur avisé selon les conditions décrites ci-avant doit également revêtir
85084
la qualité d'"investisseur accrédité" tel que ce terme est défini dans la Règle 501 (a) de la Réglementation D promulguée
dans la loi de 1933 et revête la qualité d'"acheteur avisé" aux termes de la Section 2 (a) (51) de la Loi de 1940";
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire DECIDE de remplacer, à travers l'intégralité des Statuts, toute référence à la "Loi
de 2002" par des références à la "Loi de 2007" ainsi que toute référence à un article de la "Loi de 2002" par des références
à l'article correspondant de la "Loi de 2007";
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire DECIDE d'amender le nom de la Société de, actuellement, "Aberdeen Property
Funds SICAV" en "Aberdeen Property Funds SICAV-FIS" et d'amender de la de façon correspondante l'article 1
er
des
Statuts, comme suit: "Il existe entre les Actionnaires existants et tous ceux qui pourraient devenir propriétaires d'Actions
dans le future, une société anonyme revêtant la qualité de société anonyme à capital variable - fonds d'investissement
spécialisé sous la dénomination de "Aberdeen Property Funds SICAV-FIS".
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire DECIDE d'amender l'article 5§8 des Statuts, comme suit: "La Société sera con-
sidérée comme une entité légale distincte. Cependant, les droits des Actionnaires et des créanciers, relativement à un
Sous-Fonds en particulier ou découlant de l'incorporation, des opérations, de la liquidation d'un Sous-Fonds sont limités
aux avoirs de ce Sous-Fonds. Les avoirs d'un Sous-Fonds répondront exclusivement des droits des Actionnaires relati-
vement à ces Sous-Fonds et pour les créanciers agissant relativement à l'incorporation, les opérations ou la liquidation
de ce Sous-Fonds. Concernant les relations entre les Actionnaires, chaque Sous-Fonds sera traité comme une entité
séparée".
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire DECIDE d'amender l'article 10§1 des Statuts par l'ajout de la phrase suivante: "A
toutes fins utiles, précisons que les "Personnes Interdites" inclut toute personne, société ou entité incorporée qui ne
revêt pas la qualité d'Investisseur Averti".
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états
et demeures, les membres du bureau de l'assemblée générale extraordinaire ont tous signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: J.C. MICHELS, M. VOLCKRICK, M. LAMENSCH, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1
er
juillet 2008, Relation: EAC/2008/8734. — Reçu douze Euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Belvaux, le 14 juillet 2008.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2008086729/239/259.
(080102647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.
Vellemans-Vellemans-Nys-Timmermans Société en nom collectif, Société en nom collectif.
Enseigne commerciale: Global Consulting & Finance Senc.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 139.657.
<i>Extrait de l'Acte de Constitutioni>
<i>Dénomination Raison Socialei>
Vellemans-Vellemans-Nys-Timmermans Société en nom collectif
<i>Siège Sociali>
29 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
<i>Associési>
Monsieur Vellemans CHRISTOPHE commerçant, Né 22 03-1976 à HALLE, Résident à DOREKENSTREET 24 B-1674
BELLINGEN Belgique
85085
Monsieur Vellemans RICHARD commerçant, Né 21 FEBRUARY 1936 SINT PIETERS LEEUW , Résident à DORE-
KENSTREET 24 B-1674 BELLINGEN
Madame Nys Sylvie, commerçante née 14-03-72 à Halle, Résidente à Molenborre 27 bus 32,1500 Halle
Monsieur Timmermans Georges, commerçant né 10 août 1961 à Halle , Résident a Bergensesteenweg 501 bus 14,
1500 Halle
<i>Objet Sociali>
La société pourra accomplir Toutes activités commerciales, effectuer des opérations industrielles ou financières, ainsi
que tous transferts de propriété immobilier ou mobilier,
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement a la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, a la mise en valeur et a la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer a la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir souscription de prise ferme ou d'option
<i>Géranti>
Monsieur Vellemans CHRISTOPHE , Né 22 03-1976 à HALLE
Resident DOREKENSTREET 24 B-1674 BELLINGEN Belgique
La Société est valablement engagée par la signature individuelle du Gérant
<i>Capital sociali>
2,500 Euro libéré intégralement, divisé en 100 parts sociaux de 25 Euro chacune
<i>Souscription du capitali>
1-Monsieur Vellemans Christophe, 70 parts
2- Monsieur Vellemans Richard, 10 Parts
3- Madame Nys Sylvie, 10 Parts
4- Monsieur Timmermans Georges, 10 Parts
<i>Date de Constitutioni>
15 juin 2008
La société est constituée pour une durée illimitée
Fait et Passé à Luxembourg, le 15 juin 2008 (deux mille et huit).
Signature.
Référence de publication: 2008085223/800149/47.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02429. - Reçu 89,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
AMB Le Havre Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 37.025,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 133.855.
In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth of June.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
AMB Europe Luxembourg Holding 2 S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée),
incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 122.995,
in its capacity of sole partner of AMB Le Havre Holding S. à r.l., a private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée), having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Company Register under number B 133.855, incorporated on 7 November 2007 pursuant to a deed of the
undersigned notary, published on 20 December 2007 in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number
2963 (the "Company"),
here represented by Mrs Barbara MALANIUK, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given
in Luxembourg on June 18th, 2008.
85086
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the undersigned notary and the proxyholder acting on behalf of
the appearing party, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. AMB Europe Luxembourg Holding 2 S.à r.l. is the sole partner (the "Sole Partner") of the Company;
II. The Company's share capital is presently set at thirty-seven thousand euro (EUR 37,000.-) represented by one
thousand four hundred and eighty (1,480) shares in registered form, each share having a par value of twenty-five euro
(EUR 25.-)
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Partner resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of twenty-five euro
(EUR 25.-) so as to bring the Company's share capital from its current amount of thirty-seven thousand euro (EUR
37,000.-) represented by one thousand four hundred and eighty (1,480) shares in registered form with a par value of
twenty-five euro (EUR 25.-) each, to an amount of thirty-seven thousand and twenty-five euro (EUR 37,025.-) by the
issuance of one new share with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-), having the same characteristics and entitling
to the same rights as the one thousand four hundred and eighty (1,480) existing shares of the Company (the ''Shares'').
<i>Subscription-paymenti>
Thereupon, the Sole Partner, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for one new share of
the Company, in registered form and with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-), and to have it fully paid up by a
contribution in kind to the Company consisting of a receivable which was lent by the Sole Partner to the Company in
relation to transaction called ''AMB Le Havre'' (the ''Claim'').
The contribution in kind in an aggregate amount of five hundred ninety-six thousand two hundred and twenty-five
euro (EUR 596,225.-) is to be allocated as follows:
- an amount of twenty-five euro (EUR 25.-) is to be allocated to the corporate capital account of the Company;
- an amount of five hundred ninety-six thousand and two hundred euro (EUR 596,200) is to be allocated to the share
premium account of the Company.
It further results from a declaration issued on June 18th, 2008 by the Sole Partner (the "Declaration") that:
- based on generally accepted accounting principles, the net worth of the Claim to be contributed to the Company is
valued at five hundred ninety-six thousand two hundred and twenty-five euro (EUR 596,225.-) and since the date of the
Declaration no material changes have occurred which would have depreciated the contribution to be made to the Com-
pany;
- the Claim to be contributed to the Company is freely transferable by the Sole Partner and it is not subject to any
restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities for the transfer of the legal ownership of the Claim to be contributed to the Company have been or
will be accomplished by the Sole Partner in cooperation with the Company.
It further results from a certificate issued on June 18th, 2008 by the Company (the "Certificate'') that:
- based on generally accepted accounting principles, the net worth of the Claim to be contributed to the Company is
valued at five hundred ninety-six thousand two hundred and twenty-five euro (EUR 596,225.-) and since the date of the
Certificate no material changes have occurred which would have depreciated the contribution to be made to the Com-
pany; and
- all formalities for the transfer of the legal ownership of the Claim to be contributed to the Company have been or
will be accomplished by the Company in cooperation with the Sole Partner.
Such Declaration and the Certificate, after signature "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Partner resolves to amend article 5, first paragraph, of the articles
of association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:
"5.1. The capital of the Company is fixed at thirty-seven thousand and twenty-five euro (EUR 37,025.-) represented
by one thousand four hundred and eighty-one (1,481) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR
25.-) each, all subscribed and fully paid-up".
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be
borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
five thousand euro (EUR 5,000).
85087
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancies between the English
version and the French version, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing party, the proxyholder signed
together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
En l'an deux mille huit, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
AMB Europe Luxembourg Holding 2 S. à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.995,
en sa capacité d'associé unique d'AMB Le Havre Holding S. à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, im-
matriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133.855, constituée le 7 novembre
2007 en vertu d'un acte notarié du notaire soussigné, publié le 20 décembre 2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations sous le numéro 2963 (la "Société"),
ici représentée par Madame Barbara MALANIUK, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à Luxembourg le 18 juin 2008.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire soussigné et le mandataire agissant pour le
compte de la partie comparante, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregis-
trement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. AMB Europe Luxembourg Holding 2 S. à r.l. est l'associé unique ("l'Associé Unique") de la Société;
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à trente-sept mille euros (EUR 37.000.-) divisé en mille quatre
cent quatre-vingt (1.480) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.
Sur ceci, la partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première décisioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de vingt-cinq euros (EUR
25.-) aux fins de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente-sept mille euros (EUR 37.000.-)
représenté par un mille quatre cent quatre-vingt (1.480) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à un montant de trente-sept mille vingt-cinq euros (EUR 37.025.-) par l'émission
d'une (1) nouvelle part sociale, ayant une valeur comptable de vingt-cinq euros (EUR 25.-).
<i>Souscription - libérationi>
Ces faits étant exposés, l'Associé Unique, prédésigné et représenté comme ci-dessus, déclare souscrire une (1) nou-
velle part sociale de la Société, sous forme nominative et ayant une valeur comptable de vingt-cinq euros (EUR 25,-), et
la libérer entièrement par un apport en nature à la Société consistant dans une créance qui a été prêtée par l'Associé
Unique à la Société dans le cadre de la transaction dénommée "AMB Le Havre" (la "Créance").
L'apport en nature d'un montant total de cinq cent quatre-vingt-seize mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 596.225.-)
est à allouer comme suit:
- un montant de vingt-cent euros (EUR 25,-) est à allouer au compte capital social de la Société;
- un montant de cinq cent quatre-vingt-seize mille deux cent euros (EUR 596.200.-) est à allouer au compte prime
d'émission de la Société.
De plus, il ressort d'une déclaration émise par la gérance de l'Associé Unique à la date du 18 juin 2008 (la "Déclaration")
que:
- conformément aux principes comptables généralement admis, la valeur nette de la Créance devant être apportée à
la Société est estimée à cinq cent quatre-vingt-seize mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 596.225.-) et depuis la date
de la Déclaration il n'y a pas eu de changement matériel, qui aurait déprécié l'apport devant être fait à la Société;
- la Créance devant être apportée à la Société est librement cessible par l'Associé Unique et n'est pas soumise à des
restrictions ou grevée d'un nantissement ou d'un droit de gage limitant sa transmissibilité ou diminuant sa valeur; et
- toutes les formalités pour le transfert de la possession de Créance devant être apportée à la Société ont été ou
seront accomplisses par l'Associé Unique en coopération avec la Société.
85088
De plus, il ressort d'un certificat émis par la gérance de la Société à la date du 18 juin 2008 (le "Certificat ") que:
- conformément aux principes comptables généralement admis, la valeur nette de la Créance devant être apportée à
la Société est estimée à cinq cent quatre-vingt-seize mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 596.225.-) et depuis la date
de la Déclaration il n'y a pas eu de changement matériel, qui aurait déprécié l'apport devant être fait à la Société; et
- toutes les formalités pour le transfert de la possession de Créance devant être apportée à la Société ont été ou
seront accomplisses par la Société en coopération avec l'Associé Unique.
Ladite Déclaration et le Certificat, après signature "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
<i>Deuxième décisioni>
En conséquence de la décision ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5, premier paragraphe, des statuts
de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
"5.1. Le capital social de la Société est fixé à trente-sept mille vingt-cinq euros (EUR 37.025.-) représenté par mille
quatre cent quatre-vingt-un (1.481) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-), toutes souscrites et entièrement libérées."
<i>Évaluation des fraisi>
Le montant total des frais, charges, rémunérations ou dépenses, sous toute forme qu'ils soient, qui incombent à la
Société ou qui seront facturés à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à cinq mille euros
(EUR 5.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence entre la version en anglais et la version en français,
la version en anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête du présent acte.
Le document ayant été lu au mandataire agissant pour le compte de la partie comparante, le mandataire a signé le
présent acte original avec le notaire.
Signé: B. Malaniuk et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juin 2008. LAC/2008/26425. - Reçu deux mille neuf cent quatre-vingt-un euros
treize cents, Eur 0,50% = 2.981,13.
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008085793/5770/162.
(080098149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Interflog S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 129.377.
Im Jahre zweitausendacht, den achten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.
Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der Gesellschaft INTERFLOG S.A.,
eine Aktiengesellschaft mit Sitz zu L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal, eingetragen im Handelsregister beim Be-
zirksgericht Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 129.377, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den
Notar Joseph ELVINGER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 30. Mai 2007, veröffentlicht im Memorial C Nummer 1716
vom 14. August 2007.
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn René MORIS, conseil fiscal, wohnhaft in Rameldange.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Wolfgang ENGEL, Bankkaufmann, mit beruflicher Anschrift in Lu-
xemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Gerhard KÖRBER, Betriebswirt, wohnhaft in Sarregue-
mines (Frankreich).
Da somit das Versammlungsbüro zusammengesetzt wurde, ersucht der Vorsitzende den unterzeichnenden Notar
folgendes zu beurkunden:
I.- Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
85089
1.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um zweihundertvierzigtausend Euro (EUR 240.000,-) um dasselbe auf zweihun-
dertneunzigtausend Euro (EUR 290.000,-) zu bringen durch Schaffung von vierundzwanzigtausend (24.000) neuen Aktien
mit einem Nominalwert von je zehn Euro (EUR 10,-), voll eingezahlt, zusammen mit einer Emissionsprämie von insgesamt
einhundertzwanzigtausend Euro (EUR 120.000,-).
2.- Zeichnung der neuen Aktien durch den alleinigen Aktionär - Einzahlung.
3.- Änderung von Artikel 5, Absatz 1, der Satzung, wie folgt:
'' Art. 5. (Absatz 1). Das gezeichnete Kapital wird auf zweihundertneunzigtausend Euro (EUR 290.000,-) festgesetzt,
eingeteilt in neunundzwanzigtausend (29.000,-) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-), wobei jede
einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen über je eine Stimme verfügt."
II.- Dass die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter, unter der Stückzahl der vertretenen Aktien
auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, nachdem sie durch die Aktionäre beziehungsweise
deren Bevollmächtigte unterschrieben wurde, wird durch das Versammlungsbüro geprüft und unterschrieben.
Die eventuellen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, werden, nach gehöriger "ne varietur" Unterzeichnung
durch die Parteien und den instrumentierenden Notar, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden,
als Anlage beigebogen.
III.- Dass in gegenwärtiger Versammlung das gesamte Aktienkapital vertreten ist, dass somit die Versammlung regel-
mässig gebründet und befugt ist, über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.
Sodann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von zweihundertvierzigtausend Euro
(EUR 240.000,-) zu erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Stand von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) auf zwei-
hundertneunzigtausend Euro (EUR 290.000,-) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von vierundzwanzigtausend
(24.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von zehn Euro (EUR 10,-) je Aktie, mit den gleichen Rechten und Verpflich-
tungen wie die bestehenden Aktien.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle neuen Aktien wurden gezeichnet durch den alleinigen Aktionär, die Gesellschaft LOMBARD INTERNATIONAL
ASSURANCE SA, mit Sitz in Senningerberg, 2, route de Trèves, RCS B 37.604, vertreten durch die Banque LB Lux S.A.,
mit Sitz in Luxemburg, welche hier vertreten ist durch Herrn Wolfgang ENGEL, vorgenannt, auf Grund einer privat-
schriftlichen Vollmacht vom 14. April 2008, welche hier beigefügt bleibt, und welche erklärt die vierundzwanzigtausend
(24.000) neuen Aktien zu zeichnen und die gesamten neuen Aktien in Höhe von zweihundertvierzigtausend Euro (EUR
240.000,-) in bar einzuzahlen zusammen mit einer Emissionsprämie von insgesamt einhundertzwanzigtausend Euro (EUR
120.000,-).
Die neuen Aktien und die Emissionsprämie wurden ganz in bar eingezahlt, so dass der Betrag von dreihundertsech-
zigtausend Euro (EUR 360.000,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar durch ein
Bankzertifikat nachgewiesen wurde.
<i>Zweiter Beschlussi>
Auf Grund des ersten Beschlusses beschliesst die Generalversammlung einstimmig Artikel 5, Absatz 1, der Satzung
wie folgt abzuändern:
'' Art. 5. (Absatz 1). Das gezeichnete Kapital wird auf zweihundertneunzigtausend Euro (EUR 290.000,-) festgesetzt,
eingeteilt in neunundzwanzigtausend (29.000) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-), wobei jede
einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen über je eine Stimme verfügt."
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften vom 10. August 1915 erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Kapitalerhöhung obliegen, werden auf ungefähr drei-
tausendsiebenhundert Euro (EUR 3.700,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen am Datum wie eingangs erwähnt zu Senningerberg.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchliche Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: René Moris, Wolfgang Engel, Gerhard Körber, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 15 mai 2008, LAC/2008/19713. — Reçu mille huit cents euros à 0,50%: 1.800 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
85090
Senningerberg, den 3. Juli 2008.
Paul BETTINGEN.
Référence de publication: 2008085814/202/78.
(080098207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Metros Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 6.470.
DISSOLUTION
L'an deux mille huit, le onze juin.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, né le 14 décembre 1958 à Trieste (Italie) demeurant professionnellement
à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724,
"le mandataire"
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Ersona Holding AG, ayant son siège social à Ennetbürgen (Suisse),
"le mandant"
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-
clarations et constatations:
I. La société METROS HOLDING S.A. a été constituée en date du 31 juillet 1963 par devant Maître Camille Hellinckx
notaire de résidence à Mersch, suivant acte publié au Recueil Spécial du Mémorial C
II. Les statuts de la société METROS HOLDING S.A. ont été modifiés comme indiqués ci-après:
- suivant acte reçu le 12 décembre 1967, publié au Mémorial C numéro 8 du 18 janvier 1968,
- suivant acte reçu le 18 juin 1993, publié au Mémorial C numéro 418 du 13 septembre 1993,
- suivant acte reçu le 13 août 1996, publié au Mémorial C numéro 575 du 8 novembre 1996,
- suivant acte reçu le 3 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 683 du 22 septembre 2000.
III. La société a établi son siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et est inscrite au
R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro B 6.470,
IV. Le capital social de la société METROS HOLDING S.A. est de EUR 575.000,- (cinq cent soixante quinze mille
Euros), représentés par 2.300 (deux mille trois cents) actions ayant chacune une valeur nominale de EUR 250,- (deux
cent cinquante Euros), intégralement libéré,
V. Que son mandant est devenu propriétaire de la totalité des actions de la société METROS HOLDING S.A., ci-dessus
désignée, qui en sa qualité d'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société avec
effet à ce jour,
VI. Que son mandant déclare avoir pleine connaissance des statuts de la société, qu'il connaît parfaitement la situation
financière de la société,
VII. Que son mandant, prénommé, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société, qu'en qualité d'actionnaire
unique de cette même société, déclare en outre que l'activité de la société a cessé, qu'il est investi de tout l'actif de la
société, que le passif connu de la société a été réglé ou approvisionné, le mandant prend à sa charge tout passif ou tout
engagement financier, connu ou inconnu de la société pouvant éventuellement encore exister à charge de cette dernière.
Partant de cela, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
VIII. Que par conséquent, tous les administrateurs et le commissaire aux comptes actuels de la société dissoute, sont,
par la présente, déchargés de leurs fonctions,
IX. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant 5 ans (cinq) à l'adresse de domiciliation
de la société indiquée ci-après:
Société Européenne de Banque S.A., 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
X. Que le mandataire de l'actionnaire unique a procédé à l'annulation des titres au porteur et ceci en présence du
notaire instrumentant.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. CAPUZZO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg AC, le 13 juin 2008, LAC/2008/23998. — Reçu douze euros (12 euros).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): F. SCHNEIDER.
85091
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2008.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2008085799/211/57.
(080098393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Fundtrust Holding S.A., Société Anonyme,
(anc. BERGER TRUST Luxembourg HOLDING S.A.).
Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 41.323.
In the year two thousand and eight, on the ninth day of June,
Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of "BERGER TRUST Luxembourg HOLDING S.A.", a
joint stock company under Luxembourg Law, having its registered office in L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle,
incorporated by deed of the notary André SCHWACHTGEN, then residing in Luxembourg, on 12 August 1992, published
in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 593 on 14 December 1992, modified by deed of the
said notary SCHWACHTGEN, on 13 November 1992, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C", number 71 on 13 February 1993, modified by deed of the said notary SCHWACHTGEN, on 23 February 1993,
published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 249 on 27 May 1993, modified by deed of
the said notary SCHWACHTGEN, on 23 October 1996, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C", number 32 on 27 January 1997, modified by deed of the said notary SCHWACHTGEN, on 7 February 2000, published
in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 388 on 3 May 2000, modified by a resolution of the
board of directors on 23 March 2000 in agreement with the law of 10 December 1998, published in the "Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C", number 513 on 19 July 2000, registered at the Trade and Companies' Register in Lu-
xembourg City under section B and number 41,323.
The meeting was opened with Mr Micael DA SILVA CARNEIRO, private employee, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Laurence TRAN, private employee, residing in Rollingen/Mersch.
The meeting elected as scrutineer Mrs Christine PICCO, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
Change of the company's name from "BERGER TRUST Luxembourg HOLDING S.A." to "FUNDTRUST HOLDING
S.A.", and subsequent amendment of article one of the Articles of Incorporation.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed to
the present deed.
III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and received knowledge of the agenda prior to this
meeting, no convening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on the item of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:
<i>Resolutioni>
The general meeting decides to change, with immediate effect, the company's name from "BERGER TRUST Luxem-
bourg HOLDING S.A." to "FUNDTRUST HOLDING S.A.".
As a consequence of the foregoing, the general meeting decides to amend Article one of the Articles of Incorporation
of the company and to replace the current text by the following:
« Art. 1
er
. Il est constituée par les présentes entre les comparants à l'acte de constitution et tous ceux qui deviendront
actionnaires dans la suite, une société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée "FUNDTRUST HOLDING S.A."»
There being no further business on the agenda, the meeting is terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the French and the English texts, the English text will be prevailing.
85092
In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this
deed.
The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and
residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary this original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le neuf juin,
Par devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BERGER TRUST Luxembourg
HOLDING S.A.", ayant son siège social à L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle, constituée suivant acte reçu par le
notaire André SCHWACHTGEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 12 août 1992, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 593 du 14 décembre 1992, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire
SCHWACHTGEN, en date du 13 novembre 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
71 du 13 février 1993, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire SCHWACHTGEN, en date du 23 février 1993,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 249 du 27 mai 1993, modifiée suivant acte reçu par
le prédit notaire SCHWACHTGEN, en date du 23 octobre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 32 du 27 janvier 1997, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire SCHWACHTGEN, en date du 7 février
2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 388 du 3 mai 2000, modifiée suivant procès-
verbal du conseil d'administration en date du 23 mars 2000 en accord avec la loi du 10 décembre 1998, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Assocations C, numéro 513 du 19 juillet 2000, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 41.323.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Micael DA SILVA CARNEIRO, employé privé, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
qui désigne comme secrétaire Madame Laurence TRAN, employée privée, demeurant à Rollingen/Mersch.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christine PICCO, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
Modification de la dénomination sociale de la société de "BERGER TRUST Luxembourg HOLDING S.A." en "FUND-
TRUST HOLDING S.A.", et modification subséquente de l'article premier des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées "ne varietur" par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier, avec effet immédiat, la dénomination sociale de la société de "BERGER TRUST
Luxembourg HOLDING S.A." en "FUNDTRUST HOLDING S.A.".
Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article premier des statuts de la
société, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il est constituée par les présentes entre les comparants à l'acte de constitution et tous ceux qui deviendront
actionnaires dans la suite, une société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée "FUNDTRUST HOLDING S.A."»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la demande des comparants, le
présent acte est rédigé en français suivi d'une traduction anglaise; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
85093
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres
du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: C. Picco, M. Da Silva, L. Tran, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juin 2008. LAC/2008/23710. - Reçu douze euros 12 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): F. Schneider.
Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Emile SCHLESSER.
Référence de publication: 2008085857/227/115.
(080098228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
DREYER RUPPERT REAL ESTATE S.A. Development & Investment, Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 25, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 122.266.
Im Jahre zweitausendacht, den siebenundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom METZLER, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg,
hat sich die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft "DREYER RUPPERT REAL
ESTATE S.A. DEVELOPMENT & INVESTMENT", mit Gesellschaftssitz in L-1911 Luxemburg, 9, rue du Laboratoire, ein-
gefunden.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 28. No-
vember 2006, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 115 vom 5. Februar 2007.
Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean Seckler, mit
Amtssitz in Junglinster, am 27. März 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1114 vom 9. Juni 2007.
Die Gesellschaft ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Sektion B und der
Nummer 122.266.
<i>Vorstandi>
Die Tagung wird um 9.00 Uhr, unter dem Vorsitz von Herrn Charles RUPPERT, Verwaltungsratsmitglied von Gesell-
schaften, wohnhaft in L-5433 Niederdonven, 59, rue des Romains, eröffnet.
Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär Herrn Christophe HOELTGEN, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-1261
Luxemburg, 101, rue de Bonnevoie.
Die Generalversammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn Jean Roland DIDIER, Verwaltungsratsmitglied von Ge-
sellschaften, wohnhaft in L-8023 Strassen, 18, rue des Violettes.
<i>Zusammensetzung der Versammlungi>
Die bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesenden Aktionäre sowie die Anzahl der ihnen gehörenden Aktien
wurden auf einer von den anwesenden Aktionären unterschriebenen Anwesenheitsliste aufgeführt, und auf welche, von
dem Vorstand angefertigte Liste, die Mitglieder der Versammlung erklären sich zu berufen.
Die genannte Anwesenheitsliste, nachdem sie von dem Vorstand und dem amtierenden Notar "ne varietur" gezeichnet
wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde, zusammen mit den aufgeführten Vollmachten, als Anlage beigebogen um mit der-
selben einregistriert zu werden.
<i>Erklärung des Vorsitzendeni>
Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar dieselben zu beurkunden und zwar:
I.- Die gegenwärtige Generalversammlung hat sich mit der folgenden Tagesordnung zu befassen:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1911 Luxemburg, 9, rue du Laboratoire, nach L-1274 Howald, 25, rue des
Bruyères;
2.- Abänderung des ersten Satzes von Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
"Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Howald.".
II.- Das Gesellschaftskapital ist zur Zeit in dreitausendzweihundert (3.200) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn
Euro (EUR 10.-) eingeteilt. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche dreitausendzweihundert (3.200) Aktien
anwesend sind. Die Versammlung kann somit rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen, ohne dass es
erfordert ist, Rechenschaft über die Form der Einberufungen abzugeben.
85094
<i>Feststellung der Gültigkeit der Generalversammlungi>
Die vom Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen wurden von dem Stimmenzähler überprüft und von der General-
versammlung für richtig befunden. Die Generalversammlung bekennt sich als rechtmässig einberufen und fähig, rechtsgültig
über die vorliegenden Punkte der Tagesordnung zu beraten.
<i>Beschlüssei>
Nach vorangehender Beratung hat die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-1911 Luxemburg, 9, rue du Laboratoire, nach L-1274 Howald,
25, rue des Bruyères, zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Um dem vorhergehenden Beschluss Rechnung zu tragen, beschliesst die Versammlung den ersten Satz von Artikel 2
der Satzung der Gesellschaft, abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
"Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Howald.".
<i>Abschlussi>
Da die Tagesordnung erschöpft ist und keiner der Anwesenden das Wort erbittet, schliesst der Vorsitzende die
Versammlung.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Auslagen und Gebühren die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf
den Betrag von achthundert Euro (EUR 800.-) abgeschätzt.
Worüber Protokoll, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg, in der
Amtsstube.
Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden in einer ihnen kundigen Sprache an die Mitglieder der Ge-
neralversammlung, haben die Vorstandsmitglieder, welche dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-
men, Stand und Wohnort bekannt sind, gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Charles RUPPERT, Christophe HOELTGEN, Jean Roland DIDIER, Tom METZLER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juin 2008. Relation: LAC/2008/26450. — Reçu € 12.- (douze euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations zwecks Veröffent-
lichung erteilt.
Luxemburg-Bonneweg, den 4. Juli 2008.
Tom METZLER.
Référence de publication: 2008085796/222/74.
(080098167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Atelier Pia Mai GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1218 Luxembourg, 62, rue Baudouin.
R.C.S. Luxembourg B 139.745.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendacht, den ersten Juli.
Vor uns Notar Blanche MOUTRIER, mit Amtssitz zu Esch/Alzette, Grossherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
1. Frau Pia HORMISCH, Diplom Ing. Architektin, wohnhaft in L-1218 Luxemburg, 62, rue Baudouin.
2. Herr Robert HORNUNG, Geschäftsführer, wohnhaft in L-1409 Luxemburg, 32, rue Edmond Dune.
Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen
zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Die Unterzeichneten gründen hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der sie die nachstehende
Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „ATELIER PIA MAI GmbH" und wird unter der Firmenbezeichnung MAP ver-
marktet werden.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
85095
Art. 4. Der Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Architekturbüros.
Die Gesellschaft kann alle anderen Aktivitäten, industrieller, geschäftlicher und finanzieller Natur ausführen, die diesen
Gegenstand direkt oder indirekt fördern.
Die Gesellschaft ist befugt, gleiche oder ähnliche Unternehmen zu errichten oder zu erwerben, sich an derartigen
Unternehmen zu beteiligen sowie Zweigniederlassungen zu errichten.
Die Gesellschaft untersagt sich jedwede Beteiligung oder Tätigkeit welche einen Interessenkonflikt herbeiführen oder
die berufliche Unabhängigkeit des freischaffenden Architekten respektiv beratenden Ingenieurs in Frage stellen könnte.
Die Gesellschaft verpflichtet sich ausdrücklich die gesetzlichen und diesbezüglichen beruflichen Vorschriften welchen die
betreffenden Tätigkeiten unterliegen, zu befolgen.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) eingeteilt in 1.250 (eintausendz-
weihundertfünfzig) Anteile zu je EUR 10 (zehn Euro).
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes
über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 7. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 8. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Uebertragung von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Zustimmung der Gesellschafter welche mindestens fünfundsiebzig Prozent
des Gesellschaftskapitals vertreten. Im Todesfall kann eine Uebertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmen-
mehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesell-
schaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig Tagen nach Verweigerung der Uebertragung an
Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.
Art. 9. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 10. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigen-
tums oder von Firmenschriftstücken stellen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der
Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.
Der oder die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen
und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten, jedoch können sie nur mit vorheriger Zustim-
mung des Mitgesellschafters oder von fünfundsiebzig Prozent der Gesellschafter Immobilien erwerben, Hypotheken
aufnehmen, Verpfändungen vornehmen und Beteiligungen an anderen Gesellschaften übernehmen.
Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.
Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen
kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Art. 16. Am 31 Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 18. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.
Das Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen
Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben
und Vergütungen ernannt werden.
Art. 20. Wenn und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn
von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
85096
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2008.
<i>Kapitalzeichnungi>
Von diesem Gesellschaftskapital zeichnet:
1. Frau Pia HORMISCH, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
938 Anteile
2. Herre Robert HORNUNG, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312 Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 Anteile
Alle 1.250 Anteile wurden in bar, voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro)
der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Sodann sind die Komparenten, handelnd wie erwähnt, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zu einer ausse-
rordentlichen Gesellschafterversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Zum Geschäftsführer wird ernannt:
1. Frau Pia HORMISCH, Diplom Ing. Architektin, geboren am 27. August 1972 in Neuerburg/Eifel, Deutschland, wohn-
haft in L-1218 Luxemburg, 62, rue Baudouin, vorbenannt, welche die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift in allen
Fällen verpflichten kann;
mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.
Der Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.
Das Mandat des Geschäftsführers ist für unbestimmte Dauer gültig.
Er kann wiedergewählt werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1218 Luxemburg, 62, rue Baudouin.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Esch/Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: P. Hormisch, R. Hornung, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 02 JUILLET 2008. Relation: EAC/2008/8789 — Reçu soixante-deux euros cinquante cents
12.500.- à 0,5% = 62,50.-.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 7 juillet 2008.
BLANCHE MOUTRIER.
Référence de publication: 2008085827/272/114.
(080098730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
CEREP Pic Place S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.390,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 128.650.
In the year two thousand and eight, on the eighteenth of June,
Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned
THERE APPEARED:
85097
CEREP III UK S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at
2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 130.447 (the "Sole Unitholder");
in its capacity as Sole Unitholder of CEREP Pic Place S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 128.650 and incorporated by
a deed drawn up by Me Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 16 May 2007 and whose articles of incorporation
(the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number
1540, dated on 24 July 2007, page 73905;
since the incorporation of the Company, the Articles have been amended on 11 July 2007, pursuant to a deed drawn
up by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, and published in the Mémorial number 2247, dated on 9
October 2007, page 107824;
hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg
law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "Law").
The Sole Unitholder is represented at the meeting by Flora Gibert, jurist, residing at Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg), by virtue of proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing
person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
<i>First resolutioni>
The Sole Unitholder resolves to increase the Company's unit capital by an amount of six thousand eight hundred and
forty British Pounds (GBP 6,840.-) so as to bring the unit capital from its current amount of eight thousand five hundred
and fifty British Pounds (GBP 8,550.-) to fifteen thousand three hundred and ninety British Pounds (GBP 15,390.-) by
changing the nominal value of the existing units from ten British Pounds (GBP 10.-) per unit to eighteen British Pounds
(GBP 18.-) per unit.
Therefore, the global contribution of six thousand eight hundred forty British Pounds (GBP 6,840.-) for the new units
will be entirely allocated to the unit capital.
The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the Articles of the Company is amended and now
reads as follows:
'' Art. 6. The unit capital is fixed at fifteen thousand three hundred and ninety British Pounds (GBP 15,390), represented
by eight hundred and fifty five (855) units of eighteen British Pounds (GBP 18) each".
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred Euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, said proxyholder of the appearing person signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le dix-huit juin.
Par-devant M
e
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
CEREP III UK S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 130.447 (l'"Associé Unique");
en qualité d'Associé Unique de CEREP Pic Place S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au
2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce de Luxembourg sous le numéro B 128.650 et constituée selon un acte dressé par M
e
Elvinger, notaire de
résidence à Luxembourg, le 16 mai 2007 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1540, en date du 24 juillet 2007, page 73905;
depuis la création de la Société, les Statuts de la Société ont été modifiés le 11 juillet 2007, par un acte dressé par
Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, et publié au Mémorial numéro 2247, en date du 9 octobre
2007, page 107824;
85098
prend ici les résolutions suivantes conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifiée (la "Loi").
L'Associé Unique est représenté à l'assemblée par Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé, paraphée ne varietur par la mandataire du comparant et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de six mille huit cent
quarante Livres Sterling (GBP 6.840,-) afin de le porter de son montant actuel de huit mille cinq cent cinquante Livres
Sterling (GBP 8.550,-) à quinze mille trois cent quatre-vingt dix Livres Sterling (GBP 15.390,-) en changeant la valeur
nominale des Parts Sociales existantes de dix Livres Sterling (GBP 10,-) à dix-huit Livres Sterling (GBP 18,-) par Part
Sociale.
L'apport total de six mille huit cent quarante Livres Sterling (GBP 6.840,-) sera entièrement alloué au capital social de
la Société.
Les documents justificatifs de l'existence et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.
<i>Seconde résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:
'' Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille trois cent quatre-vingts dix livres sterling (GBP 15.390) représenté par
huit cent cinquante-cinq (855) parts sociales d'une valeur nominale de dix-huit livres sterling (GBP 18) chacune".
<i>Frais et dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à mille trois cents Euro.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la personne comparante, connue du notaire instru-
mentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la personne comparante a signé avec le notaire
le présent acte.
Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 juin 2008, Relation: LAC/2008/25169. — Reçu quarante-trois euros et onze cents
(43,11.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 30 juin 2008.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2008085789/211/102.
(080098183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Vodafone Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 73.612.
In the year two thousand and eight, on the thirtieth day of May.
Before the undersigned Maître Joëlle Baden, notary residing in Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Vodafone International 1 S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its reg-
istered office at L-2540 Luxembourg, Pixel Building, 3
ème
étage, 15, rue Edward Steichen, recorded with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under section B number 83.088,
duly represented by Ms Catherine Willemyns, licenciée en droit, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on 26 May 2008.
The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of Vodafone Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée, in-
corporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-2540 Luxembourg, Pixel Building,
3
ème
étage, 15, rue Edward Steichen, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number
85099
B 73.612, incorporated pursuant to a notarial deed dated 31 December 1999, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 217 of the 20th of March 2000. The articles of incorporation have been amended for
the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 29 February 2008, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 992 of 22 April 2008 (hereinafter the "Company").
The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital, then takes the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder acknowledges that the Company repurchased four hundred thirteen thousand three hundred
sixty-one (413,361) shares on 28 May 2008.
The sole shareholder decides to reduce the share capital of the Company by an amount of four hundred thirteen
million three hundred sixty-one thousand US Dollars (USD 413,361,000), in order to bring it from its current amount of
sixty-two billion three hundred seventy-eight million six hundred eighty-nine thousand US Dollars (USD 62,378,689,000)
to an amount of sixty-one billion nine hundred sixty-five million three hundred twenty-eight thousand US Dollars (USD
61,965,328,000), through the cancellation of four hundred thirteen thousand three hundred sixty-one (413,361) shares
having a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000) each, which are held by the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, article 6 of the articles of incorporation is amended and now reads as follows:
" Art. 6. The Company's share capital is set at sixty-one billion nine hundred sixty-five million three hundred twenty-
eight thousand US Dollars (USD 61,965,328,000), represented by sixty-one million nine hundred sixty-five thousand three
hundred twenty-eight (61,965,328) shares with a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000) each."
Whereof this deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that this deed is worded in English,
followed by a French version; on request of the proxyholder of the appearing party and in case of divergences between
the English and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with the
notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le trente mai,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence au Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Vodafone International 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, Pixel Building, 3
ème
étage, 15, rue Edward Steichen, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.088,
dûment ici représentée par Mademoiselle Catherine Willemyns, licenciée en droit, demeurant professionnellement à
Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 26 mai 2008.
La procuration, signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante est la seule associée de la société Vodafone Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, Pixel
Building, 3
ème
étage, 15, rue Edward Steichen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 73.612, constituée suivant acte notarié en date du 31 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 217 du 20 mars 2000. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du
notaire soussigné en date du 29 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 992
du 22 avril 2008 (ci-après la «Société»).
La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique prend note du fait que la Société a racheté quatre cent treize mille trois cent soixante et une (413.361)
parts sociales le 28 mai 2008.
L'associée unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de quatre cent treize millions trois
cent soixante et un mille US Dollars (USD 413.361.000) pour le réduire de son montant actuel de soixante-deux milliards
trois cent soixante-dix-huit millions six cent quatre-vingt-neuf mille US Dollars (USD 62.378.689.000) à un montant de
soixante et un milliards neuf cent soixante-cinq millions trois cent vingt-huit mille US Dollars (USD 61.965.328.000) par
85100
l'annulation de quatre cent treize mille trois cent soixante et une (413.361) parts sociales d'une valeur nominale de mille
US Dollars (USD 1.000) chacune, qui sont détenues par la Société.
<i>Seconde résolutioni>
Suite à la première résolution, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à soixante et un milliards neuf cent soixante-cinq millions trois cent vingt-huit mille
US Dollars (USD 61.965.328.000) représenté par soixante et un millions neuf cent soixante-cinq mille trois cent vingt-
huit (61.965.328) parts sociales avec une valeur nominale de mille US Dollars (USD 1.000) chacune.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: C. WILLEMYNS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juin 2008, LAC/2008/22669. — Reçu douze euros € 12,-.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): SCHNEIDER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande aux fins de publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2008.
Joëlle BADEN.
Référence de publication: 2008085521/7241/94.
(080097071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Prologis Management Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 131.298.
In the year two thousand and eight, on the ninth of May,
before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
PLD INTERNATIONAL INCORPORATED, a company incorporated under the laws of the United States of America,
having its registered office at 2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America,
recorded with the corporate register of the State of Delaware, United States of America, under the number 2757518,
here represented by Mr Peter Cassells, residing professionally in Luxembourg,
acting in his capacity as First Vice-President of PLD International Incorporated and duly authorized to sign with his
sole signature on behalf of such company pursuant to the provisions of Article IV, section 5 of its articles of incorporation.
Such appearing party, represented as stated hereabove, is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of ProLogis
Management Services S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 131.298, incorporated pursuant
to a deed of the undersigned notary dated July 17, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 2236 of October 8, 2007.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, required the undersigned notary to state the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by ten million five hundred and forty-five
thousand euro (EUR 10,545,000) from its current amount of one hundred fifty thousand euro (EUR 150,000) up to ten
million six hundred and ninety-five thousand euro (EUR 10,695,000), by the issue of ten thousand five hundred and forty-
five (10,545) new shares of the Company, without designation of a nominal value.
The ten thousand five hundred and forty-five (10,545) newly issued shares of the Company amounting to ten million
five hundred and forty-five thousand euro (EUR 10,545,000), are hereby entirely subscribed and fully paid up by the Sole
Shareholder, prenamed, represented as above stated, by a contribution in kind consisting of one hundred and twenty-
five (125) shares with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000) each (the "Shares") representing the entire share
capital of ProLogis Management S.à r.l., incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and recorded with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under number B 70.940, for an aggregate amount of ten million five hundred and forty-five thousand
two hundred and seventy-three euro (EUR 10,545,273) out of which an amount of ten million five hundred and forty-five
85101
thousand euro (EUR 10,545,000) is allocated to the share capital and an amount of two hundred and seventy-three euro
(EUR 273.-) to the free reserve account.
It results from a certificate issued on 9 May 2008, by a manager of ProLogis Management S.à r.l., prenamed, and from
a certificate issued on 9 May 2008, by an officer of the Sole Shareholder, that the Shares are held by the Sole Shareholder,
have been fully paid-up, are not encumbered and are freely transferable to the Company.
The reality and the value of the contribution in kind have been proved to the undersigned notary by the above men-
tioned manager's certificate and officer's certificate delivered by ProLogis Management S.à r.l., prenamed, and by the Sole
Shareholder.
The above mentioned manager's certificate and officer's certificate will remain attached to the present deed to be filed
at the same time with the registration authorities.
If supplementary formalities are required in order to implement the transfer of the Shares, the Sole Shareholder will
undertake all the necessary steps as soon as possible and provide the undersigned notary with the relevant proof that
such formalities have been accomplished as soon as possible.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the resolution adopted above, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles
of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:
" Art. 6. The Company's share capital is set at ten million six hundred and ninety-five thousand euro (EUR 10,695,000),
represented by ten thousand six hundred and ninety-five (10,695) shares without designation of a nominal value.
Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings."
<i>Reference to the law of December 29,1971i>
As the shares newly issued by the Company have hereby been entirely subscribed by a contribution in kind consisting
of shares representing 100% of the share capital of ProLogis Management S.à r.l., prenamed, which registered office is
located in a EU member state, the Sole Shareholder declares that the present capital increase has been realized in ac-
cordance with article 4-2 of the law of December 29, 1971, as amended, regarding the tax on capital collections in civil
and commercial companies, which provides for the exemption from the capital duty.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall borne by the Company as a result
of its increase of share capital are estimated at five thousand euro (EUR 5,000.00).
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at
the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the representative of the appearing party, said representative signed together with
the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le neuf mai.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
a comparu:
PLD INTERNATIONAL INCORPORATED, une société créée sous la loi des Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège
social au 2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, inscrite au registre de
commerce de Delaware, Etats-Unis d'Amérique sous le numéro 2757518,
ici représentée par Monsieur Peter Cassells, résidant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de Premier Vice-président de la société PLD INTERNATIONAL INCORPORATED et dûment
autorisé à engager celle-ci par sa seule signature en vertu des dispositions de l'article IV, section 5 des statuts de la société.
La comparante, dûment représentée comme dit ci-avant, est l'associée unique (l'«Associée Unique») de ProLogis
Management Services S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.298, constituée suivant un acte du soussigné notaire en date du
17 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2236 du 8 octobre 2007.
L'Associée Unique, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'Associée Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de dix millions cinq cent quarante-
cinq mille euros (EUR 10.545.000), pour le porter de son montant actuel de cent cinquante mille euros (EUR 150.000) à
85102
dix millions six cent quatre-vingt-quinze mille euros (EUR 10.695.000) par l'émission de dix-mille cinq cent quarante-cinq
(10.545) nouvelles parts sociales de la Société sans désignation de valeur nominale.
Les dix mille cinq cent quarante-cinq (10.545) parts sociales de la Société nouvellement émises pour un montant de
dix millions cinq cent quarante-cinq mille euros (EUR 10.545.000) sont intégralement souscrites et libérées par l'Associée
Unique, prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, par un apport en nature constitué de cent vingt-cinq (125)
parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune (les «Parts Sociales») représentant l'intégralité
du capital social de ProLogis Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70.940, pour un montant total de dix millions cinq cent
quarante-cinq mille deux cent soixante-treize euros (EUR 10.545.273,-), duquel un montant dix millions cinq cent qua-
rante-cinq mille euros (EUR 10.545.000,-) est alloué au capital social et un montant de deux cent soixante-treize euros
(EUR 273,-) au compte de réserves libres.
Il résulte d'un certificat daté du 9 mai 2008, émis par le gérant de ProLogis Management S.à r.l., préqualifée, et d'un
certificat daté du 9 mai 2008, émis par un agent de l'Associée Unique, que les Parts Sociales sont détenues par l'Associée
Unique, qu'elles sont entièrement libérées, libres de toutes charges et qu'elles sont librement cessibles à la Société.
La réalité et la valeur de l'apport en nature ont été prouvées au notaire instrumentant par les certificats susmentionnés,
délivrés par le gérant de ProLogis Management S.à r.l., préqualifiée, et par l'agent de l'Associée Unique.
Les certificats du gérant et de l'agent susmentionnés resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux
formalités de l'enregistrement.
Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour mettre en œuvre le transfert des Parts Sociales, l'Associée
Unique prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible et fournira au notaire soussigné la preuve que ces
formalités ont été accomplies dans les meilleurs délais.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution prise ci-avant, l'Associée Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société
qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à dix millions six cent quatre-vingt-quinze mille euros (EUR 10.695.000,-), représenté par dix
mille six cent quatre-vingt-quinze (10.695) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Chaque part sociale donne droit à une voix aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»
<i>Référence à la loi du 29 décembre 1971i>
Compte tenu de ce que le présent acte documente une augmentation du capital de la Société libérée par un apport
en nature constitué respectivement de 100% du capital social de la société ProLogis Management S.à r.l., préqualifiée,
ayant son siège social dans un pays membre de l'Union Européenne, l'Associée Unique déclare que la présente augmen-
tation de capital a été faite conformément à l'article 4-2 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt
frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales, prévoyant l'exonération du droit
d'apport.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison de
son augmentation de capital sont évalués à environ cinq mille euros (EUR 5.000,00).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande du représentant de la comparante et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite au représentant de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. CASSELLS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 mai 2008. LAC / 2008 / 19480. — Reçu douze euros € 12,-.
<i>Le Receveuri> (signé): SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Joëlle BADEN.
Référence de publication: 2008085514/7241/140.
(080097064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
85103
Europ Continents Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 16.913.
EXTRAIT
L'Assemblée générale ordinaire annuelle du 25 juin 2008 a pris les résolutions suivantes:
1) L'Assemblée générale renouvelle, pour une durée d'une année, les mandats d'administrateur de:
- Madame Christiane BEAUJOLIN, administrateur de sociétés, demeurant à F-75016 Paris;
- Monsieur Jean-Marc BEAUJOLIN, administrateur de sociétés, demeurant à CH-1131 Tolochenaz (VD);
- Monsieur Marc DEFERNE, administrateur de sociétés, demeurant à CH-1272 Genolier;
- Monsieur Jean-Pierre LOUPPE, administrateur de sociétés, demeurant à F-78000 Versailles.
Le mandat de tous les Administrateurs prendra fin, sauf reconduction, lors de l'Assemblée générale ordinaire qui
statuera sur les comptes de l'exercice 2008.
2) L'Assemblée générale renouvelle le mandat de Commissaire aux comptes de la société PKF ABAX Audit, société
à responsabilité limitée, avec siège à L-2212 Luxembourg.
Le mandat de Commissaire aux comptes prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
de l'exercice 2008.
3) L'Assemblée générale autorise le Conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou
plusieurs de ses membres, respectivement à reconduire la délégation antérieure, conformément à l'article 17 des statuts.
Pour extrait conforme
<i>EUROP CONTINENTS HOLDING, Société anonyme
i>Signature
Référence de publication: 2008085017/546/27.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS01942. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080097772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.
Everest Investors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 120.607.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée des actionnaires tenue en date du 5 juin 2008 que:
Elle a réélu aux postes d'administrateurs jusqu'à l'assemblée des actionnaires qui se tiendra en 2009:
- Madame Marjorie GOLINVAUX, juriste, née le 24/08/69 à Messancy (Belgique) et demeurant à Luxembourg, L-1628,
rue des glacis, 7A
- Monsieur Patrick WEINACHT, juriste, né le 19/12/1953 à Neuilly-sur-Seine (France) et demeurant à Luxembourg,
L-1628, rue des Glacis, 7A
- Madame Anne-Françoise FOUSS, employée, née le 13/11/1969 à Rocourt (Belgique) et demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg, L-1628, rue des Glacis, 7A
La société BS CONSULTING S.A. établie et ayant son siège social au 84, Grand-Rue à L-1660 Luxembourg, inscrite
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-45 486 est nommée commissaire
aux comptes pour une durée allant jusqu'à l'assemblée ordinaire qui se tiendra en 2009, en remplacement du commissaire
démissionnaire MS GESTION S.A.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008086076/1161/25.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR06354. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080098711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
85104
Aberdeen Property Funds SICAV
Aberdeen Property Funds SICAV-FIS
ADT Finance S.A.
AKT Investments S.à r.l.
AMB Le Havre Holding S.à r.l.
Atelier Pia Mai GmbH
Belron S.A.
BERGER TRUST Luxembourg HOLDING S.A.
CEREP Pic Place S.à r.l.
CEREP Vivienne S.à r.l.
City's S.à r.l.
DREYER RUPPERT REAL ESTATE S.A. Development & Investment
Epicea Finance S.A.
EPI Highgate GP 2 S.à.r.l.
EPI Highgate GP 3 S.à.r.l.
EPI Highgate GP 4 S.à r.l.
Equity Trust (Luxembourg) S.à r.l.
E.S.T.I.M. S.à r.l.
Ets Jos Mosar S.à r.l.
Euro-Gate
Euronav Luxembourg S.A.
Europ Continents Holding
Europ Continents Holding
Everest Investors S.A.
Evolia S.à r.l.
Excell Life International S.A.
FINAGEL S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF)
Fortis L FoF
Fundtrust Holding S.A.
Gia Abanico S.à r.l.
Goodyear
Goodyear Luxembourg Tires S.A.
Haas & Knaf, Succ. Jos Mosar
Interflog S.A.
Investment 2000 S.A.
Invista European Real Estate Finance S.à r.l.
Just Move S.à r.l.
Kamps Food Retail Investments S.A.
Karma S.A.
Laudamar S.A.
Locent
Lux - Beauté
Maison Josy Juckem S.à r.l.
Mascagna Holding S.A.
Metros Holding S.A.
MGP Asia (Lux) S.à r.l.
Mitte Holdings Management S.A.
Mitte Holdings Management S.C.A.
NovEnergia 2010
Peinture Schultze Sàrl
Primera Fund
Prologis Management Services S.à r.l.
Richnou S.A.
Rocca Investments Holding S.A.
Rovi-Tech Lux S.A.
Royalino Holding S.à r.l.
Sachamadra Invest S.A.
S.M.M. spf S.A.
Sumbiosis CS S. à r.l.
Trema Architecture Sàrl
UBI Banca International S.A.
UBS (Lux) Institutional Sicav II
Universal Wireless S.A.
Vellemans-Vellemans-Nys-Timmermans Société en nom collectif
Vodafone Luxembourg S.à r.l.
Walser Portfolio
Y.E SA