This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1750
16 juillet 2008
SOMMAIRE
Ageney S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83967
Alberticho Construcion S.A. . . . . . . . . . . . .
83967
Art Décor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83955
Avenirose S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83967
Batiglobal S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83961
Broad Street Mall S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
83998
Bronze Capital SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
83954
CEP Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83957
Coiffure Eliane S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83969
Conforama Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
83960
CWS N.V. Luxembourg Branch . . . . . . . . .
83958
Eclipse Aviation Southeastern Europe S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83985
Ellergronn société coopérative . . . . . . . . . .
84000
Eurofund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83968
Francilienne Investments I S.à r.l. . . . . . . .
83964
Geminus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83969
Hastings & Cornwall S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
83957
International Shipping House S.A. . . . . . . .
83969
Investors Office Holding S.à r.l. . . . . . . . . . .
83966
Jabe Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83957
Koningslaan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83962
Le Grand Château S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
83958
Lubelair S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83963
Lux Animation SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83978
Lux Media S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83954
Lux Studio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83997
Machold Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83966
McKesson International Holdings VI S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83968
Mega Bloks International S.à r.l. . . . . . . . . .
83961
Mega Brands International . . . . . . . . . . . . . .
83961
Metallbau Roth S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83956
Mountain Aviation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
83964
Mustique Capital London Partners SA . . .
83959
Nokia Siemens Networks S.A., Succursale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83997
Noreva Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83977
Nowa Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83963
NPEI Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84000
Parinco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83969
Pauliac S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83964
Perfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83968
P.P.L.V. Finance S.A. Holding . . . . . . . . . . .
83955
Presta Concept S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83954
Private Gallery S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83965
Pro - Re - Co S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83955
R & C & Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83955
RECP IV CMBS International . . . . . . . . . . .
83978
S.E.C. Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83956
Sofires S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83960
SPE III RG S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83965
Sterling Sub Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . .
83968
SVG Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83962
SVG Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83961
Thomson International S.à r.l. . . . . . . . . . . .
83959
T.I.P. Technischer Industriebedarf Pickard
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83995
Tolmina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83956
UPG Holdings I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83970
Vailog CalEast LaSalle China S.à r.l. . . . . .
83958
Vandemoortele Participations . . . . . . . . . . .
83960
Via Santé S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83962
Villefranche S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83967
Weather Capital Finance . . . . . . . . . . . . . . .
83963
Wellington Global Commodities S. à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83985
WM Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83966
WM Investments Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83965
83953
Bronze Capital SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 138.596.
Suite à une erreur apparue dans la notification enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg le 04 juin 2008 référence LO80080112.05, il est à préciser que:
Monsieur Daniel André Schwitter, résidant 9 Wiesenrain, CH-8704 Herrliberg, en Suisse, est nommé Administrateur
de la société Bronze Capital SPF S.A. à compter du 09 mai 2008 jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2013.
Manacor (Luxembourg) S.A., immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B9098, et ayant pour adresse 46A, avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg, est nommé Administrateur de la
Société à compter du 24 avril 2008 jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>BRONZE CAPITAL SPF S.A.
i>Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Référence de publication: 2008080284/683/22.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2008, réf. LSO-CR07984. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080091414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2008.
Presta Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6931 Mensdorf, 1, rue Wangert.
R.C.S. Luxembourg B 135.244.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02/07/2008.
FIDUCIE CONSULT SARL
208, route de Burange, L-3429 DUDELANGE
Signature
Référence de publication: 2008083518/5212/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07240. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080094667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2008.
Lux Media S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 92.718.
Le bilan au 30.06.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
DIEKIRCH, le 03/07/2008.
<i>Pour la société
i>EURO COMPTES & PARTNERS
52, Esplanade, L-9227 Diekirch
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008083546/2602/17.
Enregistré à Diekirch, le 3 juillet 2008, réf. DSO-CS00022. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080095956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
83954
Art Décor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 64, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 94.570.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02/07/2008.
FIDUCIE CONSULT SARL
208, route de Burange, L-3429 DUDELANGE
Signature
Référence de publication: 2008083515/5212/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07238. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080094661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2008.
R & C & Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38-40, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 110.950.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2008.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008084799/5770/12.
(080096476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2008.
P.P.L.V. Finance S.A. Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 51, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 83.394.
Pro - Re - Co S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 25.405.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugements rendus en date du 10 avril 2008, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, sixième chambre, après avoir entendu Monsieur le Juge Commissaire, en son rapport oral, le Liquidateur
et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société
anonyme P.P.L.V. FINANCE S.A. HOLDING (B 83.394): et de la société à responsabilité limitée PRO-RE-CO s.à.r.l. (B
25.405)
Ces mêmes jugements ont mis les frais à la charge du Trésor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2008.
POUR EXTRAIT CONFORME
POUR REQUISITION
M
e
Asaël ROUBY
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2008084216/7101/27.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01405. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
(080095633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
83955
Metallbau Roth S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 108.045.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2008.
SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, B.P. 351, L-2013 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2008084097/820/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR09386. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080095702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
S.E.C. Finance S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-8077 Bertrange, 177, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 104.730.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires prises à l'unanimité le 11 juin 2008 à 14 heures au siège sociali>
<i>Résolutioni>
L'Assemblée Générale DECIDE de renommer comme administrateurs de la Société:
1. M. Lars-Johan Jarnheimer demeurant en Suède, Elfviksvägen, 40, S-181 47 Lidingö;
2. M. Francesco D'Angelo demeurant à Luxembourg, 40, rue Rollingerground L-2440 Luxembourg et
3. Mr Lars Nilsson, demeurant à Vattugatan 15, 111 52 Stockholm, Suède
Leur mandat sera renouvelé lors de l'assemblée des actionnaires de 2009.
<i>Résolutioni>
L'Assemblée Générale DECIDE de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes actuel, en la personne
de M. Vikrant MEHTA, demeurant à L - 8041 Strassen, 27, rue des Romains et DECIDE de nommer:
FIDUCIAIRE DES P.M.E. Société Anonyme, R.C.S. Luxembourg N
o
B 10.734, 58, rue Glesener, L - 1630 Luxembourg
Le mandat du nouveau commissaire sera renouvelé lors de l'assemblée des actionnaires de 2009.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour S.E.C. FINANCE S.A.
i>Etude d'Avocats S. LE GOUEFF
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2008084120/1053/26.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR10807. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Tolmina S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 31.419.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
N. SCHMITZ
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008084152/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR08986. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
83956
Jabe Holding S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 71.252.
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en date du 3 juin 2008 a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Roeland P. Pels, en tant qu'Administrateur, est acceptée avec effet immédiat.
- Monsieur Frank Walenta, domicilié au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est nommé nouvel Administrateur
de la société avec effet immédiat. Il terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée
Générale Annuelle de 2011.
Luxembourg, le 3 juin 2008.
Pour extrait conforme
Bart Zech
Référence de publication: 2008084124/724/18.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR10942. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080095938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
CEP Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.608.000,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 113.746.
EXTRAIT
L'assemblée générale extraordinaire du 1
er
mars 2008 a nommé nouveau gérant de classe A pour une durée indé-
terminée
M. Frederic M. Burditt, résidant au 128 High Valley Drive, Canton, Connecticut 06019, USA
en remplacement du gérant démissionnaire M. Kenneth W. Smith.
<i>Pour CEP HOLDINGS S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2008084125/783/18.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR11151. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Hastings & Cornwall S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 78.390.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 20 juin 2008 a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Roeland P. Pels, en tant qu'Administrateur de la société, est acceptée avec effet immédiat.
- Monsieur Frank Walenta, domiciliée au «12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg», est élu nouvel Administrateur
de la société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2011.
Luxembourg, le 20 juin 2008.
Pour extrait conforme
Bart Zech
Référence de publication: 2008084123/724/18.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR10941. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
83957
CWS N.V. Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-5280 Sandweiler, 6, Zone Industrielle Rolach-Hall.
R.C.S. Luxembourg B 60.120.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société CWS N.V., société anonyme de droit
belge, avec siège social au Berchemstadionstraat 78, B-2600, Berchem, Anvers, Belgique (la «Société»), tenu le 24 avril
2008, que la résolution suivante a été adopté:
La personne suivante a été nommée avec effet au 24 avril 2008, pour une durée déterminée se terminant le jour de
l'assemblée générale annuelle 2009 de la Société, en tant qu'administrateur de la Société:
- Monsieur Andreas Heinrick Heinze, administrateur, né le 14 novembre 1960 à Frankfurt am Main, Allemagne, de-
meurant au 38, Cecilien Allee, 40474 Düsseldorf, Allemagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008084117/1035/20.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2008, réf. LSO-CR10472. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080095419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Vailog CalEast LaSalle China S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 138.574.
<i>Attestation-rectificatif de la constitution du 21 avril 2008 de la société déposé au Registre de Commerce et des sociétés le 23 maii>
<i>2008i>
Suite à une erreur dans la constitution de la société CalEAST LaSalle China S.à.r.l., qui a été déposée au Registre de
Commerce et des Sociétés le 23 mai 2008, il s'avère que le nom de l'associé n'est pas Lasalle - CalEast Ventures I Limited
comme écrit sur la constitution du 21 avril 2008, mais:
Lasalle - CalEast I Ventures Limited
Fait à Luxembourg, le 24 juin 2008.
M
e
Joseph ELVINGER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008084144/211/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2008, réf. LSO-CR10519. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Le Grand Château S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 129.340.
<i>Extrait des résolutions des associes qui ont été prises le 4 juin 2008i>
Les Associés de Le Grand Château S.à.r.l. (la "Société") ont décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Mr Robert Whitton, ayant son adresse professionnelle au 100 Piccadilly, London W1J7NH,
Royaume-Uni, de sa fonction de Gérant et ce avec effet immédiat.
Luxembourg, le 20 juin 2008.
Cândida Gillespie
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2008084112/710/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2008, réf. LSO-CR10553. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
83958
Mustique Capital London Partners SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 31.358.
At the Ordinary General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on June 16th, 2008, it
has been resolved the following:
1 To reelect Mr Gilles WECKER residing professionally at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, as director of
the company;
2 To reelect Mr Peter ENGELBERG residing professionally at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, as director
of the company;
3 To reelect Mr Björn LINDSTRÖM as director of the Company.
4 To reelect MODERN TREUHAND S.A. situated 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg as the statutory auditor
of the company;
Fiona Finnegan / Gilles Wecker.
Lors de l'Assemblée Ordinaire des actionnaires tenue le 16 juin 2008, il a été résolu ce qui suit:
1. De ré-élire M. Peter ENGELBERG demeurant professionnellement au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
comme administrateur au conseil d'administration de la société;
2. De ré-élire M. Gilles WECKER demeurant professionnellement au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, comme
administrateur au conseil d'administration de la société;
3. De ré-élire Björn LINDSTRÖM comme membre au conseil des administrateurs.
4. De ré-élire MODERN TREUHAND S.A. comme commissaire aux comptes de la société.
Fiona Finnegan / Gilles Wecker.
Référence de publication: 2008084139/1369/27.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR09539. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Thomson International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 253.352.959,25.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 7, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 79.011.
La nouvelle adresse de Messrs Virender PURI et Joseph Johannes VERMEER, administrateurs de la société, est la
suivante:
Landis+ Gyr-Strasse 3, CH 6300 Zug
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle du 9 mai 2008i>
L'assemblée générale décide de réélire tous les gérants en fonction pour un nouveau mandat qui se terminera à l'issue
de l'assemblée générale qui se tiendra en 2009.
Le conseil de gérance est composé comme suit:
1. Mr Jean HAMILIUS, licencié en sciences économiques et financières, demeurant L-1462 Luxembourg, 10, Eicherfeld,
Président
2. Mr Gregor DALRYMPLE, directeur de sociétés, demeurant 7, boulevard Royal, Luxembourg
3. Mr Jacques LOESCH, avocat, demeurant 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
4. Mr Tom LOESCH, avocat, demeurant 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
5. Mr Virender PURI, Vice-Président pour l'Europe, demeurant Landis+ Gyr-Strasse 3, CH 6300 Zug.
6. Mr Joseph Johannes VERMEER, directeur de sociétés, demeurant Landis+ Gyr-Strasse 3, CH 6300 Zug
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour THOMSON INTERNATIONAL S.à.r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2008084118/267/27.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04774. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
83959
Conforama Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 296, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 48.369.
<i>Extraits des Résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration tenue par voie circulaire en date du 9 juin 2008i>
Il résulte du procès-verbal que Monsieur Thierry GUIBERT, Président-Directeur Général, né le 26 novembre 1970 à
Saint-Maur-Des-Fossés, demeurant à F-92190 MEUDON, 155, avenue de Verdun, a été coopté aux fonctions d'adminis-
trateur jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire en remplacement de Monsieur Christophe CUVILLIER qui a
démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 9 juin 2008.
Il résulte également du procès-verbal que Monsieur Thierry GUIBERT, pré-qualifié, a été nommé administrateur-
délégué, en remplacement de Monsieur Christophe CUVILLIER.
Il résulte encore du procès-verbal que Monsieur Thierry GUIBERT, pré-qualifié, a été nommé Président du Conseil
d'administration, en remplacement de Monsieur Christophe CUVILLIER.
Ses fonctions d'administrateur-délégué et de Président du Conseil d'administration prendront fin lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 17 juin 2008.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2008084110/819/23.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR11098. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Sofires S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 44.290.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
N. SCHMITZ
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008084155/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR08984. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Vandemoortele Participations, Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 93.002.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 12 juin 2008, que:
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la durée d'une année, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire
- PRICEWATERHOUSECOOPERS Luxembourg S.à.r.l., ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 12 juin 2008.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2008084119/802/18.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06712. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
83960
Mega Brands International, Société à responsabilité limitée,
(anc. Mega Bloks International S.à r.l.).
Capital social: EUR 876.450,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 99.516.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue au siège social le 26 mai 2008 que:
- Les gérants suivants ont été renommés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2009:
* Olivier Dorier, Directeur, 6C, parc d'activités Syrdall, L-5365 Munsbach;
* Stewart Kam-Cheong, 6C, parc d'activités Syrdall, L-5365 Munsbach;
- PricewaterhouseCoopers Sàrl a été élue jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2009 en tant que réviseur
d'entreprises.
Munsbach, le 26 mai 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2008084105/1337/23.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05442. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080096111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Batiglobal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 103.315.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2008.
SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, B.P. 351, L-2013 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2008084098/820/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR09385. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
SVG Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 81.754.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 3 juillet 2008i>
Madame Nadine LAMBALLAIS, née le 1
er
janvier 1972 à Thionville (France), adresse professionnelle au 3, avenue
Pasteur, L-2311 Luxembourg, a été nommé en tant que Représentant Permanent de la société FMS SERVICES S.A.
<i>Pour la société
SVG HOLDINGS S.A.
i>N. SCHMITZ
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008084107/1023/16.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01460. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
83961
SVG Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 81.754.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 3 juillet 2008i>
Monsieur Daniel FELLER, né le 23 mars 1956 à Bruxelles (Belgique), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg, a été nommé en tant que Représentant Permanent de la société S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Pour la société SVG HOLDINGS S.A.
i>N. SCHMITZ
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008084108/1023/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01459. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080095723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Via Santé S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 76.609.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2008i>
L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse
professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de la société Lux Business Management Sàrl ayant son
siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social au
5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Co-Ventures S.A., avec
siège social au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur
les comptes de l'exercice 2008.
Luxembourg, le 6 juin 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008084103/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2008, réf. LSO-CR10143. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Koningslaan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 67.493.
Constituée par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg),
et maintenant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 26 novembre 1998, acte publié au Mémorial
C no 123 du 26 février 1999, et dont les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire, en date du 25 septembre
2002, acte publié au Mémorial C no 1676 du 22 novembre 2002,
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Koningslaan S.à r.l.
i>Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008083989/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR11020. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
83962
Lubelair S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 42.233.
Constituée en date du 30 novembre 1992 par-devant M
e
André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de rési-
dence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C no 93 en 1993, modification des statuts pour la dernière fois par
acte sous seing privé, conversion du capital social en euros en date du 14 novembre 2001, dont l'extrait a été publié
au Mémorial C n
o
747 du 16 mai 2002.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LUBELAIR S.A.
i>Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008083994/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR11008. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080095559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Weather Capital Finance, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 115.030.
Constituée par-devant M
e
Jean-Joseph WAGNER, notaire alors de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg)
et maintenant à Belvaux (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 16 février 2006, acte publié au Mémorial C no
1071 du 1
er
juin 2006, modifiée par-devant M
e
Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg-Eich (Grand-
Duché de Luxembourg) en date du 13 juin 2007, acte publié au Mémorial C no 1728 du 16 août 2007.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Weather Capital Finance
i>Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008084013/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR11001. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Nowa Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 67.960.
Constituée par-devant M
e
Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg),
maintenant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 16 décembre 1998, acte publié au Mémorial
C no 200 du 24 mars 1999. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par-devant le même notaire en date
du 15 février 2001, acte publié au Mémorial C no 886 du 16 octobre 2001.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Nowa Holding S.à r.l.
i>Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008084687/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2008, réf. LSO-CS00244. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080096246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2008.
83963
Pauliac S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 117.639.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 14 avril 2008i>
Monsieur Guy HORNICK, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg, est nommé
gérant pour une durée indéterminée avec effet au 14 avril 2008 en remplacement de Monsieur Claude ZIMMER, gérant
démissionnaire.
Luxembourg, le 20 juin 2008.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2008084651/534/16.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2008, réf. LSO-CS00110. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080096752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2008.
Francilienne Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 105.243.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution de l'associé unique prise en date du 22 février 2008 qu'ont été nommés aux fonctions de
gérants de la société en remplacement de Mr Robert C.M. La Fors, démissionnaire, avec effet au 23 février 2008:
- Ms Stéphanie Duval, demeurant professionnellement au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Et
- Mr Martin Pollard, demeurant professionnellement au 33 Cavendish Square, W1A2NF London, United Kingdom.
Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008084649/2570/20.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01845. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080096806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2008.
Mountain Aviation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 116.707.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration tenu à Luxembourg en date du 30 mai 2008 que le siège social
de la Société a été transféré avec effet immédiat du 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg vers le 41, boulevard
Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 19 juin 2008.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008084242/1035/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2008, réf. LSO-CR10469. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
83964
WM Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 272.000,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 129.441.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance tenue en date du 20 mai 2008 que:
La société a déménagé son siège social au 31-33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet le 30 avril
2008
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 2008.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008084225/9146/18.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR11006. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080096126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Private Gallery S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 90.269.
EXTRAIT
La convention de domiciliation conclue entre PRIVATE GALLERY S.A., N
o
immatriculation: B 90 269 et la Fiduciaire
FIDUFISC S.A., N
o
immatriculation: B 73 560 est résiliée. Le siège social jusqu'alors fixé au 7, Grand-rue à L-1661
Luxembourg est dénoncé avec effet immédiat.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 10 avril 2008.
FIDUFISC S.A.
C. WETZEL
Référence de publication: 2008084220/4906/16.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07895. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080096083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
SPE III RG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 136.826.
<i>Extrait de la résolution du Conseil de gérance du 20 mai 2008i>
Le Conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société
du
14, rue Erasme, L- 1468 Luxembourg
au
35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 24 juin 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2008.
SPE III Spinelli S. à r.l.
Signature
Référence de publication: 2008084234/250/20.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2008, réf. LSO-CS00445. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
83965
WM Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 228.429,40.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 129.146.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance tenue en date du 20 mai 2008 que:
La société a déménagé son siège social au 31-33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet le 30 avril
2008
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 2008.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008084229/9145/18.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR11003. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080096125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Investors Office Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 112.946.
<i>Extrait de la résolution du gérant unique du 20 mai 2008i>
Le gérant unique de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société
du
3, rue du Fort Rheinsheim, L- 2419 Luxembourg
au
35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 24 juin 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2008.
Investors Office Holding S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2008084233/250/20.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2008, réf. LSO-CS00443. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Machold Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 89.419.
EXTRAIT
Nous vous informons que l'adresse professionnelle de Maître Beatriz Garcia, administrateur de la Société, n'est plus
au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg, mais est, à partir d'aujourd'hui, au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2008.
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2008084635/536/16.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2008, réf. LSO-CR08202. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080096483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2008.
83966
Alberticho Construcion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 130.752.
Le bilan au 31 décembre 2007 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait conforme
Alberticho Construcion S.A.
Signature
Référence de publication: 2008083835/7491/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2008, réf. LSO-CS00258. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080095404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Avenirose S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 134.635.
Le bilan au 31 décembre 2007 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait conforme
Avenirose S.A.
Signature
Référence de publication: 2008083832/7491/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2008, réf. LSO-CS00254. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Ageney S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 36.682.
Le bilan au 31 décembre 2007 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait conforme
AGENEY S.A.
Signature
Référence de publication: 2008083833/7491/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2008, réf. LSO-CS00255. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Villefranche S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 119.232.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30.06.08.
Signature.
Référence de publication: 2008083795/1369/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2008, réf. LSO-CR10369. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
83967
Sterling Sub Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 104.772.
Le bilan au 31 décembre 2007 et les annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2008083831/7718/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR11016C. - Reçu 107,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080095382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Perfin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 95.870.
Le bilan au 31 décembre 2007 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait conforme
PERFIN S.A.
Signature
Référence de publication: 2008083836/7491/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2008, réf. LSO-CS00259. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Eurofund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 58.019.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008083828/1176/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2008, réf. LSO-CS00169. - Reçu 40,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
McKesson International Holdings VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 101.213.
Les comptes annuels au 31 mars 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02/07/08.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2008083725/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00816. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
83968
Parinco, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 16.295.
Le bilan au 30 septembre 2007 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait conforme
Parinco
Signature
Référence de publication: 2008083834/7491/15.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2008, réf. LSO-CS00256. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080095401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Geminus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 105.537.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2008083805/1463/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2008, réf. LSO-CR10197. - Reçu 50,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Coiffure Eliane S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1243 Luxembourg, 25, rue Félix de Blochausen.
R.C.S. Luxembourg B 83.210.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008083827/8121/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01370. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
International Shipping House S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 2, Am Broch.
R.C.S. Luxembourg B 85.682.
Le bilan arrêté au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 30 juin 2008.
<i>Pour INTERNATIONAL SHIPPING HOUSE SA
i>Fiduciaire Roger Linster
p.d. Viviane Roman
Référence de publication: 2008083797/598/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR09372. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
83969
UPG Holdings I, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 139.626.
STATUTES
In the year two thousand and eight, on the eighteenth of June.
Before the undersigned Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Applica Pet Products - UPG Holding Company S.e.n.c., a société en nom collectif (general corporate partnership), duly
incorporated and validly existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6 C, Parc d'Activités Syrdall,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Registre de Commerce
et des Sociétés (Trade and Companies Register);
Here represented by Annick Braquet, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue
of proxy given under private seal.
The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such party, appearing in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of
association (the "Articles") of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incor-
porated:
Title I - Form - name - purpose - duration - registered office
Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by
Luxembourg law as well as by the present Articles (the "Company").
Art. 2. Name. The Company's name is UPG Holdings I.
Art. 3. Purpose. The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form what-
soever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions,
purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the
Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in
part, for such consideration as the Company may think fit.
The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions and grant to any company or entity
which form part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including
companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance,
loan, advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as
borrow and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.
Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its
purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Munsbach, Grand Duchy
of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Munsbach by means of a resolution of the sole
manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles or
to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case of
plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-
five per cent (75%) of the share capital.
The Company may have branches and offices, both in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
Title II - Capital - shares
Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at EUR 135,000 (one hundred thirty five thousand euros) divided
into 135,000 (one hundred thirty five thousand) shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) each, fully paid-up.
The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case
of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five per cent (75%) of the share capital.
Art. 7. Voting Rights. Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights com-
mensurate to such shareholder's ownership of shares.
Art. 8. Indivisibility of shares. Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only
one owner per share.
83970
Art. 9. Transfer of shares. The shares are freely transferable among shareholders or where the Company has a sole
shareholder.
Transfers of shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least
seventy-five per cent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.
Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the Law.
Art. 10. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient
distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a decrease of the Company's share capital.
Title III - Management
Art. 11. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers. Where
more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers constituted by two different
types of managers, namely type A managers and type B managers.
No manager needs be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole
shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty per
cent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be
determined in the same manner.
A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or
in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of
the share capital of the Company, as the case may be.
Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the law of August 10, 1915 concerning com-
mercial companies, as amended from time to time (the "Law") or by these Articles to the sole shareholder, or in case of
plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the sole manager or the
board of managers, as the case may be.
The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint
signature of at least one type A manager and one type B manager.
The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one
or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board
of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as
well as any other relevant condition.
Art. 13. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among
its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and
who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.
The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed,
the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except
when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.
Meetings of the board of managers shall be held within the Grand-Duchy of Luxembourg.
Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another
manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.
Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication
means, initiated from the Grand-Duchy of Luxembourg and allowing all managers participating in the meeting to hear
each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.
A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present
in person or by alternate at least one type A manager and at least one type B manager.
Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers
of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting
of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken
together, shall constitute the same instrument.
Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two managers.
Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two managers.
Art. 14. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly
made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of
the Company.
Title IV - Shareholder meetings
Art. 15. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in
accordance with the Law.
83971
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-
reholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.
Art. 16. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of
managers, as the case may be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by
shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least
24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.
If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed
on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as
such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.
Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of share-
holders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at
a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.
Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share
capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of
the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.
The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed
twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority
vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receive prior to its written vote and
in writing by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.
When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand-
Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice,
on the third Thursday of December or on the following business day if such day is a public holiday.
Title V - Financial year - balance sheet - profits - audit
Art. 17. Financial year. The financial year of the Company starts on July 1 and ends on June 30, with the exception of
the first financial year that shall start today and end on June 30, 2009.
Art. 18. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as
the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an
inventory will be annexed, all together the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in case
of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.
Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,
charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general
meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.
Each year, five per cent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This
allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed
at any time when it has been broken into.
The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution
of the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute
it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.
Art. 20. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the
case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement
of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.
Art. 21. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be
entrusted to a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several
statutory auditors.
No statutory auditor needs be a shareholder of the Company.
Statutory auditor(s) shall be appointed by resolution of the shareholders representing more than fifty per cent (50%)
of the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of
shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of
shareholders.
83972
Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register
as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts
audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.
Title VI - Dissolution - liquidation
Art. 22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality
of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders,
representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death,
suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.
Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the
sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the
shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five per cent (75%) of the
share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets
of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders
proportionally to the shares they hold.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 135,000 (one hundred thirty five thousand) shares representing the entire share capital of the Company, have
been entirely subscribed by Applica Pet Products - UPG Holding Company S.e.n.c., named above, and fully paid up in cash,
therefore the total amount of EUR 135,000 (one hundred thirty-five thousand euros) is as now at the disposal of the
Company, proof of which has been duly given to the notary by producing a blocked funds certificate.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 2,800.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed
share capital passed the following resolutions:
1) - Lisa R. Carstarphen, born on July 27, 1965 in Charlotte, North Carolina, United States of America, residing
professionally at 3633 Flamingo Road, Miramar, Florida 33027, United States of America; and
- Ivan R. Habibe, born on January 20, 1967 in Oranjestad, Aruba, residing professionally at 3633 Flamingo Road,
Miramar, Florida 33027, United States of America;
are each appointed as type A manager for an undetermined duration;
- Hermann-Günter Schommarz, born on November 20, 1970 in Amersfoort, South Africa, residing professionally at
6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg;
is appointed as type B manager for an undetermined duration.
2) The registered office of the Company shall be established at 6 C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand
Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with us, the Notary, the
present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand - Duché de Luxembourg,
A comparu:
Applica Pet Products - UPG Holding Company S.e.n.c., une société en nom collectif de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 6 C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatricu-
lation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg;
Ici représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand - Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
La dite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte aux fins d'enregistrement.
83973
La dite partie comparante, agissant es qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les "Statuts")
d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
Titre I
er
- Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois
ainsi que par les présents Statuts (la "Société").
Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est UPG Holdings I.
Art. 3. Objet. L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des
participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et
licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, déve-
lopper, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.
La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales, d'accorder à
toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec
la Société, incluant les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre
forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou de consentir au profit de tiers des sûretés ou des garanties afin de garantir
les obligations des sociétés précitées, ainsi que d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de
garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.
Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement
à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut
être transféré en tout autre lieu de la commune de Munsbach par décision du gérant unique ou en cas de pluralité de
gérants, par décision du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand - Duché de
Luxembourg par résolution de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des
associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.
La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand - Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Titre II - Capital - parts sociales
Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à EUR 135.000 (cent trente cinq mille euros), divisé en 135.000 (cent trente
cinq mille) parts sociales ayant une valeur nominale d'EUR 1 (un euro) chacune, entièrement libérées.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par
résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société.
Art. 7. Droits de vote. Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote
proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.
Art. 8. Indivisibilité des parts. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire
par part sociale.
Art. 9. Transfert des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé unique.
Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins
soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.
Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la Loi.
Art. 10. Rachat des parts. La Société peut racheter ses propres parts sociales pour autant que la société ait des réserves
distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social.
Titre III - Gérance
Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où
plus d'un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance qui sera alors composé de deux catégories
différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B.
Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en
cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.
Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé
unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société.
83974
Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée (la "Loi") ou les Statuts à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés,
à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant.
La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe
d'au moins un gérant de type A et un gérant de type B.
Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques
à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil
de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes
autres modalités ou conditions de leur mandat.
Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses
membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé
de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour,
l'heure et le lieu de la réunion, est donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y est
renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand - Duché de Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen
de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre
moyen de communication approprié initié depuis le Grand - Duché de Luxembourg et permettant à l'ensemble des gérants
participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente
à une participation physique.
Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, au moins un gérant de type A
et au moins un gérant de type B sont présents en personne ou représentés.
Lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par
un vote favorable de la majorité des gérants de la Société présents ou représentés.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors
d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux
étant un original et tous ensembles constituant un seul et même acte.
Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants.
Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.
Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régu-
lièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux
Statuts.
Titre IV - Assemblée générale des associes
Art. 15. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés con-
formément à la Loi.
Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la
Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.
Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou,
le cas échéant, par le conseil de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s'il existe. A défaut,
elles sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.
Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins
24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de
l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit
un tiers qui n'a pas à être associé de la Société.
Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant
plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première
assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représentée.
Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des
associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.
La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-
cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des
83975
votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par
tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalable-
ment à son vote écrit.
Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement à
Luxembourg au siège social de la Société le troisième jeudi du mois de décembre ou le jour ouvrable suivant si ce jour
est férié.
Titre V - Exercice social - comptes sociaux - profits - audit
Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin, à l'exception
du premier exercice qui commence ce jour et se terminera le 30 juin 2009.
Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas
échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire est annexé,
l'ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité
d'associés à l'assemblé générale des associés.
Art. 19. Bénéfice. Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements,
charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des
associés, représente le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être
obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu'à
entière reconstitution.
Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés re-
présentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution aux associés
proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve
distribuable.
Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant,
peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi
par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles
pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.
Art. 21. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un
commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance composé de plusieurs commissaires.
Aucun commissaire n'a à être associé de la Société.
Le(s) commissaire(s) sont nommés par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur
mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.
Lorsque les conditions de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes
à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée
générale des associés peut cependant nommé un réviseur d'entreprise à tout moment.
Titre VI - Dissolution - liquidation
Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société est décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par
l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au
moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est pas dissoute par la mort, la sus-
pension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.
Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé
unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité
des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui dé-
terminera leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront
attribués à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils
détiennent.
<i>Souscription - Paiementi>
L'intégralité des 135.000 (cent trente cinq mille) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société
a été entièrement souscrite par Applica Pet Products - UPG Holding Company S.e.n.c., prénommée, et a été intégralement
libérée en numéraire. Le montant de EUR 135.000 (cent trente cinq mille euros) est donc à la disposition de la Société
ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat de blocage de fonds.
83976
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui
sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à EUR 2.800,-.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit,
a pris les résolutions suivantes:
1) - Lisa R. Carstarphen, né le 27 juillet 1965 à Charlotte, Caroline du Nord, Etats-Unis d'Amérique, résidant profes-
sionnellement au 3633 Flamingo Road, Miramar, Florida 33207, Etats-Unis d'Amérique; et
- Ivan R. Habibe, né le 20 janvier 1967 à Oranjestad, Aruba, résidant professionnellement au 3633 Flamingo Road,
Miramar, Florida 33207, Etats-Unis d'Amérique;
sont chacun nommés gérants de type A pour une période indéterminée.
- Hermann-Günter Schommarz, né le 20 novembre 1970 à Amersfoort, Afrique du Sud, résidant professionnellement
au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché du Luxembourg;
est nommé gérant de Type B pour une période indéterminée.
2) Le siège social de la Société est établi 6 C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête de la personne comparante
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et
français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 juin 2008. Relation: LAC/2008/25880. — Reçu six cent soixante-quinze euros
(0,50% = 675,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2008.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2008084292/242/412.
(080096308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2008.
Noreva Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2628 Luxembourg, 96, rue des Trévires.
R.C.S. Luxembourg B 79.858.
<i>Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au nouveau siège, le 15 Décembre 2006i>
<i>Résolutionsi>
L'assemblée générale révoque avec effet immédiat la société PARGESTION SA de son poste d'administrateur délégué
suite à l'assemblée générale extraordinaire notariée du 02 juillet 2003 tenue chez M
e
THYES WALCH, qui avait enregistré
la révocation en qualité d'administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 Décembre 2006.
Pour extrait conforme
<i>NOREVA FINANCE SA, 26, rue des Trévires - L2628, LUXEMBOURG, BP 1128-L1011 Luxembourg
i>GENDRON Franck
<i>Scrutateuri>
Référence de publication: 2008084641/7783/20.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2008, réf. LSO-CQ00414. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080096896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2008.
83977
Lux Animation SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 6, Chemin des Douaniers.
R.C.S. Luxembourg B 96.514.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008084425/7430/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00895. - Reçu 36,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080096607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2008.
RECP IV CMBS International, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Renert.
R.C.S. Luxembourg B 139.634.
STATUTES
In the year two thousand and eight, on the twentieth day of June.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
"RECP IV CMBS International LLC", a company incorporated and existing under the laws of Delaware, United States
of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4559525, having its registered
office at C/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle,
Delaware 19808, United States of America,
here represented by Ms Cathie SCALIA, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in New-
York, on June 16, 2008.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the
articles of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - duration - name - registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who
may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the "Company")
which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as
well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding
of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, pro-
motion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations
of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as
the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which
form part of the same group of companies as the Company.
The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any
debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it may deem useful in accomplishment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of "RECP IV CMBS International".
83978
Art. 5. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several
managers, of the board of managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the manager or, in case of several managers, by the board of managers.
In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social
developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.
B. Share capital - shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least in accordance with the provision of the Law.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the owners of shares representing three quarters of the rights of the survivors,
subject to and in accordance with the Law. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.
The Company may have one or several partners, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided
by law.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case
may be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one
manager, by joint signature of any two managers and by the signature of any duly authorised representative within the
limits of such authorisation.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, email or any other similar means of communication. A special notice will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
83979
No notice shall be required in case all the managers are present or represented at a meeting of such board of managers
or in case of resolutions by circular means approved and signed by all the members of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous
basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, email or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - collective decisions of the partners
Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each
partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as
they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the Law. In such case, any reference made herein to the "general meeting of
shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and
powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.
E. Financial year - annual accounts - distribution of profits
Art. 21. The Company's financial year commences on 1st of January and ends on 31st December of the same year.
Art. 22. Each year on 31st December, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.
Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners in proportion to the shares of the Company held by them.
83980
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.
<i>Subscription and paymenti>
All of the five hundred (500) shares have been subscribed by RECP IV CMBS International LLC, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 December
2008.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.
<i>General meeting of partnersi>
The incorporating partner, representing the entire share capital of the Company and considering itself as fully convened,
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 3, rue Renert, L-2422 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period:
- Mr Thomas Stephen HAINES, born in Rainham, England on 11 October 1953, residing at 3, rue Renert, L-2422
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Graham LANGLAY- SMITH, born in Philadelphia, United States of America on 23 February 1960, residing at 1
Cabot Square, London E14 4 QJ, United Kindgdom,
- Mr Kenneth LOHSEN, born in New York, United States of America on 17 December 1958, residing at 11 Madison
Avenue, New York, United States of America, and
- Mr James Douglas ALLEN, born in New Jersey, United States of America, on 19 February 1963, residing at 11 Madison
Avenue, New York, United States of America.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, known to the notary by their name,
first name, civil status and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le vingt juin.
Par-devant Maître Jean Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
"RECP IV CMBS International LLC", une société constituée et existant selon les lois de Delaware, Etats-Unis d'Amé-
rique, enregistrée auprès du Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 4559525, ayant son siège social
au C/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle,
Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique,
ici représentée par Madame Cathie SCALIA, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seing privé donnée à New-York, le 16 juin 2008.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera attachée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte de
constitution d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - durée - dénomination - siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
l'administration, le contrôle et la mise en valeur de son portfolio.
Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de
Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la détention de
83981
participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans
l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à, ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte des sociétés ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut emprunter sous toute forme et émettre des titres obligataires, des obligations garanties, des lettres
de change ainsi que généralement toute sorte de titres de participation, d'obligations et/ou d'obligations hybrides con-
formément au droit luxembourgeois.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de "RECP IV CMBS International".
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré
dans la même commune par décision du gérant ou, lorsqu'ils sont plusieurs, du conseil de gérance.
Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par simple
décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, du conseil de gérance.
Au cas où le gérant unique ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique,
économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre ce
siège social et des personnes à l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré
provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société
luxembourgeoise.
B. Capital social - parts sociales
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social conformément aux dispositions de la Loi.
Art. 8. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part sociale. Les copropriétaires indivis de parts
sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux associés
survivants sujet à et conformément aux dispositions de la Loi. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas
requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
La Société peut avoir un ou plusieurs associés avec un nombre maximal de quarante (40) sauf dispositions légales
contraires.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou l'insolvabilité de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur
les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature conjointe de deux gérants et par la signature de tout représentant dûment mandaté dans les limites de son
mandat.
83982
Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres
un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a
pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de
convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil
de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres de façon continue et permettant une participation effective de toutes ces personnes à la
réunion. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contract(ent), en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l'associé unique - décisions collectives des associés
Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 19. L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et
par les présents statuts. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont
valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts nécessitent l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 20. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la Loi. Dans ce cas, toute référence dans les présentes à "l'assemblée générale des associés"
devra être interprétée comme désignant l'associé unique, selon le contexte et selon le cas, et les pouvoirs conférés à
l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.
E. Année sociale - bilan - répartition
Art. 21. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
83983
Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.
Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
F. Dissolution - liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement des dettes sera partagé entre les associés en proportion
des parts sociales détenues par eux dans la Société.
Art. 25. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.
<i>Souscription et libérationi>
Le capital a été souscrit comme suit:
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par RECP IV CMBS International LLC, prénommée.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2008.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge en raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cens euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et se considérant comme dûment
convoqué, a tenu une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 3, rue Renert, L-2422 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg;
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Thomas Stephen HAINES, né le 11 octobre 1953 à Rainham, Angleterre, ayant son adresse professionnelle
au 3, rue Renert, L-2422 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Graham LANGLAY-SMITH, né le 23 février 1960 à Philadelphie, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse
professionnelle au 1 Cabot Square, Londres E14 4 QJ, Royaume-Uni,
- Monsieur Kenneth LOHSEN, né le 17 décembre 1958 à New York, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse pro-
fessionnelle au 11 Madison Avenue, New York, Etats-Unis d'Amérique, et
- Monsieur James Douglas ALLEN, né le 19 février 1963 à New Jersey, Etats-Unis, ayant son adresse professionnelle
au 11 Madison Avenue, New York, Etats-Unis d'Amérique.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentaire
par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. SCALIA, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 juin 2008. Relation: EAC/2008/8460. — Reçu soixante-deux Euros cinquante
Cents (12.500.- à 0,5 % = 62,50 EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): BOIÇA.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Belvaux, le 1
er
JUILLET 2008.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2008084287/239/366.
(080096716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2008.
83984
Eclipse Aviation Southeastern Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 113.427.
Acte Constitutif publié à la page 33 372 du Mémorial C n
o
696 du 05 avril 2006, modifié à la page 27 075 du Mémorial
C n
o
565 du 07 avril 2007.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04/07/08.
Signature.
Référence de publication: 2008084421/1459/15.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00820. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080096555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2008.
Wellington Global Commodities S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 139.633.
STATUTES
In the year two thousand eight, on the seventeenth of June.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
1. Platinum Partners Value Arbitrage Fund L.P., a company incorporated under the laws of the Caymans Islands, having
its registered office at Walker House, Mary Street, P.O. Box 908, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, regis-
tered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number CR-13869;
2. Shmuel Gelb, consultant, born on 16 January 1956 in Soviet Union, residing at St. Weitzman 53/4, Netanya 42250,
Israel,
both here represented by Nicolas van Heule, attorney at law, with professional address in Luxembourg, by virtue of
two powers of attorney given in New York, USA, on 13 June 2008 and given in Netanya, Israel, on 16 June 2008.
Such powers of attorney, after having been signed "ne varietur" by the representative of the appearing parties and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as above, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - registered office - object - duration
Art. 1. Name. The name of the company is Wellington Global Commodities S. à r.l. (the Company). The Company is
a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles
of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the reg-
istered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.
83985
Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may proceed to the sale and purchase of commodities including, but not limited to, metals, petro-
leum and petroleum related products across differing regions. The Company may also proceed with the placement of
commodity transactions with third parties.
3.3. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.4. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five
hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for
that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
III. Management - representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
7.3. The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several A managers and one or several
B managers.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
83986
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which,
in principle, is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions
of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that, if the
single shareholder or the shareholders have appointed one or several A managers and one or several B managers, at least
one (1) A manager and one (1) B manager (in each case, whether in person or by proxy) votes in favour of the resolution.
The chairman shall not be entitled to a second or casting vote.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the signature of one manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
(iii) If the single shareholder or the shareholders have appointed one or several A managers and one or several B
managers, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one A manager and one B manager.
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to
be read as a reference to such sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made
by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
83987
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three quarters
of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - allocation of profits - supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by
law.
14.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the
term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distrib-
utable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the
date of the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one-half of the
shareholders holding three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need
not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise
decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the
Company.
16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
83988
VII. General provisions
17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.
17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Res-
olutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which
taken together constitute one and the same document.
17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to
any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2008.
<i>Subscription and paymenti>
1. Platinum Partners Value Arbitrage Fund L.P., represented as stated above, subscribes to twelve thousand one hun-
dred and twenty-five (12,125) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay
them in full by a contribution in cash in the amount of twelve thousand one hundred and twenty-five (EUR 12,125);
2. Shmuel Gelb, represented as stated above, subscribes to three hundred seventy-five (375) shares in registered form,
with a par value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of three
hundred seventy-five euro (EUR 375).
The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire sub-
scribed capital, have passed the following resolutions:
1. The following person is appointed as A manager of the Company for an indefinite period:
Ari Glass, born on 29 July 1972 in New York (U.S.A), residing at 53 Paine Avenue, New Rochelle, NY 10804, USA.
2. The following person is appointed as B manager of the Company for an indefinite period:
Stéphane Weyders, company manager, born on 2 January 1972 in Arlon (Belgium), professionally residing at rue
Goethe, 22, L-1637 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
3. The registered office of the Company is set at rue Goethe, 22, L-1637 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks German, states that, on the request of the appearing parties,
this deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and
the German text, the English text prevails.
WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representatives of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned
notary
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundacht, am siebzehnten Juni.
Vor Uns Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1. Platinum Partners Value Arbitrage Fund L.P., eine Gesellschaft gegründet gemäß dem Recht der Kaiman-Inseln, mit
Gesellschaftssitz in Walker House, Mary Street, P.O. Box 908, George Town, Grand Cayman, Kaiman-Inseln, eingetragen
im Firmenregister Limited Partnerships der Kaiman-Inseln unter der Nummer CR-13869;
2. Shmuel Gelb, fachmännischer Berater, geboren am 16. Januar 1956 in der Sowjetunion, wohnhaft in St. Weitzman
53/4, Netanya 42250, Israel,
beide hier vertreten durch Nicolas van Heule, Anwalt, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, kraft einer Vollmacht, die
in New York, USA und in Netanya, Israel ausgestellt wurde.
83989
Die genannte Vollmacht bleibt, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar "ne varietur"
unterzeichnet wurde, dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung beigebogen.
Die Komparenten, wie vorstehend vertreten, haben den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée"), die hiermit gegründet wird, wie folgt zu dokumentieren:
I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Firma. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") unter der Be-
zeichnung Wellington Global Commodities S. à r.l. (nachstehend die Gesellschaft) gegründet, die dem Luxemburger Recht
unterliegt, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in letzter Fassung (nachstehend
das Gesetz), sowie der vorliegenden Satzung (nachstehend die Satzung).
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch einfachen Be-
schluss des Geschäftsführungsrates an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Des weiteren kann
der Sitz durch einen Beschluss der Gesellschafter gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen
ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
2.2. Zweigniederlassungen, Filialen und andere Geschäftsräume können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder
im Ausland durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft errichtet werden. Sollte der Geschäfts-
führungsrat der Gesellschaft beschließen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereig-
nisse bestehen oder bevorstehen, und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit am Sitz
der Gesellschaft oder die Kommunikation zwischen der Gesellschaft und im Ausland befindlichen Personen beeinträch-
tigen würden, kann der Sitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz
der vorübergehenden Sitzverlegung des Gesellschaftssitzes eine Luxemburger Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb jedweder Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften, sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft der Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder sonst
wie die Veräußerung mittels Verkauf, Tausch und sonstigen Rechtsgeschäften, von jeglichen Wertpapieren, sowie die
Verwaltung und Auswertung des Wertpapiervermögens, welches sie besitzen wird. Darüber hinaus ist Gegenstand des
Unternehmens die Beratung über die Strukturierung von Kapitalstrukturen und industrielle Strategien, sowie die Beratung
von Unternehmen bei Zusammenschlüssen und Übernahmen und bei Verwertung von Wirtschaftsgütern. Die Gesellschaft
kann außerdem in Patente, sowie in die Wertpapierverwaltung, sowie an geistigem Eigentum jeglicher Art oder Ursprungs,
investieren.
Die Gesellschaft kann die Aufnahme und die Gewährung von Anleihen und Darlehen, mit oder ohne diesbezügliche
Sicherheiten vornehmen; sie kann an der Gründung und Entwicklung jeglicher Unternehmen teilnehmen und ihnen jegliche
Unterstützung bewilligen, im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll-, Überwachungs- und Dokumentierungs-
maßnahmen treffen und die Ausübung jedweder Tätigung zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes vor-
nehmen.
3.2. Die Gesellschaft kann den Ankauf und Verkauf von Gebrauchsgütern vornehmen, einschließlich, aber nicht be-
grenzt auf, Metalle, Erdöl und in die in Verbindung stehende Produkte des Erdöls in unterschiedlichen Regionen. Die
Geselschaft kann Gebrauchsgutverhandlungen mit Drittparteien führen
3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeder Art aufnehmen, außer auf dem Wege von öffentlichen Angeboten. Sie kann,
jedoch nur durch Privatplatzierung, Schuldscheine, Anleihen und Rentenwerte, sowie jede Art von Schuldtiteln und/oder
Dividendenpapieren ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel verleihen, einschließlich, ohne Begrenzung, die Erlöse
aus Kreditverbindlichkeiten und/oder Emissionen von Schuld- oder Dividendenpapieren an ihre Zweigunternehmen, an-
gegliederte Gesellschaften und/oder jede andere Gesellschaft. Die Gesellschaft kann in Bezug auf ihr gesamtes oder
teilweises Vermögen ebenfalls Sicherheiten leisten; sie kann verpfänden, übertragen, belasten oder sonstwie Sicherheiten
bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und Vereinbarungen und/oder den Verpflichtungen und Ver-
einbarungen jeder anderen Gesellschaft nachzukommen, und sie im Allgemeinen zu eigenem Nutzen und/oder zum
Nutzen jeder anderen Gesellschaft oder Person abzusichern. In keinem Fall wird die Gesellschaft regulierten Aktivitäten
des Finanzsektors nachgehen um Missverständnisse zu verhindern.
3.4. Mit dem Ziel einer effizienten Verwaltung kann sich die Gesellschaft im Allgemeinen in Bezug auf ihre Anlagen aller
Techniken und Instrumente bedienen, einschließlich der Techniken und Instrumente, die dazu konzipiert sind, die Ge-
sellschaft gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.
3.5. Die Gesellschaft darf alle Handels-, Finanz- und Gewerbetätigkeiten und alle Transaktionen auf unbeweglichem
oder beweglichem Eigentum ausführen, die dazu bestimmt sind, ihren Gesellschaftszweck zu fördern oder die sich auf
ihren Gesellschaftszweck beziehen.
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
83990
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch Tod, Aufhebung von Bürgerrechten, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz,
Konkurs oder ein vergleichbares Ereignis, das einen oder mehrere Gesellschafter betrifft.
II. Stammkapital - Gesellschaftsanteile
Art. 5. Stammkapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in zwölftau-
sendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile in Form von Namenspapieren mit einem Nennwert von jeweils einem Euro
(EUR 1) alle Gesellschaftsanteile sind gezeichnet und voll eingezahlt.
5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrmals durch Beschluss durch die Gesellschafterver-
sammlung gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen ist, erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Gesellschaftsanteile.
6.1. Die Gesellschaftsanteile der Gesellschaft sind unteilbar, da nur ein Eigentümer je Gesellschaftsanteil zugelassen ist.
6.2. Die Gesellschaftsanteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar.
Im Falle eines alleinigen Gesellschafters, sind die Geschäftsanteile an Dritte frei übertragbar.
Falls die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat, erfordert die Übertragung von Gesellschaftsanteilen (inter
vivos) an Dritte die Einwilligung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft ver-
treten.
Die Übertragung eines Gesellschaftsanteils bindet die Gesellschaft oder Dritte nur, wenn eine Mitteilung an die Ge-
sellschaft oder einer Billigung durch die Gesellschaft, gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches (code civil)
erfolgt ist.
6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird gemäß den Bestimmungen des Gesetzes ein Gesellschaftsanteilsregister aufbewahrt,
das von jedem Gesellschafter auf Verlangen eingesehen werden kann.
6.4. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes ihre eigenen Gesellschaftsanteile zurückkaufen unter der Voraus-
setzung dass genügend verteilbare Reserven zu diesem Zweck vorhanden sind, oder wenn der Ablösungsbetrag aus der
Kapitalherabsetzung des Stammkapitals der Gesellschaft resultiert.
III. Geschäftsführung - Vertretung
Art. 7. Ernennung und Absetzung der Geschäftsführer.
7.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet. Der oder die Geschäftsführer werden
durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung ernannt, der deren Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen
nicht Gesellschafter sein.
7.2. Die Geschäftsführer, und jeder einzelne von ihnen, können ad nutum abberufen werden (ohne Grund).
7.3. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafter können einen oder mehrere A-Geschäftsführer und ein oder
mehrere B-Geschäftsführer bestellen.
Art. 8. Geschäftsführungsrates. Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, bilden sie einen Geschäftsführungsrat.
(der Geschäftsführungsrat).
8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch die vorliegende Satzung der Gesellschafterver-
sammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft, der befugt
ist, alle Handlungen und Geschäfte zu tätigen, die dem Gesellschaftszweck dienen.
(ii) Besondere und begrenzte Befugnisse können für bestimmte Angelegenheiten vom Geschäftsführungsrat an einen
oder mehrere Beauftragte(n) delegiert werden.
8.2. Verfahren
(i) Der Geschäftsführungsrat tritt so oft an dem in der Einberufungseinladung bezeichneten Ort zusammen, im Prinzip
in Luxemburg, auf Verlangen von zwei (2) Geschäftsführern.
(ii) Schriftliche Mitteilung über jede Geschäftsführungsratssitzung ergeht mindestens 24 (vierundzwanzig) Stunden vor
dem Tag der Geschäftsführungsratssitzung an alle Geschäftsführer, außer in dringenden Fällen, in welchem Fall die Art
dieser Umstände in der Einberufungsseinladung für die Geschäftsführungsratssitzung anzugeben ist.
(iii) Eine Einberufungseinladung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft
in der Geschäftsführungsratssitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, volle Kenntnis von der Tagesordnung
zu besitzen. Ein Geschäftsführer kann entweder vor oder nach einer Geschäftsführungsratssitzung auf eine Einberufungs-
einladung verzichten. Auf eine separat aufgeführte schriftliche Einberufungseinladung kann verzichtet werden, bei Ge-
schäftsführungsratssitzung die an einem Tag und Ort vorab vom Geschäftsführungsrat beschlossen wurden.
(iv) Jeder Geschäftsführer der Gesellschaft kann an jeder Geschäftsführungsratssitzung teilnehmen, indem er einen
anderen Geschäftsführer der Gesellschaft zu seinem Vertreter bestellt.
a. Der Geschäftsführungsrat kann nur wirksam beraten und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrats werden wirksam mit der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men gefasst. Vorausgesetzt dass der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafter einen oder mehrere A-Geschäfts-
83991
führer und einen oder mehrere B-Geschäftsführer bestellt haben, mindestens einen (1) A-Geschäftsführer und einen (1)
B-Geschäftsführer (in jedem Fall, entweder persönlich oder durch Vertretung) zu Gunsten des Beschlusses abstimmen.
Der Vorsitzende besitzt keine Zweit- oder ausschlaggebende Stimme.
b. Jeder Geschäftsführer kann über Telefon oder Videokonferenz oder durch jedwedes andere vergleichbare Kom-
munikationsmittel an einer Geschäftsführungsratssitzung teilnehmen, das allen an der Sitzung teilnehmenden Personen
ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Geschäftsfüh-
rungsratssitzung durch diese Mittel ist einer persönlichen Teilnahme an dieser Geschäftsführungsratssitzung gleichgestellt.
(vii) Umlaufbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet werden (die Umlaufbeschlüsse), sind ebenso
wirksam und verbindlich wie Beschlüsse, die in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungs-
ratssitzung gefasst wurden und die das Datum der letzten Unterschrift tragen.
8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten gegenüber Dritten durch die einzelne Unterschrift eines Geschäfts-
führers verpflichtet.
(ii) Die Gesellschaft ist außerdem gegenüber Dritten durch die Unterschrift jeder Person, der eine derartige Vollmacht
zur Unterzeichnung erteilt wurde, verpflichtet.
(iii) Falls der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafter einen oder mehrere A-Geschäftsführer und einen oder
mehrere B-Geschäftsführer bestellt haben, ist die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterschrift
eines A-Geschäftsführers und eines B-Geschäftsführers verpflichtet.
Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer.
9.1. Wird die Gesellschaft von einem alleinigen Geschäftsführer geführt, so ist es angemessen, jedweden Verweis,
welcher sich in diesen Satzungen auf den Geschäftsführungsrat oder auf die Geschäftsführer bezieht, als Verweis auf den
alleinigen Geschäftsführer anzusehen.
9.2. Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten gegenüber Dritten durch die einzelne Unterschrift des einzigen
Geschäftsführers verpflichtet.
9.3. Die Gesellschaft ist außerdem gegenüber Dritten durch die Unterschrift jeder Person, der eine derartige Vollmacht
zur Unterzeichnung erteilt wurde, verpflichtet.
Art. 10. Haftung der Geschäftsführer.
10.1. Die Geschäftsführer sind durch ihr Amt nicht persönlich haftbar für Verpflichtungen, die sie im Namen der
Gesellschaft wirksam eingegangen haben, unter der Bedingung, dass diese Verpflichtungen in Übereinstimmung mit vor-
liegender Satzung sowie den anwendbaren Bestimmungen des Gesetzes stehen.
IV. Gesellschafter
Art. 11. Gesellschafterversammlung und Umlaufbeschlüsse.
11.1. Befugnisse und Stimmrechte
(i) Gesellschafterbeschlüsse sind entweder in Gesellschafterversammlungen (den Gesellschafterversammlungen) oder
aufgrund schriftlicher Beratungen im Wege des Umlaufverfahrens (die Umlaufbeschlüsse) zu fassen.
(ii) Da wo Beschlüsse als Umlaufbeschlüsse angenommen werden, soll der Text an alle Gesellschafter, in Überein-
stimmung mit den Satzungen, geschickt werden. Umlaufbeschlüsse, welche von allen Gesellschaftern unterschrieben
wurden, sind ebenso wirksam und verbindlich wie Beschlüsse, die in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen
Gesellschafterversammlung gefasst wurden und die das Datum der letzten Unterschrift tragen.
(iii) Jeder Gesellschaftsanteil besitzt eine Stimme (1).
11.2. Form - Beschlussfähigkeit - Mehrheit
(i) Die Gesellschafter werden zur Gesellschafterversammlung einberufen oder schriftlich informiert auf Initiative einer
der Geschäftsführer oder von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals besitzen.
(ii) Schriftliche Mitteilung über jede Gesellschafterversammlung ergeht mindestens acht (8) Tage vor dem Tag der
Gesellschafterversammlung an alle Gesellschafter, außer in einem Notfall, in welchem Fall die Art dieser Umstände im
Einberufungsschreiben für die Gesellschafterversammlung anzugeben ist.
(iii) Gesellschafterversammlungen finden an Ort und Zeit statt, die in den Einberufungsschreiben festgelegt wurden.
(iv) Wenn alle Gesellschafter der Gesellschaft in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und
erklären, über die Gesellschafterversammlung rechtmäßig informiert worden zu sein und die Tagesordnung zu kennen,
findet die Gesellschafterversammlung ohne Einberufungsschreiben statt.
(v) Jeder Gesellschafter der Gesellschaft kann an jeder Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere
Person, die nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein muss, zu seinem Vertreter bestellt.
(vi) Beschlüsse welche in einer Gesellschafterversammlung oder durch Umlaufbeschlüsse von den Gesellschaftern
genommen werden, werden wirksam gefasst durch die Zustimmung von Gesellschaftern welche mehr als die Hälfte des
Stammkapitals besitzen. Wenn diese Mehrheit auf der ersten Gesellschafterversammlung oder in den ersten Umlaufbe-
schlüssen nicht erreicht wird, werden die Gesellschafter mittels eingeschriebenen Briefes zu einer zweiten Gesellschaf-
terversammlung einberufen oder ein zweites Mal konsultiert und die Beschlüsse werden bei dieser Gesellschafterver-
83992
sammlung oder bei diesen Umlaufbeschlüssen mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom
Anteil des vetretenen Stammkapital.
(vii) Die Satzung kann abgeändert werden mit der Zustimmung einer Mehrheit (in Anzahl) der Gesellschafter welche
wenigstens dreiviertel (3/4) des Stammkapitals besitzen.
(viii) Jede Aenderung der Nationalität der Gesellschaft sowie die Erhöhung der Verpflichtungen der Gesellschafter
verlangt die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.
Art. 12. Alleiniger Gesellschafter.
12.1 Ist die Anzahl der Gesellschafter auf einen (1) reduziert, übt der alleinige Gesellschafter alle Befugnisse aus, welche
vom Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
12.2. Jeder, in der Satzung vorgesehenen Verweis auf die Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung oder den
Umlaufbeschlüssen, ist auf Referenz zu solchem alleinigen Gesellschafter oder dessen Beschlüsse wie passend zu deuten.
12.3. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden protokoliert oder schriftlich aufgenommen.
V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Beaufsichtigung
Art. 13. Geschäftsverteilung und Gewinnverteilung.
13.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines
jeden Jahres.
13.2. Jedes Jahr bereitet der Geschäftsführungsrat die Bilanz und das Gewinn- und Verlustkonto, sowie eine Inventur,
welches den Wert des Vermögens und die Schulden der Gesellschaft mit einem Anhang, welcher die Verpflichtungen der
Gesellschaft, sowie die Schulden der Geschäftsführer und der Gesellschafter, vor.
13.3. Jeder Gesellschafter kann die Inventur und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
13.4. Die Bilanz und das Gewinn- und Verlustkonto werden den Gesellschaftern innerhalb der ersten sechs Monate
nach dem Ende des Geschäftsjahres während der Gesellschafterversammlung oder mittels Umlaufbeschluss genehmigt.
Art. 14. Buchprüfer.
14.1. Die Aktivitäten der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Buchprüfern (réviseurs d'entreprises) be-
aufsichtigt, falls dies vom Gesetz vorgeschrieben wird.
14.2. Die Gesellschafter benennen die Buchprüfer (réviseurs d'entreprises), und bestimmen deren Anzahl, Vergütung
und deren Amtszeit, welche sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf. Die Buchprüfer (réviseurs d'entreprises) können
wiederernannt werden.
Art. 15. Gewinnverteilung.
15.1. Ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5 %) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft wird der gesetzlichen
Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent (10 %) des Stammkapital der Gesellschaft erreicht hat
15.2. Die Gesellschafterversammlung kann nach freiem Ermessen über den Überschuss verfügen. Insbesondere kann
sie den Gewinn zu einer Dividendenzahlung freigeben oder sie der Rücklage zuweisen oder auch als Gewinn vortragen.
15.3. Zwischendividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden;
(i) die Zwischenkonten (interim accounts) werden vom Geschäftsführungsrat vorbereitet.
(ii) Diese Zwischenkonten müssen genügend Gewinne und andere Reserven (eingeschlossen den Emissionsprämien),
welche zur Ausschüttung verfügbar sind, aufweisen; dies unter dem Vorbehalt, dass der zu ausschüttende Betrag, die
Gewinne welche seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, für welches die jährlichen Konten angenommen wurden, falls
vorhanden, erhöht durch die vertagte Profite und die auschüttbaren Reserven, und vermindert durch vertagten Verluste
und Beträge der vorgeschriebenen Reserve zuzuteilen sind, nicht überschreiten.
(iii) Die Entscheidung zur Zahlung von Zwischendividenden wird von den Gesellschaftern innerhalb von zwei (2) Mo-
naten ab dem Datum der Erstellung der Zwischenkonten getroffen werden.
(iv) Die Entscheidung zur Zahlung von Zwischendividenden wird von den Gesellschaftern innerhalb von zwei (2) Mo-
naten ab dem Datum der Erstellung der Zwischenkonten getroffen werden.
(iv) Eine Zusicherung wurde gegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht gefährdet sind
(v) übersteigen die zu zahlenden Zwischendividenden am Ende eines Geschäftsjahres, müssen die Gesellschafter den
Ueberschuss an die Gesellschaft zurückzahlen falls die augezahlten Zwischendividenden am Ende des Geschäftsjahres die
verteilbaren Gewinne überschreiten, müssen die Gesellschafter der Gesellschaft die überschüssigen Dividenden zurück-
zahlen.
VI. Auflösung - Liquidation
16.1. Durch einen Beschluss der Gesellschafter, welcher von der Hälfte der Gesellschafter, die über drei viertel des
Stammkapitals verfügen, angenommen wird, kann die Gesellschaft zu jeder Zeit aufgelöst werden. Im Falle einer Auflösung
der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt, die keine Gesellschafter sein
müssen, und die durch einen Beschluss der Gesellschafter ernannt werden, die ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung
bestimmt. Vorbehaltlich eines abweichenden Beschlusses der Gesellschafter haben die Liquidatoren die umfassendsten
Befugnisse für die Veräußerung der Vermögenswerte und die Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft.
83993
16.2. Der Überschuss aus der Veräußerung der Vermögenswerte und Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft
wird an die Gesellschafter im Verhältnis zu der Anzahl der Gesellschaftsanteile, die jeder Gesellschafter in der Gesellschaft
hält, ausgezahlt.
VII. Allgemeine Bestimmung
17.1. Die Verfassung und der Verzicht von Beschlüssen und Mitteilungen und die Geschäftsführerbeschlüsse, sowie die
Gesellschafterbeschlüsse sind bindend, sei es im Original oder als Faksimile oder Email, sowie in jeder anderen Form der
elektronischen Kommunikation.
17.2. Vollmachten werden wie vorstehend vergeben. Vollmachten in Verbindung mit den Gesellschafterversammlungen
können von einem Geschäftsführer gewährt werden, entsprechend der Bedingungen, die vom Geschäftsführungsrat fest-
gelegt wurden.
17.3. Unterschriften können handschriftlich sowie elektronisch erstellt werden, vorausgesetzt dass sie allen legalen
Anforderungen gerecht werden, die handschriftlichen Unterschriften gleichkommen. Unterschriften der Geschäftsfüh-
rerbeschlüsse oder der Gesellschafterbeschlüsse, je nach Lage, sind einem Original oder verschiedenen Duplikate
desselben Dokumentes beigefügt, die alle zusammen ein und dasselbe Dokument ausmachen.
17.4. Alle Befugnisse die nicht ausdrücklich unter die vorliegende Satzung fallen, fallen in den Zuständigkeitsbereich
des Gesetzes, und abhängig von Zwangsverfügungen des Gesetzes unter jegweiges Abkommen, welches zwischen den
Gesellschaftern von Zeit zu Zeit abgeschlossen wird.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag dieser Urkunde und endet am 31. Dezember 2008.
<i>Zeichnung - Zahlungi>
1. Platinum Partners Value Arbitrage Fund L.P vertreten wie vorstehend angegeben, zeichnet für zwölftausendeinhun-
dertfünfundzwanzig (12,125) Gesellschaftsanteile in Form von Namenspapieren, mit einem Nennwert von jeweils einem
Euro (EUR 1), und erklärt diese Gesellschaftsanteile vollständig durch eine Bareinlage in Höhe von zwölftausendeinhun-
dertfünfundzwanzig Euro (EUR 12,125) einzuzahlen.
2. Shmuel Gelb, vertreten wie vorstehend angegeben, zeichnet für dreihundertfünfundsiebzig (375) Gesellschaftsanteile
in Form von Namenspapieren, mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-), und erklärt diese Gesellschafts-
anteile vollständig durch eine Bareinlage in Höhe von dreihundertfünfundsiebzig Euro (EUR 375) einzuzahlen.
Der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) steht somit zur Verfügung der Gesellschaft, wie dem
unterzeichneten Notar bescheinigt wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Auslagen jeder Art, die von der Gesellschaft aus Gründen ihrer Gründung zu
tragen sind, werden auf ungefähr eintausend Euro (EUR 1.000) geschätzt.
<i>Beschlüsse der Gesellschafteri>
Sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter der Gesellschaft, die das gesamte gezeichnete
Stammkapital vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Folgende Person wird auf unbestimmte Zeit zum A-Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
Ari Glass, geboren am 29. Juli 1972 in New York (Vereinigte Staaten von Amerika), wohnhaft in 53 Paine Avenue,
New Rochelle, NY 10804, USA.
2. Folgende Person wird auf unbestimmte Zeit zum B-Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
Stéphane Weyders, Geschäftsführer, geboren am 2 Januar 1972 in Arlon (Belgien), mit Geschäftsadresse in rue Goethe,
22, L-1637 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
3. Der Sitz der Gesellschaft ist in rue Goethe, 22, L-1637 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf
Ersuchen der vorstehend bezeichneten Erschienenen in englischer Sprache abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen
Version, und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Version maß-
geblich ist.
Worüber Urkunde errichtet wurde in Luxemburg, am zu Beginn dieses Dokuments bezeichneten Tag.
Nachdem das Dokument den Erschienenen vorgelesen wurde, haben sie die vorliegende Urkunde gemeinsam mit dem
Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: N. van Heule et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 25 juin 2008. LAC/2008/25721. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents, Eur
0,5% = 62,50.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
83994
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008084288/5770/542.
(080096554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2008.
T.I.P. Technischer Industriebedarf Pickard S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6871 Wecker, 2, Op Huefdréisch.
R.C.S. Luxembourg B 139.648.
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend acht, den zwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg),
IST ERSCHIENEN:
Frau Annette FIEDLER, geborene BLAU, Steuerberaterin, wohnhaft in D-54317 Thomm, Ringstrasse 4.
Welche Komparentin den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung
sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "T.I.P. Technischer Industriebedarf Pickard S.à r.l.".
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wecker.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-
burg verlegt werden.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand das Betreiben eines Grossund Einzelhandels mit technischem Industrie-
bedarf, insbesondere der Handel mit Maschinen, Werkzeugen, Kugellager und Betriebseinrichtungen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder
denselben fördern.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500,-), aufgeteilt in EIN
HUNDERT (100) Anteile von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125,-), welche integral durch Frau
Annette FIEDLER, geborene BLAU, Steuerberaterin, wohnhaft in D-54317 Thomm, Ringstrasse 4, übernommen wurden.
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€
12.500,-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachge-
wiesen wurde.
Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.
Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen
Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690
des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-
tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die
Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
83995
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er
Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-
schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtun-
gen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der
Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt.
Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-
ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,
sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen
Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch-
geführt.
Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2008.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr neun hundert Euro (€ 900.-).
<i>Erklärungi>
Die Komparentin erklärt, dass der unterfertigte Notar ihr Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach
Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung, hat die alleinige Gesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Wolfgang Matthias QUINT, Groß- und Aussenhandelskaufmann, wohnhaft in D-54668 Ernzen, Theisstrasse 3.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und
verpflichtet.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6871 Wecker, 2, Op Huefdréisch.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. FIEDLER, Henri BECK.
83996
Enregistré à Echternach, le 25 juin 2008, Relation: ECH/2008/837. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents
12.500.-à 0,5% = €62,50.
<i>Le Receveuri> (signé): MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Echternach, den 3. Juli 2008.
Henri BECK.
Référence de publication: 2008084295/201/106.
(080096845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2008.
Lux Studio S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 2-6, Chemin des Douaniers.
R.C.S. Luxembourg B 96.258.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008084424/7430/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00896. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080096609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2008.
Nokia Siemens Networks S.A., Succursale, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.
R.C.S. Luxembourg B 119.387.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision prise par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de droit belge
Nokia Siemens Networks S.A. (la « Société») en date du 30 mars 2007 que Monsieur Peter Geilen a été révoqué de ses
fonctions de délégué à la gestion journalière.
Il est, en outre, constaté que Monsieur Dirk Wauters et Monsieur Francis Verheughe ont démissionné de leurs fonc-
tions d'administrateurs tandis que Monsieur Filip Rommelaere, Monsieur Guido Aertgeerts et Monsieur Marc Goris
nommés administrateurs de la Société de sorte qu'ils disposent d'un pouvoir d'engager la Succursale.
Il est à nouveau rappeler que Monsieur Michael Olivier Mueller a été nommé délégué à la gestion journalière de la
succursale, et ce, à partir du 1
er
avril 2007 conformément à la décision prise par le conseil d'administration de la Société
en date du 30 mars 2007.
Enfin, conformément à une décision du conseil d'administration de la société datée du 23 juin 2008, Monsieur Michael
Krause a été nommé délégué à la gestion journalière de la Succursale avec prise d'effet à compter du jour de ladite
décision, à savoir le 23 juin 2008.
En conséquence:
(i) les délégués à la gestion journalière de la Succursale sont, à ce jour, les personnes suivantes:
- Monsieur Michael Olivier Mueller, et
- Monsieur Pascal Paulin.
(ii) Les représentants permanents de la Succursale sont:
- Monsieur Pascal Paulin,
- Monsieur Nicolas Binsfeld, et
- Monsieur Michael Krause.
(iii) Les membres du conseil de la Société ayant pouvoir d'engager la Succursale sont:
- Monsieur Filip Rommalaere,
- Monsieur Guido Aertgeerts, et
- Monsieur Marc Goris.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
83997
Luxembourg, le 30 juin 2008.
<i>Pour Nokia Siemens Networks S.A., Succursale
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008084852/4067/39.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR11077. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080096907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2008.
Broad Street Mall S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 82.347.
In the year two thousand and seven, on the fourteenth of December.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "Broad Street Mall S. à r.l.", a "société à respon-
sabilité limitée", established at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 82 347,
incorporated by deed of the undersigned notary on the 21 May 2001, published in the Luxembourg Memorial C number
1,151 of December 12, 2001, whose articles of association have been amended for the last time by deed of March 3,
2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 473 of May 5, 2004
The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg,
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing professionally
in Luxembourg,
The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the sole shareholder present or represented and the number of its shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will
be registered with this minute.
II.- As appears from the attendance list, the 500 shares representing the whole capital of the corporation (with an
amount of 32,500) are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Decision to throw deliberately the company into liquidation and to dissolve it early.
2. Discharge to the sole manager.
3. Appointment of Mrs Hannah Zelda Weiss, as liquidator and determination of her powers.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides the early dissolution of the company and its deliberated throwing into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to grant full and total discharge to the sole manager concerning her mandate until today.
<i>Third resolutioni>
The meeting appoints as liquidator Mrs Hannah Zelda Weiss, residing at 141 B, Upper Clapton Road, E5 9DB London
(United Kingdom)
All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation
purpose, to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the shareholders
in proportion to their shareholding, in kind or in cash.
The said liquidator may in particular, without the following enumeration being limitative, Sell, exchange and alienate
all movable properties and rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver
of all chattels, charges, mortgages and rescissory actions, of all registrations, entries, garnishments and attachments,
absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede
priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, com-
pound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law
or acquired rights of prescription.
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
83998
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le quatorze décembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de "Broad Street Mall S. à r.l." une société à
responsabilité limitée, ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 82 347, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 21 Mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1151 du 12 décembre 2001, dont les statuts ont
été modifiés pour la dernière fois par acte reçu le 3 Mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 473 du 5 Mai 2004.
La séance est ouverte sous la présidence de Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert, juriste, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que l'actionnaire unique présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence et la
procuration resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que les 500 actions représentant l'intégralité du capital social (d'un montant
de 32.500), sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de la mise en liquidation volontaire et dissolution anticipée de la société.
2. Décharge au gérant unique.
3. Nomination de Mrs Hannah Zelda Weiss, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'accorder pleine et entière décharge au gérant unique pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce
jour.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée nomme comme liquidateur Mrs Hannah Zelda Weiss résidant à 141 B, Upper Clapton Road, E5 9DB
London (United Kingdom)
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de
la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens meubles
et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de
toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre
inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous
paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et com-
promettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions
acquises.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est
en langue anglaise, suivi d'une version française.
A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
83999
Signé: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg AC, le 19 décembre 2007. LAC/2007/41623. - Reçu douze euros (12 euros).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 4 JANVIER 2008.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2008084253/211/109.
(080096045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.
Ellergronn société coopérative, Société Coopérative.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 1, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 139.592.
<i>Liste des membres du Conseil d'Administration au 29 février 2008i>
Blanche Christiane, administratrice, institutrice en retraite, L-5953 Itzig, 10, rue des Champs
Femmes en Détresse A.s.b.l, ayant son siège à L.-1260 Luxembourg. 1, rue de Bonnevoie administratrice, représentée
par sa présidente, Karin Manderscheid, fonctionnaire d'Etat, L-5893 Hesperange, 7, rue TH. Urbain,
Franke Ralph, administrateur, commerçant, L-4017 Esch-sur-Alzette, 3, rue des Artisans
Manderscheid Karin, présidente, fonctionnaire d'Etat, L-5893 Hesperange, 7, rue Th. Urbain
Schanck Myriam, vice-présidente, employée privée, L-1254 Luxembourg, 21, rue M. de Brabant
Schranck Joëlle, administratrice, éducatrice, L-2168 Luxembourg, 75, rue de Mühlenbach
Thinnes Catherine, trésorière, employée d'Etat, L-1232 Howald, 46, rue Ernest Beres
Welter Christiane, secrétaire, fonctionnaire d'Etat, L-1227 Luxembourg, 3, rue Bellevue
Luxembourg, le 29 février 2008.
Certifiée conforme aux décisions du Conseil d'administration
Karin Manderscheid
<i>Présidentei>
Référence de publication: 2008083450/8933/23.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2008, réf. LSO-CQ08246. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080095266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2008.
NPEI Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 103.855.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de NPEI Lux S.A. tenue à Luxembourg le 24i>
<i>juin 2008i>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé unanimement de:
- prendre acte de la démission de Mr Jean-François Helfer, avec effet immédiat;
- nommer Monsieur Pierre Hervé, résidant professionnellement au 5-7, rue de Monttessuy, F-75340 Paris Cedex 07
comme nouveau membre du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les
comptes qui se clôtureront au 31 décembre 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2008.
<i>Pour la Société
NPEI LUX. S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008084639/1138/21.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR10981. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080096890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
84000
Ageney S.A.
Alberticho Construcion S.A.
Art Décor S.A.
Avenirose S.A.
Batiglobal S.à r.l.
Broad Street Mall S.à r.l.
Bronze Capital SPF S.A.
CEP Holdings S.à r.l.
Coiffure Eliane S.à.r.l.
Conforama Luxembourg
CWS N.V. Luxembourg Branch
Eclipse Aviation Southeastern Europe S.à r.l.
Ellergronn société coopérative
Eurofund
Francilienne Investments I S.à r.l.
Geminus S.A.
Hastings & Cornwall S.A.
International Shipping House S.A.
Investors Office Holding S.à r.l.
Jabe Holding S.A.
Koningslaan S.à r.l.
Le Grand Château S.à.r.l.
Lubelair S.A.
Lux Animation SA
Lux Media S.A.
Lux Studio S.A.
Machold Holding S.A.
McKesson International Holdings VI S.à r.l.
Mega Bloks International S.à r.l.
Mega Brands International
Metallbau Roth S.à r.l.
Mountain Aviation S.A.
Mustique Capital London Partners SA
Nokia Siemens Networks S.A., Succursale
Noreva Finance S.A.
Nowa Holding S.à r.l.
NPEI Lux S.A.
Parinco
Pauliac S.à r.l.
Perfin S.A.
P.P.L.V. Finance S.A. Holding
Presta Concept S.à r.l.
Private Gallery S.A.
Pro - Re - Co S.à.r.l.
R & C & Partners S.A.
RECP IV CMBS International
S.E.C. Finance S.A.
Sofires S.A.
SPE III RG S.à r.l.
Sterling Sub Holdings S.A.
SVG Holdings S.A.
SVG Holdings S.A.
Thomson International S.à r.l.
T.I.P. Technischer Industriebedarf Pickard S.à r.l.
Tolmina S.A.
UPG Holdings I
Vailog CalEast LaSalle China S.à r.l.
Vandemoortele Participations
Via Santé S.A.
Villefranche S.à r.l.
Weather Capital Finance
Wellington Global Commodities S. à r.l.
WM Holding Sàrl
WM Investments Sàrl