logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1746

16 juillet 2008

SOMMAIRE

Apeiron Advisors S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

83808

Apeiron Investments S.C.A. . . . . . . . . . . . . .

83808

Bankwerk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83766

BG Real Estate Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . .

83772

Bonissim S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83785

BP Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83786

Brupez S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83776

Caloocan Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83784

Ciba Specialty Chemicals Finance Luxem-

bourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83777

Clemington Corporation S.à r.l.  . . . . . . . . .

83780

Cogit S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83779

Continental Real Estate Company  . . . . . . .

83776

C.P.I. Holding - Compagnie de Placements

Immobiliers S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83784

DAULUX S.A. Internationale Transport &

Spedition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83785

Digidoc International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .

83783

Digidoc International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .

83782

Digidoc International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .

83782

Digidoc International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .

83782

ECM Real Estate Investments A.G.  . . . . . .

83765

EFI Eurofinance Investments Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83785

Entreprise Générale S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

83781

Finances Europe Tourisme S.A.  . . . . . . . . .

83784

Fréon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83780

Fusion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83784

General Mediterranean Holding  . . . . . . . . .

83780

Genius International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

83778

Halifax S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83785

Holpar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83794

Immobilière Beaumont S.A.  . . . . . . . . . . . .

83808

Immobilière de Gestion Financière S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83783

Immo-Croissance SICAV-FIS  . . . . . . . . . . .

83767

Ital Property S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83786

JAS Worldwide  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83786

JPMorgan Investment Strategies Funds  . .

83763

JPMorgan Private Bank Funds I . . . . . . . . . .

83762

Jumi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83762

Larissa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83763

Leonardo Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83764

Leyla S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83762

LS Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83779

McKesson Information Solutions Holdings

II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83783

McKesson International Capital S.à r.l.  . . .

83783

Mediterranean Holding (Luxembourg)  . . .

83777

OWR Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83777

Participations A & F S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

83808

Pérez Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

83802

Rausz Consulting Luxembourg S.A. . . . . . .

83779

Shire Holdings Europe No.2 S.à r.l.  . . . . . .

83778

Société Privée d'Investissement S.A. . . . . .

83782

Solupa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83778

Spinnaker II Investment Fund SIF  . . . . . . .

83767

Techhol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83795

The World Trust Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . .

83764

Vega Advisory Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

83781

Vermont International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

83786

Waterstock Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83772

Weather Capital Special Purpose 1 S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83781

W.S. Fund (la société)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83765

83761

Jumi S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 11.774.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i> 1 

<i>er

<i> août 2008  à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mai 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

mai 2008.

4. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2008086457/1023/16.

Leyla S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 67.392.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 juillet 2008 à 17.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008073710/696/16.

JPMorgan Private Bank Funds I, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 114.378.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the "Meeting") of JPMorgan Private Bank Funds I the ("Company") will be held on Friday, <i>25 July

<i>2008 at 12.00 noon (Luxembourg time) at the Registered Office of the Company, as set out above, with the following
Agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation and approval of the Report of the Board of Directors for the accounting year ended March 31, 2008.
2. Presentation of the Report of the Auditors for the accounting year ended March 31, 2008.
3. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended March 31, 2008.
4. Discharge of the Board of Directors in respect of their duties carried out for the accounting year ended March 31,

2008.

5. Approval of Directors' Fees.
6. Re-election of Mr Jacques Elvinger, Mr Benoit Dumont, Mr Alain Feis and Mr Jean Fuchs to serve as Directors of

the Company, until the next Annual General Meeting of Shareholders, approving the Financial Statements for the
accounting year ending on March 31, 2009.

7. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. to serve as Auditors until the Annual General Meeting of Share-

holders, approving the Financial Statements for the accounting year ending on March 31, 2009.

83762

8. Allocation of the results for the accounting year ended March 31, 2008.
9. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

<i>Voting

Resolutions on the Agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes

expressed by Shareholders present or represented at the Meeting.

<i>Voting arrangements

Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to use the prescribed Form of Proxy (available

from the Registered Office of the Company or from www.jpmorgan.com/assetmanagement/extra) and return it by no
later than the close of business in Luxembourg on Wednesday, 23 July 2008 at the Registered Office of the Company
(Client Services Department, fax +352 3410 8000) or to your usual client adviser.

<i>By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2008080934/755/34.

Larissa S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 22.316.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>24 juillet 2008 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

mars 2008.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008082570/1023/17.

JPMorgan Investment Strategies Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 63.762.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the "Meeting") of JPMorgan Investment Strategies Funds (the "Company") will be held on Friday, <i>25

<i>July 2008 at 12.00 noon (Luxembourg time) at the Registered Office of the Company, as set out above, with the following
Agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation and approval of the Report of the Board of Directors for the accounting year ended March 31, 2008.
2. Presentation of the Report of the Auditors for the accounting year ended March 31, 2008.
3. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended March 31, 2008.
4. Discharge of the Board of Directors in respect of their duties carried out for the accounting year ended March 31,

2008.

5. Approval of Directors' Fees.
6. Re-election of Mr Jacques Elvinger, Mr Alain Feis, Mr Jean Fuchs, Mr Berndt May and Ms Andrea L. Hazen to serve

as Directors of the Company until the Annual General Meeting of Shareholders approving the Financial Statements
for the accounting year ending on March 31, 2009.

7. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. to serve as Auditors until the Annual General Meeting of Share-

holders approving the Financial Statements for the accounting year ending on March 31, 2009.

8. Allocation of the results for the accounting year ended March 31, 2008.
9. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

83763

<i>Voting

Resolutions on the Agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes

expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.

<i>Voting arrangements

Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to use the prescribed Form of Proxy (available

at the Registered office of the Company or from www.jpmorgan.com/assetmanagement/extra) and return it by no later
than the close of business in Luxembourg on Wednesday, 23 July 2008 at the Registered Office of the Company (Client
Services Department, fax +352 3410 8000) or, to your usual client adviser.

<i>By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2008081454/755/34.

Leonardo Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 125.012.

Due to a lack of quorum, the extraordinary general meeting held on Tuesday 24 June 2008, was not able to validly

decide on its agenda.

Thus we are pleased to invite you to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders (the "Meeting") of LEONARDO INVEST (the "Company") that will be held at the registered office of

the Company, as set above <i>1st August 2008 at 10.00 a.m., for the purpose of considering the following agenda:

<i>Agenda:

Amendment of the last paragraph of article 16 of the articles of incorporation of the Company in order to modify
the investment policy. The new paragraph shall read as follows:
"Unless otherwise provided specifically for a class in the prospectus of the Corporation, the Corporation will not
invest more than 10% of the net assets of any class in units of undertakings for collective investment as defined in
Article 41 (1) e) of the Law."

Resolution on the agenda of the reconvened extraordinary general meeting will require no quorum and the resolution

shall be passed by a majority of two thirds of the shares of the Company present or represented.

In order to attend or to be represented to the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their

shares certificates five days before the Meeting at the office of BNP Paribas Luxembourg, 10A, boulevard Royal, L- 2093
Luxembourg where proxy forms are available.

<i>By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2008077812/755/24.

The World Trust Fund, Société d'Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 37.154.

As the Extraordinary General Meeting of 27th June 2008 could not validly deliberate for lack of quorum, Notice is

hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of The World Trust Fund (the "Fund") will be held at 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg at 2.30 p.m. on

<i>31 July 2008 for the purpose of considering and, if thought fit, passing the following resolutions:

<i>Agenda:

1. the Fund's share capital be reduced by cancelling all of the ordinary shares (i.e. three million one hundred and

seventy thousand and three (3,170,003 shares) held by the Fund in treasury and that paragraph 2 in article 5 of the
Fund's articles of incorporation (the "Articles") be altered accordingly.

2. second paragraph of article 20 of the Articles be amended.
3. articles 2, 3, 4, 10, 13, 19 and 29 of the Articles be amended.

A detailed letter to shareholders and the full text of the proposed amendments are available free of charge upon

request at the registered office of the Fund.

83764

Shareholders may vote in person or by proxy. Proxy forms are available at the registered office of the Fund. They

must be completed and signed, and sent to State Street Bank Luxembourg (for the attention of Mr Jean-Baptiste Simba)
at 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg and/or by fax at +352 46 40 10 413 no later than 6.00 p.m. on 29 July
2008.

<i>By Order of the Board
Jeremy Sillem
<i>Chairman

Référence de publication: 2008079021/755/26.

W.S. Fund (la société), Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 66.039.

Par la présente le liquidateur soussigné a l'honneur de vous convoquer à

l'ASSEMBLEE GENERALE

des Actionnaires de la SICAV qui aura lieu le <i>24 juillet 2008 , à 10.00 heures, auprès du cabinet KAUFHOLD OSSOLA

&amp; ASSOCIES (KOA) 20, avenue Marie-Thérèse BP 477, L-2014 Luxembourg, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des états financiers de la SICAV à la date de la mise en liquidation au 20.07.2005.
2. Approbation du rapport du réviseur à la liquidation.
3. Décharge donnée aux administrateurs de la SICAV pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de la mise en

liquidation de la SICAV.

4. Décharge donnée au liquidateur et au réviseur à la liquidation.
5. Clôture de la liquidation.
6. Distribution du boni de liquidation en faveur des actionnaires et dépôt, en vertu de la loi, auprès de la Caisse de

Consignation de toute partie du boni de liquidation non réclamé.

7. Désignation de l'emplacement où seront conservés pendant cinq ans les livres comptables et documents sociaux

de la SICAV. Il est proposé par le liquidateur soussigné de désigner le dernier siège social de la SICAV.

Luxembourg, le 27 juin 2008.

e

 Charles OSSOLA

<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2008080938/755/24.

ECM Real Estate Investments A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 65.153.

ECM Real Estate Investments A.G. (the "Company") hereby gives notice that a

MEETING

of the holders of the Bonds (the "Bondholders") will be held at the registered offices of the Company on <i>25 July

<i>2008 at 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg (the "Meeting"), for the purpose of considering and, if thought fit,
passing the following resolution which will be proposed:

<i>Resolution

"That this Meeting of all the holders of the outstanding 21,221 Bonds issued on 9 October 2007 and 5,311 Bonds

issued on 2 November 2007 (with 70 warrants attached to each bond) (the "Bonds") of ECM Real Estate Investments
A.G. respectively constituted by the Securities Note and Summary dated 3 October 2007 hereby approves the appoint-
ment of Mr Vítezslav Gloser as representative of the body of bondholders of the Company for a term ending at the end
of the Bonds issue.

<i>Background

The Company is convening the Meeting of the Bondholders by the present Notice to request their agreement by the

Resolution to the matters contained in such Resolution.

The Company considers that the proposed appointment contained in the Resolution set out above is fair and reaso-

nable in the circumstances and, accordingly, the Company urges Bondholders to vote in favour of the Resolution.

Bondholders who wish to vote must do so in accordance with the procedures of Euroclear Bank, S.A. / NV as operator

of the Euroclear System ("Euroclear") or Clearstream, Banking, Société Anonyme ("Clearstream") or any alternative

83765

clearing system (any "Alternative Clearing System"). Bondholders must allow sufficient time for compliance with the
standard operating procedures of Euroclear or Clearstream or any Alternative Clearing System, in order to ensure
delivery of their voting instructions to the Bond Agent in due course.

Beneficial owners of Bonds held through a broker, dealer, commercial bank, custodian, trust company or accountholder

(each, an "Intermediary") are urged to confirm the deadline for receipt of their voting instructions by such Intermediary
to ensure onward delivery of such instructions to the Bond Agent by the relevant deadline.

Voting instructions shall comply with and be transmitted in accordance with the usual procedures of Euroclear or

Clearstream or any Alternative Clearing System, as the case may be, so as to be received by Euroclear or Clearstream
or any Alternative Clearing System, sufficiently in advance of the deadlines set out below for their transmittal to the Bond
Agent by the relevant deadline.

Voting instructions should clearly specify whether the Bondholder wishes to vote in favour of or against the Resolu-

tions.

By submitting voting instructions to Euroclear or to Clearstream or to any Alternative Clearing System, each Bond-

holder will be deemed to appoint the Bond Agent (acting through any of its officers, employees, agents or other nominee)
as its proxy to attend and vote at the Meeting and, if the original Meeting is adjourned, at any adjourned Meeting in respect
of the Bonds blocked by it in the relevant Clearing System in conjunction with such instructions and either in favour of
or against the Resolutions, as specified in such instructions.

Bondholders acknowledge that by communicating their voting instructions and blocking their Bonds in the relevant

Clearing System they will be deemed to consent to having the relevant Clearing System provide details concerning their
identity to the Bond Agent and the Company.

<i>Voting and quorum

(1) A Bondholder wishing to attend and vote at the Meeting in person must produce at the Meeting either the Bond

(s), or a valid voting certificate issued by the Bond Agent relating to the Bond(s), in respect of which he wishes to vote.

A  Bondholder not  wishing to attend  and  vote  at  the  Meeting in person  may  either deliver  his  Bond(s) or  voting

certificate(s) to the person whom he wishes to attend on his behalf or give, or a duly authorised person on his behalf
must give, a voting instruction (on a voting instruction form obtainable from the specified offices of the Bond Agent set
out  below)  directing  the  Bond  Agent  to  appoint  a  proxy  to  attend  and  vote  at  the  Meeting  in  accordance  with  his
instructions.

To obtain a voting certificate or to give voting instructions, Bonds must be deposited with the Bond Agent or (to the

satisfaction of such Bond Agent) held to its order or under its control by Clearstream or Euroclear or any Alternative
Clearing System or any other depositary approved by it, for the purpose of obtaining voting certificates, not later than
24 hours before the time appointed for holding the Meeting (or, if applicable, any adjournment of such Meeting). Bonds
so deposited or held will not be released until the earlier of the conclusion of the Meeting (or, if applicable, any adjourn-
ment of such Meeting).

(2) There is no quorum required at the Meeting which will decide upon the appointment of a representative of the

body of bondholders.

(3) To be passed, the Resolution shall be adopted by a simple majority of the votes cast by the Bondholders present

or represented at the Meeting. If passed, the Resolution will be binding on all the Bondholders.

Bond Agent
Caceis Bank Luxembourg
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Fax: + 352 47 67 7411
Attention: Corporate Trust Department, Mr Romain Lux

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2008082564/534/69.

Bankwerk, Groupement Européen d'Intérêt Economique.

Siège social: L-1274 Howald, 25, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg D 70.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait de l'assemblée des membres de Bankwerk

«Par la présente, et conformément aux statuts du GEIE Bankwerk, l'assemblée des membres (Mitgliederversammlung)

a décidé unanimement dans sa séance du 29 avril courant de liquider le GEIE Bankwerk à la date du 30 avril 2008. Elle a
constaté au 30 avril 2008 la clôture de la liquidation volontaire du GEIE Bankwerk par le liquidateur.

83766

Les livres et documents seront déposés et conservés pendant cinq ans au moins au 25, rue des Bruyères, L-1274

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à en trois exemplaires à Howald/Luxembourg, le 30 avril 2008.

Advantage / Paulinus Verlag / Zweipunktnull
Alain Ierace / Thomas Juncker / Frank Schu

Référence de publication: 2008084640/9138/20.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2008, réf. LSO-CR10480. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080096894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2008.

Spinnaker II Investment Fund SIF, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion prenant effet le 8 mai 2008 concernant le fonds commun de placement Spinnaker II Investment

Fund SIF, a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

The management regulations effective as of may 8 2008 with respect to the fund Spinnaker II Investment Fund SIF

registered in Luxembourg has been filed with the Luxembourg trade and companies register.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations à Luxembourg.

Spinnaker Venture S.A.
Signature

Référence de publication: 2008080778/250/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2008, réf. LSO-CR09866. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080092784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2008.

Immo-Croissance SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 28.872.

In the year two thousand and eight, on the ninth day of July.
Before us Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Gérard LECUIT,

notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to whom remains the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Immo-Croissance SICAV-FIS (the "Company"), a

société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé governed by the laws of Grand Duchy of
Luxembourg and in particular the law of February 13, 2007 on specialized investment funds, with registered office at 69,
route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, entered in the Luxembourg Register of Commerce and
Companies, Section B, under number 28.872, and incorporated following a deed of notary Jacques Delvaux, notary residing
at the time in Esch-sur-Alzette, dated September 22, 1988, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (the "Memorial") n 

o

 286 of November 3, 1988. The articles of incorporation of the Company were amended

for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary of June 4, 2007, not yet published in the Memorial.

The meeting is declared open at 11:00 a.m. by Mr Jean-François Willems, director of the Company, professionally

residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mr Karl Heinz Dick, director of the Company, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Riccardo Falconi, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1 To approve the unaudited interim accounts of the Company as of April 30, 2008.
2 To receive the reports issued by the board of directors of the Company and by PricewaterhouseCoopers S.à r.l.,

respectively, in relation to the below proposed merger.

3 To approve the merger proposal whereby the Company would merge with and absorb BG Real Estate Europe, a

société d'investissement à capital variable - Fonds d'Investissement Spécialisé under the law of 13 February 2007 on
specialized investment funds, with registered office at 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number R.C.S. Luxembourg B-132.221, in accordance with
articles 261 and following of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

83767

4 To issue and allot new shares to the shareholders of BG Real Estate Europe as a consequence of the Merger and as

indicated in the relevant merger proposal.

5 To convert all distribution shares and all capitalisation shares of the Company into ordinary shares.
6 To elect new directors of the Company.
7 To delegate special powers in relation to the above proposed resolutions.
8 Miscellaneous.
(ii) That the present meeting has been convened by publications in the Luxembourg and Belgian State gazettes and

newspapers on June 9, 2008 and June 20, 2008 as follows:

* Memorial
* Luxemburger Wort
* Financieel Economische Tijd
* Tageblatt
* Moniteur Belge
and in the Echo de la Bourse and the Financieel Economische Tijd on June 10, 2008 and June 20, 2008.
(iii) That the registered shareholders have further been convened by registered mail on June 30, 2008 in accordance

with applicable provisions.

(iv) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing
parties will also remain annexed to the present deed.

(v) That it appears from the attendance list that 43,398 capitalisation shares out of the 46,084 outstanding capitalisation

shares (with the remaining 2,686 capitalisation shares being treasury shares held by the Company) and 310,853 distribution
shares out of the 310,853 outstanding distribution shares of the Company in issue are present or represented at the
present meeting and the shareholders declare having had prior knowledge of the agenda so that as a result of the foregoing
the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the afore described agenda.

(vi) That the acting notary declares and certifies the existence and/or performance of all formalities and actions which

article 271 of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies, as amended, requires from the Company.

Then the general meeting, after deliberation, adopted with a majority of more than two thirds of the votes of the

shareholders  present  or  represented  for  each  class  of  shares of the Company  (i.e. the  capitalisation  shares  and the
distribution shares) the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting acknowledged the merger proposal (the "Merger Proposal") issued on June 4, 2008 by the Com-

pany and published in the Memorial on June 9, 2008, whereby it is proposed that the Company merge with and absorb
BG Real Estate Europe, a société d'investissement à capital variable - Fonds d'Investissement Spécialisé under the law of
13 February 2007 on specialized investment funds, with registered office at 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number R.C.S. Luxembourg B-132.221
("BG").

The general meeting further resolved to approve the interim accounts of the Company as of April 30, 2008 as referred

to in the Merger Proposal.

<i>Second resolution

The general meeting acknowledged the reports issued by the board of directors of the Company and by Pricewate-

rhouseCoopers, respectively, in relation to the above proposed merger.

<i>Third resolution

The general meeting resolved to approve the merger as more fully described in the Merger Proposal whereby the

Company is to merge with and absorb, effective on the date hereof, BG in accordance with articles 261 and following of
the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies (the "Merger").

The general meeting in particular resolved that as a consequence of the Merger (i) all assets and liabilities held by BG

on the date hereof will automatically transfer to the Company on the same date with no restriction or limitation, and
that (ii) as of the date hereof the Company shall bear all existing liabilities of BG and perform any and all obligations related
thereto as well as the Company shall bear and pay any and all costs, expenses and taxes arising pursuant to the Merger.

<i>Fourth resolution

In consideration for the Merger, the general meeting resolved to issue forty-two thousand two hundred and thirty-

one (42,231) new distribution shares, each such share having no nominal value, being fully paid up and having the same
rights and privileges as the existing shares, as relevant.

83768

Pursuant to the Merger Proposal, these new distribution shares are hereby allotted directly to the shareholders of BG

in accordance with an exchange ratio amounting to zero point one three five two two one eight five two nine three
(0.13522185293) new distribution shares of the Company for each existing share of BG.

The above exchange ratio is duly justified in the report issued by the board of directors of the Company dated June

4, 2008.

The general meeting further acknowledged that the shareholders of BG forfeited their respective right to receive an

exact number of new distribution shares and accepted to be issued and allotted, pro rata to their current holdings in BG,
only the nearest lower full number of new distribution shares so as to prevent the Company from issuing fraction of
shares.

<i>Fifth resolution

The general meeting resolved to convert all capitalisation shares and all distribution shares of the Company into

ordinary shares so as to terminate the current classification of shares.

The general meeting resolved in particular that the above mentioned conversion be achieved by using the following

ratio: two point eight one zero six six five five zero six three five seven seven zero (2.81066550635770) new ordinary
shares for one (1) existing capitalisation share and one (1) new ordinary share for one (1) existing distribution share.

The general meeting further acknowledged that the holders of distribution shares of the Company, forfeited their

respective right to receive an exact number of new ordinary shares and accepted to be issued and allotted, pro rata to
their current holdings in the Company, only the nearest lower full number of new ordinary shares corresponding to their
existing distribution shares so as to prevent the Company from issuing fraction of shares.

<i>Sixth resolution

The general meeting resolved to confirm the mandates of all current directors of the Company and not to elect any

additional director.

<i>Seventh resolution

The general meeting resolved to confer all and any powers to any director of the Company, each acting individually

and with full power of substitution, in order to implement the above resolutions.

<i>Eighth resolution

The general meeting resolved that all resolutions hereinabove adopted shall be conditional to the approval of the

Merger by the shareholders of BG.

The general meeting further acknowledged that BG shall automatically cease to exist upon effectiveness of the Merger.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 11:30 a.m.

<i>Declaration for tax purposes

The contribution of all the assets and liabilities of the absorbed company is made in compliance with the provisions of

article 4.1 of the law of 29 December 1971, as amended, which provides for a capital duty exemption.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at seven thousand euro (EUR 7,000).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le neuvième jour de juillet.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Gérard

LECUIT, notaire, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la
présente minute,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Immo-Croissance SICAV-FIS (la "So-

ciété"), une société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé régie par les lois du Grand-Duché
de Luxembourg et en particulier la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés, avec siège
social au 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 28.872 et constituée suivant acte de Maître Jacques Delvaux,
notaire demeurant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 22 septembre 1988, publié au Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") n 

o

 286 du 3 novembre 1988. Les statuts de la Société ont été

modifiés dernièrement par acte du notaire instrumentant en date du 4 juin 2008, non encore publié au Mémorial.

83769

L'assemblée est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur Jean-François Willems, administrateur de la

Société, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Karl Heinz Dick, administrateur de la Société, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Riccardo Falconi, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1 Approbation des états financiers intérimaires non-audités de la Société au 30 avril 2008.
2 Présentation des rapports émis respectivement par le conseil d'administration de la Société et par Pricewaterhou-

seCoopers S.à r.l. sur la fusion ci-après proposée.

3 Approbation du projet de fusion par lequel la Société fusionne et absorbe la société BG Real Estate Europe, une

société d'investissement à capital variable - Fonds d'Investissement Spécialisé régie par la loi du 13 février 2007 concernant
les fonds d'investissement spécialisés, ayant son siège social au 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, et
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-132.221, conformément aux
articles 261 et suivants de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée sur les sociétés commerciales.

4 Émission et allocation de nouvelles actions aux actionnaires de BG Real Estate Europe en conséquence de la Fusion

et tel qu'indiqué dans le projet de fusion.

5 Conversion de l'ensemble des actions de capitalisation et des actions de distributions de la Société en actions ordi-

naires.

6 Élection de nouveaux membres du conseil d'administration.
7 Délégation de pouvoirs spéciaux en rapport aux résolutions ci-avant proposées.
8 Divers.
(ii) Que la présente assemblée générale a été convoquée par voie de publications dans les journaux officiels luxem-

bourgeois et belges suivants en date des 9 juin 2008 et 20 juin 2008,

* Mémorial
* Luxemburger Wort
* Tageblatt
* Moniteur Belge
et dans l' Écho de la Bourse et le Financieel Economische Tijd en date des 10 juin 2008 et 20 juin 2008.
(iii) Que les actionnaires nominatifs ont par ailleurs été convoqués par lettre recommandée en date du 30 juin 2008

conformément aux dispositions applicables.

(iv) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées
aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

(v) Qu'il résulte de ladite liste de présence que 43.398 actions de capitalisation sur un total de 46.084 actions de

capitalisation émises (avec le reste des 2.686 actions de capitalisation étant des actions propres détenues par la Société)
et 310.853 actions de distribution sur un total de 310.853actions de distribution émises par la Société sont présentes ou
représentées à la présente assemblée et que les actionnaires de la Société ont déclaré avoir eu connaissance préalable
de l'ordre du jour de sorte que ladite assemblée est valablement constituée et peut valablement décider sur tous les
points portés à l'ordre du jour ci-avant énoncé.

(vi) Qu'en exécution de l'article 271 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,

le notaire instrumentant déclare avoir vérifié et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la
Société.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, a pris ensuite adopté les résolutions suivantes à la majorité de plus des

deux tiers dans chaque catégorie d'actions de la Société (i.e. les actions de capitalisation et les actions de distribution):

<i>Première résolution

L'assemblée générale a pris acte de le projet de fusion (la "Projet de Fusion") émis par la Société en date du 4 juin 2008

et publié au Mémorial en date du 9 juin 2008, au titre duquel il est proposé que la Société fusionne avec et absorbe BG
Real Estate Europe, une société d'investissement à capital variable - Fonds d'Investissement Spécialisé régie par la loi du
13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés, ayant son siège social au 35a, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-132.221
("BG").

83770

L'assemblée générale a décidé d'approuver les états intérimaires de la Société au 30 avril 2008 tel qu'indiqués au Projet

de Fusion.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale a pris acte des rapports émis respectivement par le conseil d'administration de la Société et

PricewaterhouseCoopers S.à r.l. quant à la fusion ci-dessous proposée.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale a décidé d'approuver la fusion telle que plus amplement décrite dans le Projet de Fusion au titre

duquel la Société doit fusionner avec et absorber BG en application des articles 261 et suivants de la loi du 10 août 1915
telle que modifiée sur les sociétés commerciales (la "Fusion").

L'assemblée générale a en particulier décidé qu'en conséquence de la Fusion (i) l'universalité du patrimoine de BG (soit

l'ensemble de ses actifs et passifs) à la date des présentes sera automatiquement transféré à la même date, sans aucune
restriction ou limitation, et que (ii) au jour des présentes la Société supportera l'ensemble du passif de BG, ainsi qu'elle
exécutera tous les engagements et obligations y afférant et payera et supportera tous les frais, impôts et charges quel-
conques résultant de la Fusion.

<i>Quatrième résolution

En en contrepartie de la Fusion l'assemblée générale a décidé d'émettre quarante-deux mille deux cent trente-et une

(42.231) nouvelles actions de distribution, chacune de ces actions n'ayant pas de valeur nominale, entièrement libérées
et ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et correspondantes.

En conformité au Projet de Fusion, ces nouvelles actions de distribution sont par les présentes directement allouées

aux actionnaires de BG en application du ratio d'échange suivant: zéro virgule un trois cinq deux deux un huit cinq deux
neuf trois (0, 13522185293) nouvelles actions de distribution pour chaque action existante de BG.

Le ratio d'échange ci-avant énoncé est dûment justifié dans le rapport du conseil d'administration de la Société daté

du 4 juin 2008.

L'assemblée générale a par ailleurs pris acte de ce les actionnaires de BG ont renoncé a leur droit à recevoir un nombre

exact de nouvelles actions de distribution et ont accepté de n'être émis et alloués, au pro rata de leur participation
respective dans BG, que le seul nombre de nouvelles actions de distribution arrondi au nombre entier inférieur le plus
proche de sorte à éviter à la Société d'émettre des rompus d'actions.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale a décidé de convertir l'ensemble des actions de capitalisation et l'ensemble des actions de dis-

tribution de la Société en actions ordinaires de sorte à ne plus disposer de l'actuelle catégorisation d'actions.

L'assemblée générale a en particulier décidé de ce que la conversion suive un ratio de une (1) action ordinaire nouvelle

pour deux virgule huit un zéro six six cinq cinq zéro six trois cinq sept sept zéro (2,81066550635770) actions de capi-
talisation existantes et une (1) action ordinaire nouvelle pour une (1) action de distribution existante.

L'assemblée générale a par ailleurs pris acte de ce que chacun des titulaires d'actions de distribution de la Société a

renoncé a son droit à recevoir un nombre exact d'actions ordinaires nouvelles et a accepté de n'être émis et alloué, au
pro rata de sa participation respective dans la Société, que le seul nombre d'actions nouvelles ordinaires correspondant
à leurs actions de distribution arrondi au nombre entier inférieur le plus proche de sorte à éviter à la Société d'émettre
des rompus d'actions.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale a décidé de confirmer les mandats de l'ensemble des administrateurs de la Société et de ne pas

en élire de nouveaux.

<i>Septième résolution

L'assemblée générale a décidé de déléguer tous pouvoirs à chacun des membres du conseil d'administration de la

Société, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de mettre en œuvre et réaliser les réso-
lutions ci-avant adoptées.

<i>Huitième résolution

L'assemblée générale a décidé que l'ensemble des résolutions ci-avant adoptées était conditionnel à l'approbation de

la Fusion par les actionnaires de BG.

L'assemblée générale a par ailleurs pris acte de ce que BG cessera d'exister lorsque la Fusion devient effective.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale est close à 11.30 heures.

<i>Déclaration pour raisons fiscales

L'apport de l'universalité du patrimoine actif et passif de la société absorbée est faite en conformité avec les dispositions

de l'article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971, comme modifiée, qui prévoit une exemption du droit d'apport.

83771

<i>Évaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à sept mille euros (EUR 7.000).

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-Fr. Willems, K.H. Dick, R. Falconi, J. Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 juillet 2008, LAC/2008/28299. - Reçu douze euros (12.- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en vertu d'un mandat verbal, en remplacement

de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

Luxembourg, le 10 juillet 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008085394/220/269.
(080101130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Waterstock Fund, Fonds Commun de Placement.

Sondervermögen, verwaltet von der SEB Fund Services S.A., mit Sitz in 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347

Luxemburg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 44.726.

Das Sonderreglement des Waterstock Fund (Stand: Juni 2008) wurde am 26.6.2008 beim Handelsregister hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SEB Fund Services S.A.
Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

Référence de publication: 2008084384/755/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR09211. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080091977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2008.

BG Real Estate Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 132.221.

In the year two thousand and eight, on the ninth day of July.
Before us Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Gérard LECUIT,

notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to whom remains the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of BG Real Estate Europe (the "Company"), a Société

d'Investissement à Capital Variable-fonds d'investissement spécialisé organised under the Luxembourg law of 13 February
2007 concerning specialised investment funds, with registered office at 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, entered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under
number 132.221, and incorporated following a deed of notary Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, dated
October 5, 2007, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") n 

o

 2496 of No-

vember 3, 2007, and the articles of incorporation of which have been amended for the last time pursuant to a deed of
notary Blanche Moutrier, prenamed, dated December 19, 2007 published in the Mémorial n 

o

 60 dated January 10, 2008.

The meeting is declared open at 12:00 a.m. by Mr Jean-François Willems, director of the Company, professionally

residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mr Riccardo Falconi, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Karl Heinz Dick, director of Immo-Croissance SICAV-FIS, professionally residing

in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:

83772

<i>Agenda:

1 To approve the unaudited interim accounts of the Company as of April 30, 2008.
2 To receive the reports issued by the board of directors of the Company and by PricewaterhouseCoopers S.à r.l.,

respectively, in relation to the below proposed merger.

3 To approve the merger proposal whereby the Company would merge with and be absorbed by Immo-Croissance

SICAV-FIS, a société d'investissement à capital variable - Fonds d'Investissement Spécialisé under the law of 13 February
2007 on specialized investment funds, with registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg and registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number R.C.S. Luxembourg B-28.872, in accordance with articles
261 and following of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

4 To grant full discharge to the member of the board of directors of the Company for the performance of their

mandates for the period up to April 30, 2008.

5 To delegate special powers in relation to the above proposed resolutions.
6 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing
parties will also remain annexed to the present deed.

(iii) That the whole corporate capital being represented at the present meeting and all the shareholders present or

represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

(iv) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items of the agenda.

(v) That the acting notary declares and certifies the existence and/or performance of all formalities and actions which

article 271 of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies, as amended, requires from the Company.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously adopted the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting acknowledged the merger proposal (the "Merger Proposal") issued by the Company on June 4,

2008 and published in the Mémorial on June 9, 2008, whereby it is proposed that the Company merge with and be
absorbed by Immo-Croissance SICAV-FIS, a société d'investissement à capital variable - Fonds d'Investissement Spécialisé
under the law of 13 February 2007 on specialized investment funds, with registered office at 69, route d'Esch, L-1470
Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number R.C.S. Luxembourg
B-28.872 ("IC").

The general meeting further resolved to approve the interim accounts of the Company as of April 30, 2008 as referred

to in the Merger Proposal (the "Interim Accounts").

<i>Second resolution

The general meeting acknowledged the reports issued by the board of directors of the Company and by Pricewate-

rhouseCoopers S.à r.l., respectively, in relation to the below proposed merger.

<i>Third resolution

The general meeting resolved to approve the merger as more fully described in the Merger Proposal whereby the

Company is to merge with and be absorbed, effective on the date hereof, by IC in accordance with articles 261 and
following of the law of August 10, 1915, as amended, on commercial companies (the "Merger").

The general meeting in particular resolved that as a consequence to the Merger (i) all assets and liabilities held by the

Company on the date hereof will automatically transfer to IC on the same date with no restriction or limitation, that (ii)
IC shall bear all existing liabilities of the Company and perform any and all obligations related thereto as well as IC shall
bear and pay any and all costs, expenses and taxes arising pursuant to the Merger, and that (iii) the Company shall
automatically dissolve and cease to exist on the date hereof.

The general meeting further resolved that in consideration for the Merger, an aggregate of forty-two thousand two

hundred and thirty-one (42,231) new distribution shares of IC shall be issued and allotted directly to the current share-
holders  of  the  Company,  those  new  shares  having  the  same  rights  and  obligations  as  the  existing  capitalisation  and
distribution shares of IC, as relevant.

Pursuant to the Merger Proposal, these forty-two thousand two hundred and thirty-one (42,231) new distribution

shares of IC are hereby allotted directly to the shareholders of BG in accordance with the following exchange ratio: zero
point one three five two two one eight five two nine three (0.13522185293) new distribution shares of IC for each existing
share of the Company.

The above exchange ratio is duly justified in the report issued by the board of directors of the Company dated June

4, 2008.

83773

The general meeting further acknowledged that each of Dial Square Holding EHF and Kaupthing Bank Luxembourg

S.A., as shareholders of the Company, forfeited their respective right to receive an exact number of new distribution
shares of IC and accepted to be issued and allotted, pro rata to their current holdings in the Company, only the nearest
lower full number of new distribution shares of IC so as to prevent the latter from issuing fraction of shares.

<i>Fourth resolution

After having reviewed and approved the Interim Accounts the general meeting resolved to grant full discharge to each

member of the board of directors of the Company for the proper performance of his respective functions up to April
30, 2008.

<i>Fifth resolution

The general meeting resolved to confer all and any powers to any director of IC, each acting individually and with full

power of substitution, in order to implement the Merger as approved above.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 12:15 a.m.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at seven thousand euro (EUR 7,000).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le neuvième jour de juillet.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Gérard

LECUIT, notaire, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la
présente minute,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BG Real Estate Europe (la "Société"),

une  société  d'investissement  à  capital  variable  -  fonds  d'investissement  spécialisé  régie  par  la  loi  du  13  février  2007
concernant les fonds d'investissement spécialisés, avec siège social au 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous
le numéro 132.221 et constituée suivant acte de Maître Blanche Moutrier, notaire demeurant à Esch-sur-Alzette, Grand-
Duché  de  Luxembourg,  en  date  du  5  octobre  2007,  publié  au  Mémorial  C  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  (le
"Mémorial") n 

o

 2496 du 3 novembre 2007 et dont les statuts ont été modifiés dernièrement par acte du notaire Maître

Blanche Moutrier, prénommé, en date du 19 décembre 2007, publié au Mémorial n 

o

 60 du 10 janvier 2008.

L'assemblée est ouverte à 12 heures sous la présidence de Monsieur Jean-François Willems, administrateur de la

Société, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Riccardo Falconi, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Karl Heinz Dick, administrateur de Immo-Croissance SICAV-FIS,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1 Approbation des états financiers intérimaires non-audités de la Société au 30 avril 2008.
2 Présentation des rapports émis respectivement par le conseil d'administration de la Société et par Pricewaterhou-

seCoopers S.à r.l. sur la fusion ci-après proposée.

3 Approbation du projet de fusion par lequel la Société fusionnerait avec et serait absorbée par la société Immo-

Croissance SICAV-FIS, une société d'investissement à capital variable - Fonds d'Investissement Spécialisé régie par la loi
du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés, ayant son siège social au 69, route d'Esch, L-1470
Luxembourg,  et  immatriculée  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg  sous  le  numéro  B-28.872,
conformément aux articles 261 et suivants de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée sur les sociétés commerciales.

4 Décharge pleine et entière des membres du conseil d'administration de la Société pour l'accomplissement de leurs

mandats jusqu'au 30 avril 2008.

5 Délégation de pouvoirs spéciaux en rapport aux résolutions ci-avant proposées.
6 Divers.

83774

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées
aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

(iii) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

(iv) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

(v) Qu'en exécution de l'article 271 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,

le notaire instrumentant déclare avoir vérifié et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la
Société.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, a ensuite adopté les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée générale a pris acte de le projet de fusion (la "Projet de Fusion") émis par la Société en date du 4 juin 2008

et publié au Mémorial en date du 9 juin 2008, au titre duquel il est proposé que la Société fusionne avec et soit absorbée
par Immo-Croissance SICAV-FIS, une société d'investissement à capital variable - Fonds d'Investissement Spécialisé régie
par la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés, ayant son siège social au 69, route d'Esch,
L-1470 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-28.872
("IC").

L'assemblée générale a décidé d'approuver les états intérimaires de la Société au 30 avril 2008 tel qu'indiqués au Projet

de Fusion (les "États Financiers Intérimaires").

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale a pris acte des rapports émis respectivement par le conseil d'administration de la Société et

PricewaterhouseCoopers S.à r.l. quant à la fusion ci-dessous proposée.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale a décidé d'approuver le Projet de Fusion au titre duquel la Société doit fusionner avec et être

absorbée par IC en application des articles 261 et suivants de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée sur les sociétés
commerciales (la "Fusion").

L'assemblée générale a en particulier décidé (i) d'approuver les états intérimaires de la Société au 30 avril 2008 tel

qu'indiqués au Projet de Fusion, et (ii) qu'en conséquence de la Fusion (x) l'universalité du patrimoine de la Société (soit
l'ensemble de ses actifs et passifs) à la date des présentes sera automatiquement transféré à la même date, sans aucune
restriction ou limitation, que (y) IC supportera l'ensemble du passif de la Société, ainsi qu'elle exécutera tous les enga-
gements et obligations y afférant et payera et supportera tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la
Fusion, et que (z) la Société sera dissoute et cessera d'exister au jour des présentes.

L'assemblée générale a également décidé qu'en contrepartie de la Fusion, un total de quarante-deux mille deux cent

trente-et une (42.231) nouvelles actions de distribution de IC seront émises et allouées aux actionnaires actuels de la
Société, ces nouvelles actions comportant les mêmes droits et privilèges que les actions de capitalisation et que les actions
de distributions existantes de IC, tel qu'applicable.

En conformité au Projet de Fusion, ces quarante-deux mille deux cent trente-et une (42.231) nouvelles actions de

distribution sont par les présentes directement allouées aux actionnaires de la Société en application du ratio d'échange
suivant: zéro virgule un trois cinq deux deux un huit cinq deux neuf trois (0, 13522185293) nouvelles actions de distribution
pour chaque action existante de la Société.

Le ratio d'échange ci-avant énoncé est dûment justifié dans le rapport du conseil d'administration de la Société daté

du 4 juin 2008.

L'assemblée générale a par ailleurs pris acte de ce que chacun de Dial Square Holding EHF et de Kaupthing Bank

Luxembourg S.A., en qualité d'actionnaires de la Société, a renoncé a son droit à recevoir un nombre exact de nouvelles
actions de distribution de IC et a accepté de n'être émis et alloué, au pro rata de sa participation respective dans la
Société, que le seul nombre de nouvelles actions de distribution de IC arrondi au nombre entier inférieur le plus proche
de sorte à éviter à IC d'émettre des rompus d'actions.

<i>Quatrième résolution

Après examen et approbation des États Financiers Intérimaires, l'assemblée générale a décidé de donner décharge

pleine et entière aux membres du conseil d'administration de la société pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'au 30
avril 2008.

83775

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale a décidé de déléguer tous pouvoirs à chacun des membres du conseil d'administration de IC,

chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de mettre en œuvre et réaliser la Fusion telle que
ci-avant approuvée.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale est close à 12.15 heures.

<i>Évaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à sept mille euros (EUR 7.000).

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-Fr. Willems, R. Falconi, K.H. Dick, J. Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 juillet 2008, LAC/2008/28300. - Reçu douze euros (€ 12.-).

<i>Le Receveur

 (signé): Fr. Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en vertu d'un mandat verbal, en remplacement

de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

Luxembourg, le 10 juillet 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008085395/220/212.
(080101127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

Brupez S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 345, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg E 675.

Avec effet au 18 mai 2008, le siège social de BRUPEZ s.c.i est transféré du 107, rue de la Tour Jacob à L-1831 Lu-

xembourg au 345, rue de Neudorf, 345 à L-2221 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2008.

<i>Pour BRUPEZ s.c.i.
Andrew BRUCE
<i>Gérant

Référence de publication: 2008079099/5068/16.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2008, réf. LSO-CR08830. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080090189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Continental Real Estate Company, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 19.098.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 13 mai 2008 à 9.00 heures à Luxembourg

Veuillez noter le changement d'adresse suivant:
Montbrun Révision Sàrl, "Le Dôme", Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008083634/1128/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR06242. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

83776

Mediterranean Holding (Luxembourg), Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 21.310.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 14 mai 2008

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer comme nouvel Administrateur, sous réserve d'appro-

bation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale:

Monsieur Suhail NASSER, residing professionnally, C/O ITALGRADE LIMITED Lincoln House,137-143 Hammersmith

Road GB-LONDON W14 0 QL.

Jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en juin 2008.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008083633/1128/18.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR06262. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080095762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

OWR Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 105.042.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions du Conseil de Surveillance prises en date du 18 janvier 2008 conformément à l'article 15 des

articles de constitution de la société OWR HOLDINGS S.A. que:

M. Hans-Jakob BAUM, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, né le 11 mars 1952

est élu au poste de membre du directoire de la société avec effet au 18 janvier 2008 et ce jusqu'au 31. janvier 2011.

Luxembourg, le 16 juin 2008.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008083620/1729/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2008, réf. LSO-CR08133. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 93.778.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 16 mai 2008, les mandats des administra-

teurs MM. Thomas BUCHER, Peter BÜRGIN, Harry MÜLLER, Max DETTWILER, et Daniel PETITPIERRE, ainsi que celui
du commissaire aux comptes ERNST &amp; YOUNG S.A., ont été renouvelés pour une durée d'un an, prenant fin à l'issue
de l'assemblée générale annuelle de l'an 2009.

Luxembourg, le 10 JUIN 2008.

<i>Pour CIBA SPECIALTY CHEMICALS FINANCE LUXEMBOURG S.A., société anonyme
Experta Luxembourg, société anonyme
Catherine Day-Royemans / Mireille Wagner
<i>Vice-Président

Référence de publication: 2008083649/1017/18.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05707. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080096140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

83777

Shire Holdings Europe No.2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 21.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.468.

<i>Déclaration

Il est noté que l'associé unique de la Société, Shire Holdings Europe S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant

son siège social au 20, rue Eugene Ruppert, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (numéro RCS B 110480) (l'«As-
socié Unique»), a changé de forme juridique et de dénomination sociale par acte notarié en date du 25 avril 2008.

Il en résulte que l'Associé Unique n'a désormais plus la forme d'une société à responsabilité limitée dénommée Shire

Holdings Europe S.à r.l. mais a pris la forme d'une société anonyme dénommée Shire Holdings Europe S.A. et, ce en date
du 25 avril 2008.

Luxembourg, le 3 juillet 2008.

<i>Pour SHIRE HOLDINGS EUROPE NO. 2 S.A R.L.
Signature

Référence de publication: 2008083614/2134/20.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01758. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080095985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Solupa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 61.548.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution du conseil d'administration en date du 3 janvier 2008 que le mandat d'administrateur délégué

de Madame Nives Zanotto a été renouvelé pour une durée de deux ans.

Son mandat prendra donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>SOLUPA SA
Patrick Meunier
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008083639/6102/17.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04573. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Genius International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 80.774.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 19 avril 2007, la démission en date du 31 mai 2006 de M. Christoph

Kossmann de ses fonctions d'administrateur a été ratifiée. De ce fait, le nombre des administrateurs est réduit de quatre
à trois.

Luxembourg, le 11 JUIN 2008.

<i>Pour GENIUS INTERNATIONAL S.A., société anonyme
Experta Luxembourg, société anonyme
Catherine Day-Royemans / Liette Heck
<i>Vice-Président

Référence de publication: 2008083648/1017/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05709. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080096141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

83778

LS Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 123.220.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 11 juin 2008 à 11.30 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Joseph WINANDY, Jean QUINTUS et

Koen LOZIE, Administrateurs ainsi que de V.O. CONSULTING LUX S.A., Commissaire aux Comptes, L-8399 Windhof,
Windhof Business Center, 4, rue d'Arlon, pour une période qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui
statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2008.

Pour copie certifiée conforme
J. WINANDY / J. QUINTUS
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008083603/1172/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00691. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080095827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Cogit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 118.483.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 2 juin 2008 à 10.30 heures à Luxembourg

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes arrivent à échéance à la présente assemblée.
L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs Messieurs Joseph WINANDY, Jean QUINTUS et

COSAFIN S.A. et de renouveler le mandat de Fiduciaire HRT au poste de Commissaire aux Comptes.

Les mandats des administrateurs Jean QUINTUS, Joseph WINANDY, COSAFIN S.A. et du Commissaire aux Comptes

Fiduciaire HRT arriveront à échéance à l'assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre
2008.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008083598/1172/19.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00685. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Rausz Consulting Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 85.587.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2008
- est élu au poste d'administrateur, en replacement de l'administrateur démissionnaire Mr Patrick van Dessel,
Madame Marie-Paul van Waelem, demeurant 7, rue du fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg
Son mandat se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2008
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008083619/1031/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00988. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

83779

Fréon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 77.246.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 14 mai 2008 à 16.30 heures à Luxembourg

Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes arrivent à échéance à la présente assemblée.
L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs Messieurs Joseph WINANDY, Jean QUINTUS et

COSAFIN S.A. et de renouveler le mandat de V.O. Consulting Lux S.A. au poste de Commissaire aux Comptes.

Les mandats des administrateurs Jean QUINTUS, Joseph WINANDY, COSAFIN S.A. et du Commissaire aux Comptes

V.O. Consulting Lux S.A. arriveront à échéance à l'assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 31
décembre 2008.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008083606/1172/19.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00695. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080095812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

General Mediterranean Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 16.453.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 décembre 2007 à 10.00 heures à

<i>Luxembourg

Veuillez noter le changement d'adresse de Montbrun Révision Sàrl:
"Le Dôme", Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 LUXEMBOURG

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008083635/1128/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR06247. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Clemington Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 103.355.

<i>Extrait suite au changement de gérant

Par les résolutions écrites du 25 Juin 2008, l'associé de la société a décidé:
- d'accepter la démission de BGP Investment S.à r.l. en tant que gérant de la Société, prenant effet le 25 Juin 2008.
- de nommer en tant que gérant, prenant effet le 25 Juin 2008, et pour une durée indéterminée,
- Babcock &amp; Brown European Investments S.à r.l., enregistré sous le numéro B109507 au Registre de Commerce et

des Sociétés, et ayant comme adresse 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 Juin 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008083643/6765/18.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2008, réf. LSO-CS00419. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080096023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

83780

Vega Advisory Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 86.226.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 22 novembre 2007

Le mandat du Commissaire aux Comptes de la société ERNST &amp; YOUNG S.A., Société Anonyme, avec siège social

au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'As-
semblée Générale Statutaire de l'an 2008 est acceptée.

Luxembourg, le 22 novembre 2007.

Certifié sincère et conforme
<i>VEGA ADVISORY HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008083675/795/18.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2008, réf. LSO-CR08798. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080095917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Entreprise Générale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 37.769.

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg en date du 7 décembre 2007

Après délibérations et à l'unanimité, les membres du Conseil d'Administration décident:
- de nommer Madame Chantal MATHU comme Présidente du Conseil d'Administration. Le mandat de Présidente du

Conseil d'Administration de Madame Chantal MATHU viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2008.

Luxembourg, le 7 décembre 2007.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ENTREPRISE GENERALE S.A.
Services Généraux de Gestion S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008083676/795/19.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR00985. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Weather Capital Special Purpose 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 125.495.

Constituée par-devant M 

e

 Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en

date du 22 mars 2007, acte publié au Mémorial C no 620 du 17 avril 2007.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Weather Capital Special Purpose 1 S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008083995/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR11007. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

83781

Digidoc International Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 66.374.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2008084009/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00518. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080095617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Digidoc International Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 66.374.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2008084010/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00519. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Digidoc International Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 66.374.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2008084011/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00516. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Société Privée d'Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 69.744.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008083816/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2008, réf. LSO-CS00222. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

83782

Digidoc International Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 66.374.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2008084008/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00517. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080095614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

McKesson Information Solutions Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 89.830.

Les comptes annuels au 31 mars 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02/07/08.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008084016/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00802. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

McKesson International Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 88.499.

Les comptes annuels au 31 mars 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02/07/2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008084017/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2008, réf. LSO-CS00805. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Immobilière de Gestion Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 27.858.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03/07/08.

Signature.

Référence de publication: 2008083819/1128/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR06236. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

83783

Fusion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 62.763.

Le bilan de la société au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008083959/655/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2008, réf. LSO-CR10083. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080095446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Caloocan Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 78.376.

Le bilan de la société au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008083967/655/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2008, réf. LSO-CR10113. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

C.P.I. Holding - Compagnie de Placements Immobiliers S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 48.839.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>C.P.I. HOLDING - COMPAGNIE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008083985/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR09092. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Finances Europe Tourisme S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 112.096.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008083904/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2008, réf. LSO-CR10006. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

83784

Halifax S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 58.782.

Le bilan de la société au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008083935/655/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2008, réf. LSO-CR10088. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080095437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

EFI Eurofinance Investments Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 68.875.

Le bilan de la société au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008083930/655/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2008, réf. LSO-CR10096. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Bonissim S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1726 Luxembourg, 4, rue Pierre Hentges.

R.C.S. Luxembourg B 99.158.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02/07/2008.

EASIT SA
Signature

Référence de publication: 2008083939/3579/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2008, réf. LSO-CR10741. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

DAULUX S.A. Internationale Transport &amp; Spedition, Société Anonyme.

Siège social: L-8059 Bertrange, 3, Grevelsbarriere.

R.C.S. Luxembourg B 25.660.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008083907/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2008, réf. LSO-CR09937. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

83785

Ital Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 116.657.

Le bilan de la société au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008083942/655/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2008, réf. LSO-CR10105. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080095444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Vermont International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 71.229.

Le bilan de la société au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008083943/655/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2008, réf. LSO-CR10093. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

BP Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8309 Capellen, Aire de Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 45.782.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2008.

Par mandat

e

 Nicolas SCHAEFFER

Référence de publication: 2008083950/273/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2008, réf. LSO-CS00198. - Reçu 40,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

JAS Worldwide, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 139.671.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the seventeenth day of June.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

- Trident Luxembourg Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), duly incor-

porated and validly existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6 C, Parc d'Activités Syrdall,
L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 20,000 and registered with the Luxembourg
Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number B 138.308; and

83786

- Universi Limited Partnership, a limited partnership duly formed and validly existing under the laws of the State of

Georgia, United States of America, having its registered office at 5424 Glenridge Drive, NE Atlanta, GA 30342, United
States of America;

both here represented by Mr Raymond THILL, "maître en droit", residing professionally in Luxembourg,
by virtue of two powers of attorney given on June 16, 2008.
The said powers of attorney, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing parties and the undersigned notary,

shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such parties, appearing in the capacity of which they act, have requested the notary to draw up the following articles

of association (the "Articles") of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby
incorporated:

Title I - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by

Luxembourg law as well as by the present Articles (the "Company").

Art. 2. Name. The Company's name is JAS Worldwide.

Art. 3. Purpose. The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form what-

soever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions,
purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the
Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in
part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions and grant to any company or entity

which form part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including
companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance,
loan, advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as
borrow and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its

purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Munsbach, Grand-Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other place within the city of Munsbach by means of a resolution of the sole manager,
or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles or to any
other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality
of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five
percent (75%) of the share capital.

The Company may have branches and offices, both in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

Title II - Capital - Shares

Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) divided into

12,500 shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.

Art. 7. Voting Rights. Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights com-

mensurate to such shareholder's ownership of shares.

Art. 8. Indivisibility of shares. Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only

one owner per share.

Art. 9. Transfer of shares. The shares are freely transferable among shareholders or where the Company has a sole

shareholder.

Transfers of shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least

seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the law of August 10, 1915 concerning com-

mercial companies, as amended from time to time (the "Law").

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall be able to redeem its own shares, in the framework of a decrease

of its subscribed capital by cancellation of the redeemed shares, under the following terms and conditions:

- the redemption price shall be set by reference to the nominal value of each redeemed share, or if higher within the

total amount of any distributable sums in accordance with the entitlement of the redeemed shares as provided for by the

83787

Articles. Where the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption
may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price;

- the redemption shall be carried out by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders,

by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of
the share capital; and

- the redeemed shares shall be cancelled following the decrease of the capital.

Title III - Management

Art. 11. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers. Where

more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers.

No manager needs be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent
(50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be
determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or

in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the
share capital of the Company, as the case may be.

Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence
of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint

signature of at least two managers.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board
of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as
well as any other relevant condition.

Art. 13. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among

its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and
who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed,

the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except
when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held within the Grand-Duchy of Luxembourg.
Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another

manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication

means, initiated from the Grand-Duchy of Luxembourg and allowing all managers participating in the meeting to hear
each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present

in person or by alternate not less than one-half of the total number of managers, unless there are less than three (3)
managers in which case the quorum shall be all of the managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers

of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting

of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken
together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies

or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Art. 14. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly

made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of
the Company.

Title IV - Shareholder meetings

Art. 15. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in

accordance with the Law.

Except  in  case  of  current  operations  concluded  under  normal  conditions,  contracts  concluded  between  the  sole

shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

83788

Art. 16. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of

managers, as the case may be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by
shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least

24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed

on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as

such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of share-

holders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at
a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share

capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of

the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed

twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholder resolutions are validly taken in writing, at the same majority
vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receives prior to its written vote
and in writing by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand-

Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice,
on the third Thursday of June or on the following business day if such day is a public holiday.

Title V - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit

Art. 17. Financial year. The financial year of the Company starts on January 1 and ends on December 31.

Art. 18. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as

the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an
inventory will be annexed, constituting altogether the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder,
or in case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general
meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This

allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed
at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution

of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute
it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

Art. 20. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the

case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement
of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

Art. 21. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be

entrusted to a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several
statutory auditors.

No statutory auditor needs be a shareholder of the Company.
Statutory auditor(s) shall be appointed by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%)

of the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of
shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of
shareholders.

Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register

as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts
audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

83789

Title VI - Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality

of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders,
representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death,
suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the

sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the
shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the
share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets
of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders
proportionally to the shares they hold.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2008.

<i>Subscription - Payment

All the 12,500 shares representing the entire share capital of the Company, have been entirely subscribed as follows:
- 12,250 shares representing 98% of the share capital subscribed by Trident Luxembourg Holding, S.à r.l. named above,

by payment in cash of an amount of EUR 12,250; and

- 250 shares representing 2% of the share capital subscribed by Universi Limited Partnership named above, by payment

in cash of an amount of EUR 250.

Therefore the total amount of EUR 12,500 is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly

given to the notary by producing a blocked funds certificate.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand one hundred (2,100.-)
Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders representing the entirety of the subscribed

share capital passed the following resolutions:

1) - Mr. Biagio Bruni, residing in Via Gesu'. 11, 20121 Milan, Italy,
- Mr. Marco Rebuffi, residing in 8641 Ellard Drive, Alpharetta, GA 30022, USA, and
- Ms. Tahira Fumo, residing in 1235 Dunwoody Village Drive, Dunwoody, GA 30338, USA;
are each appointed as managers of the Company for an undetermined duration;
2) The registered office of the Company shall be established at 6 C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-

Duchy of Luxembourg.

In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person and in case
of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with us, the Notary, the

present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- Trident Luxembourg Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 6 C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de 20.000
EUR et immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.308; et

- Universi Limited Partnership, une société de droit de l'Etat de Géorgie, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social

au 5424 Glenridge Drive, NE Atlanta, GA 30342, Etats-Unis d'Amérique,

toutes deux ici représentées par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg,

en vertu de deux procurations données sous seing privé, le 16 juin 2008.

83790

Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Lesdites parties comparantes, agissant ès qualité, ont requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les "Sta-

tuts") d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

Titre I 

er

 - Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois

ainsi que par les présents Statuts (la "Société").

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est JAS Worldwide.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque

forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des
participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et
licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, déve-
lopper, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales, d'accorder à

toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec
la Société, incluant les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre
forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou de consentir au profit de tiers des sûretés ou des garanties afin de garantir
les obligations des sociétés précitées, ainsi que d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de
garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement

à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré

en tout autre lieu de la commune de Munsbach par décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par
décision du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par
résolution de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des associés représentant
plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand - Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II - Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros), divisé en 12.500 parts sociales

d'une valeur nominale de 1 EUR, chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par

résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société.

Art. 7. Droits de vote. Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote

proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.

Art. 8. Indivisibilité des parts. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire

par part sociale.

Art. 9. Transfert des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé unique.
Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins

soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales telle que modifiée (la "Loi").

Art. 10. Rachat des parts. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales, dans le cadre d'une

réduction de son capital souscrit par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions sui-
vantes:

- le prix de rachat est fixé par référence à la valeur nominale de chacune des parts sociales rachetées, ou, s'il est

supérieur, dans la limite du montant total de toutes les sommes distribuables et en conformité avec les droits conférés
aux parts sociales rachetées tels que prévus par les Statuts. Lorsque le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale
des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes
sont disponibles pour couvrir l'excédent de prix;

- le rachat est décidé par une résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par une résolution prise

par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société;

- les parts sociales rachetées sont annulées immédiatement après la réduction du capital social.

83791

Titre III - Gérance

Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où

plus d'un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en

cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé

unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société.

Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique,

ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du
conseil de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe

d'au moins deux gérants.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques

à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil
de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes
autres modalités ou conditions de leur mandat.

Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses

membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé
de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour,

l'heure et le lieu de la réunion, est donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y est
renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen

de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre

moyen de communication approprié initié depuis le Grand - Duché de Luxembourg et permettant à l'ensemble des gérants
participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente
à une participation physique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, sont présents en personne ou

représentés au moins la moitié du nombre total des gérants, à moins qu'il n'y ait moins de trois (3) gérants, au quel cas
le quorum ne sera atteint que par la présence de tous les gérants.

Lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par

un vote favorable de la majorité des gérants de la Société présents ou représentés.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors

d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux
étant un original et tous ensembles constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants.

Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régu-

lièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux
Statuts.

Titre IV - Assemblée générale des associés

Art. 15. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés con-

formément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la

Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou,

le cas échéant, par le conseil de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s'il existe. A défaut,
elles sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins

24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

83792

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit

un tiers qui n'a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant

plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première
assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que

soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des

associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-

cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des
votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par
tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalable-
ment à son vote écrit.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au

Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société le troisième jeudi du mois de juin ou le jour ouvrable suivant
si ce jour est férié.

Titre V - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas

échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire est annexé,
l'ensemble  de  ces  documents  constituant  les  comptes  annuels  sera  soumis  à  l'associé  unique  ou  en  cas  de  pluralité
d'associés à l'assemblé générale des associés.

Art. 19. Bénéfice . Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements,

charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des
associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être

obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu'à
entière reconstitution.

Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés re-

présentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution aux associés
proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve
distribuable.

Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant,

peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi
par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles
pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

Art. 21. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un

commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance constitué de plusieurs commissaires.

Aucun commissaire n'a à être associé de la Société.
Le(s) commissaire(s) sont nommés par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)

du capital social de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur
mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les conditions de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes
à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée
générale des associés peut cependant nommé un réviseur d'entreprise à tout moment.

Titre VI - Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société est décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par

l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au
moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est pas dissoute par la mort, la sus-
pension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé

unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité

83793

des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui dé-
terminera  leurs  pouvoirs et rémunérations.  Au  moment  de  la  clôture  de liquidation,  les  avoirs de  la  Société seront
attribués à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils
détiennent.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2008.

<i>Souscription - Paiement

L'intégralité des 12.500 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société a été entièrement sou-

scrite comme suit:

- 12.250 parts sociales représentant 98% du capital social souscrit par Trident Luxembourg Holding S.à r.l., prénommée,

intégralement libérées par un paiement en numéraire d'un montant de 12.250 EUR; et

- 250 parts sociales représentant 2 % du capital social souscrit par Universi Limited Partnership, prénommée, inté-

gralement libérées par un paiement en numéraire d'un montant de 250 EUR.

Le montant de 12.500 EUR est donc à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant

par la production d'un certificat de blocage de fonds.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à deux mille cent (2.100,-) euros.

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés représentant la totalité du capital social souscrit, ont

pris les résolutions suivantes:

1) - M. Biagio Bruni, demeurant à Via Gesu'. 11, 20121 Milan, Italy;
- M. Marco Rebuffi, demeurant au 8641 Ellard Drive, Alpharetta, GA 30022, USA; et
- Mme Tahira Fumo, demeurant au 1235 Dunwoody Village Drive, Dunwoody, GA 30338, USA
sont chacun nommés gérants de la Société pour une période indéterminée.
2) Le siège social de la Société est établi au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête de la personne comparante

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et
français, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 25 juin 2008, LAC/2008/25713. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents Eur

0,5% = 62,50.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008085056/5770/438.
(080097338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

Holpar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 133.866.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008084911/4333/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2008, réf. LSO-CR10786. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080096202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2008.

83794

Techhol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 139.670.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the seventeenth of June.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mrs Nathalie MAGER, private employee, residing professionally in L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
2) Mrs Helena TONINI-DI VITO, employee, residing professionally in L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
This appearing parties, have requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of an

"public limited company" (société anonyme), which is hereby incorporated.

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued, a public limited company (société anonyme) in the form of a société anonyme, under the name of "TECHHOL
S.A."(the Company).

The Company is established for an undetermined period.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of the shareholders of the Company

adopted in the manner required for the amendment of these Articles.

The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be established

either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures notes and other securities of
any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The Company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and

debentures.

The Company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate
transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The Company may carry out its object directly or indirectly for itself or for the account of third parties, alone or in

association, by making any operation which it deems useful for the attainment or development of its object or the object
of corporations in which it has participations.

The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (31.000.- EUR) consisting of three hundred ten (310)

shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, entirely paid in.

The authorized capital is fixed at three hundred ten thousand euro (310.000.- EUR) consisting of three thousand one

hundred (3.100) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) per share.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 6 hereof.

Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these

Articles, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased
amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may from time to
time determine. The board of directors is specially authorized to proceed to such issues without reserving to the then
existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 4. The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.
The Company will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.

83795

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations
of the Company.

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company,

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first Friday of June at 10.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circum-
stances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these Articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless

at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the

Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the
Luxembourg Official Gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce
the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be
carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased

only with the unanimous consent of the shareholders of the Company.

Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Company by conference call or similar means

of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and
properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members except where it

has been established at a general meeting of shareholders that the Company has a single shareholder, the board of
directors may be constituted by a sole member until the ordinary general meeting following the establishment of the
existence of more than one shareholder. In that case, the sole member of the board of directors of the Company assumes
all powers conferred by the Law to the board of directors. The members of the board of directors need not be share-
holders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting or as the case may be by a

resolution of the sole shareholder of the Company. The shareholders of the Company or as the case may be the sole
shareholder of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their
office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the
general meeting of shareholders of the Company or as the case may be by a resolution of the sole shareholder of the
Company.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of the Company
or as the case may be until the next resolution of the sole shareholder of the Company.

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated

in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

83796

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at  a  meeting  of  the  board  of  directors.  Decisions  shall  be  taken  by  a  majority  of  votes  of  the  directors  present  or
represented at such meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed by circulary

means in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors. Such resolution shall
consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and every director (résolution circulaire).
The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interests. All powers not expressly reserved by the Luxembourg law dated August 10th, 1915 on
commercial companies (the "Companies Law 1915") and by the Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of share-
holders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be shareholders
of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their
emoluments.

Art. 10. The Company shall be bound towards third parties by (i) the joint signatures of any two directors of the

Company in all matters unless otherwise decided by the general meeting of the shareholders of the Company; or (ii) as
the case may be, by the single signature of the single director; or (iii) the joint signatures or single signature of any persons
to whom such signatory power has been granted by the board of directors, but only within the limits of such power.

Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the single

signature of any person to whom daily management powers have been delegated.

Art. 11. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

Art. 12. The accounting year of the Company shall begin on January 1st and shall terminate on December 31st of each

year.

Art. 13. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 14. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 15. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Law 1915.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Subscribers

Subscribed

Paid-in Number

capital

capital of shares

EUR

EUR

1) Mrs Nathalie MAGER, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500.- 4.000.-

155

2) Mrs Helena TONINI-DI VITO, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500.- 4.000.-

155

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000.- 8.000.-

310

The shares have been paid in by cash to an extend of twenty-five point eight one pour cent (25,81 %) so that the

amount of eight thousand euro (8.000.- EUR) is of now available to the Company, proof of which has been given to the
notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of

December 2008.

83797

The First Annual General Meeting shall be held in 2009.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

<i>Resolutions

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of the statutory auditors at one (1).
2. Are appointed as directors:
-  Mrs  Nathalie  MAGER,  employee,  born  in  Longwy  (France)  on  May  2nd,  1966,  residing  professionally  in  L-2180

Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet;

- Mrs Helena TONINI-DI VITO, employee, born in Messancy (Belgium) on September 8th, 1968, residing professionally

in L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet;

- Mr Pierfrancesco AMBROGIO, president, employee, born in Rende (Italy) on January 4th, 1978, residing professionally

in L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

The mandate of the sole member or as the case may be of the board of directors shall expire immediately after the

annual ordinary meeting of shareholders to be held in 2014.

3. To set at one (1) the number of statutory auditors and further resolves to appoint the following as statutory auditor:
Kohnen &amp; Associés S. à r.l., registered with the Luxembourg Trade and Company's register under number B 114.190

and with registered office at L-2128 Luxembourg, 66, rue Marie-Adelaïde.

The mandate of the statutory auditor shall expire immediately after the annual ordinary meeting of shareholders to

be held in 2014.

4. To fix the address of the registered office of the company at L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of any divergences between the
English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

1) Madame Nathalie MAGER, employée privée, demeurant professionnellement à L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean

Monnet;

2) Madame Helena TONINI-DI VITO, employée privée, demeurant professionnellement à L-2180 Luxembourg, 8-10,

rue Jean Monnet.

Les parties comparantes ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme

qu'ils déclarent constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une Société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de "TECHHOL S.A." (la Société).

La Société est constituée pour une durée indéterminée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société

prise de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'adminis-

tration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

83798

La Société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obliga-

tions.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

La Société pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou

en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000.- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000.- EUR) représenté par trois mille cents (3.100) actions

d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-
après.

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents Statuts dans

le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le
conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société, ou à tout

autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois de juin à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents Statuts. Tout

actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes ses

dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée, dans

les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant
l'assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en
indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valablement

83799

quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblée des actionnaires, les résolutions pour être
valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent

être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires de la Société.

Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence téléphonique

ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les actionnaires concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, à moins qu'il

ait été établie durant une assemblée générale des actionnaires de la Société que la Société a un actionnaire unique, auquel
cas le conseil d'administration pourra comprendre un membre unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra
l'établissement de l'existence de plus d'un actionnaire. Dans ce cas, l'administrateur unique de la Société assumera tous
les pouvoirs conférés par la Loi au conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne seront pas
nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et
ils seront rééligibles.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société ou le

cas échéant par décision du seul actionnaire de la Société. Les actionnaires de la Société ou le cas échéant le seul actionnaire
de la Société déterminera (ont) également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat.
Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'as-
semblée générale des actionnaires de la Société ou le cas échéant par décision du seul actionnaire de la Société.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les adminis-

trateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste
devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société ou le cas échéant jusqu'à la prochaine
décision du seul actionnaire de la Société.

Art. 8. Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également choisir

un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration de la Société peut également être

prise par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs. Une telle résolution
doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil
d'administration de la Société (résolution circulaire). La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la Loi de 1915) ou que les Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont
de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à

la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux

administrateurs de la Société à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par l'assemblée générale des actionnaire de la
Société; ou (ii) le cas échéant, par la signature unique de l'administrateur unique; ou (iii) les signatures conjointes ou
uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration
de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

En ce qui concerne la gestion journalière, la Société sera légalement engagée vis-à-vis des tiers par la signature indivi-

duelle de toute personne à qui la gestion journalière aura été déléguée.

83800

Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.

Art. 12. L'exercice social de la Société commencera le 1 

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi de 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

Souscripteurs

Capital Capital Nombre

souscrit libéré d'actions

EUR

EUR

1) Madame Nathalie MAGER, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500.- 4.000.-

155

2) Madame Helena TONINI-DI VITO, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500.- 4.000.-

155

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000.- 8.000.-

310

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de vingt-cinq virgule quatre-vingt-un pour

cent (25,81 %), de sorte que la somme de huit mille euros (8.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2008.
L'assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois en 2009.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500.-).

<i>Résolutions

Les comparants ci-avant désignés, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Madame Nathalie MAGER, employée privée, née à Longwy (France) le 2 mai 1966, demeurant professionnellement

à L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet;

- Madame Helena TONINI-DI VITO, employée, née à Messancy (Belgique) le 8 septembre 1968, demeurant profes-

sionnellement à L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet;

- Monsieur Pierfrancesco AMBROGIO, président, employé, né à Rende (Italie) le 4 janvier 1978, demeurant profes-

sionnellement à L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

Le mandat d'administrateur ou le cas échéant, des administrateurs se terminera lors de l'assemblée générale annuelle

devant être tenue en 2014.

3. De fixer à un (1) le nombre de commissaires aux comptes et de nommer comme commissaire aux comptes:
Kohnen &amp; Associés S. à r.l., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B 114.190 et ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 66, rue Marie-Adelaïde.

Le mandat du commissaire aux comptes se termine lors de l'assemblée générale annuelle devant être tenue en 2014.

83801

4. De fixer l'adresse du siège social de la Société à L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même personne, en cas de
divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, elles ont signé avec Nous notaire.

Signé: N. Mager, H. Tonini-Di Vito et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 25 juin 2008. LAC/2008/25715. — Reçu cent cinquante-cinq euros, Eur 0,5% = 155.-.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008085057/5770/401.
(080097314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

Pérez Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 139.666.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the thirteenth of June.
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1. TORO CAPITAL S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1st Floor,
here represented by its managing director, NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660

Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1st Floor, itself here represented by its managing director Mrs. Rika MAMDY, company
director, with professional address in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

2. Mrs. Caroline Pérez, director, residing in Grev Magnigatan 8, 114 55 Stockholn, Sweden,
Here represented by Mrs. Rika Mamdy, prenamed,
By virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of Pérez Investments S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out for personal purposes trading in securities of any kind and any commercial,

industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation
may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and

83802

control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at THIRTY-TWO THOUSAND EURO (32.000.- EUR) rep-

resented by three hundred and twenty (320) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors elects from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a die, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of shareholders,

shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the 1st Monday of May at 10.00 a.m. and the first time in the year 2009.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the

general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2008.

83803

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal
reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will

be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows:

Shares

1. TORO CAPITAL S.A., prenamed, two hundred and eighty-eight shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

288

2. Mrs. Caroline Pérez, prenamed, thirty-two shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

TOTAL: three hundred and twenty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of THIRTY-TWO THOUSAND EURO (32.000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately TWO THOUSAND EURO
(2.000.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2013:
a) NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1st Floor,

RCS Luxembourg B 99.746, represented by Mrs Rika Mamdy, company director, with professional address in L-1660
Luxembourg, 60, Grand-Rue,

b) TYNDALL MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1st Floor, RCS

Luxembourg B 99.747, represented by Mrs Rika Mamdy, company director, with professional address in L-1660 Luxem-
bourg, 60, Grand-Rue.

c) ALPMANN MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1st Floor, RCS

Luxembourg B 99.739, represented by Mrs Rika Mamdy, company director, with professional address in L-1660 Luxem-
bourg, 60, Grand-Rue.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2013:

FIDUCIAIRY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., having its registered office at Road Town, Tortola, British Virgin

Islands, IBC number 303554.

4.- The registered office of the company is established in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1st Floor.

<i>Meeting of the Board of Directors

The members of the board, duly present or represented, and accepting their nomination, have immediately thereafter

proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., prenamed, as managing director.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

83804

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, the said proxyholder signed together

with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le treize juin.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. TORO CAPITAL S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1 

er

 étage,

ici  représentée  par  son  administrateur-délégué,  TYNDALL  MANAGEMENT  S.A.,  ayant  son  siège  social  à  L-1660

Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1 

er

 étage, elle-même ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Rika MAM-

DY, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

2. Madame Caroline Pérez, administrateur, demeurant à Grev Magnigatan 8, 114 55 Stockholm, Suède,
ici représentée par Madame Rika MAMDY, prénommée,
en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une

société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 : Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de Pérez Investments S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir pour des besoins personnels le commerce de titres de toutes sortes et toutes

opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-DEUX MILLE EUROS (32.000.- EUR) représenté par trois cent vingt (320)

actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour

un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués
à tout moment par l'assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

83805

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée

générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier lundi jour du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2009.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour,

l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu'au 31 décembre 2008.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

83806

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

Actions

1. TORO CAPITAL S.A., préqualifiée, deux cent quatre-vingt-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

288

2. Madame Caroline Pérez, prénommée, trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

TOTAL: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de TRENTE-DEUX

MILLE EUROS (32.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ DEUX MILLE EUROS (2.000.-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2013:
a) NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1 

er

 étage, RCS

Luxembourg B 99.746, représentée par Madame Rika MAMDY, administrateur de société, avec adresse professionnelle
à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

b) TYNDALL MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1 

er

 étage, RCS

Luxembourg B 99.747, représentée par Madame Rika MAMDY, administrateur de société, avec adresse professionnelle
à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue,

c) ALPMANN MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1 

er

 étage, RCS

Luxembourg B 99.739, représentée par Madame Rika MAMDY, administrateur de société, avec adresse professionnelle
à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2013:
FIDUCIAIRY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., ayant son siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

IBC numéro 303554.

4. Le siège social de la société est fixé à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1 

er

 étage.

<i>Réunion du conseil d'administration

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l'unanimité NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: R. MAMDY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 juin 2008, Relation: LAC/2008/25271. — Reçu cent soixante euros (0,50% = 160.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

83807

Luxembourg, le 27 juin 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008085061/242/305.
(080097231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2008.

Immobilière Beaumont S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 18.200.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03/07/08.

Signature.

Référence de publication: 2008083820/1128/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR06228. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080095720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Apeiron Investments S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 112.912.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2008084072/1023/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR08935. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Apeiron Advisors S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 112.911.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2008084071/1023/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2008, réf. LSO-CR08934. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Participations A &amp; F S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 70.807.

<i>Réunion du Conseil d'Administration du 18 mai 2007

En exécution de la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2007, en cours de publication au Mémorial,

les membres du Conseil d'Administration décident à l'unanimité de transférer le siège social de la société PARTICIPA-
TIONS A &amp; F S.A. de 18, rue de la Gare au 12, rue de la Gare, L- 7535 Mersch.

Mersch, le 18 mai 2007.

Nico AREND / Carlo FISCHBACH / Sylvie WINKIN-HANSEN.

Référence de publication: 2008083671/8537/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2008, réf. LSO-CR00380. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080095691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

83808


Document Outline

Apeiron Advisors S. à r.l.

Apeiron Investments S.C.A.

Bankwerk

BG Real Estate Europe

Bonissim S.à r.l.

BP Luxembourg S.A.

Brupez S.C.I.

Caloocan Holding S.A.

Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg S.A.

Clemington Corporation S.à r.l.

Cogit S.A.

Continental Real Estate Company

C.P.I. Holding - Compagnie de Placements Immobiliers S.A.

DAULUX S.A. Internationale Transport &amp; Spedition

Digidoc International Sàrl

Digidoc International Sàrl

Digidoc International Sàrl

Digidoc International Sàrl

ECM Real Estate Investments A.G.

EFI Eurofinance Investments Holding S.A.

Entreprise Générale S.A.

Finances Europe Tourisme S.A.

Fréon S.A.

Fusion S.A.

General Mediterranean Holding

Genius International S.A.

Halifax S.A.

Holpar S.A.

Immobilière Beaumont S.A.

Immobilière de Gestion Financière S.A.

Immo-Croissance SICAV-FIS

Ital Property S.A.

JAS Worldwide

JPMorgan Investment Strategies Funds

JPMorgan Private Bank Funds I

Jumi S.A.

Larissa S.A.

Leonardo Invest

Leyla S.A.

LS Management S.A.

McKesson Information Solutions Holdings II S.à r.l.

McKesson International Capital S.à r.l.

Mediterranean Holding (Luxembourg)

OWR Holdings S.A.

Participations A &amp; F S.A.

Pérez Investments S.A.

Rausz Consulting Luxembourg S.A.

Shire Holdings Europe No.2 S.à r.l.

Société Privée d'Investissement S.A.

Solupa S.A.

Spinnaker II Investment Fund SIF

Techhol S.A.

The World Trust Fund

Vega Advisory Holding S.A.

Vermont International S.A.

Waterstock Fund

Weather Capital Special Purpose 1 S.A.

W.S. Fund (la société)