logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1664

7 juillet 2008

SOMMAIRE

AKT Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

79858

Alma Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79867

Ameriforge International  . . . . . . . . . . . . . . .

79851

AOL Participations II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

79863

Biomet Holdings Luxembourg S.à r.l.  . . . .

79863

BS Real Estate (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

79865

Castell Concept  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79859

Château de Puycharnaud S. à r. l. . . . . . . . .

79863

Comont S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79861

Cosima Purchase No. 6 S.A.  . . . . . . . . . . . .

79859

Coven S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79862

Delta Lloyd Privilege  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79872

Fireblade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79855

Five Stars S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79864

Heliopolis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79867

I.E. Lux Berlin n° 1 S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

79868

Imvo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79851

Intercultures S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79855

Intercultures S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79855

INVISTA Technologies S.à.r.l. . . . . . . . . . . .

79852

Ipotek Financing S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79860

Jewel Holding S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79863

La Financière Montbrillant S.A.  . . . . . . . . .

79866

Les Résidences d'Howald  . . . . . . . . . . . . . . .

79862

Letalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79852

Letalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79860

Linston S.P.F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79860

Lubelux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79867

Lux-Confort S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79870

Luxconnect S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79856

Luxsa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79857

Marcell LuxCo II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

79861

Midelbe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79866

Mode Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79865

OCM Luxembourg Ice Cream GP S.A.  . . .

79872

OCM Luxembourg OPPS Meats Holdings

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79868

OCM Luxembourg Outdoor Holdings S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79871

OCM Luxembourg POF III S.à r.l.  . . . . . . .

79870

OCM Luxembourg POF IV S.à r.l.  . . . . . . .

79869

OCM Luxembourg Spirits Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79871

OCM / Nordenia Luxembourg GP S.A. . . .

79869

OCM / Nordenia Opps Luxembourg S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79870

OCM / Nordenia POF Luxembourg S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79868

Particorp S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79864

Sealed Air Luxembourg (II) S.à r.l.  . . . . . .

79858

Sealed Air Luxembourg (II) S.à r.l.  . . . . . .

79859

Sealed Air Luxembourg (I) S.à r.l.  . . . . . . .

79857

Sealed Air Luxembourg (I) S.à r.l.  . . . . . . .

79858

Sealed Air Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

79856

Sealed Air Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

79857

Sealed Air Luxembourg S.C.A.  . . . . . . . . . .

79855

Sealed Air Luxembourg S.C.A.  . . . . . . . . . .

79856

Socfinasia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79854

Socfinasia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79854

Société Financière Luxembourgeoise  . . . .

79852

Sorg Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79865

Steel Partner S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79866

Top Granit S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79871

Tramade S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79869

UPRN 1 SE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79826

Waterland Lux II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

79851

Zweiter International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

79864

79825

UPRN 1 SE, Société Européenne.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 81.377.

In the year two thousand and eight, on the twenty-sixth day of the month of June.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of UPRN 1 SE, (the "Company"), a société européenne

having its registered office at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg incorporated by deed of M 

e

 Joseph Elvinger,

notary, residing in Luxembourg, on 4th March, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the "Mémorial"), number 936 on 30th October, 2001.

The articles of incorporation of the Company were amended for the last time by deed of the undersigned notary on

21st April 2008 published in the Mémorial number 1022 of 25th April 2008.

The meeting was presided by Mr Dennis Bosje, accountant, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Ms Mariya Gadzhalova, maître en droit, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as

secretary and scrutineer.

The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by

the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will remain attached to this
document to be filed with the registration authorities.

2. It appears from said attendance list that all five thousand eight hundred sixty five (5,865) shares in issue are repre-

sented at the present general meeting.

3. All shareholders represented declared having had full knowledge of the agenda of the meeting and waive their rights

to prior notice so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

4. On 12th February 2008 the board of directors of the Company resolved to propose to the shareholders of the

Company to transfer the registered office of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to the Netherlands.

5. All formalities with respect to the transfer of the registered office of the Company from the Grand Duchy of

Luxembourg to the Netherlands as provided for by articles 101-2 to 101-9 of the law of 10th August 1915 on commercial
companies, as amended (the "Law") and by article 8 of the Council Regulation (EC) N 

o

 2157/2001 of 8th October 2001

on the Statute for a European company (the "Regulation"), have been complied with, in particular:

a) the board has drawn up a transfer proposal which was published in the Mémorial number 1037 on 26th April 2008,

i.e. at least two months prior to the holding of the present extraordinary general meeting of the shareholders of the
Company;

b) the board has drawn up a board report on the proposed transfer of registered office from the Grand Duchy of

Luxembourg to the Netherlands in accordance with article 101-4 of the Law and article 8 (3) of the Regulation;

c) the board report and the transfer proposal were available for consultation to the creditors and the shareholders

and the shareholders and the creditors have been duly informed of their right to consult the board report and the transfer
proposal at the registered office of the Company one month prior to the present general meeting;

d) the creditors were duly informed of their right to apply for security to the Tribunal d'Arrondissement de et à

Luxembourg sitting in commercial matters within a two-month period starting on the date of publication of the transfer
proposal in the Mémorial.

The Company has no employees and no bondholders so that the requirements relating thereto are not applicable.
6. The agenda of the meeting was as follows:
A. Presentation and approval of the transfer proposal as published in the Mémorial number 1037 of 26th April 2008

and the board report on the transfer of the registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to the Netherlands.

B. Approval of the change of nationality and approval of the transfer of the registered office of the Company from 17,

boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, the
Netherlands.

C. Approval and adoption of new articles of associations of the Company compliant with Dutch law, substantially in

the form attached to the proxies, the proxyholder being expressly authorised and empowered to make and agree to such
changes and amendments as deemed appropriate.

D. Acceptance of the resignation Mr Neil Mepham, Mr Paul de Haan and Mr Dennis Bosje as directors of the Company

with effect from 26th June 2008 and appointment of the following persons as additional directors of the Company until
the annual general meeting of the shareholders of the Company approving the accounts for the financial year which shall
end 31st December 2008:

- Ms Margaretha Johanna Springintveld, chartered accountant, born on 14th November 1967 in Aalsmeer, the Neth-

erlands, residing at Jac.P. Thijsselaan 3, 1431 JH Aalsmeer, the Netherlands;

79826

- Mr Michel Klaas Schoenmakers, managing director, born on 10th August 1960 in Voorburg, the Netherlands, residing

at Kwaakhaven 8, 2341 NW Oegstgeest, the Netherlands; and

- Mr Nicolas Michael Perkins, international tax manager, born on 16th September 1969 in Bridgend, United Kingdom,

residing at Flat 1, 46 Islington Park Street, London N1 1PX, United Kingdom.

E. Acceptance of the resignation of Ms Valérie Fisson as statutory auditor of the Company with effect from 26th June

2008.

Thereafter the meeting unanimously passed the following resolutions:

<i>First resolution

The transfer proposal relating to the transfer of the registered office of the Company from 17, boulevard Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, the Netherlands as published
in the Mémorial number 1037 of 26th April 2008 and the board report thereon were presented to the meeting.

Thereafter the general meeting carefully considered the terms thereof and resolved to approve such transfer proposal

subject to any amendments which appeared necessary as provided for in the following resolutions.

<i>Second resolution

The general meeting resolved to change the nationality of the Company from Luxembourg to Dutch and to transfer

the registered office of the Company from 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
to Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, the Netherlands with effect from the date hereof.

<i>Third resolution

The general meeting noted the proposed articles of association as set out in the transfer proposal published in the

Memorial number 1037 of 26th April 2008 and noted that the new articles of association of the Company to be adopted
by it further to the transfer of the Company's registered office to the Netherlands approved hereabove shall comply with
Dutch law.

The general meeting noted and acknowledged that there had been a change in Dutch company law since the transfer

proposal had been published in the Memorial and that article 7 of the proposed articles of association as set out in the
transfer proposal did not comply any more with Dutch law. Therefore, the general meeting resolved to adopt new articles
of association of the Company as follows:

"Amended and Restated Consolidated Articles of Incorporation

Articles of Association

Art. 1. Definitions.
1.1. In these articles of association:
- "Body" (orgaan) is a term that applies to the Management Board or the General Meeting;
- "Company" means this Societas Europaea;
- "General Meeting" (algemene vergadering) is the Body consisting of the Shareholders;
- "General Meeting of Shareholders" (algemene vergadering van aandeelhouders) means the gathering of the Share-

holders in a meeting;

- "Managing Director" (bestuurder) is a managing director as referred to in Dutch law, being a natural person or a legal

entity;

- "Management Board" (bestuur) is the Body made up of the Managing Directors;
- "Shareholder" (aandeelhouder) means a holder of one or more shares in the capital of the Company, being a natural

person or a legal entity.

Art. 2. Name and seat.
2.1. The name of the Company is: UPRN 1 SE.
2.2. The Company shall have its seat in Amsterdam (The Netherlands).
2.3. As long as the Company has its seat in the Netherlands, it must also have its head office in the Netherlands.

Art. 3. Objects.
3.1. The objects of the Company are:
- to incorporate, to participate in and to finance companies or businesses;
- to collaborate with, to manage the affairs of and to provide advice and other services to companies and other

businesses;

- to lend and to borrow funds;
- to provide collateral for the debts and other obligations of the Company, of other companies and businesses that

are affiliated with the Company in a group and of third parties;

- to acquire, to operate and to dispose of property, including registered property; and
- to acquire, to operate and to dispose of industrial and intellectual property rights,

79827

as well as to carry out all that which is incidental or conducive to the above, in the broadest sense.

Art. 4. Capital and shares.
4.1. The authorised capital is seven hundred thirty-three thousand one hundred and twenty-five Euro (€ 733,125.-)

and shall be divided into twenty-nine thousand three hundred and twenty-five (29,325) shares, each having a nominal
value of twenty-five Euro (€ 25.-).

4.2. The shares shall be registered and shall be numbered consecutively, starting at one.
4.3. Share certificates shall not be issued by the Company.
4.4. If shares or the right to shares are jointly held, the joint Shareholders may only be represented by a single person

holding a written proxy signed by them all.

Art. 5. Issue.
5.1. Shares shall be issued pursuant to a resolution adopted by the General Meeting. Furthermore, the resolution shall

set out the price and other terms and conditions of issue. The issue price shall not be below par.

5.2. The general meeting may delegate its powers in this respect to another constituent body for a fixed period not

exceeding five years.

On such designation the number of shares which may be issued must be specified.
The designation may be extended from time to time for periods not exceeding five years.
Unless such designation provides otherwise, it may not be withdrawn.
5.3. Within eight days after a resolution of the general meeting to issue or to make a designation, the Company shall

deposit the full text thereof at the office of the commercial register.

5.4. Within eight days after each issue of shares, the Company shall report the same to the office of the commercial

register, stating the number.

5.5. Without prejudice to any provision of Dutch law, every Shareholder shall have a preemptive right on any issue of

shares "pro rata" to the aggregate amount of his shares. A pre-emptive right is non-transferable.

5.6. A notice of any issue in respect of which there is a pre-emptive right and the period during which such right can

be exercised, shall be given in writing to all the Shareholders at the addresses as indicated by them to the Company.

5.7. The pre-emptive right may be exercised during a period of four weeks after the days of sending such notice to

the Shareholders.

5.8. The pre-emptive right may be limited or excluded by virtue of a resolution adopted by the general meeting.
The pre-emptive right may also be restricted or excluded by the constituent body designated pursuant to subsection

2 of this article, if, by a resolution of the general meeting, it was designated and authorized for a fixed period not exceeding
five years, to restrict or exclude such pre-emptive right.

The designation may be extended, from time to time, for a period not exceeding five years.
The designation is only valid as long as the designation as referred to in paragraph 2 is valid.
Unless the designation provides otherwise, it may be withdrawn.
5.9. If less than fifty percent of the issued capital is represented at the meeting, a majority of at least two-thirds of the

votes cast shall be required for a resolution of the general meeting to restrict or exclude the pre-emptive right or to
make such designation.

Within eight days after the resolution the Company shall deposit the full text thereof at the office of the commercial

register.

5.10. On the grant of rights to subscribe for shares, the Shareholders have a pre-emptive right.
The provisions of the above subsections are applicable "mutatis mutandis" to the granting of a right to subscribe for

shares.

Shareholders shall have no pre-emptive right in respect of shares issued to a person who exercises a previously acquired

right to subscribe for shares.

5.11 On subscription for a share, payment must be made of its nominal amount. It may be provided that a part, not

exceeding three-quarters of the nominal amount, need only be paid after the Company has called it up.

Art. 6. Own shares.
6.1. On an issue of shares the Company is not able to subscribe to its own shares.
6.2. The acquisition by the Company of its own shares when those shares have not been fully paid up shall be null and

void, unless acquired under universal title.

6.3. The Company may only acquire its own fully paid-up shares either gratuitously or as specified in Dutch law.
6.4. The provisions set out in these articles for the restriction on the transfer of shares are applicable to the Company's

disposal of its own shares.

6.5. In this article "shares" includes depositary receipts for shares.

79828

Art. 7. Financial assistance.
7.1. The Company shall not provide collateral, provide a price guarantee or otherwise guarantee, or bind itself with

or on behalf of third parties for the purpose of subscription to or acquisition by third parties of shares in its own capital,
or of depository receipts issued in respect thereof. This prohibition shall also extend to its subsidiaries.

7.2. The Company may grant loans, for the purpose of subscription to or acquisition by third parties of shares in its

own capital, or of depository receipts issued in respect thereof, with due observance of Dutch law.

7.3. The prohibition of the first subsection shall not apply if shares or depositary receipts are acquired by or on behalf

of employees of the Company or a group company as meant in Dutch law.

Art. 8. Reduction of capital.
8.1. The General Meeting may resolve to reduce the issued capital by cancelling shares or by amending the Articles of

Association to reduce the nominal amount of the shares.

8.2. Dutch law applies to such a resolution and its implementation.

Art. 9. The issue of depositary receipts for, the pledging of and the establishment of a right of usufruct over shares.
9.1. The Company shall not lend assistance in the issuance of depositary receipts for shares in the Company.
9.2. A right of usufruct or a right of pledge may be granted over shares. Voting rights shall not be vested in a holder

of a right of usufruct nor in a holder of a right of pledge of shares, unless voting rights are vested in a holder of a right of
usufruct pursuant to article 2:88, paragraph 3, final sentence, of the Dutch Civil Code.

Art. 10. Register of Shareholders.
10.1.The Management Board shall keep a register recording the names and addresses of all Shareholders, the date on

which they acquired the shares, the date of acknowledgement by or service upon the Company and the amount paid up
on each share. The names and addresses of those who have a right of usufruct or a right of pledge in respect of shares
shall also be recorded, stating the date on which they acquired the right and the date of acknowledgement by or service
upon the Company.

10.2. Every Shareholder, holder of a right of usufruct or holder of a right of pledge is obliged to ensure that the

Company is notified of the address of the Shareholder or holder of a right of usufruct or pledge.

10.3. The register shall be regularly updated in accordance with Dutch law.
10.4. All entries in, copies of, or extracts from the register of Shareholders shall be authenticated by a Managing

Director.

Art. 11. Transfer of shares.
11.1. The issue and transfer of a registered share, or the transfer or waiver of a limited right to a registered share,

require a deed which has been executed before a notary practicing in the Netherlands and to which all persons involved
are a party.

11.2. The transfer of a registered share, or the transfer or waiver of a limited right to a registered share, in accordance

with the provisions of the previous section shall also, by operation of Dutch law, be legally binding on the Company.
Except in the event that the Company itself is a party to the legal transaction, the rights accruing to the share may not
be exercised until the Company has either acknowledged this legal transaction or been served with the deed of transfer
in accordance with Dutch law.

Art. 12. Management Board.
12.1. The Company shall have a Management Board consisting of at least three Managing Directors. The number of

Managing Directors shall be laid down by the General Meeting taking into account the aforementioned minimum. If the
number of appointed Managing Directors at any time falls below one, then one or more new Managing Directors will be
appointed by the General Meeting as soon as possible. The Management Board shall appoint one of the Managing Directors
as chairman of the Management Board.

The Managing Director-legal entity shall designate a natural person to exercise its functions and authorities.
12.2. Managing Directors shall be appointed by the General Meeting for a maximum period of six years. Managing

Directors may be reappointed once or more than once, each time for a maximum period of six years.

12.3. Managing Directors may be suspended or dismissed by the General Meeting at any time.
12.4.The total period of a suspension, including any extensions, may lastno longer than three months.
12.5. The remuneration and other terms and conditions for the appointment of each individual Managing Director

shall be determined by the General Meeting.

Art. 13. Adoption of resolutions by the Management Board.
13.1.The Management Board shall adopt resolutions by an absolute majority of the total number of votes cast by all

the Managing Directors in a meeting in which at least one half of the Managing Directors is present or represented.

13.2. In meetings of the Management Board each Managing Director shall be entitled to cast one vote. In case of a tie

in the votes, the vote of the chairman of the Management Board shall be decisive.

79829

13.3. Managing Directors may only be represented in meetings of the Management Board by another Managing Director

pursuant to a written power of attorney.

13.4. The Management Board may also adopt resolutions without convening a meeting, provided that all Managing

Directors have been consulted and none of them have raised an objection to adopt resolutions in this manner.

13.5. The approval of the General Meeting shall be required for decisions by the Management Board leading to an

important change in the company's or its business enterprise's entity or character, including in any case:

a. the transfer the business of the company or almost the entire business of the company to a third party;
b. the entering into or termination of any long-term co-operation of the company with another legal entity or company

or  as  a  fully  liable  partner  in  a  limited  or  general  partnership,  if  such  co-operation  or  termination  is  of  far-reaching
significance to the company;

c. the acquisition or disposal by the company or by a subsidiary of the company of a participation in the capital of

another company with a value of at least one third of the amount of the assets according to the balance sheet with
explanatory notes, or in case the company prepares a consolidated balance sheet, according to the consolidated balance
sheet with explanatory notes, forming part of the most recently adopted annual accounts of the company.

13.6. The absence of the approval as defined in paragraph 5 of this article shall not affect the powers of the Managing

Board or of the Managing Directors to represent the Company.

Art. 14. Unavailability or inability to act of a Managing Director. If a Managing Director is unavailable or unable to act,

then the management of the Company shall be vested in the remaining Managing Director or Managing Directors. If no
Managing Director is available or able to act, the management of the Company shall be temporarily vested in one or more
persons appointed for that purpose by the General Meeting.

Art. 15. Representation of the Company.
15.1. The authority to represent shall vest exclusively in:
- the Management Board;
- any one of the Managing Directors.
15.2. In the event that a conflict of interest arises between the Company and a Managing Director, the Management

Board will represent the Company. The General Meeting is authorised to appoint one or more persons to represent the
Company at any time.

If it does so, the representative authority contemplated in the previous sentence of this paragraph will no longer apply.

Without prejudice to the representative authority, in any case involving a conflict of interest, the Management Board may
act on behalf of the Company only after obtaining express prior permission from the General Meeting.

Art. 16. Confidentiality. The Managing Directors shall be under a duty, even after they have ceased to hold office, not

to divulge any information which they have concerning the company the disclosure of which might be prejudicial to the
company's interest, except where such disclosure is required under the law or is in the public interest.

Art. 17. Financial year, annual accounts and annual report.
17.1. The Company's financial year shall be concurrent with the calendar year.
17.2. The Management Board shall prepare the annual accounts, which shall consist of the balance sheet and the profit

and loss statement with explanatory notes. The annual accounts shall be prepared within five months of the end of each
financial year, unless the General Meeting grants an extension to a maximum of six months in special circumstances. The
annual accounts require the signatures of all the Managing Directors. The absence of a signature, and the reason therefore,
shall be expressly stated. Unless the provisions of article 2:403 of the Dutch Civil Code are applicable to the Company,
the Management Board shall also prepare an annual report within the above-mentioned period.

17.3. If, and to the extent that, any relevant provision of Dutch law is applicable to the Company, the General Meeting

shall retain a registered accountant or a firm of registered accountants, as defined in article 2:393, section 1, of the Dutch
Civil Code, to examine the annual accounts and, if prepared, the annual report prepared by the Management Board, in
order to write a report and to provide an opinion.

17.4. The annual accounts shall be adopted by the General Meeting.
17.5. If, and to the extent that, it is required under Dutch law, the Company is obliged to make the annual accounts

publicly available at the Trade Register.

Art. 18. Appropriation of the profits.
18.1. The Company may make distributions to the Shareholders and other persons entitled to the distributable profits,

to the extent the equity of the Company exceeds the paid-up and called-up part of the Company's equity, plus the reserves
which must be maintained under Dutch law.

18.2. The profits evidenced by the profit and loss statement adopted by the General Meeting shall be at the disposal

of the General Meeting.

79830

18.3. The Company may make interim (profit-)distributions after the General Meeting has granted its approval, to the

extent that the provisions as set out in subsection 1 above have been complied with as evidenced by an interim statement
in conformity with Dutch.

The Company shall deposit the interim statement at the office of the commercial register within eight days after the

day on which the resolution to distribute is published.

18.4. There shall be no distribution of profits on shares or depositary receipts for shares held by the Company in its

own capital.

18.5. The shares and depositary receipts for shares for which no distribution will be made as described in section 4

above shall be disregarded when calculating the distribution of profits.

18.6. The right to receive a distribution shall expire five years from the day on which such a distribution became

payable.

Art. 19. Shareholder meetings.
19.1. The annual meeting of Shareholders shall be held every year within six months of the end of the financial year.

In this meeting the following, amongst other matters, shall be brought up for consideration, unless the six-month time
period mentioned above in Article 17.2, has been extended in accordance with the provisions set out in the said article:

- the annual report;
- the adoption of the annual accounts;
- the granting of discharge to the Managing Directors from liability for actions in respect of their management during

the preceding financial year;

- if required by Dutch law, the instruction of an expert as referred to in article 2:393, of the Dutch Civil Code; and
- the language in which the items of the next annual accounts shall be stated and the currency.
19.2. The General Meeting of Shareholders shall be held in the municipality where the Company has its registered

seat.

19.3. One or more shareholders who together hold at least ten percent (10%) of the subscribed capital may request

to convene a General Meeting of Shareholders and to draw up an agenda therefore. If, following the request a General
Meeting of Shareholders is not held in due time and, in any event, within two months, the judge (voorzieningenrechter)
of the court may order that a General Meeting of Shareholders shall be convened within a given period or authorize the
shareholders who have requested it to convene a General Meeting of Shareholders.

19.4. Unless the last sentence of the preceding paragraph is applicable, notice of the convening of the General Meeting

of Shareholders shall be issued by the Management Board, or one of the Managing Directors by means of written notices
dispatched no later than the fifteenth day before the date of the meeting.

19.5. The written notices convening the meeting shall set out the place, date and time of the meeting and the matters

to be considered. One or more shareholders who together hold at least one percent (1%) of the subscribed capital may
request that one or more additional items be put on the agenda of any General Meeting of Shareholders, provided that
the company has received the request no later than on the sixtieth day before the day of the meeting.

19.6. The written notices shall be dispatched to the addresses recorded in the Shareholder register. The failure of one

or more of the written notices dispatched in accordance with the stipulations set out above to reach the destination shall
not affect the validity of the General Meeting of Shareholders or the resolutions adopted thereby.

19.7. The General Meeting of Shareholders appoints a chairman from its midst.
19.8. Minutes shall be taken of the matters dealt with in a General Meeting of Shareholders unless a notarial record

of the proceedings is drawn up. The minutes shall be entered into a register maintained for that purpose and require the
adoption and signature of the chairman of the meeting and the secretary of the meeting, who shall be appointed by the
chairman at the commencement of the meeting. The minutes or the notarial record of the proceedings shall serve as
evidence of the resolutions adopted in the General Meeting of Shareholders.

Art. 20. Adoption of resolutions in a General Meeting of Shareholders.
20.1. All Shareholders shall be entitled to attend a General Meeting of Shareholders and to address that meeting. The

shareholder-legal entity shall designate a natural person to exercise its functions and authorities. This person shall be able
to resolve and act on behalf of the shareholder-legal entity without limitation or consultation.

The Managing Director or Managing Directors, shall have, in these capacities, an advisory vote in the General Meeting

of Shareholders.

20.2. In order to be able to participate in the voting the Shareholders - in case of shareholders-legal entities the persons

designated pursuant to article 20.1 - must sign the attendance book, recording the number of shares represented by
them.

20.3. Every share entitles the holder thereof to cast one vote.
20.4. In a General Meeting of Shareholders, no votes may be cast for shares held by the Company or by any subsidiary

thereof, nor may votes be cast for a share for which either of them holds a depositary receipt for a share.

79831

20.5.The sum of the shares for which no voting rights may be exercised according to Dutch law shall be disregarded

in determining the extent to which the Shareholders are entitled to vote, are present or represented, or to which extent
the share capital is provided or represented.

20.6. Resolutions passed in a General Meeting of Shareholders shall be adopted by an absolute majority of the votes

validly cast in a meeting in which at least half of the Shareholders is present or represented. The votes cast shall not
include votes attaching to shares in respect of which the Shareholder has not taken part in the vote or has abstained or
has returned a blank or spoilt ballot paper.

20.7. The votes shall be cast orally, unless the chairman of the meeting decides otherwise.
20.8. In case of a tie in the vote, the proposal shall be deemed to have been rejected.
20.9. In a General Meeting of Shareholders in which the entire issued capital is represented valid resolutions can be

adopted provided they are adopted unanimously, even if the requirements in respect of the convening and holding of
meetings have not been complied with.

20.10. The Management Board shall keep a record of the adopted resolutions. This record shall be made available at

the Company's office for inspection by the Shareholders. Each Shareholder shall, upon request, be provided with a copy
of or extract from this record at no more than the actual costs.

Art. 21. Adoption of resolutions outside a General Meeting of Shareholders.
21.1. Shareholders may also adopt resolutions without convening a meeting of Shareholders, provided that all Share-

holders have declared in writing (including all generally accepted means of communication) to be in favour of the resolution
and provided that the Managing Director or Managing Directors, have had the opportunity to cast an advisory vote.

Art. 22. Merger, division, amendment to the articles of association, dissolution.
22.1. The General Meeting may resolve to merge the Company, to divide the Company, to amend the Articles of

Association or to dissolve the Company.

22.2. Those who convene a General Meeting of Shareholders in which a proposal is made to adopt a resolution to

amend the Articles of Association or to dissolve the Company must deposit a copy of the proposal, stating the verbatim
text of the proposed amendment, at the offices of the Company for inspection by the Shareholders. The proposal must
be deposited at the same time as the notice of the meeting and kept there until after the close of the meeting. The
Shareholders must be given the opportunity to obtain a copy of the proposal described in the previous sentence from
the day on which the convening notice for that meeting is dispatched until the day of the General Meeting of Shareholders.
Such copies shall be provided free of charge.

22.3. In the event that a resolution to dissolve the Company is adopted, the liquidation shall be arranged by the

Management Board, unless the court should appoint another liquidator or other liquidators. If a resolution to liquidate
the Company is passed, a resolution regarding the remuneration to be paid to the liquidator, or the joint liquidators,
must be passed at the same time.

22.4. The Articles of Association shall, as far as possible, remain effective during the process of liquidation.
22.5. The liquidation surplus shall be distributed to Shareholders and other parties entitled thereto in proportion to

their respective rights.

22.6. After the liquidation has been completed, the books and records of the dissolved Company shall remain in custody

of a person to be appointed for that purpose by the General Meeting for a period of seven years."

"STATUTEN

Art. 1. Definities.
1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:
orgaan: het bestuur of de algemene vergadering;
vennootschap: deze Societas Europaea;
algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders;
algemene vergadering van aandeelhouders: bijeenkomst van aandeelhouders;
bestuurder(s): de bestuurder(s) in de zin van de wet, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen;
bestuur: het orgaan gevormd door de bestuurder(s);
aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen in het kapitaal van de vennootschap, zijnde een natuurlijk

persoon of een rechtspersoon.

Art. 2. Naam en zetel.
2.1 De vennootschap draagt de naam: UPRN 1 SE.
2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.
2.3 Zolang de vennootschap haar statutaire zetel in Nederland heeft, dient het hoofdbestuur van de vennootschap

gelegen te zijn in Nederland.

79832

Art. 3. Doel.
3.1 De vennootschap heeft ten doel:
- het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van vennootschappen of ondernemingen;
- het samenwerken met-, het voeren van bestuur over- en het verlenen van adviezen en andere diensten aan ven-

nootschappen of ondernemingen;

- het opnemen en verstrekken van geldleningen;
- het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennoot-

schappen of ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of van derden;

- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen; en
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriele en intellectuele eigendomsrechten,
alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in

de ruimste zin van het woord.

Art. 4. Kapitaal en aandelen.
4.1  Het  maatschappelijk  kapitaal  bedraagt  zevenhonderd  drieëndertig  duizend  eenhonderd  vijfentwintig  euro  (€

733.125,-) en is verdeeld in negenentwintig duizend driehonderd vijfentwintig (29.325) aandelen van nominaal vijfentwintig
euro (€ 25,-) elk.

4.2 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
4.3 Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
4.4 Indien aandelen of rechten op aandelen tot een gemeenschap behoren kunnen de deelgenoten zich slechts tegen-

over de vennootschap doen vertegenwoordigen door een persoon, daartoe schriftelijk door hen alien gemachtigd.

Art. 5. Uitgifte.
5.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering dat tevens de koers en de

verdere voorwaarden van uitgifte bevat.

5.2 De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
De algemene vergadering kan een ander orgaan aanwijzen om de bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld uit te

oefenen en wel voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren.

Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
5.3 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing

een volledige tekst daarvan neer bij het handelsregister.

5.4 De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave bij het handelsregister, met

vermelding van het aantal.

5.5 Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk

bedrag van zijn aandelen behoudens het bepaalde in de wet.

Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.
5.6 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in

een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres.

5.7 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende vier weken na verzending van de aankondiging aan de

aandeelhouders.

5.8 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge lid 2 van dit artikel aangewezen orgaan,

indien dit bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als
bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.

Zodanige aanwijzing kan slechts geschieden indien het betreffende orgaan tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen

als het tot uitgifte bevoegde orgaan als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
De aanwijzing geldt slechts zolang een aanwijzing als bedoeld in lid 2 van kracht is.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.
5.9 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing

is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het
geplaatste kapitaal in de vennootschap is vertegenwoordigd.

De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer bij het handelsregister.
5.10 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht.
Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

79833

Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds

verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

5.11 Bij het nemen van een aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden

dat een deel, ten hoogste drie Vierden van het nominale bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap
het zal hebben opgevraagd.

Art. 6. Eigen aandelen.
6.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
6.2 Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte eigen aandelen is nietig, tenzij wordt verkregen onder

algemene titel.

6.3 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen slechts verkrijgen om niet of met inachtneming van het bepaalde

in de wet.

6.4 Met betrekking tot vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen is het bepaalde in de blok-

keringsregeling in deze statuten van toepassing.

6.5 Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Art. 7. Verboden steunverlening.
7.1 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal

of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk
of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

7.2 De vennootschap mag, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van

certificaten daarvan, leningen verstrekken met inachtneming van het bepaalde in de wet.

7.3 Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of

verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij als bedoeld in de wet.

Art. 8. Kapitaalvermindering.
8.1 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen

of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

8.2 Op een dergelijk besluit en de uitvoering daarvan is het bepaalde in de wet van toepassing.

Art. 9. Certificering, verpanding en vestiging van vruchtgebruik op aandelen.
9.1 De vennootschap verleent geen medewerking aan uitgifte van certificaten van aandelen van de vennootschap.
9.2 Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd.
Aan de vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen kan het stemrecht niet worden toegekend, tenzij het stemrecht

toekomt aan een vruchtgebruiker op grond van artikel 2:88 lid 3 laatste volzin van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 10. Aandeelhoudersregister.
10.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met

vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede
van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op

aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen alsmede de datum van erkenning
of betekening.

10.2 Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de ven-

nootschap bekend is.

10.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van de wet.
10.4 Alle aantekeningen in en afschriften of uittreksels uit het aandeelhoudersregister zullen worden ondertekend door

een bestuurder.

Art. 11. Levering van aandelen.
11.1 Voor de uitgifte en levering van een aandeel op naam of de levering of afstanddoening van een beperkt recht

daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de
betrokkenen partij zijn.

11.2 De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het in lid 1 bepaalde

werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap.

Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden

rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeen-
komstig het daaromtrent bepaalde in de wet.

Art. 12. Bestuur.
12.1 De vennootschap heeft een bestuur bestaande uit ten minste drie bestuurders. Het aantal bestuurders wordt

met inachtneming van dit minimum door de algemene vergadering vastgesteld. Is het aantal bestuurders minder dan één,

79834

dan benoemt de algemene vergadering zo spoedig mogelijk een of meer nieuwe bestuurders. Het bestuur benoemt uit
zijn midden een voorzitter.

Een bestuurder rechtpersoon wijst voor de uitoefening van zijn bevoegdheden een natuurlijk persoon als vertegen-

woordiger aan.

12.2 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van ten hoogste zes jaar. Zij

kunnen een of meerdere malen worden herbenoemd, steeds voor een periode van ten hoogste zes jaar.

12.3 Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
12.4 Een schorsing kan, ook na een of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.
12.5 De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere bestuurder afzonderlijk, bepaald door de

algemene vergadering.

Art. 13. Besluitvorming bestuur.
13.1 Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van het in totaal door alle bestuurders uit te brengen aantal

stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

13.2 In de vergaderingen van het bestuur brengt iedere bestuurder één stem uit. In geval van staking van stemmen is

de stem van de voorzitter van het bestuur doorslaggevend.

13.3 ledere bestuurder kan zich in de bestuursvergaderingen uitsluitend door een medebestuurder doen vertegen-

woordigen. Die vertegenwoordiging dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht.

13.4 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en geen van hen zich

tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.

13.5 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een

belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of haar onderneming, waaronder in ieder
geval:

a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een

andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap
of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde

van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans
opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennoot-
schap, door haar of een dochtermaatschappij.

13.6 Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in lid 5 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur

of de bestuurders niet aan.

Art. 14. Belet of ontstentenis.
14.1 In geval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders berust het bestuur van de vennootschap bij de

overblijvende bestuurders dan wel de enig overgebleven bestuurder.

In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur van de vennoot-

schap tijdelijk bij een of meer door de algemene vergadering daartoe aangewezen personen.

Art. 15. Vertegenwoordiging.
15.1 De vennootschap wordt slechts vertegenwoordigd door:
- hetzij het bestuur;
- hetzij iedere bestuurder.
15.2 In alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een bestuurder, wordt de vennootschap

vertegenwoordigd door het bestuur. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe
aan te wijzen, waardoor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging zoals beschreven in de vorige volzin, komt te vervallen.
Onverminderd de bevoegdheid tot vertegenwoordiging, is het handelen door het bestuur namens de vennootschap in
alle gevallen van tegenstrijdig belang onderworpen aan uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de algemene verga-
dering.

Art. 16. Geheimhouding. De directeuren mogen, ook nadat zij hun funcţie hebben beëindigd, geen ruchtbaarheid geven

aan de te hunner beschikking staande inlichtingen over de vennootschap waarvan de openbaarmaking de belangen van de
vennootschap zou kunnen schade, behalve in gevallen waarin deze openbaarmaking krachtens de wet of om reden van
algemeen belang verplicht of toegestaan zijn.

Art. 17. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag.
17.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
17.2 Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ver-

gadering met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening
(bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt.

79835

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
Tenzij artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, maakt het bestuur binnen voornoemde

termijn een jaarverslag op.

17.3 Indien en voorzover het dienaangaande in de wet bepaalde op de vennootschap van toepassing is, zal door de

algemene vergadering opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel
2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de door het bestuur ontworpen jaarrekening alsmede - indien opgemaakt
- het jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.

17.4 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
17.5 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking bij het handelsregister indien en voorzover de wet dit vereist.

Art. 18. Winstbestemming.
18.1 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts

uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het
kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

18.2 De winst blijkende uit de door de algemene vergadering vastgestelde winst- en verliesrekening staat ter beschik-

king van de algemene vergadering.

18.3 De vennootschap mag tussentijds slechts (winst-)uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 1 is voldaan

blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig de wet en na voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering.

De vennootschap legt de vermogensopstelling bij het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het

besluit tot uitkering wordt bekendgemaakt.

18.4 Op door de vennootschap gehouden aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan vindt geen uitkering ten

behoeve van de vennootschap plaats.

18.5 Bij de berekening van de winstverdeling teilen de aandelen of certificaten van aandelen, waarop ingevolge het in

lid 4 bepaalde geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaatsvindt, niet mee.

18.6 De vordering tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaars-

telling.

Art. 19. Vergaderingen van aandeelhouders.
19.1 Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

gehouden. In deze jaarvergadering worden onder meer - tenzij de termijn als bedoeld in artikel 17.2 van deze Statuten
overeenkomstig het aldaar bepaalde is verlengd -, aan de orde wordt gesteld:

- de behandeling van het jaarverslag;
- de vaststelling van de jaarrekening;
- het verlenen van decharge aan het bestuur voor het door haar in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;
- het verlenen van een opdracht aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, voorzover

wettelijk vereist;

- de taal waarin de posten van de eerstvolgende jaarrekening worden gesteld en de geldeenheid.
19.2 De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel

heeft.

19.3 Het verzoek tot bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders en tot vaststelling van de agenda

kan worden gedaan door een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigen. Indien na de indiening van het verzoek de algemene vergadering van aandeelhouders niet
tijdig, in elk geval binnen een termijn van twee maanden, wordt gehouden, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
de bijeenroeping binnen een bepaalde termijn gelasten of de aandeelhouders die het verzoek hebben gedaan machtigen
tot bijeenroeping.

19.4 Tenzij de laatste zin van het vorige artikel van toepassing is, geschiedt de bijeenroeping van aandeelhouders door

het bestuur of door een bestuurder door middel van oproepingsbrieven welke moeten worden verzonden niet later dan
op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.

19.5 De oproepingsbrieven vermelden plaats, dag en uur van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen.

Een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen,
kan of kunnen verzoeken om een of meer nieuwe punten op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders
te plaatsen indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft
ontvangen.

19.6 De oproepingsbrieven worden verzonden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister.
Wanneer een of meer oproepingsbrieven, overeenkomstig het hiervoor bepaalde verzonden, hun bestemming niet

bereiken, dan zal dit geen invloed uitoefenen op de geldigheid van de algemene vergadering van aandeelhouders en de
daarin te nemen besluiten.

79836

19.7 De algemene vergadering van aandeelhouders voorziet zelf haar voorzitterschap.
Indien hij niet aanwezig is voorziet de algemene vergadering van aandeelhouders zelf in haar leiding.
19.8  Van  het  verhandelde  in  een  algemene  vergadering  van  aandeelhouders  worden  notulen  gehouden  tenzij  een

notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

De notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en vastgesteld en getekend door de voorzitter van

de vergadering en de door deze bij de aanvang van de vergadering aangewezen secretaris van de vergadering.

De notulen of het notarieel proces-verbaal strekken tot bewijs van het in de vergadering beslotene.

Art. 20. Besluitvorming in vergadering.
20.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord

te voeren. Een aandeelhouder-rechtspersoon wijst voor de uitoefening van zijn bevoegdheden een natuurlijke persoon
als vertegenwoordiger aan. Deze persoon dient zonder last of ruggespraak namens de aandeelhouder-rechtspersoon te
kunnen besluiten en handelen.

De bestuurder(s) heeft (hebben) als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.
20.2 Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders - in geval van aandeelhouders-re-

chtspersonen de personen aangewezen op grand van artikel 20.1 - de presentielijst tekenen, onder vermelding van het
aantal door ieder vertegenwoordigde aandelen.

20.3 Elk aandeel geeft recht op één stem.
20.4 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene

vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de
certificaten houdt.

20.5 Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre

het aandelenkapitaal verschaff wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de
wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

20.6 De besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen met volstrekte meerderheid van

de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de aandeelhouders aanwezig of verte-
genwoordigd is.

De uitgebrachte stemmen omvatten niet de stemmen die verbunden zijn aan aandelen ten aanzien waarvan de aan-

deelhouder niet aan de stemming heeft deelgenomen of zich heeft onthouden, dan wel blanco of ongeldig heeft gestemd.

20.7 Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt.
20.8 Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
20.9 In een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is,

kunnen, mits met algemene stemmen, rechtsgeldige besluiten worden genomen ook al zijn de voorschriften met betrek-
king tot het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

20.10 Het bestuur van de vennootschap houdt van de genomen besluiten aantekening.
De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen

wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Art. 21. Besluitvorming buiten vergadering. Besluitvorming door aandeelhouders kan op andere wijze dan in een ver-

gadering van aandeelhouders plaatsvinden doordat alle aandeelhouders zich schriftelijk (waaronder begrepen elk gangbaar
communicatiemiddel) vóór het voorstel hebben verklaard, en mits de bestuurder(s) de gelegenheid heeft (hebben) gehad
raadgevende stem uit te brengen.

Art. 22. Fusie, splitsing, statutenwijziging, ontbinding.
22.1 De algemene vergadering kan besluiten tot fusie, splitsing, wijziging van de statuten en tot ontbinding van de

vennootschap.

22.2 Degenen, die een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders hebben gedaan, waarin een voor-

stel tot het nemen van een besluit tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moeten tegelijkertijd met de
oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de
vennootschap neerleggen ter inzage van aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.

De aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging tot die van de algemene

vergadering van aandeelhouders een afschrift van het voorstel, zoals in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen.

Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.
22.3 Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door het bestuur tenzij de rechter

een andere vereffenaar of andere vereffenaars benoemt.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald door de vereffenaar, of de vereffenaars gezamenlijk,

te genieten.

22.4 Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.

79837

22.5 Het overschot na vereffening wordt aan aandeelhouders en andere rechthebbenden in verhouding tot ieders

recht uitgekeerd.

22.6 Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende zeven

jaren blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering te benoemen."

<i>Fourth resolution

The general meeting acknowledged and accepted the resignation of Mr Neil Mepham, Mr Paul de Haan and Mr Dennis

Bosje as directors of the Company with effect from 26th June 2008 and resolved to appoint the following persons as
additional directors of the Company until the annual meeting of the shareholders of the Company approving the accounts
for the financial year which shall 31st December 2008:

- Ms Margaretha Johanna Springintveld, chartered accountant, born on 14th November 1967 in Aalsmeer, the Neth-

erlands, residing at Jac.P. Thijsselaan 3, 1431 JH Aalsmeer, the Netherlands;

- Mr Michel Klaas Schoenmakers, managing director, born on 10th August 1960 in Voorburg, the Netherlands, residing

at, Kwaakhaven 8, 2341 NW Oegstgeest, the Netherlands; and

- Mr Nicolas Michael Perkins, international tax manager, born on 16th September 1969 in Bridgend, United Kingdom,

resinding at Flat 1, 46 Islington Park Street, London N11PX, United Kingdom.

<i>Fifth resolution

The general meeting acknowledged and accepted the resignation of Ms Valerie Fisson as statutory auditor of the

Company with effect from 26th June 2008.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the transfer of its registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to the Netherlands are estimated at
€ 3,500,-.

There being no further business on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.

Done in Luxembourg, on the day beforementioned
After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-sixième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire demeurant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'UPRN 1 SE, (la «Société»), une société européenne

avec siège social au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée par acte de M 

e

 Joseph Elvinger, notaire

demeurant à Luxembourg, le 4 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»)
numéro 936 du 30 octobre 2001.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné le 21 avril 2008 publié au

Mémorial numéro 1022 du 25 avril 2008.

L'assemblée a été présidée par M. Dennis Bosje, comptable, résidant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Mme Mariya Gadzhalova, maître en droit, résidant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, a été désignée comme

secrétaire et comme scrutateur.

Le président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:
1. Les actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur une liste de présence signée par

le président, le secrétaire et le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste restera annexée au présent acte pour
être soumise aux formalités d'enregistrement.

2. Il apert de ladite liste que toutes les cinq mille huit cent soixante cinq (5.865) actions émises par la Société sont

représentées à la présente assemblée générale.

3. Tout les actionnaires représentés déclarent avoir eu une connaissance complète de l'ordre du jour de l'assemblée

et renoncer à leur droit à une convocation préalable de sorte que l'Assemblée peut valablement délibérer sur tous les
points portés à l'ordre du jour.

4. Le 12 février 2008 le conseil d'administration de la Société a décidé de proposer aux actionnaires de la Société de

transférer le siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers les Pays-Bas.

5. Toutes les formalités relatives au transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers les

Pays-Bas telles que prévues par les articles 101-2 à 101-9 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi») et par l'article 8 du Règlement CE 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut
de la société européenne (le «Règlement») ont été respectées, notamment:

79838

a) le conseil a établi un projet de transfert lequel a été publié au Mémorial numéro 1037 le 26 avril 2008, c.à.d. au

moins deux mois avant la tenue de la présente assemblée générale des actionnaires de la Société;

b) le conseil a établi un rapport du conseil d'administration sur le transfert proposé du siège social du Grand-Duché

de Luxembourg vers les Pays-Bas conformément à l'article 101-4 de la Loi et à l'article 8(3) du Règlement;

c) le rapport du conseil d'administration et le projet de transfert étaient disponibles à la consultation par les créanciers

et les actionnaires et les actionnaires et les créanciers ont été dûment informés de leur droit de consulter le rapport du
conseil d'administration et le projet de transfert au siège social de Société un mois avant la présente assemblée générale;

d) les créanciers ont été dûment informés de leur droit de demander au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg

siégeant en matière commerciale la constitution de sûretés pendant une période de deux mois à partir de la date de
publication du projet de transfert au Mémorial.

La Société n'a pas d'employés ni d'obligataires de sorte que les conditions y relatives ne sont pas applicables.
6. Que l'ordre du jour de l'assemblée est comme suit:
A. Présentation et approbation du projet de transfert tel que publié au Mémorial numéro 1037 du 26 avril 2008 et du

rapport du conseil d'administration concernant le transfert du siège social du Grand-Duché de Luxembourg vers les Pays-
Bas.

B. Approbation du changement de nationalité et approbation du transfert du siège social de la société du 17, boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, Pays-Bas.

C. Approbation et adoption de nouveaux statuts de la Société conformes au droit néerlandais, substantiellement dans

la forme annexée aux procurations, le mandataire étant expressément autorisé et ayant le pouvoir de procéder et de
donner son accord aux modifications qui lui sembleront appropriées.

D. Acceptation de la démission de M. Neil Mepham, M. Paul de Haan et M. Dennis Bosje en tant qu'administrateurs

de la Société avec effet au 26 juin 2008 et nomination des personnes suivantes en tant qu'administrateurs supplémentaires
de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui statuera sur les comptes annuels de
l'année sociale prenant fin le 31 décembre 2008:

- Mme Margaretha Johanna Springintveld, expert comptable, née le 14 novembre 1967 à Aalsmeer, Pays-Bas, demeurant

au Jac.P. Thijsselaan 3, 1431 JH Aalsmeer, Pays-Bas;

- M. Michel Klaas Schoenmakers, directuer, né le 10 août 1960 à Voorburg, Pays-Bas, demeurant au Kwaakhaven 8,

2341 NW Oegstgeest, Pays-Bas; et

- M. Nicolas Michael Perkins, directeur fiscalité internationale, né le 16 septembre 1969 à Bridgend, Royaume-Uni,

demeurant à Appartement 1, 46 Islington Park Street, Londres N1 1PX, Royaume-Uni.

E. Acceptation de la démission de Mme Valérie Fisson en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet

au 26 juin 2008.

Suite à quoi, l'assemblée a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le projet de transfert concernant le transfert du siège social de la Société du 17, boulevard Prince Henri, L-1724

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, Pays-Bas, tel que publié au Mémorial
numéro 1037 du 26 avril 2008 et du rapport du conseil d'administration y relatif ont été présentés à l'assemblée.

Ensuite l'assemblée a attentivement examiné leurs termes et a décidé d'approuver le projet de transfert sous réserve

de toutes modifications nécessaires telles que prévues dans les résolutions suivantes.

<i>Seconde résolution

L'assemblée générale a décidé de changer la nationalité de la Société luxembourgeoise en néerlandaise et de transférer

le siège social de la Société du 17, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au
Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, Pays-Bas avec effet à partir de la date du présent acte.

<i>Troisième résolution

L'assemblée a pris note des statuts proposés tels que figurant au projet de transfert publié au Mémorial numéro 1037

du 26 avril 2008 et a pris note que les statuts de la Société devant être adoptés suite au transfert du siège social de la
Société vers les Pays-Bas approuvé ci-dessus doivent être conformes aux droits néerlandais.

L'assemblée a constaté que des changements dans le droit de Société néerlandais sont intervenus depuis que le projet

de transfert a été publié au Mémorial et que l'article 7 des statuts proposés tels que figurant au projet de transfert n'étaient
plus conformes au droit néerlandais.

Par conséquent, l'assemblée a décidé d'adopter des nouveaux statuts de la Société comme suit:

«Statuts consolidés, modifiés et reformulés

Art. 1. Definitions.
1.1. In these articles of association:
- "Body" (orgaan) is a term that applies to the Management Board or the General Meeting;
- "Company" means this Societas Europaea;

79839

- "General Meeting" (algemene vergadering) is the Body consisting of the Shareholders;
- "General Meeting of Shareholders" (algemene vergadering van aandeelhouders) means the gathering of the Share-

holders in a meeting;

- "Managing Director" (bestuurder) is a managing director as referred to in Dutch law, being a natural person or a legal

entity;

- "Management Board" (bestuur) is the Body made up of the Managing Directors;
- "Shareholder" (aandeelhouder) means a holder of one or more shares in the capital of the Company, being a natural

person or a legal entity.

Art. 2. Name and seat.
2.1. The name of the Company is: UPRN 1 SE.
2.2. The Company shall have its seat in Amsterdam (The Netherlands).
2.3 As long as the Company has its seat in the Netherlands, it must also have its head office in the Netherlands.

Art. 3. Objects.
3.1. The objects of the Company are:
- to incorporate, to participate in and to finance companies or businesses;
- to collaborate with, to manage the affairs of and to provide advice and other services to companies and other

businesses;

- to lend and to borrow funds;
- to provide collateral for the debts and other obligations of the Company, of other companies and businesses that

are affiliated with the Company in a group and of third parties;

- to acquire, to operate and to dispose of property, including registered property; and
- to acquire, to operate and to dispose of industrial and intellectual property rights,
as well as to carry out all that which is incidental or conducive to the above, in the broadest sense.

Art. 4. Capital and shares.
4.1. The authorised capital is seven hundred thirty-three thousand one hundred and twenty-five Euro (€ 733,125.-)

and shall be divided into twenty-nine thousand three hundred and twenty-five (29,325) shares, each having a nominal
value of twenty-five Euro (€ 25.-).

4.2. The shares shall be registered and shall be numbered consecutively, starting at one.
4.3. Share certificates shall not be issued by the Company.
4.4. If shares or the right to shares are jointly held, the joint Shareholders may only be represented by a single person

holding a written proxy signed by them all.

Art. 5. Issue.
5.1. Shares shall be issued pursuant to a resolution adopted by the General Meeting. Furthermore, the resolution shall

set out the price and other terms and conditions of issue. The issue price shall not be below par.

5.2. The general meeting may delegate its powers in this respect to another constituent body for a fixed period not

exceeding five years.

On such designation the number of shares which may be issued must be specified.
The designation may be extended from time to time for periods not exceeding five years.
Unless such designation provides otherwise, it may not be withdrawn.
5.3. Within eight days after a resolution of the general meeting to issue or to make a designation, the Company shall

deposit the full text thereof at the office of the commercial register.

5.4. Within eight days after each issue of shares, the Company shall report the same to the office of the commercial

register, stating the number.

5.5. Without prejudice to any provision of Dutch law, every Shareholder shall have a preemptive right on any issue of

shares "pro rata" to the aggregate amount of his shares. A pre-emptive right is non-transferable.

5.6. A notice of any issue in respect of which there is a pre-emptive right and the period during which such right can

be exercised, shall be given in writing to all the Shareholders at the addresses as indicated by them to the Company.

5.7. The pre-emptive right may be exercised during a period of four weeks after the days of sending such notice to

the Shareholders.

5.8. The pre-emptive right may be limited or excluded by virtue of a resolution adopted by the general meeting.
The pre-emptive right may also be restricted or excluded by the constituent body designated pursuant to subsection

2 of this article, if, by a resolution of the general meeting, it was designated and authorized for a fixed period not exceeding
five years, to restrict or exclude such pre-emptive right.

The designation may be extended, from time to time, for a period not exceeding five years.

79840

The designation is only valid as long as the designation as referred to in paragraph 2 is valid.
Unless the designation provides otherwise, it may be withdrawn.
5.9. If less than fifty percent of the issued capital is represented at the meeting, a majority of at least two-thirds of the

votes cast shall be required for a resolution of the general meeting to restrict or exclude the pre-emptive right or to
make such designation.

Within eight days after the resolution the Company shall deposit the full text thereof at the office of the commercial

register.

5.10. On the grant of rights to subscribe for shares, the Shareholders have a pre-emptive right.
The provisions of the above subsections are applicable "mutatis mutandis" to the granting of a right to subscribe for

shares.

Shareholders shall have no pre-emptive right in respect of shares issued to a person who exercises a previously acquired

right to subscribe for shares.

5.11 On subscription for a share, payment must be made of its nominal amount. It may be provided that a part, not

exceeding three-quarters of the nominal amount, need only be paid after the Company has called it up.

Art. 6. Own shares.
6.1. On an issue of shares the Company is not able to subscribe to its own shares.
6.2. The acquisition by the Company of its own shares when those shares have not been fully paid up shall be null and

void, unless acquired under universal title.

6.3. The Company may only acquire its own fully paid-up shares either gratuitously or as specified in Dutch law.
6.4. The provisions set out in these articles for the restriction on the transfer of shares are applicable to the Company's

disposal of its own shares.

6.5. In this article "shares" includes depositary receipts for shares.

Art. 7. Financial assistance.
7.1. The Company shall not provide collateral, provide a price guarantee or otherwise guarantee, or bind itself with

or on behalf of third parties for the purpose of subscription to or acquisition by third parties of shares in its own capital,
or of depository receipts issued in respect thereof. This prohibition shall also extend to its subsidiaries.

7.2. The Company may grant loans, for the purpose of subscription to or acquisition by third parties of shares in its

own capital, or of depository receipts issued in respect thereof, with due observance of Dutch law.

7.3. The prohibition of the first subsection shall not apply if shares or depositary receipts are acquired by or on behalf

of employees of the Company or a group company as meant in Dutch law.

Art. 8. Reduction of capital.
8.1. The General Meeting may resolve to reduce the issued capital by cancelling shares or by amending the Articles of

Association to reduce the nominal amount of the shares.

8.2. Dutch law applies to such a resolution and its implementation.

Art. 9. The issue of depositary receipts for, the pledging of and the establishment of a right of usufruct over shares.
9.1. The Company shall not lend assistance in the issuance of depositary receipts for shares in the Company.
9.2. A right of usufruct or a right of pledge may be granted over shares. Voting rights shall not be vested in a holder

of a right of usufruct nor in a holder of a right of pledge of shares, unless voting rights are vested in a holder of a right of
usufruct pursuant to article 2:88, paragraph 3, final sentence, of the Dutch Civil Code.

Art. 10. Register of Shareholders.
10.1.The Management Board shall keep a register recording the names and addresses of all Shareholders, the date on

which they acquired the shares, the date of acknowledgement by or service upon the Company and the amount paid up
on each share. The names and addresses of those who have a right of usufruct or a right of pledge in respect of shares
shall also be recorded, stating the date on which they acquired the right and the date of acknowledgement by or service
upon the Company.

10.2. Every Shareholder, holder of a right of usufruct or holder of a right of pledge is obliged to ensure that the

Company is notified of the address of the Shareholder or holder of a right of usufruct or pledge.

10.3. The register shall be regularly updated in accordance with Dutch law.
10.4. All entries in, copies of, or extracts from the register of Shareholders shall be authenticated by a Managing

Director.

Art. 11. Transfer of shares.
11.1. The issue and transfer of a registered share, or the transfer or waiver of a limited right to a registered share,

require a deed which has been executed before a notary practicing in the Netherlands and to which all persons involved
are a party.

79841

11.2. The transfer of a registered share, or the transfer or waiver of a limited right to a registered share, in accordance

with the provisions of the previous section shall also, by operation of Dutch law, be legally binding on the Company.
Except in the event that the Company itself is a party to the legal transaction, the rights accruing to the share may not
be exercised until the Company has either acknowledged this legal transaction or been served with the deed of transfer
in accordance with Dutch law.

Art. 12. Management Board.
12.1. The Company shall have a Management Board consisting of at least three Managing Directors. The number of

Managing Directors shall be laid down by the General Meeting taking into account the aforementioned minimum. If the
number of appointed Managing Directors at any time falls below one, than one or more new Managing Directors will be
appointed by the General Meeting as soon as possible.

The Management Board shall appoint one of the Managing Directors as chairman of the Management Board.
The Managing Director-legal entity shall designate a natural person to exercise its functions and authorities.
12.2. Managing Directors shall be appointed by the General Meeting for a maximum period of six years. Managing

Directors may be reappointed once or more than once, each time for a maximum period of six years.

12.3. Managing Directors may be suspended or dismissed by the General Meeting at any time.
12.4.The total period of a suspension, including any extensions, may last no longer than three months.
12.5. The remuneration and other terms and conditions for the appointment of each individual Managing Director

shall be determined by the General Meeting.

Art. 13. Adoption of resolutions by the Management Board.
13.1. The Management Board shall adopt resolutions by an absolute majority of the total number of votes cast by all

the Managing Directors in a meeting in which at least one half of the Managing Directors is present or represented.

13.2. In meetings of the Management Board each Managing Director shall be entitled to cast one vote. In case of a tie

in the votes, the vote of the chairman of the Management Board shall be decisive.

13.3. Managing Directors may only be represented in meetings of the Management Board by another Managing Director

pursuant to a written power of attorney.

13.4.The Management Board may also adopt resolutions without convening a meeting, provided that all Managing

Directors have been consulted and none of them have raised an objection to adopt resolutions in this manner.

13.5. The approval of the General Meeting shall be required for decisions by the Management Board leading to an

important change in the company's or its business enterprise's entity or character, including in any case:

a. the transfer the business of the company or almost the entire business of the company to a third party;
b. the entering into or termination of any long-term co-operation of the company with another legal entity or company

or  as  a  fully  liable  partner  in  a  limited  or  general  partnership,  if  such  co-operation  or  termination  is  of  far-reaching
significance to the company;

c. the acquisition or disposal by the company or by a subsidiary of the company of a participation in the capital of

another company with a value of at least one third of the amount of the assets according to the balance sheet with
explanatory notes, or in case the company prepares a consolidated balance sheet, according to the consolidated balance
sheet with explanatory notes, forming part of the most recently adopted annual accounts of the company.

13.6. The absence of the approval as defined in paragraph 5 of this article shall not affect the powers of the Managing

Board or of the Managing Directors to represent the Company.

Art. 14. Unavailability or inability to act of a Managing Director. If a Managing Director is unavailable or unable to act,

then the management of the Company shall be vested in the remaining Managing Director or Managing Directors. If no
Managing Director is available or able to act, the management of the Company shall be temporarily vested in one or more
persons appointed for that purpose by the General Meeting.

Art. 15. Representation of the Company.
15.1. The authority to represent shall vest exclusively in:
- the Management Board;
- any one of the Managing Directors.
15.2. In the event that a conflict of interest arises between the Company and a Managing Director, the Management

Board will represent the Company. The General Meeting is authorised to appoint one or more persons to represent the
Company at any time.

If it does so, the representative authority contemplated in the previous sentence of this paragraph will no longer apply.

Without prejudice to the representative authority, in any case involving a conflict of interest, the Management Board may
act on behalf of the Company only after obtaining express prior permission from the General Meeting.

Art. 16. Confidentiality. The Managing Directors shall be under a duty, even after they have ceased to hold office, not

to divulge any information which they have concerning the company the disclosure of which might be prejudicial to the
company's interest, except where such disclosure is required under the law or is in the public interest.

79842

Art. 17. Financial year, annual accounts and annual report.
17.1. The Company's financial year shall be concurrent with the calendar year.
17.2. The Management Board shall prepare the annual accounts, which shall consist of the balance sheet and the profit

and loss statement with explanatory notes. The annual accounts shall be prepared within five months of the end of each
financial year, unless the General Meeting grants an extension to a maximum of six months in special circumstances. The
annual accounts require the signatures of all the Managing Directors. The absence of a signature, and the reason therefore,
shall be expressly stated. Unless the provisions of article 2:403 of the Dutch Civil Code are applicable to the Company,
the Management Board shall also prepare an annual report within the above-mentioned period.

17.3. If, and to the extent that, any relevant provision of Dutch law is applicable to the Company, the General Meeting

shall retain a registered accountant or a firm of registered accountants, as defined in article 2:393, section 1, of the Dutch
Civil Code, to examine the annual accounts and, if prepared, the annual report prepared by the Management Board, in
order to write a report and to provide an opinion.

17.4. The annual accounts shall be adopted by the General Meeting.
17.5. If, and to the extent that, it is required under Dutch law, the Company is obliged to make the annual accounts

publicly available at the Trade Register.

Art. 18. Appropriation of the profits.
18.1. The Company may make distributions to the Shareholders and other persons entitled to the distributable profits,

to the extent the equity of the Company exceeds the paid-up and called-up part of the Company's equity, plus the reserves
which must be maintained under Dutch law.

18.2. The profits evidenced by the profit and loss statement adopted by the General Meeting shall be at the disposal

of the General Meeting.

18.3. The Company may make interim (profit-)distributions after the General Meeting has granted its approval, to the

extent that the provisions as set out in subsection 1 above have been complied with as evidenced by an interim statement
in conformity with Dutch.

The Company shall deposit the interim statement at the office of the commercial register within eight days after the

day on which the resolution to distribute is published.

18.4. There shall be no distribution of profits on shares or depositary receipts for shares held by the Company in its

own capital.

18.5. The shares and depositary receipts for shares for which no distribution will be made as described in section 4

above shall be disregarded when calculating the distribution of profits.

18.6.The right to receive a distribution shall expire five years from the day on which such a distribution became payable.

Art. 19. Shareholder meetings.
19.1. The annual meeting of Shareholders shall be held every year within six months of the end of the financial year.

In this meeting the following, amongst other matters, shall be brought up for consideration, unless the six-month time
period mentioned above in Article 17.2, has been extended in accordance with the provisions set out in the said article:

- the annual report;
- the adoption of the annual accounts;
- the granting of discharge to the Managing Directors from liability for actions in respect of their management during

the preceding financial year;

- if required by Dutch law, the instruction of an expert as referred to in article 2:393, of the Dutch Civil Code; and
- the language in which the items of the next annual accounts shall be stated and the currency.
19.2. The General Meeting of Shareholders shall be held in the municipality where the Company has its registered

seat.

19.3. One or more shareholders who together hold at least ten percent (10%) of the subscribed capital may request

to convene a General Meeting of Shareholders and to draw up an agenda therefore. If, following the request a General
Meeting of Shareholders is not held in due time and, in any event, within two months, the judge (voorzieningenrechter)
of the court may order that a General Meeting of Shareholders shall be convened within a given period or authorize the
shareholders who have requested it to convene a General Meeting of Shareholders.

19.4. Unless the last sentence of the preceding paragraph is applicable, notice of the convening of the General Meeting

of Shareholders shall be issued by the Management Board, or one of the Managing Directors by means of written notices
dispatched no later than the fifteenth day before the date of the meeting.

19.5. The written notices convening the meeting shall set out the place, date and time of the meeting and the matters

to be considered. One or more shareholders who together hold at least one percent (1%) of the subscribed capital may
request that one or more additional items be put on the agenda of any General Meeting of Shareholders, provided that
the company has received the request no later than on the sixtieth day before the day of the meeting.

79843

19.6. The written notices shall be dispatched to the addresses recorded in the Shareholder register. The failure of one

or more of the written notices dispatched in accordance with the stipulations set out above to reach the destination shall
not affect the validity of the General Meeting of Shareholders or the resolutions adopted thereby.

19.7. The General Meeting of Shareholders appoints a chairman from its midst.
19.8. Minutes shall be taken of the matters dealt with in a General Meeting of Shareholders unless a notarial record

of the proceedings is drawn up. The minutes shall be entered into a register maintained for that purpose and require the
adoption and signature of the chairman of the meeting and the secretary of the meeting, who shall be appointed by the
chairman at the commencement of the meeting. The minutes or the notarial record of the proceedings shall serve as
evidence of the resolutions adopted in the General Meeting of Shareholders.

Art. 20. Adoption of resolutions in a General Meeting of Shareholders.
20.1. All Shareholders shall be entitled to attend a General Meeting of Shareholders and to address that meeting. The

shareholder-legal entity shall designate a natural person to exercise its functions and authorities. This person shall be able
to resolve and act on behalf of the shareholder-legal entity without limitation or consultation. The Managing Director or
Managing Directors, shall have, in these capacities, an advisory vote in the General Meeting of Shareholders.

20.2. In order to be able to participate in the voting the Shareholders - in case of shareholders-legal entities the persons

designated pursuant to article 20.1 - must sign the attendance book, recording the number of shares represented by
them.

20.3. Every share entitles the holder thereof to cast one vote.
20.4. In a General Meeting of Shareholders, no votes may be cast for shares held by the Company or by any subsidiary

thereof, nor may votes be cast for a share for which either of them holds a depositary receipt for a share.

20.5. The sum of the shares for which no voting rights may be exercised according to Dutch law shall be disregarded

in determining the extent to which the Shareholders are entitled to vote, are present or represented, or to which extent
the share capital is provided or represented.

20.6. Resolutions passed in a General Meeting of Shareholders shall be adopted by an absolute majority of the votes

validly cast in a meeting in which at least half of the Shareholders is present or represented. The votes cast shall not
include votes attaching to shares in respect of which the Shareholder has not taken part in the vote or has abstained or
has returned a blank or spoilt ballot paper.

20.7. The votes shall be cast orally, unless the chairman of the meeting decides otherwise.
20.8. In case of a tie in the vote, the proposal shall be deemed to have been rejected.
20.9. In a General Meeting of Shareholders in which the entire issued capital is represented valid resolutions can be

adopted provided they are adopted unanimously, even if the requirements in respect of the convening and holding of
meetings have not been complied with.

20.10. The Management Board shall keep a record of the adopted resolutions. This record shall be made available at

the Company's office for inspection by the Shareholders. Each Shareholder shall, upon request, be provided with a copy
of or extract from this record at no more than the actual costs.

Art. 21. Adoption of resolutions outside a General Meeting of Shareholders.
21.1. Shareholders may also adopt resolutions without convening a meeting of Shareholders, provided that all Share-

holders have declared in writing (including all generally accepted means of communication) to be in favour of the resolution
and provided that the Managing Director or Managing Directors, have had the opportunity to cast an advisory vote.

Art. 22. Merger, division, amendment to the articles of association, dissolution.
22.1. The General Meeting may resolve to merge the Company, to divide the Company, to amend the Articles of

Association or to dissolve the Company.

22.2. Those who convene a General Meeting of Shareholders in which a proposal is made to adopt a resolution to

amend the Articles of Association or to dissolve the Company must deposit a copy of the proposal, stating the verbatim
text of the proposed amendment, at the offices of the Company for inspection by the Shareholders. The proposal must
be deposited at the same time as the notice of the meeting and kept there until after the close of the meeting. The
Shareholders must be given the opportunity to obtain a copy of the proposal described in the previous sentence from
the day on which the convening notice for that meeting is dispatched until the day of the General Meeting of Shareholders.
Such copies shall be provided free of charge.

22.3. In the event that a resolution to dissolve the Company is adopted, the liquidation shall be arranged by the

Management Board, unless the court should appoint another liquidator or other liquidators. If a resolution to liquidate
the Company is passed, a resolution regarding the remuneration to be paid to the liquidator, or the joint liquidators,
must be passed at the same time.

22.4. The Articles of Association shall, as far as possible, remain effective during the process of liquidation.
22.5. The liquidation surplus shall be distributed to Shareholders and other parties entitled thereto in proportion to

their respective rights.

79844

22.6. After the liquidation has been completed, the books and records of the dissolved Company shall remain in custody

of a person to be appointed for that purpose by the General Meeting for a period of seven years.»

«STATUTEN

Art. 1. Definities.
1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:
orgaan: het bestuur of de algemene vergadering;
vennootschap: deze Societas Europaea;
algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders;
algemene vergadering van aandeelhouders: bijeenkomst van aandeelhouders;
bestuurder(s): de bestuurder(s) in de zin van de wet, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen;
bestuur: het orgaan gevormd door de bestuurder(s);
aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen in het kapitaal van de vennootschap, zijnde een natuurlijk

persoon of een rechtspersoon.

Art. 2. Naam en zetel.
2.1 De vennootschap draagt de naam: UPRN 1 SE.
2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.
2.3 Zolang de vennootschap haar statutaire zetel in Nederland heeft, dient het hoofdbestuur van de vennootschap

gelegen te zijn in Nederland.

Art. 3. Doel.
3.1 De vennootschap heeft ten doel:
- het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van vennootschappen of ondernemingen;
- het samenwerken met-, het voeren van bestuur over- en het verlenen van adviezen en andere diensten aan ven-

nootschappen of ondernemingen;

- het opnemen en verstrekken van geldleningen;
- het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennoot-

schappen of ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of van derden;

- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen; en
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten,
alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in

de ruimste zin van het woord.

Art. 4. Kapitaal en aandelen.
4.1  Het  maatschappelijk  kapitaal  bedraagt  zevenhonderd  drieëndertig  duizend  éénhonderd  vijfentwintig  euro  (€

733.125,-) en is verdeeld in negenentwintig duizend driehonderd vijfentwintig (29.325) aandelen van nominaal vijfentwintig
euro (€ 25,-) elk.

4.2 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
4.3 Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
4.4 Indien aandelen of rechten op aandelen tot een gemeenschap behoren kunnen de deelgenoten zich slechts tege-

nover de vennootschap doen vertegenwoordigen door een persoon, daartoe schriftelijk door hen alien gemachtigd.

Art. 5. Uitgifte.
5.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering dat tevens de koers en de

verdere voorwaarden van uitgifte bevat.

5.2 De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
De algemene vergadering kan een ander orgaan aanwijzen om de bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld uit te

oefenen en wel voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren.

Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
5.3 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing

een volledige tekst daarvan neer bij het handelsregister.

5.4 De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave bij het handelsregister, met

vermelding van het aantal.

5.5 Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk

bedrag van zijn aandelen behoudens het bepaalde in de wet.

79845

Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.
5.6 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in

een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres.

5.7 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende vier weken na verzending van de aankondiging aan de

aandeelhouders.

5.8 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge lid 2 van dit artikel aangewezen orgaan,

indien dit bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als
bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.

Zodanige aanwijzing kan slechts geschieden indien het betreffende orgaan tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen

als het tot uitgifte bevoegde orgaan als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
De aanwijzing geldt slechts zolang een aanwijzing als bedoeld in lid 2 van kracht is.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.
5.9 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing

is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het
geplaatste kapitaal in de vennootschap is vertegenwoordigd.

De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer bij het handelsregister.
5.10 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht.
Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds

verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

5.11 Bij het nemen van een aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden

dat een deel, ten hoogste drie Vierden van het nominale bedrag, eerst behoeft te worden gestört nadat de vennootschap
het zal hebben opgevraagd.

Art. 6. Eigen aandelen.
6.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
6.2 Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte eigen aandelen is nietig, tenzij wordt verkregen onder

algemene titel.

6.3 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen slechts verkrijgen om niet of met inachtneming van het bepaalde

in de wet.

6.4 Met betrekking tot vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen is het bepaalde in de blok-

keringsregeling in deze Statuten van toepassing.

6.5 Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Art. 7. Verboden steunverlening.
7.1 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal

of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zieh op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk
of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

7.2 De vennootschap mag, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van

certificaten daarvan, leningen verstrekken met inachtneming van het bepaalde in de wet.

7.3 Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of

verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij als bedoeld in de wet.

Art. 8. Kapitaalvermindering.
8.1 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen

of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

8.2 Op een dergelijk besluit en de uitvoering daarvan is het bepaalde in de wet van toepassing.

Art. 9. Certificering, verpanding en vestiging van vruchtgebruik op aandelen.
9.1 De vennootschap verleent geen medewerking aan uitgifte van certificaten van aandelen van de vennootschap.
9.2 Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd.
Aan de vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen kan het stemrecht niet worden toegekend, tenzij het stemrecht

toekomt aan een vruchtgebruiker op grond van artikel 2:88 lid 3 laatste volzin van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 10. Aandeelhoudersregister.
10.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met

vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede
van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

79846

Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op

aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen alsmede de datum van erkenning
of betekening.

10.2 Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de ven-

nootschap bekend is.

10.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van de wet.
10.4 Alle aantekeningen in en afschriften of uittreksels uit het aandeelhoudersregister zullen worden ondertekend door

een bestuurder.

Art. 11. Levering van aandelen.
11.1 Voor de uitgifte en levering van een aandeel op naam of de levering of afstanddoening van een beperkt recht

daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de
betrokkenen partij zijn.

11.2 De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het in lid 1 bepaalde

werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap.

Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbunden

rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeen-
komstig het daaromtrent bepaalde in de wet.

Art. 12. Bestuur.
12.1 De vennootschap heeft een bestuur bestaande uit ten minste drie bestuurders. Het aantal bestuurders wordt

met inachtneming van dit minimum door de algemene vergadering vastgesteld. Is het aantal bestuurders minder dan één,
dan benoemt de algemene vergadering zo spoedig mogelijk een of meer nieuwe bestuurders. Het bestuur benoemt uit
zijn midden een voorzitter.

Een bestuurder rechtpersoon wijst voor de uitoefening van zijn bevoegdheden een natuurlijk persoon als vertegen-

woordiger aan.

12.2 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van ten hoogste zes jaar. Zij

kunnen een of meerdere malen worden herbenoemd, steeds voor een periode van ten hoogste zes jaar.

12.3 Bestuurders kunnen te alien tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
12.4 Een schorsing kan, ook na een of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.
12.5 De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere bestuurder afzonderlijk, bepaald door de

algemene vergadering.

Art. 13. Besluitvorming bestuur.
13.1 Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van het in totaal door alle bestuurders uit te brengen aantal

stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

13.2 In de vergaderingen van het bestuur brengt iedere bestuurder één stem uit. In geval van staking van stemmen is

de stem van de voorzitter van het bestuur doorslaggevend.

13.3 Iedere bestuurder kan zich in de bestuursvergaderingen uitsluitend door een medebestuurder doen vertegen-

woordigen. Die vertegenwoordiging dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht.

13.4 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en geen van hen zieh

tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.

13.5 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een

belangrljke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of haar onderneming, waaronder in ieder
geval:

a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een

andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap
of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde

van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans
opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennoot-
schap, door haar of een dochtermaatschappij.

13.6 Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in lid 5 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur

of de bestuurders niet aan.

Art. 14. Belet of ontstentenis.
14.1 In geval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders berust het bestuur van de vennootschap bij de

overblijvende bestuurders dan wel de enig overgebleven bestuurder.

79847

In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur van de vennoot-

schap tijdelijk bij een of meer door de algemene vergadering daartoe aangewezen personen.

Art. 15. Vertegenwoordiging.
15.1 De vennootschap wordt slechts vertegenwoordigd door:
- hetzij het bestuur;
- hetzij iedere bestuurder.
15.2 In alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een bestuurder, wordt de vennootschap

vertegenwoordigd door het bestuur. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe
aan te wijzen, waardoor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging zoals beschreven in de vorige volzin, komt te vervallen.
Onverminderd de bevoegdheid tot vertegenwoordiging, is het handelen door het bestuur namens de vennootschap in
alle gevallen van tegenstrijdig belang onderworpen aan uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de algemene verga-
dering.

Art. 16. Geheimhouding. De directeuren mogen, ook nadat zij hun funcţie hebben beëindigd, geen ruchtbaarheid geven

aan de te hunner beschikking staande inlichtingen over de vennootschap waarvan de openbaarmaking de belangen van de
vennootschap zou kunnen schade, behalve in gevallen waarin deze openbaarmaking krachtens de wet of om reden van
algemeen belang verplicht of toegestaan zijn.

Art. 17. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag.
17.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
17.2 Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ver-

gadering met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening
(bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
Tenzij artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, maakt het bestuur binnen voornoemde

termijn een jaarverslag op.

17.3 Indien en voorzover het dienaangaande in de wet bepaalde op de vennootschap van toepassing is, zal door de

algemene vergadering opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel
2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de door het bestuur ontworpen jaarrekening alsmede - indien opgemaakt
- het jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.

17.4 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
17.5 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking bij het handelsregister indien en voorzover de wet dit vereist.

Art. 18. Winstbestemming.
18.1 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts

uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het
kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

18.2 De winst blijkende uit de door de algemene vergadering vastgestelde winst- en verliesrekening staat ter be-

schikking van de algemene vergadering.

18.3 De vennootschap mag tussentijds slechts (winst-)uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 1 is voldaan

blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig de wet en na voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering.

De vennootschap legt de vermogensopstelling bij het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het

besluit tot uitkering wordt bekendgemaakt.

18.4 Op door de vennootschap gehouden aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan vindt geen uitkering ten

behoeve van de vennootschap plaats.

18.5 Bij de berekening van de winstverdeling teilen de aandelen of certificaten van aandelen, waarop ingevolge het in

lid 4 bepaalde geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaatsvindt, niet mee.

18.6 De vordering tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaars-

telling.

Art. 19. Vergaderingen van aandeelhouders.
19.1 Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

gehouden. In deze jaarvergadering worden onder meer - tenzij de termijn als bedoeld in artikel 17.2 van deze Statuten
overeenkomstig het aldaar bepaalde is verlengd -, aan de orde wordt gesteld:

- de behandeling van het jaarverslag;
- de vaststelling van de jaarrekening;
- het verlenen van decharge aan het bestuur voor het door haar in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;

79848

- het verlenen van een opdracht aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, voorzover

wettelijk vereist;

- de taal waarin de posten van de eerstvolgende jaarrekening worden gesteld en de geldeenheid.
19.2 De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel

heeft.

19.3 Het verzoek tot bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders en tot vaststelling van de agenda

kan worden gedaan door een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigen. Indien na de indiening van het verzoek de algemene vergadering van aandeelhouders niet
tijdig, in elk geval binnen een termijn van twee maanden, wordt gehouden, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
de bijeenroeping binnen een bepaalde termijn gelasten of de aandeelhouders die het verzoek hebben gedaan machtigen
tot bijeenroeping.

19.4 Tenzij de laatste zin van het vorige artikel van toepassing is, geschiedt de bijeenroeping van aandeelhouders door

het bestuur of door een bestuurder door middel van oproepingsbrieven welke moeten worden verzonden niet later dan
op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.

19.5 De oproepingsbrieven vermelden plaats, dag en uurvan de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen.

Een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen,
kan of kunnen verzoeken om een of meer nieuwe punten op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders
te plaatsen indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft
ontvangen.

19.6 De oproepingsbrieven worden verzonden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister.
Wanneer een of meer oproepingsbrieven, overeenkomstig het hiervoor bepaalde verzonden, hun bestemming niet

bereiken, dan zal dit geen invloed uitoefenen op de geldigheid van de algemene vergadering van aandeelhouders en de
daarin te nemen besluiten.

19.7 De algemene vergadering van aandeelhouders voorziet zelf haar voorzitterschap.
Indien hij niet aanwezig is voorziet de algemene vergadering van aandeelhouders zelf in haar leiding.
19.8  Van  het  verhandelde  in  een  algemene  vergadering  van  aandeelhouders  worden  notulen  gehouden  tenzij  een

notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

De notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en vastgesteld en getekend door de voorzitter van

de vergadering en de door deze bij de aanvang van de vergadering aangewezen secretaris van de vergadering.

De notulen of het notarieel proces-verbaal strekken tot bewijs van het in de vergadering beslotene.

Art. 20. Besluitvorming in vergadering.
20.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord

te voeren. Een aandeelhouder-rechtspersoon wijst voor de uitoefening van zijn bevoegdheden een natuurlijke persoon
als vertegenwoordiger aan. Deze persoon dient zonder last of ruggespraak namens de aandeelhouder-rechtspersoon te
kunnen besluiten en handelen.

De bestuurder(s) heeft (hebben) als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.
20.2 Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders - in geval van aandeelhouders-rechts-

personen de personen aangewezen op grand van artikel 20.1 - de presentielijst tekenen, onder vermelding van het aantal
door ieder vertegenwoordigde aandelen.

20.3 Elk aandeel geeft recht op één stem.
20.4 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene

vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de
certificaten houdt.

20.5 Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre

het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de
wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

20.6 De besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen met volstrekte meerderheid van

de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de aandeelhouders aanwezig of verte-
genwoordigd is.

De uitgebrachte stemmen omvatten niet de stemmen die verbunden zijn aan aandelen ten aanzien waarvan de aan-

deelhouder niet aan de stemming heeft deelgenomen of zieh heeft onthouden, dan wel bianco of ongeldig heeft gestemd.

20.7 Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt.
20.8 Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
20.9 In een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is,

kunnen, mits met algemene stemmen, rechtsgeldige besluiten worden genomen ook al zijn de voorschriften met be-
trekking tot het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

20.10 Het bestuur van de vennootschap houdt van de genomen besluiten aantekening.

79849

De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen

wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Art. 21. Besluitvorming buiten vergadering. Besluitvorming door aandeelhouders kan op andere wijze dan in een ver-

gadering van aandeelhouders plaatsvinden doordat alle aandeelhouders zieh schriftelijk (waaronder begrepen elk gangbaar
communicatiemiddel) vóór het voorstel hebben verklaard, en mits de bestuurder(s) de gelegenheid heeft (hebben) gehad
raadgevende stem uit te brengen.

Art. 22. Fusie, splitsing, statutenwijziging, ontbinding.
22.1 De algemene vergadering kan besluiten tot fusie, splitsing, wijziging van de Statuten en tot ontbinding van de

vennootschap.

22.2  Degenen,  die  een  oproeping  tot  een  algemene  vergadering  van  aandeelhouders  hebben  gedaan,  waarin  een

voorstel tot het nemen van een besluit tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moeten tegelijkertijd met
de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van
de vennootschap neerleggen ter inzage van aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.

De aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging tot die van de algemene

vergadering van aandeelhouders een afschrift van het voorstel, zoals in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen.

Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.
22.3 Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door het bestuur tenzij de rechter

een andere vereffenaar of andere vereffenaars benoemt.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald door de vereffenaar, of de vereffenaars gezamenlijk,

te genieten.

22.4 Tijdens de vereffening blijven de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
22.5 Het overschot na vereffening wordt aan aandeelhouders en andere rechthebbenden in verhouding tot ieders

recht uitgekeerd.

22.6 Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende zeven

jaren blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering te benoemen.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale a constaté et accepté la démission de Messieurs Neil Mepham, Paul de Haan et Denis Bosje en

tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 26 juin 2008 et a décidé de nommer les personnes suivantes en tant
qu'administrateurs supplémentaires de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui
statuera sur les comptes annuels de l'année sociale prenant fin le 31 décembre 2008:

- Mme Margaretha Johanna Springintveld, expert comptable, née le 14 novembre 1967 à Aalsmeer, Pays-Bas, demeurant

au Jac.P. Thijsselaan 3, 1431 JH Aalsmeer, Pays-Bas;

- M. Michel Klaas Schoenmakers, administrateur délégué, né le 10 août 1960 à Voorburg, Pays-Bas, demeurant au

Kwaakhaven 8, 2341 NW Oegstgeest, Pays-Bas; et

- M. Nicolas Michael Perkins, directeur fiscalité internationale, né le 16 septembre 1969 à Bridgend, Royaume-Uni,

demeurant au Appartement 1, 46 Islington Park Street, Londres N1 1PX, Royaume-Uni.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée  générale  a  constaté  et  accepté  la  démission  de  Madame  Valérie  Fisson  en  tant  que  commissaire  aux

comptes de la Société avec effet au 26 juin 2008.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison du transfert du siège social du Grand Duché de Luxembourg vers les Pays-Bas, sont évalués à € 3.500,-.

Aucun point ne restant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé en

langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. Bosje, M. Gadzhalova, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 juin 2008. Relation: EAC/2008/8522. — Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): Nathalie BOICA.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

79850

Esch-sur-Alzette, le 30 juin 2008.

BLANCHE MOUTRIER.

Référence de publication: 2008081281/260/1378.
(080095448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Ameriforge International, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 128.187.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 30 mai 2008 que Mr Charles A. ARMBRUST

a démissionné de son mandat de gérant A de la Société en date du 31 janvier 2008 et que Mr David V. HEMINGER, né
le 8 novembre 1947 à Midland (Michigan), USA et ayant son adresse professionnelle au 13770 Industrial Road, 77015
Houston (Texas), USA, a été nommé en qualité de gérant A de la Société pour une durée illimitée et avec effet au 31
janvier 2008.

A compter du 31 janvier 2008, le conseil de gérance de la Société est donc composé de:
- David V. HEMINGER, gérant A, et
- Catherine KOCH, gérant B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2008.

<i>POUR AMERIFORGE INTERNATIONAL
MERCURIA SERVICES S.A.
8-10, rue Mathias Hardt, B.P. 3023, L-1030 Luxembourg
<i>Mandataire
Signature

Référence de publication: 2008078253/1005/26.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06967. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.

Imvo S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 61.121.

Constituée par-devant M 

e

 Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage (Grand-Duché de Luxembourg), en date du

30 septembre 1997, acte publié au Mémorial C n° 25 du 13 janvier 1998. Le capital a été converti en EUROS suivant
acte sous seing privé, en date du 12 avril 2001, dont l'extrait a été publié au Mémorial C n° 1044 du 21 novembre
2001.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IMVO S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008077357/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04207. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Waterland Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 114.976.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

79851

Richard Brekelmans
<i>Manager

Référence de publication: 2008077411/751/13.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04809. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Letalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 73.837.

<i>Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 23 Mai 2008

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Letalux S.A., il a été décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Monsieur Edsel Doran en tant qu'Administrateur de la Société, avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Joannes Baptista Antonius Theodorus Alfonsus Brekelmans, ayant son adresse professionnelle

au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant qu'Administrateur avec effet immédiat;

En conséquence des présentes et précédentes résolutions et assemblées:
Le Conseil d'Administration est composé de:
Monsieur Reinier Teixeira
Monsieur Joannes Baptista Antonius Theodorus Alfonsus Brekelmans
Monsieur Jochem van Rijn
Leur mandat expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

Luxembourg, le 23 Mai 2008.

Reinier Teixeira / Jochem van Rijn
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008077431/710/23.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03541. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

SOCFINAL, Société Financière Luxembourgeoise, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 5.937.

Le bilan consolidé au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008077413/1214/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05869. - Reçu 120,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

INVISTA Technologies S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 42.952.550,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 67.098.

In the year two thousand and eight, on the twenty-nine of April.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

KoSa Foreign Investments S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of the

Grand  Duchy  of  Luxembourg,  having  its  registered  office  at  23,  Val  Fleuri,  L-1526  Luxembourg,  registered  with  the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 100.563,

here represented by Mr Olivier Ferres, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of a proxy given on April 22nd, 2008.

79852

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of "INVISTA Technologies S.à r.l.", a private limited liability company,

incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 23, Val Fleuri,
L-1526 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 67.098, incorpo-
rated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, of
November 16th, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 48 of January 27th,
1999, and which bylaws have been last amended pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary in
Luxembourg, of January 3rd, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 684 of
April 4th, 2006.

II. The Company's share capital is fixed at forty-two million nine hundred fifty-two thousand five hundred and fifty

United States Dollars (USD 42,952,550.-) represented by eight hundred fifty-nine thousand and fifty-one (859,051) shares
of fifty United States Dollars (USD 50.-) each.

III. The shareholders resolve to amend article 8 third paragraph of the articles of association of the Company, which

shall henceforth read as follows:

"The Company may indemnify and advance expenses to any director, officer, or employee of the Company who was

or is a party, or threatened to be made a party, to any threatened, pending, or completed action, suit, or proceeding,
whether civil, criminal, administrative, or investigative, by reason of the fact that such person is or was a director, officer,
or employee of the Company, or is or was serving at the request of the Company as a director, officer, or employee of
any other entity, to the fullest extent permitted by applicable law."

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately at one thousand Euro (€ 1,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarized deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-neuf avril.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

KoSa Foreign Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 100.563,

ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg,

en vertu d'une procuration donnée le 22 avril 2008.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée "INVISTA Technologies S.à r.l." une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, et enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.098, constituée suivant
acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, reçu en date du 16 novembre 1998, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 48 du 27 janvier 1999, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, reçu en date du 3 janvier
2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 684 du 4 avril 2006.

II. Le capital social de la Société est fixé à quarante-deux millions neuf cent cinquante-deux mille cinq cent cinquante

Dollars Américains (USD 42.952.550,-) représenté par huit cent cinquante-neuf mille cinquante et une (859.051) parts
sociales de cinquante Dollars Américains (USD 50,-) chacune.

79853

III. L'associé unique décide de modifier le troisième paragraphe de l'Article 8 des statuts de la Société pour lui donner

désormais la teneur suivante:

"La Société peut indemniser et avancer les frais à tout gérant, agent ou employé de la Société qui a été ou est partie,

ou est menacée d'être partie, dans toute action, en cours ou aboutie, toute poursuite ou procédure, civile, criminelle,
administrative ou enquête, en raison du fait que cette personne est ou était un gérant, un agent, ou un employé de la
Société, ou qu'elle est ou était à la demande de la Société, gérant, agent ou employé de n'importe quelle autre entité,
dans les limites autorisés par la loi en vigueur."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille Euro (€ 1.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom et prénom, état

et demeure, il a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: O. FERRES, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 07 mai 2008. Relation: LAC/2008/18505. - Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 21 MAI 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008080167/211/96.
(080091300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2008.

Socfinasia S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 10.534.

Le bilan consolidé au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008077415/1214/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05856. - Reçu 112,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Socfinasia S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 10.534.

Le bilan (comptes sociaux) au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008077416/1214/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05852. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

79854

Intercultures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 6.225.

Le bilan consolidé au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008077417/1214/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05846. - Reçu 120,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080087780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Fireblade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 124.618.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 6 juin 2008 que:
- Madame Myriam FRANCQ a été révoquée avec effet immédiat de son mandat d'administrateur
- En remplacement de l'administrateur révoqué, l'assemblée nomme avec effet immédiat:
Monsieur Carsten SÖNS, juriste, né le 16/11/1975 à Düsseldorf (D), domicilié professionnellement au 196, rue de

Beggen à L-1220 Luxembourg; son mandat s'achèvera avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire prévue en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008078245/607/18.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04503. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.

Intercultures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 6.225.

Le bilan (comptes sociaux) au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juin 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008077418/1214/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05788. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Sealed Air Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 89.671.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2007 de Sealed Air Corporation, société mère de 'Sealed Air Luxembourg

S.C.A.' ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008077419/5564/13.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06653. - Reçu 46,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

79855

Luxconnect S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 120.379.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2008

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Paul SCHUH, fonctionnaire d'Etat, demeurant 17, rue de la Toison

d'Or, L-2265 LUXEMBOURG, de ses fonctions d'administrateur et appelle en remplacement Monsieur Edouard WAN-
GEN, directeur, demeurant 48, rue d'Olingen, L-6914 ROODT-SUR-SYRE.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2010.
L'assemblée accepte la démission de Fiduciaire GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18A, boulevard de la Foire,

L-1528 LUXEMBOURG, de ses fonctions de commissaire aux comptes.

L'assemblée décide de nommer comme réviseur d'entreprises PKF ABAX AUDIT, société à responsabilité limitée,

ayant son siège social au 7, rue Thomas Edison, L-1445 LUXEMBOURG-STRASSEN.

Le mandat du réviseur d'entreprises viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes de l'exercice 2008.

<i>Extrait du rapport du conseil d'administration du 30 mai 2008

Monsieur Edouard WANGEN, directeur, demeurant 48, rue d'Olingen, L-6914 ROODT-SUR-SYRE, est nommé ad-

ministrateur-délégué pour une période venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l'exercice 2010.

Monsieur Thomas ENGEL, professeur à l'Université du Luxembourg, demeurant Rubenstrasse 3, D-54294 TRIER, est

élu à l'unanimité Président du Conseil d'Administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008077464/506/29.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06747. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Sealed Air Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 89.671.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008077420/5564/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06655. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Sealed Air Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 89.341.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2007 de Sealed Air Corporation, société mère de 'Sealed Air Luxembourg

S.à r.l.' ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008077421/5564/13.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06659. - Reçu 46,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

79856

Luxsa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 61.501.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2008

L'assemblée  accepte  la  démission  de  Monsieur  Jürg  BAUMANN,  demeurant  28,  Sagenstrasse,  FL-9492  ESCHEN

(Liechstenstein), de Madame Thérèse SCHMITTER, demeurant 27, Schützenweg, FL-9470 BUCHS (Liechstenstein) et de
Monsieur Rolf SCHMID, demeurant 49, Im Rossfeld, FL-9494 SCHAAN (Liechstenstein), de leurs fonctions d'adminis-
trateurs.

L'assemblée appelle en remplacement:
- Monsieur Marc KOEUNE, économiste, avec adresse professionnelle au 18, rue de l'Eau, L-1449 LUXEMBOURG
- Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, avec adresse professionnelle au 18, rue de l'Eau, L-1449 LUXEMBOURG
- Monsieur Sébastien GRAVIERE, juriste, avec adresse professionnelle au 18, rue de l'Eau, L-1449 LUXEMBOURG
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, avec adresse professionnelle au 18, rue de l'Eau, L-1449 LUXEM-

BOURG

L'assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au

18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG et appelle en remplacement CeDerLux-Services S.à r.l., ayant son
siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 LUXEMBOURG.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2012.

Le siège social est transféré au 18, rue de l'Eau, L-1449 LUXEMBOURG, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008077904/506/29.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06739. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Sealed Air Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 89.341.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008077422/5564/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06661. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Sealed Air Luxembourg (I) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 89.318.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2007 de Sealed Air Corporation, société mère de 'Sealed Air Luxembourg

S.à r.l.' ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008077423/5564/13.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06665. - Reçu 46,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

79857

AKT Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 198.690,98.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 138.485.

Il résulte du transfert de parts sociales en date du 19 mai 2008 que AKT Holdings Limited, ayant son siège social à

Paget-Brown Trust Company Ltd, Boundary Hall, Cricket Square, PO Box 1111, Grand Cayman KY1-1102, Iles Caïmans,
a transféré à Investcorp Private Equity 2007 Fund AIV I, L.P., ayant son siège social à Paget-Brown Trust Company Ltd,
Boundary Hall, Cricket Square, PO Box 1111, Grand Cayman KY1-1102, Iles Caïmans, enregistrée auprès du Registre de
Commerce des Iles Caïmans sous le numéro 26031, les parts sociales suivantes:

- 82.635 parts sociales ordinaires de classe A;
- 82.635 parts sociales ordinaires de classe B;
- 82.635 parts sociales ordinaires de classe C;
- 82.636 parts sociales ordinaires de classe D;
- 82.636 parts sociales ordinaires de classe E;
- 82.636 parts sociales ordinaires de classe F;
- 82.636 parts sociales ordinaires de classe G;
- 82.636 parts sociales ordinaires de classe H; et
- 3.503.114 parts sociales privilégiées de classe B.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008078145/631/29.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05894. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.

Sealed Air Luxembourg (I) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 89.318.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008077424/5564/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06670. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Sealed Air Luxembourg (II) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 89.319.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2007 de Sealed Air Corporation, société mère de 'Sealed Air Luxembourg

(II) S.à r.l.' ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008077425/5564/13.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06674. - Reçu 46,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

79858

Castell Concept, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 75.925.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration du 12 février 2007 a résolu de nommer Wolf Christian Massner (Prinzregentenufer 7,

D-90489 Nurenberg) et Benoît Paquay (3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) à la fonction de dirigeants, délégués à
la gestion journalière de la société.

Le Conseil d'Administration du 2 août 2007 a résolu de mettre au fin aux mandats de délégués à la gestion journalière

de messieurs George-Marios Prantzos et Jerry Hilger avec effet au 13 février 2007.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg, le 20 novembre 2007 a adopté les

résolutions suivantes:

1. L'assemblée a approuvé la réélection de:
Jacques De Saussure (60 route des Acacias, CH-1211 Genève 73),
Ferdinand Graf Castell-Castell (7, Prinzregentenufer, D-90489 Nurenberg),
Jerry Hilger (1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg)
Ulrich Treppner (7, Prinzregentenufer, D-90489 Nurenberg)
à la fonction d'administrateur pour une période d'un an se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle

ou se terminant le jour où leurs successeurs seront nommés.

2. L'Assemblée a approuvé la ré-élection des réviseurs, Deloitte S.A., pour la période d'un an se terminant lors de la

prochaine assemblée générale annuelle ou se terminant le jour où leurs successeurs seront nommés.

<i>Pour Castell Concept
Pictet Funds (Europe) S.A
Signatures

Référence de publication: 2008078217/52/29.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR06048. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.

Sealed Air Luxembourg (II) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 89.319.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008077426/5564/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06678. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Cosima Purchase No. 6 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 116.817.

Le bilan abrégé du 29 mai 2006 au 31 mars 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008077428/8548/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02406. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

79859

Letalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 73.837.

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 23 Mai, 2008

Au conseil d'Administration de Letalux S.A. ("la société"), il a été décidé comme suit:
- De déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à

Mr Joannes Baptista Antonius Theodorus Alfonsus Brekelmans ayant son adresse professionnelle au 2-8, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, et ce avec effet immédiat, jusqu'à l'Assemblée de 2011.

Luxembourg, le 23 Mai 2008.

Reinier Teixeira de Maltos / Jochem van Rijn
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008077432/710/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03546. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080087816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Linston S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 59.773.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008077586/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03888. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Ipotek Financing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 122.469.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 25 mai 2007 au siège social de la société, il a été décidé:

- De nommer comme nouveaux administrateurs de catégorie A, avec effet au 12 mars 2007

* Monsieur Sergio BERTASI, employé privé, né le 26 octobre 1958 à Padova en Italie, résident professionnellement au

19/21, boulevard du Prince Henri;

* Monsieur Simon BODJANSKI, employé privé, né le 20 juillet 1977 à Gniezno en Pologne, résident professionnelle-

ment au 19/21, boulevard du Prince Henri;

* Monsieur Francesco MOGLIA, employé privé, né le 27 mai 1968 à Rome en Italie, résident professionnellement au

19/21, boulevard du Prince Henri.

leur mandat ayant comme échéance l'assemblée générale annuelle de 2012.

- De préciser que le premier exercice social commençant le 27 novembre 2006 se terminera le 31 décembre 2007,

et non le 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IPOTEK FINANCING S.A.
Société Européenne de Banque Banque
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008077436/24/25.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05960. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

79860

Comont S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 57.552.

<i>Extrait des résolutions prises au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 avril 2008

1) Les démissions des administrateurs Madame Antonella GRAZIANO et de Monsieur Jean Robert BARTOLINI, tous

deux résidants professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont acceptées avec effet à la date de
la présente assemblée.

2) La démission de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, avec siège social au 26, rue Louvigny, L-1946

Luxembourg de son mandat de Commissaire aux Comptes, est acceptée avec effet à la date de la présente assemblée.

3) Monsieur John MILLS, Directeur, né le 28/02/1969 à Cape Town (Afrique du sud), demeurant professionnellement

au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg et Monsieur Jean Claude PICK, dirigeant d'entreprise, né le 04/06/1930
à Boulogne Billancourt (France), demeurant au 26, Chemin de Bellevue, CH-1005 Lausanne, sont nommés nouveaux
Administrateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

4) La société Crown Corporate Services S. à r.l. société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 25A, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, est nommée nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat viendra à échéance lors de
l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

5) Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 66, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg.

Le 14 avril 2008.

Certifié sincère et conforme
<i>COMONT S.A.
John MILLS / Jean Claude PICK
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008078523/795/29.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2008, réf. LSO-CQ08492. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.

Marcell LuxCo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.515.660,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 121.635.

<i>Extrait de la résolution prise par 'l'associé unique de la Société en date du 10 juin 2008

En date du 10 juin 2008, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Monsieur Daniel Harris WEINTRAUB, né le 16 août 1970 à Massachusetts, Etats-Unis, ayant comme

adresse professionnelle: 101, Huntington Avenue, MA 02199 Boston, Etats-Unis, en tant que nouveau gérant de Classe
A de la Société avec effet au 16 juin 2008 et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le Conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
- Monsieur Olivier C EWALD, gérant de Classe A
- Monsieur Young Jin LEE, gérant de Classe A
- Monsieur Daniel Harris WEINTRAUB, gérant de Classe A
- Domels S.à r.l., gérant de Classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2008.

<i>MARCELL LUXCO II S.A R.L.
Par procuration
Signature

Référence de publication: 2008077441/250/25.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05879. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

79861

Coven S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.923.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 4 juin 2008

Résolutions:
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2008 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

MM. Jonathan Lepage, employé privé, né le 27.08.1975 à Namur (Belgique), demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur et président;
Sergio Bertasi, employé privé, né le 26.10.1958 à Padova (Italie), demeurant professionnellement à Luxembourg,
19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg administrateur;
Sébastien Schaack, employé privé, né le 22.07.1978 à Thionville (France), demeurant professionnellement à Lu-
xembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg administrateur;

Mme Sandrine Cecala, née le 28.05.1977 à Villerupt (France), employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008078911/24/29.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07745. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Les Résidences d'Howald, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.

R.C.S. Luxembourg B 135.669.

<i>Extrait d'une résolution de la gérance

En date du 22 décembre 2007, Monsieur Louis-Marie Piron
agissant en sa qualité de gérant de la société "Les Résidences d'Howald"
ci-après dénommée la «Société»
déclare accepter au nom de la Société, conformément à l'article 1690 du code civil, la cession de 200 parts sociales

de la Société par Monsieur Louis-Marie Piron

à la société Les Résidences SA, avec siège social à 2, rue Marie Curie, L-8049 Strassen, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B35.243

Les 200 parts sociales, représentant 100% du capital social de la Société sont donc la propriété de la société Les

Résidences SA.

Louis-Marie Piron
<i>Le Gérant

Référence de publication: 2008077555/202/21.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2008, réf. LSO-CP08086. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

79862

Biomet Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.502,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 134.391.

Les associés de la Société ont décidé en date du 3 juin 2008 de nommer Monsieur Renaat Vermeulen, né le 6 octobre

1956 à St-Niklaas, Belgique, et résidant au Cadzandstraat 10, 9112 Sinaai, Belgique, gérant A de la Société avec effet au 3
juin 2008 et pour une durée illimitée.

En conséquence de ce qui précède le conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- Monsieur Paulus Stephanus Alexander Renaud, gérant B;

- Monsieur Roger Van Broeck, gérant A; et

- Monsieur Renaat Vermeulen, gérant A.

Pour extrait conforme
Biomet Holdings Luxembourg S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008077561/5499/21.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06500. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Jewel Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Château de Puycharnaud S. à r. l.).

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 113.222.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 51500 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008078154/211/12.

(080089372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.

AOL Participations II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.789.450,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 72.729.

L'associé unique de la Société a décidé de révoquer le mandat de gérant de Monsieur Roderick Day avec effet au 16

mai 2008.

L'associé a en outre nommé:

- Monsieur Michael James Roark, né en Californie, USA le 27 mars 1968, et résidant au Flat 13 Hill View, 2-4 Primrose

Hill Road, London, UK, comme gérant de la Société avec effet au 16 mai 2008 et pour une durée illimitée.

En conséquence de quoi, le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Rick Minor, gérant;

- Monsieur Michael James Roark, gérant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

79863

Pour extrait
AOL Participations II S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008077562/5499/23.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06499. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Five Stars S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 109.907.

<i>Mention rectificative du dépôt du 24 janvier 2008 (No L080013416)

Le bilan modifié au 31.12.2006, les comptes annuels au 31.12.2006 régulièrement approuvés, le rapport de la personne

chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats de l'exercice 2006 ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008077583/24/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05966. - Reçu 42,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Particorp S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 39.078.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S G A SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signature

Référence de publication: 2008077592/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03794. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Zweiter International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 80.717.

<i>Mention rectificative du dépôt du 28 janvier 2008 (No L080014952)

Le bilan modifié au 31.12.2006, les comptes annuels au 31.12.2006 régulièrement approuvés, le rapport de la personne

chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats de l'exercice 2006 ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

79864

Société Européenne de Banque S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008077584/24/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR06014. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Sorg Finances S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 42.805.

Le bilan au 30.11.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008077611/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR00788. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

BS Real Estate (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 125.870.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 20 mars 2008 au siège social

- L'assemblée prend note de la démission de Mr. Thijs Van Ingen du conseil de gérance de la société avec effet au 20

mars 2008.

- L'assemblée décide de ne pas remplacer Mr. Thijs Van Ingen et décide de réduire le nombre de gérants de la société

de cinq (5) a quatre (4).

La composition du conseil de gérance est désormais la suivante:

MM. Edmond De Forest, gérant;

Lorenzo Patrassi, gérant;
Tomas Lichy, gérant;
Iain Macleod, gérant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BS Real Estate (Lux) S.ar.l.
Lorenzo Patrassi
<i>Mandaté à cet effet

Référence de publication: 2008078124/9063/24.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05192. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.

Mode Finance S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 52.458.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

79865

N. SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008077612/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03892. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Midelbe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 110.283.

Le bilan au 31.08.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008077613/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03890. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080087909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Steel Partner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4747 Pétange, 35, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 46.204.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 23 avril 2008 que:
- M. Alain ROB, administrateur-délégué de la société, demeurant 10, boucle des Lièvres à F-57100 Thionville (France)

a été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur de la société, soit
jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2012.

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 21 mai 2008

que:

- la démission de Monsieur Jean-Marc FABER de ses fonctions de Commissaire aux Comptes a été acceptée;
- Monsieur Denis BOUR, né le 19 août 1961 à Metz (France), demeurant professionnellement au 2, rue Wilson, L-2732

Luxembourg a été nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la société. Son mandat prendra fin à l'issue de
l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2012.

- la démission de Madame Jacqueline ZIMMERMANN de ses fonctions d'Administrateur a été acceptée;
- Monsieur Nicolas ROB, né le 14 mai 1984 à Mont-Saint-Martin (France), demeurant 10, boucle des Lièvres à F-57100

Thionville a été nommé aux fonctions d'Administrateur de la société pour un mandat qui prendra fin à l'issue de l'As-
semblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2012.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008078182/717/28.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR01035. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.

La Financière Montbrillant S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 78.857.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

79866

N. SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008077614/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03887. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Heliopolis S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 38.063.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008077615/1023/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03886. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080087916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Alma Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 118.901.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 02 juin 2008 et d'une résolution du conseil d'adminis-

tration du même jour que:

1°) la démission de Monsieur Eric Tardy de ses fonctions d'Administrateur a été acceptée avec effet au 2 avril 2008.
2°) les mandats des organes suivants de la société ont été renouvelés pour une durée de 3 ans.
- Monsieur Jean Arvis - Administrateur;
- Monsieur Henri Vernhes- Administrateur;
- Monsieur Andreas Lehmann - Administrateur
3°) Administrateur délégué: Monsieur Jean Arvis, Bab el Hana Rue Ifrane Marakech, Maroc, a été nommé au poste

d'Administrateur Délégué pour une durée de 3 ans.

4°)  La  société  CLERC  S.A,  1,  rue  Pletzer  L-8080  Bertrange,  a  été  nommée  commissaire  aux  comptes,  avec  effet

immédiat, pour une durée de 3 ans, en remplacement de MRM CONSULTING S.A dont le mandat n'a pas été renouvelé.

Tous les mandats susvisés prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra

en 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ALMA EUROPE
AGIR Luxembourg S.A
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008078240/6102/28.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02757. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.

Lubelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 21, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 106.578.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

79867

<i>Pour LUBELUX S.A
Signature

Référence de publication: 2008077624/278/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR06376. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

OCM / Nordenia POF Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 114.638.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008077628/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05964. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080088264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

I.E. Lux Berlin n° 1 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.500.000,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 106.754.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique prises en date du 28 mars 2008

1. La démission de Monsieur Massimo Morlotti a été acceptée avec effet au 28 mars 2008.
2. Monsieur Massimiliano Maffioli, gérant, né le 1 

er

 mars 1973 à Varese en Italie, avec adresse professionnelle au Piazza

Missori 2, Milan, I-20122 Italie, a été nommé gérant de la Société, en remplacement de Monsieur Massimo Morlotti, jusqu'à
l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se tiendra en 2009. Sa nomination prend avec effet au 28 mars
2008.

3. Monsieur Jean-Louis Camuzat, gérant, né le 1 

er

 septembre 1963 à Fontenay aux Roses en France, avec adresse

professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société, jusqu'à l'issue de la prochaine
assemblée générale ordinaire, qui se tiendra en 2009. Sa nomination prend effet au 28 mars 2008.

Le conseil de gérance est dorénavant composé comme suit:
- Massimiliano Maffioli (Gérant)
- Brian Anthony McMahon (Gérant)
- Jean-Louis Camuzat (Gérant)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008078301/1649/27.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05747. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2008.

OCM Luxembourg OPPS Meats Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 15, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 118.210.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

79868

Luxembourg, le 18 juin 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008077629/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05968. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

OCM Luxembourg POF IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 121.748.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008077630/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05972. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Tramade S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2181 Luxembourg, 4-6, rue G. C. Marschall.

R.C.S. Luxembourg B 57.419.

<i>Extrait de l'assemblée générale du 22 mai 2002 statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001

Les associés de la société à responsabilité limitée TRAMADE S.à r.l. ayant son siège social à L-2181 Luxembourg, 4-6,

rue Marshall (RCS Luxembourg N° B.57.419) ont décidé cinq résolutions lors de cette assemblée et dont la cinquième
qui fait l'objet d'un dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et la publication au Mémorial C, qui
a la teneur suivante:

L'Assemblée générale des associés décide de convertir le capital de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR)
Conformément à l'article 54bis/1 LIR du 26 août 1998, la société est autorisé d'augmenter le capital à concurrence de

4% des réserves. Par conséquent, l'assemblée générale des associés décide d'augmenter le capital social pour le porter
de son capital actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze et soixante-huit cents (12.394,68 EUR) à douze mille
cinq cents euros (12.500,- EUR) par incorporation des résultats reportés à concurrence d'un montant de cent cinq euros
et trente-deux cents (105,32 EUR), sans création de parts sociales nouvelles, et en portant la valeur nominale par actions
à cent vingt-cinq euros (125,- EUR).

Luxembourg, le 4 juin 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2008078942/206/26.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03658. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

OCM / Nordenia Luxembourg GP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 114.639.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

79869

Luxembourg, le 18 juin 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008077631/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05974. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

OCM Luxembourg POF III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 109.801.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008077632/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05978. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Lux-Confort S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 78.873.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 20.04.2007

Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:
Il a été constaté que les mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué sont venus à échéance et il a été

décidé de renouveler les mandats pour une durée de six années.

Le conseil d'administration se composera donc comme suit:
Madame Catherine SCHNEIDER-SOANNI, administrateur de sociétés, L-4985 Sanem, 3, rue des Pommiers (également

administrateur délégué);

Madame Caroline SCHNEIDER, administrateur de sociétés, L-4985 Sanem, 3, rue des Pommiers;
Monsieur Jean-Paul SCHNEIDER, administrateur de sociétés, L-4985 Sanem, 3, rue des Pommiers.
Le mandat de ARTEFACTO S.à r.l. comme commissaire n'est pas renouvelé. Sera désormais nouveau commissaire

aux comptes: la société SOFINTER GESTION S.à r.l. avec siège social à L-5365 Munsbach, 2, Parc d'activités Syrdall.

Tous les mandats expireront après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2013, statuant sur les comptes de l'exer-

cice 2012.

Bertrange, le 20 avril 2007.

Pour extrait conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Référence de publication: 2008079106/820/26.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2008, réf. LSO-CQ03990. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

OCM / Nordenia Opps Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 114.637.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

79870

Luxembourg, le 18 juin 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008077633/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05981. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

OCM Luxembourg Outdoor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 121.948.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008077634/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05984. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Top Granit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 29, Parc d'Activités Mamer-Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 94.565.

Par décision de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 05 mai 2008 ont été nommés, jusqu'à

l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31.12.2009:

- Monsieur Raimund LAMBERTZ demeurant 322, Brückenstrasse, D-54459 Wiltingen -Administrateur-Délégué et

Président du Conseil d'Administration, Administrateur

- Monsieur Marc HILGERT, demeurant 22a, rue de la gare, L-8471 Eischen, Administrateur-Délégué et administrateur,

responsable de la gestion administrative de la société

- Henri HILGERT, employé privé, 38, rue de Kopstal L-8291 Meispelt, Administrateur
- Marie-Josée KNEPPER, employée privée, 38, rue de Kopstal L-8291 Meispelt, Administrateur
- Mireille HILGERT, licenciée en communications appliquées, 7, rue Basse, L-8313 Capellen, Administrateur
- EURAUDIT Sàrl, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.
Monsieur Marc HILGERT pourra engager la société sous sa seule signature pour tout ce qui concerne la gestion

administrative.

En outre, Monsieur Raimund LAMBERTZ, demeurant 322, Brückenstrasse, D-54459 Wiltingen, est nommé gérant

technique de la société jusqu'à l'assemblée statuant sur les comptes clôturant au 31.12.2009 et pourra de ce fait engager
la société sous sa seule signature pour tout ce qui concerne la gestion technique.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008079125/504/26.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ06882. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080090159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

OCM Luxembourg Spirits Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 118.872.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

79871

Luxembourg, le 18 juin 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008077635/2460/14.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05987. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

OCM Luxembourg Ice Cream GP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 113.114.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2008.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008077636/2460/14.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05991. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

Delta Lloyd Privilege, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 96.850.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires du 18 avril 2008

En date du 18 avril 2008, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- De prendre acte de la démission de Monsieur Fernand Reiners, 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg depuis

le 15 octobre 2007;

- De renouveler les mandats d'administrateur de:

* Mr Peter KOK, 50, av. J.F. Kennedy, L-2351 Luxembourg

* Mr Japhet Pieter AARDOOM, 50, av. J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg

* Mr Alex OTTO, 50, av. J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg

* DELTA LLOYD BANK (représentée par Mr Geert CEUPPENS), 50, av. J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg

pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2009.

- De renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en tant que réviseur d'entreprise pour une période

d'un an venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de 2009.

Luxembourg, le 25 avril 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour DELTA LLOYD PRIVILEGE SICAV
Fortis Banque Luxembourg, Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2008079158/584/26.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05016. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080089645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

79872


Document Outline

AKT Investments S.à r.l.

Alma Europe

Ameriforge International

AOL Participations II S.à r.l.

Biomet Holdings Luxembourg S.à r.l.

BS Real Estate (Lux) S.à r.l.

Castell Concept

Château de Puycharnaud S. à r. l.

Comont S.A.

Cosima Purchase No. 6 S.A.

Coven S.A.

Delta Lloyd Privilege

Fireblade S.A.

Five Stars S.A.

Heliopolis S.A.

I.E. Lux Berlin n° 1 S. à r.l.

Imvo S.A.

Intercultures S.A.

Intercultures S.A.

INVISTA Technologies S.à.r.l.

Ipotek Financing S.A.

Jewel Holding S. à r.l.

La Financière Montbrillant S.A.

Les Résidences d'Howald

Letalux S.A.

Letalux S.A.

Linston S.P.F.

Lubelux S.A.

Lux-Confort S.A.

Luxconnect S.A.

Luxsa S.A.

Marcell LuxCo II S.à r.l.

Midelbe S.A.

Mode Finance S.A.

OCM Luxembourg Ice Cream GP S.A.

OCM Luxembourg OPPS Meats Holdings S.à r.l.

OCM Luxembourg Outdoor Holdings S.à r.l.

OCM Luxembourg POF III S.à r.l.

OCM Luxembourg POF IV S.à r.l.

OCM Luxembourg Spirits Holdings S.à r.l.

OCM / Nordenia Luxembourg GP S.A.

OCM / Nordenia Opps Luxembourg S.C.A.

OCM / Nordenia POF Luxembourg S.C.A.

Particorp S.A.

Sealed Air Luxembourg (II) S.à r.l.

Sealed Air Luxembourg (II) S.à r.l.

Sealed Air Luxembourg (I) S.à r.l.

Sealed Air Luxembourg (I) S.à r.l.

Sealed Air Luxembourg S.à r.l.

Sealed Air Luxembourg S.à r.l.

Sealed Air Luxembourg S.C.A.

Sealed Air Luxembourg S.C.A.

Socfinasia S.A.

Socfinasia S.A.

Société Financière Luxembourgeoise

Sorg Finances S.A.

Steel Partner S.A.

Top Granit S.A.

Tramade S.àr.l.

UPRN 1 SE

Waterland Lux II S.à r.l.

Zweiter International S.A.