logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1463

13 juin 2008

SOMMAIRE

Agria Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70200

Aliunde S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70223

Astringo Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

70199

ATEEL - Allied Technology Experts. Enter-

prise of Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

70204

Beauty Case, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70189

Bocimar Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70200

BVP II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70213

Capital Ventures (Australasia) Sàrl  . . . . . .

70178

Carspaze Services G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . .

70206

Carspaze Services GmbH & Co. KG  . . . . .

70208

Centre de Transferts Electroniques . . . . . .

70203

Commercial Real Estate Investments S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70199

CVI GVF Luxembourg Seven S.à r.l.  . . . . .

70179

CVI GVF Luxembourg Six S.à r.l.  . . . . . . . .

70179

Degussa Re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70223

Entreprise Applications and services Inte-

gration Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70223

Europay Luxembourg, Société coopérative

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70203

Imbrex Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70200

Info-Logement a.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70178

ITW Alpha Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70178

Logica General Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . .

70201

Logica Holdings Luxfive S.à r.l.  . . . . . . . . . .

70198

Logica Holdings Luxfour S.à r.l.  . . . . . . . . .

70202

Logica Holdings Luxthree S.à r.l.  . . . . . . . .

70203

Logica Holdings Luxtwo S.à r.l.  . . . . . . . . . .

70202

Macquarie Luxembourg Gas S. à r.l.  . . . . .

70213

MEIF Germany Eight S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . .

70189

Nordica Administration S.à r.l.  . . . . . . . . . .

70222

Novo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70201

NTR Finance Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . .

70222

NTR Treasury Luxembourg S.à r.l.  . . . . . .

70222

PPG Luxembourg Finance S.àr.l.  . . . . . . . .

70201

QLux Aviation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70214

Randstad Holding Luxembourg S.à r.l.  . . .

70182

Sàrl Wilmes & Söhne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70182

Savizor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70222

Sodema S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70189

Stodiek Beteiligung II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

70179

Stryker Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

70179

Sword Technologies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

70224

The Swatch Group Re (Luxembourg) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70224

WPP Luxembourg Holdings S.àr.l.  . . . . . .

70223

ZBI SCAIAP Opportunity Real Estate Fund

One S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70213

Zurich Finance (Luxembourg) S.A.  . . . . . .

70224

Zurich Group Funding Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70224

70177

Capital Ventures (Australasia) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 87.722.

EXTRAIT

Il résulte d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 30 avril 2007 que l'associé unique ITW Participations S.à r.l. a

changé d'adresse. La nouvelle adresse est: 7, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2008.

Maurits De Smedt
<i>Gérant

Référence de publication: 2008066161/6679/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06055. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080074159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

ITW Alpha Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 103.881.

EXTRAIT

Il résulte d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 30 avril 2007 que l'associé unique ITW Participations S.à r.l. a

changé d'adresse. La nouvelle adresse est: 7, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2008.

Maurits De Smedt
<i>Gérant

Référence de publication: 2008066162/6679/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06058. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

Info-Logement a.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 6, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg F 3.366.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la INFO-LOGEMENT a.s.b.l. tenue le 7 avril 2008

que:

1) Après discussion, l'assemblée générale a décidé, à l'unanimité de ses membres, de prononcer la dissolution de

l'association.

2) Concernant l'affectation des biens de l'association, l'assemblée a décidé, conformément à l'article 14 des statuts, de

virer - après acquittement du passif - l'excédent éventuel à la Trésorerie de l'Etat.

Luxembourg, le 15 mai 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour l'association
Constant KIFFER / Eliane SALVESTRIN
<i>Président du conseil d'administration / Trésorière du conseil d'administration

Référence de publication: 2008066495/9022/22.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06616. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

70178

CVI GVF Luxembourg Seven S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 130.767.

<i>Extrait de la résolution prise par les gérants de la Société, datée du 15 mai 2008

Les gérants de la Société ont décidé en date du 15 mai 2008, de transférer le siège de la Société du 25B, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 15 mai 2008.

Luxembourg, le 15 mai 2008.

Hille-Paul Schut.

Référence de publication: 2008066480/710/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2008, réf. LSO-CQ04481. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080073671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

CVI GVF Luxembourg Six S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 130.765.

<i>Extrait de la résolution prise par les gérants de la Société, datée du 15 mai 2008

Les gérants de la Société ont décidé en date du 15 mai 2008, de transférer le siège de la Société du 25B, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 15 mai 2008.

Luxembourg, le 15 mai 2008.

Hille-Paul Schut.

Référence de publication: 2008066481/710/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2008, réf. LSO-CQ04480. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080073670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

Stryker Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 109.153.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour STRYKER LUXEMBOURG S.à R.L.
Services Généraux de Gestion S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008066936/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05959. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Stodiek Beteiligung II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 113.384.

In the year two thousand and eight, on the ninth of May.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

The private limited company (société à responsabilité limitée) STODIEK BETEILIGUNG I S.à r.l., R.C.S. Luxembourg

section B number 113244, with its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

70179

represented by Mr Paul MARX, docteur en droit, residing professionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said power of attorney, after having been signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state that:
I. the private limited company (société à responsabilité limitée) STODIEK BETEILIGUNG I S.à r.l., prenamed, repre-

sented by Mr. Paul MARX, prenamed, is the sole member of the private limited company STODIEK BETEILIGUNG II S.à
r.l., R.C.S.  Luxembourg  section B  number  113384, having  its  registered office  at L-1331 Luxembourg,  65,  boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, hereinafter referred to as "the Company", constituted by a deed of the undersigned notary
on December 15, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 726 of April 10, 2006,
and whose articles of association have been amended by a deed of the undersigned notary on December 6, 2007, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 334 of February 8, 2008;

II. the subscribed capital is fixed at forty nine million three hundred twenty five thousand and six hundred EURO (EUR

49,325,600.-) represented by one million nine hundred seventy three thousand and twenty four (1,973,024) sharequotas
of twenty-five Euro (25.- EUR) each, which are all held by the sole member, the private limited company (société à
responsabilité limitée) STODIEK BETEILIGUNGI S.à r.l., prenamed;

III. the private limited company (société à responsabilité limitée) STODIEK BETEILIGUNG I S.à r.l., prenamed, in its

capacity of sole member of the company STODIEK BETEILIGUNG II S.à r.l., represented as here above stated, then has
taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole member resolves to decrease the corporate capital by an amount of fourteen million and six hundred thousand

EURO (EUR 14,600,000.-) so as to reduce it from its present amount of forty nine million three hundred twenty five
thousand and six hundred EURO (EUR 49,325,600.-) to thirty four million seven hundred twenty five thousand and six
hundred EURO (EUR 34,725,600.-), by the cancellation of five hundred and eighty four thousand (584,000) sharequotas
with a nominal value of twenty five EURO (EUR 25.-) each, and by the repayment of fourteen million and six hundred
thousand EURO (EUR 14,600,000.-) to the sole member in accordance with the legal requirements and especially with
article 69 of the amended law of August 10,1915 on commercial companies.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, article six of the articles of association is amended as follows:

Art. 6. The corporate capital is set at thirty four million seven hundred twenty five thousand and six hundred EURO

(EUR 34,725,600.-) represented by one million three hundred eighty nine thousand and twenty four (1,389,024) share-
quotas of twenty-five EURO (25.- EUR) each.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the

amended law of August 10, 1915 on commercial companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as
well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the
general shareholders' meeting are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at one thousand eight hundred EURO.

The undersigned notary who knows English and German, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the German text, the English text will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the attorney, who is known to the notary by his surname, first name, civil status

and residence, the said person signed together with notary this original deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendacht, am neunten Mai.
Vor Maître Jean SECKLER, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung STODIEK BETEILIGUNG I S.à r.l., H.G.R. Luxemburg Sektion B Nummer

113244, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

vertreten durch Herrn Paul MARX, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht.

70180

Diese Vollmacht wird nach „ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar

dieser Urkunde beigelegt werden, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie vorher erwähnt, hat den unterzeichneten Notar zu beurkunden beauftragt, dass:
I. die Gesellschaft mit beschränkter Haftung STODIEK BETEILIGUNG I S.à r.l., vorbenannt, vertreten durch Herrn

Paul MARX, vorbenannt, die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung STODIEK BETEILI-
GUNG II S.à r.l. ist, H.G.R. Luxemburg Sektion B Nummer 113384, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, nachstehend die "Gesellschaft" genannt, gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars am
15. Dezember 2005, welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 726 vom 10. April 2006
veröffentlicht ist, und deren Satzung gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars am 6. Dezember 2007 abgeändert
worden ist, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 334 vom 8. Februar 2008;

II. das gezeichnete Kapital der Gesellschaft auf neunundvierzig Millionen dreihundertfunfundzwanzigtausendsechshun-

dert EURO (EUR 49.325.600,-) festgesetzt ist, eingeteilt in eine Millionen neunhundert-dreiundsiebzigtausendvierund-
zwanzig (1.973.024) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), welche vollständig durch die alleinige Gesellschafterin,
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung STODIEK BETEILIGUNG I S.à r.l., vorbenannt, gehalten werden;

III. die Gesellschaft mit beschränkter Haftung STODIEK BETEILIGUNG I S.à r.l., vorbenannt, in ihrer Eigenschaft als

alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft STODIEK BETEILIGUNG II S.à r.l., vertreten wie vorher erwähnt, folgende
Beschlüsse gefasst hat:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst das Gesellschaftskapital um vierzehn Millionen sechshunderttausend EURO

(EUR 14.600.000,-) von seinem jetzigen Betrag von neunundvierzig Millionen dreihundertfünfundzwanzigtausendsechs-
hundert  EURO  (EUR  49.325.600,-)  auf  vierunddreissig  Millionen  siebenhundertfunfundzwanzig-tausendsechshundert
EURO (EUR 34.725.600,-) herabzusetzen, durch die Annullierung von funfhundertvierundachtzigtausend (584.000) An-
teilen mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig EURO (EUR 25,-) und durch Rückzahlung von vierzehn Millionen
sechshunderttausend EURO (EUR 14.600.000,-) an die alleinige Gesellschafterin gemäss den gesetzlichen Bestimmungen
und insbesondere gemäss Artikel 69 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

<i>Zweiter Beschluss

Als Folge des ersten Beschlusses wird Artikel sechs der Satzung wie folgt geändert:

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf vierunddreissig Millionen siebenhundertfünfundzwanzigtausendsechshundert

EURO (EUR 34.725.600,-) festgesetzt, dargestellt durch eine Million dreihundertneunundachtzigtausendvierundzwanzig
(1.389.024) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, dann sind, unter anderen, die Artikel 200-1 und 200-2

des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften anzuwenden, d.h. dass jeder Beschluss
des alleinigen Gesellschafters sowie jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft schriftlich festgehalten werden muss
und dass die

Bestimmungen über die Generalversammlungen der Teilhaber nicht anwendbar sind.
Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre eigenen Anteile zu erwerben unter der Bedingung, dass sie annulliert werden und

das Kapital verhältnismässig herabgesetzt wird."

<i>Kostenabschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Honorare und Lasten, welche von der Gesellschaft zu tragen sind auf Grund dieser Urkunde

wird auf eintausendachthundert EURO geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische und die deutsche Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Antrag

der erschienenen Partei diese Urkunde in Englisch verfasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass
im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text der englische Text Vorrang hat.

WORÜBER URKUNDE, in Luxemburg erstellt worden ist, am Tag wie anfangs erwähnt.
Und nachdem diese Urkunde dem Bevollmächtigten, welcher dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnsitz

bekannt ist, vorgelesen worden ist, hat dieser zusammen mit dem Notar die Originalurkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: MARX; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 Mai 2008 Relation GRE/2008/2127. — Reçu douze euros 12 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Junglinster, den 22. Mai 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008068667/231/119.
(080077141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2008.

70181

Sàrl Wilmes &amp; Söhne, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 100.432.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 28/05/2008.

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
50, Esplanade L-9227 Diekirch
Adresse postale: B.P. 126, L-9202 Diekirch
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008068458/2602/18.
Enregistré à Diekirch, le 27 mai 2008, réf. DSO-CQ00199. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080076654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Randstad Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, Place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 138.753.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the sixteenth of May,
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

"Randstad Holding N.V.", a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at

Diemermere 25, 1112 TC Diemen, The Netherlands;

The founder is here represented by Régis Galiotto, jurist, with professional address at Luxembourg, by virtue of a

proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" which its

declares to incorporate.

Name - registered office - object - duration

Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company, governed by the present

articles  of  incorporation  and  by  current  Luxembourg  laws,  especially  the  laws  of  August  10th,  1915  on  commercial
companies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on "sociétés à responsabilité limitée", as amended, and
the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

Art. 2. The Company's name is "Randstad Holding Luxembourg S.à r.l.".

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose.

70182

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - shares

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25 (twenty-five euros) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company will be managed by at least one manager. In the case where more than one manager would be

appointed, the managers would form a board of managers. ln this case, managers will be appointed as type A manager or
type B manager. The manager(s) need not to be shareholders of the Company. ln the case where only one manager would
be appointed, the sole manager has on his sole signature all the powers of the board of managers.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of sha-

reholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder.
The remuneration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general
meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace
any manager. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or
the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

ln the case of one sole manager, the sole signature of this manager shall bind the Company. ln the case of plurality of

managers, dealing with third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one A manager and one B
manager. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad
hoc agent(s) who need not to be shareholder(s) or manager(s) of the Company

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (If any) of its agent(s), the duration of the

period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The Company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,

compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct ; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with

70183

such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another

manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted

by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of

shareholders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the Company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting

of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves,
but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles
of incorporation.

However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the Company.

70184

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2008.

<i>Subscription - payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by Randstad Holding N.V.,

prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) is as now
at the disposal of the Company Randstad Holding Luxembourg S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 2,000.- Euros.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration
- Mr Gietelink Joost Carel Sandor, as Class A Manager, residing at Van Crombrugghelaan 16, 1150 Sint-Pieters-Woluwe,

Belgium;

- Mr Heinig Horst Lutz, as Class A Manager, residing at Theodoor-Storm-Str. 14, Münster, Germany;
- Mr Gérard Becquer, as Class B Manager, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
In accordance with article eleven of the by-laws, the Company shall be bound by the joint signature of one A manager

and one B manager.

2) The Company shall have its registered office at 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le seize mai.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

"Randstad Holding N.V.", une société de droit néerlandais, ayant son siège social à Diemermere 25, 1112 TC Diemen,

Pays-Bas

Fondateur ici représenté par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - siège - objet - durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée,
telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera "Randstad Holding Luxembourg S.à r.l.".

70185

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de
toute société les acquérant ; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou
d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier
direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties ; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée ; enfin de mener à bien toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature

à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert
du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12,500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de EUR 25 (vingt-cinq euro) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

Art. 11. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants

formeraient un conseil de gérance. Dans ce cas, les gérants seront nommés soit gérant de type A, soit gérant de type B.
Les gérants peuvent ne pas être actionnaires. Le gérant unique a tous les pouvoirs du conseil de gérance.

Les gérants sont désignés, et leur rémunération fixée, par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant

à la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l'actionnaire unique La rémunération des gérants pourra
être modifiée par une résolution prise aux mêmes conditions de majorité L'assemblée générale des actionnaires ou le
cas échéant, l'actionnaire unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant. Tous les pouvoirs
non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires ou le cas échéant à l'actionnaire unique, par la Loi ou
les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la société. Dans le cas de pluralité de gérants,

traitant avec des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant de type A et d'un gérant de type B.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être actionnaire(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance déterminé les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

70186

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous

frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société ; en cas d'arrange-
ment transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans
le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses
devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres
droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément

formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Exercice social - comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de

la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la Société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec

le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

70187

Les actionnaires peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices
reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu
d'une obligation légale ou statutaire.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le

capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à

sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1 

er

 , ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application

partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2008.

<i>Souscription - libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par Randstad

Holding N.V., prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
EUR 12,500 (douze mille cinq cents euro) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 2.000.- Euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) sont nommés gérants pour une durée indéterminée
- Mr Gietelink Joost Carel Sandor, comme gérant de type A, résidant au 16 Van Crombrugghelaan, 1150 Sint-Pieters-

Woluwe, Belgique;

- Mr Heinig Horst Lutz, comme gérant de type A, résidant au 14 Theodoor-Storm-Str., Münster, Allemagne;
- Mr Gérard Becquer, comme gérant de type B, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xembourg;

Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe d'un gérant de type

A et d'un gérant de type B.

2) Le siège social de la Société est établi à 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante

les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 mai 2008, Relation: LAC/2008/19933. - Reçu à 0,5 %: soixante deux euros cin-

quante cents (62,50 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 23 mai 2008.

Joseph ELVINGER..

Référence de publication: 2008068534/211/360.
(080077179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2008.

70188

Beauty Case, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9640 Boulaide, 1, rue Romaine.

R.C.S. Luxembourg B 114.989.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
BEAUTY CASE SARL
Signature

Référence de publication: 2008068454/557/14.
Enregistré à Diekirch, le 21 mai 2008, réf. DSO-CQ00134. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080076518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Sodema S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 104.728.

<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société en date du 22 avril 2008

<i>Première résolution

La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, avec siège social à
Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite au registre de commerce des

Iles Vierges Britanniques sous le numéro 398986,

est remplacée en qualité de Président du Conseil d'administration,
par Monsieur Jean-Louis TOMASZKIEWICZ, né le 02/02/1954 à Rocourt, Belgique, demeurant à 4, Plaine de la Sarte,

B-4500 Huy, et ce avec effet au 22/04/2008.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'Assemblée.

Fait à Strassen, le 22/04/2008.

Jeannot MOUSEL / Gisèle KLEIN / Nadine NOYER
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2008068453/3220/21.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2008, réf. LSO-CP10003. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

MEIF Germany Eight S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 138.736.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the sixteenth of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

MIF Holdings S.àr.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under

the laws of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Lux-
embourg Trade and Companies Register under number B118664,

here represented by Annick Braquet, residing professionally in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, by virtue of a

proxy hereto attached.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

MEIF Germany Eight S.àr.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by

70189

the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determine that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.

General object

The object of the Company is to carry out all types of financial investments in securities and all transactions pertaining

directly or indirectly to the acquisition of participations in Luxembourg companies and foreign companies, in any form
whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to group companies, any assistance, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial
assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or
all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are

directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Particular object

The Company will issue a jouissance right (the Genussrecht) to Macquarie Infrastrukturgesellschaft Nr. 8 mbH &amp; Co.

KG, a German asset management partnership (vermögensverwaltend Kommanditgesellschaft) (the Partnership) and will
use the proceeds received from the Partnership in consideration for the Genussrecht to subscribe for a limited partnership
interest (the Interest) in the Macquarie European Infrastructure Fund III LP (MEIF III). Further MEIF III will in turn invest
in a portfolio of infrastructure and related assets (the Portfolio).

The Genussrecht will entitle the Partnership to receive returns and proceeds from the Company including the returns

and proceeds received from MEIF III, and interest earned thereon, in accordance with the Interest, except those resulting
from the investment of means and sources of the Company other than its specific Genussrecht. In practice the returns
received by MEIF III from the Portfolio (after the deduction of relevant expenses) shall be paid to the Company as due
under the Interest, and the Company will in turn allocate these returns and proceeds to the Partnership under and in
accordance with the Genussrecht it has issued. Any funds as collected from the issue of the Genussrecht and not drawn
by MEIF III will be placed in money market accounts until MEIF III is fully invested.

Any total or partial payment of capital or any distribution which the Company shall receive from MEIF III from the

Interest must be used by the Company as distribution on the Genussrecht, to the extent required under the Genussrecht
agreement, or as repayment of the capital of the Genussrecht.

The Company may also perform all acts and transact all business, which directly or indirectly favour or relate to its

above mentioned object.

Art. 4. Duration.

4.1 The Company is formed for an unlimited period.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

70190

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at fifteen thousand euro (EUR 15,000) represented by five hundred (500)

shares in registered form with a par value of thirty euro (EUR 30) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence (a Share or collectively the Shares).

6.2. Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are transferable only with the consent of the Company. Such consent may only be given if the new share-

holder is not an individual and only, if after the transfer the total number of shareholders amounts to not more than 10.

A Share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The board of managers consists of three managers, being one group A-manager and two group B-managers,

appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their
office. The A-manager appointed by the affirmative vote of seventy five per cent (75%) of the share capital and the B-
manager by simple majority vote in the general meeting. The managers need not to be shareholders.

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the group A-manager and any group B-manager of the Company acting jointly.

8.3. No particular authorisation by the board of managers is necessary for the total or partial reimbursement of the

Genussrecht, in accordance with the terms and conditions thereof.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

70191

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters, except as indicated in article

8.3. of these Articles, by the joint signature of the group A-manager and any group B-manager of the Company or by the
joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with
article 8.2. of these Articles. The total or partial reimbursement of the Genussrecht issued by the Company, in accordance
with the terms and conditions thereof, may be effected by the sole signature of the group A-manager, without this having
to be approved by the board of managers.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Agreements

Art. 14. Conclusion of Agreements. The Company shall enter into the Genussrecht agreement with the above-men-

tioned  Partnership  pursuant  to  which  the  Company  will  issue  the  Genussrecht  to  the  Partnership.  According  the
Genussrecht agreement, the Genussrecht or parts thereof may be transferred by the Partnership to third parties only
with the consent of the Company. Such consent may only be given if the new Genussrecht holder is not an individual and
only, if after the transfer the total number of Genussrecht holders amounts to not more than 10.

The Company shall enter into a Transfer Consent Agreement with a direct or indirect Macquarie Group Limited

subsidiary from which it will receive an annual fee.

Art. 15. Termination of the Agreements. The termination, cancellation, revocation or amendments of the agreements

mentioned under Art. 14 require the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three
quarters of the share capital of the company.

VI. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 16. Accounting Year.
16.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the 31 December.
16.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

16.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. Allocation of Profits.
17.1. Under the Genussrecht agreement, the Partnership will receive returns and proceeds from the Company in-

cluding the returns and proceeds received from MEIF III, and interest earned thereon, in accordance with the Interest,
except those resulting from the investment of means and sources of the Company other than its specific Genussrecht.
In practice the returns received by MEIF III from the Portfolio (after the deduction of relevant expenses) shall be paid to
the Company as due under the Interest, and the Company will in turn allocate these returns and proceeds to the Part-
nership under and in accordance with the Genussrecht it has issued.

The profits allocated by the Company in consideration for the Genussrecht to the Partnership is calculated prorata

temporis, i.e., from the first day of the financial year to the last day (including the first day and the last day of the period)
during which the Genussrecht is outstanding.

The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and

expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

70192

17.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular

allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward. Dividends may be paid
in kind, at the discretion of the general meeting of shareholders.

17.3 Interim dividends may be distributed, at any time by the board of managers, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

Interim dividends may be paid in kind, at the discretion of the manager or the board of managers.

VII. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation.
18.1. In the event of a dissolution of the Company which shall be decided when the Company does not hold any of

the Interest or in the event the Company has fully redeemed or cancelled the Genussrecht, the liquidation will be carried
out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the general meeting
of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution
of the shareholders or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

18.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.

VIII. General provision

Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2008.

<i>Subscription and payment

Thereupon, the corporate capital has been subscribed as follows:

shares

MIF Holdings S.àr.l., prenamed, Five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: Five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

All the five hundred (500) shares have been paid by contributions in cash, so that the amount of fifteen thousand euro

(EUR 15,000) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowl-
edges it.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately EUR 2,000.- (two thousand euro).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

share capital have passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
(a) A - Manager:
- Mr Heribert Geistler, born on January 23, 1971 in Vienna (Austria), with professional address at 1-3 Herrengasse, A

1010 Vienna (Austria);

(b) B - Managers:
- Mr Philippe Salpetier, company director, born on August 19, 1970 in Libramont (Belgium), with professional address

at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; and

- Mr Frank Przygodda, company director, born on February 28, 1968 in Bochum (Germany), with professional address

at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 28, boulevard Royal, Level 3 L-2449 Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

70193

WHEREOF  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Luxembourg,  on  the  date  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Deutsche Fassung des vorherigen Textes:

Im Jahre zweitausendundacht, am sechzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

MIF Holdings S.àr.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Gesellschaftssitz

in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter Nummer B 118.664,

hier vertreten durch Annick Braquet, mit beruflicher Adresse in L-1319 Luxemburg, 101, rue Cents, auf Grund einer

Vollmacht unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.

Die Vollmachten, ordnungsgemäß durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den Notar unterzeichnet, bleiben

dieser Urkunde beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienenen, vertreten wie oben angeführt, ersuchen den unterzeichneten Notar die Satzung einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden.

I. Name - Gesellschaftssitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Name. Es wird hiermit, nach luxemburgischen Recht, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à

responsabilité limitée) gegründet, welche die Firmenbezeichnung "MEIF Germany Eight S.àr.l." (die Gesellschaft) annimmt,
welche der folgenden Satzung (die Satzung) und insbesondere dem Gesetz vom 10 August 1915 über Handelsgesellschaf-
ten und dessen Abänderungen (das Gesetz) unterliegt.

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz kann durch einfachen

Beschluss des alleinigen Geschäftsführers, bzw. durch Beschluss des Geschäftsführerrats an einen anderen Ort innerhalb
der Gemeinde verlegt werden. Er kann jederzeit in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch
einfachen Beschluss, angenommen auf ähnlicher Weise wie für die Abänderung der Satzung, des alleinigen Gesellschafters
oder der Gesellschafter verlegt werden.

2.2. Die Gesellschaft kann, durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers bzw. der Geschäftsführer, Niederlassungen,

Tochtergesellschaften oder andere Büros in Luxemburg sowie im Ausland errichten. Sofern der alleinige Geschäftsführer
bzw. der Geschäftsführerrat bestimmen, dass außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer oder militärischer
Natur drohen einzutreten oder eingetreten sind, die drohen die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem
Sitz oder die Verbindungen zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten zu beeinträchtigen, kann der Sitz der Ge-
sellschaft vorübergehend verlegt werden bis zur vollkommenen Einstellung der o. e. Ereignisse. Die Nationalität der
Gesellschaft bleibt luxemburgisch, unbeeinflusst von einer derartigen vorübergehenden Sitzverlegung.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft.
Allgemeiner Zweck der Gesellschaft
Der Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von allen finanziellen Investitionen in Geldpapieren und alle Ge-

schäfte, die in mittelbarem und unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erwerb von Beteiligungen in luxemburgischen
und ausländischen Unternehmen, gleich in welcher Form, stehen, sowie die Verwaltung, die Führung, die Kontrolle und
die Entwicklung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zur Anlegung in Immobilien, zur Erstellung, Führung, Entwicklung und

Übertragung ihrer Vermögenswerte insbesondere jedoch nicht beschränkt auf ihr Portfolio von Wertpapieren von jeg-
licher Herkunft, zur Teilnahme in der Gründung, Entwicklung und Kontrolle von jeglichen Unternehmen, zum Erwerben
mittels Beteiligung, Zeichnung, Kaufoption, Wertpapiere und jegliche Rechte an geistigem Eigentum und diese durch
Verkauf, Übertragung, Austausch oder auf sonst eine Weise zu verwerten oder veräußern, um Lizenzen auf geistigem
Eigentum zu erhalten oder zu vergeben. Die Gesellschaft kann auch dritten Gesellschaften, in denen die Gesellschaft eine
mittelbare oder unmittelbare Beteiligung besitzt und Gesellschaften der gleichen Unternehmensgruppe, sämtliche Hilfen,
einschliesslich jedoch nicht beschränkt auf jegliche Unterstützung der Geschäftsführung und der Entwicklung der Gesell-
schaften und deren Portfolios, finanzielle Unterstützung, Darlehen, Vorauszahlungen oder Garantien gewähren. Sie kann
alle oder teils ihre Vermögensgegenstände verpfänden, übertragen, belasten oder jegliche Werte auf ihre Vermögensge-
genstände bestellen.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen, finanziellen, persönliche und Immobiliengeschäfte vornehmen,

die mittelbar und unmittelbar im Zusammenhang mit ihrem Zweck stehen und notwendig zur Erfüllung ihres Gesell-
schaftszwecks stehen.

Besonderer Zweck der Gesellschaft
Die Gesellschaft wird ein Genussrecht (das Genussrecht) an Macquarie Infrastrukturgesellschaft Nr. 8 GmbH &amp; Co.

KG, eine deutsche vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft (die Kommanditgesellschaft) begeben und wird die als

70194

Gegenleistung für das Genussrecht und von der Kommanditgesellschaft bezogene Erträge nutzen, um Vermögenswerte
(die Vermögenswerte) als eine der Kommanditisten in Macquarie European Infrastructure Fund III LP (MEIF III) zu zeich-
nen. MEIF III wird seinerseits in ein Portfolio von Infrastruktur- und Infrastruktur bezogene Aktiva investieren.

Das Genussrecht wird der Kommanditgesellschaft Anspruch geben auf die Erträge und Gewinne von der Gesellschaft,

einschliesslich die von MEIF III bezogenen Erträge und Gewinne, im Einklang mit den am Genussrecht verbundenen Ver-
mögenswerten, jedoch mit Ausnahme von den Erträgen und Gewinnen die von dem Investment der Mittel der Gesellschaft
stammen, und die nicht dem spezifischen Genussrecht entsprechen. In der Praxis werden die von MEIF III über das
Portfolio bezogenen Erträge (nach Abzug der entsprechenden Kosten) an die Gesellschaft als fällig aufgrund der Vermö-
genswerte gezahlt. Die Gesellschaft wird diese Erträge und Erlöse der Kommanditgesellschaft übergeben gemäss des von
ihr  begebenen  Genussrechts.  Jene  Mittel,  die  durch  die  Begebung  des  Genussrechts  erhalten  und  von  MEIF  III  nicht
abgerufen worden sind, werden so lange in Geldmarktinstrumente angelegt bis MEIF III voll investiert ist.

Jede Voll- oder Teilzahlung von Kapital oder jede Ausschüttung, die von der Gesellschaft von MEIF III von den Ver-

mögenswerten bezogen wird, muss von der Gesellschaft als Ausschüttung über das Genussrecht, in dem Umfang, wie in
dem mit der Kommanditgesellschaft unterzeichneten Genussrechtvertrag vorgesehen, oder als Rückerstattung des Ka-
pitals dieses Genussrechts, genutzt werden.

Die Gesellschaft kann auch alle anderen Geschäfte, welche den o.e. Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar

begünstigen oder ihm nützlich sind, nachgehen.

Art. 4. Dauer der Gesellschaft.
4.1. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht durch das Ableben, die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, den Konkurs oder

die Zahlungsunfähigkeit oder ähnliche Ereignisse, des alleinigen Gesellschafters bzw. mehrerer Gesellschafter aufgelöst.

II. Kapital - Anteile

Art. 5. Kapital.
5.1. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 15.000 (fünfzehntausend euros), eingeteilt in 500 (fünfhundert) voll gezeich-

nete und eingezahlte Anteile mit einem Nennwert von je EUR 30.

5.2. Das Gesellschaftskapital kann in einem oder mehreren Schritten erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss

des alleinigen Gesellschafter bzw. der Versammlung der Gesellschafter, der wie für eine Satzungsänderung vorgeschrieben
getroffen wird.

Art. 6. Anteile.
6.1. Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und der Gewinne der Gesellschaft, der im proportionalen

Verhältnis zur Anzahl der existierenden Anteile steht (der Anteil oder gemeinsam, die Anteile).

6.2. Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile unteilbar; nur ein Inhaber pro Anteil ist zugelassen. Bruchteilseigen-

tümer müssen sich von einer einzigen Person gegenüber der Gesellschaft vertreten lassen.

6.3. Die Anteile können nur mit der Genehmigung der Gesellschaft übertragen werden. Solche Genehmigung kann nur

dann erteilt werden, wenn es sich bei dem neuen Gesellschafter nicht um eine natürliche Person handelt und wenn nach
der Übertragung die Anzahl der Gesellschafter nicht höher als zehn ist.

Für die Gesellschaft und gegenüber Dritten ist die Übertragung der Anteile nur bindend nachdem die Übertragung der

Gesellschaft mitgeteilt wurde oder nachdem die Übertragung von der Gesellschaft genehmigt wurde, im Einklang mit
Artikel 1690 des bürgerlichen Gesetzbuches.

Alle andere Angelegenheiten werden von den Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes geregelt.
6.4. Wie vom Gesetz festgelegt, wird am Sitz der Gesellschaft ein Register über die Anteile der Gesellschaft geführt.

Der Register steht jedem Gesellschafter auf Anfrage zur Einsicht zur Verfügung.

III. Geschäftsführung - Vertretung

Art. 7.
7.1. Der Geschäftsführerrat besteht aus drei Geschäftsführer, von welchen einer der Klasse A und zwei der Klasse-B

gehören. Die Geschäftsführer werden von dem alleinigen Gesellschafter bzw. der Generalversammlung der Gesellschafter
ernannt, welche auch über die Dauer ihres Amts bestimmen. Die Ernennung des Klasse A Geschäftsführers bedarf 75%
der Stimmen des Gesellschaftskapitals und die Ernennung der Klasse B Geschäftsführer bedarf der einfachen Mehrheit
der Stimmen während der Generalversammlung. Die Geschäftsführer brauchen nicht Gesellschafter zu sein

7.2. Die Widerrufung der Geschäftsführer findet ad nutum statt.

Art. 8. Befugnisse des Geschäftsführerrates.
8.1. Alle Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung der

Gesellschafter vorbehalten sind, werden von dem Geschäftsführerrat übernommen, welcher befugt ist, alle Geschäfte
vorzunehmen, die dem Zweck der Gesellschaft dienen.

70195

8.2. Besondere und beschränkte Vollmachten können gemeinsam von dem A-Geschäftsführer oder von irgendeinem

B-Geschäftsführer der Gesellschaft für bestimmte Aufgaben an einen oder mehreren Bevollmächtigten erteilt werden,
die nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

8.3. Eine Gesamt- oder Teilrückzahlung des Genussrechts bedarf keiner besonderen Genehmigung des Geschäftsfüh-

rerrates, gemäss den Bedingungen dieses Genussrechts.

Art. 9. Sitzungen des Rates.
9.1. Der Geschäftsführerrat trifft zusammen, so oft es die Angelegenheiten der Gesellschaft erfordern oder auf Antrag

irgendeinem Geschäftsführer, an einem Sitzungsort, der in der Einberufung festgelegt wird.

9.2. Jeder Geschäftsführer wird durch schriftliche Einberufung vor jedem Geschäftsführerrat mindestens 24 (vierund-

zwanzig) Stunden im voraus informiert, außer in Dringlichkeitsfällen, in welchem Falle die Art dieser Dringlichkeitsfällen
in der Einberufung erläutert wird.

9.3. Auf eine schriftliche Einberufung kann verzichtet werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten

sind und bestätigen, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Sitzung informiert wurden. Auf Einberufung kann
durch schriftliches Einverständnis von jedem Mitglied des Geschäftsführerrats der Gesellschaft verzichtet werden, ent-
weder per Brief, per Telegramm, Telex; Telefax oder E-Mail

9.4. Für jeden Geschäftsführerrat kann jeder Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer schriftlich zu seiner Ver-

tretung bevollmächtigen.

9.5. Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Die Beschlüsse des
Geschäftsführerrates sind durch Protokolle zu beurkunden, die von allen anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern
zu unterzeichnen sind.

9.6. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Konferenzschaltung oder Videokonferenz oder einer ähnlichen

Kommunikationstechnik, welche erlaubt, dass die teilnehmenden Personen sich gegenseitig verständigen können, teil-
nehmen. In diesem Fall gilt das entsprechend teilnehmende Mitglied des Geschäftsführer als persönlich anwesend.

9.7. Umlaufbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterschrieben sind, sind auf gleicher Weise bindend, als Be-

schlüsse, die während einer ordentlich einberufenen und gehaltenen Versammlung getroffen wurden. Die Unterschriften
können von einer bzw. mehrere Kopien eines Beschlusses getragen werden. Ebenfalls gilt hier die Stimmabgabe per Brief
oder Telefax.

Art. 10. Vertretung. Die Gesellschaft wird, ausser als in Artikel 8.3 dieser Satzung erwähnt, gegenüber Dritten und in

allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift von dem A-Geschäftsführer und irgendeinem B-Geschäftsfüh-
rer bzw. durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift von irgendwelchen Personen, denen Unterschriftsbefugnis
ordentlich und gemäss Artikel 8.2 dieser Satzung erteilt wurde, verpflichtet. Die Voll- oder Teilrückzahlung von dem
Genussrecht, der von der Gesellschaft gemäss den Bedingungen der Genussrechte begeben wurde, kann unter der allei-
nigen Unterschrift eines A-Geschäftsführers erfolgen und bedarf keiner besonderen Genehmigung des Geschäftsführer-
rates.

Art. 11. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer gehen keine persönliche Haftung in Bezug auf die Verbind-

lichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft eingegangen sind, solange diese Verbindlichleiten gemäss dieser Satzung und
den Bestimmungen des Gesetzes eingegangen wurden.

VI. Generalversammlung der Gesellschafter

Art. 12. Befugnisse und Stimmrechte.
12.1. Während der Versammlung der Gesellschafter, hat der alleinige Gesellschafter alle Befugnisse, die ihm von dem

Gesetz vorbehalten wurden.

12.2. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile.
12.3. Jeder Gesellschafter ist befugt, irgendeine natürliche oder juristische Person als seinen Mandanten zu bestellen

mittels einer schriftlichen Vollmacht, die per Brief, Telegramm, Telex, Telefax oder E-mail erteilt wurde, um ihn bei der
Gesellschafterversammlung zur vertreten.

Art. 13. Form - Beschlussfähigkeit - Mehrheit.
13.1. Sofern die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig nicht überschreitet, können die Beschlüsse per Umlaufbe-

schluss gefasst werden, dessen Inhalt allen Gesellschaftern schriftlich, entweder per Brief, Telegramm, Telex, Telefax oder
E-Mail, zugestellt wird. Die Gesellschafter geben ihre Stimme schriftlich ab, indem sie den Umlaufbeschluss unterschreiben.
Die Unterschriften können von einer bzw. mehrere Kopien eines Beschlusses getragen werden. Ebenfalls gilt hier die
Stimmabgabe per Brief oder Telefax.

13.2. Kollektive Beschlüsse sind nur dann gültig, wenn sie von Gesellschaftern gefasst werden, die mehr als die Hälfte

des Gesellschaftskapitals besitzen.

13.3. Beschlüsse, die die Satzung ändern, oder die die Gesellschaft auflösen oder liquidieren, können jedoch nur von

der Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen, gefasst werden.

70196

V. Verträge

Art. 14. Abschliessen von Verträgen. Die Gesellschaft wird ein Genussrechtvertrag mit der o.e. Kommanditgesellschaft

abschliessen und im Rahmen dieses Vertrags das Genussrecht an die Kommanditgesellschaft begeben. Gemäss des Ge-
nussrechtvertrags, kann der Genussrecht oder Teile des Genussrechts von der Kommanditgesellschaft an Dritten nur
mit der Genehmigung der Gesellschaft übertragen werden. Erteilt werden kann die Genehmigung nur wenn es sich bei
dem neuen Genussrechtinhaber nicht um eine natürliche Person handelt und nur wenn nach der Übertragung die gesamte
Anzahl von Genussrechtinhabern zehn nicht überschreitet.

Die Gesellschaft wird mit einer mittelbaren oder unmittelbaren Macquarie Group Limited Tochtergesellschaft über-

tragungsgenehmigungsabkommen unterzeichnen, und von dieser Tochtergesellschaft eine Jahresgebühr erhalten.

Art. 15. Beendigung der Verträge. Die Beendigung, die Kündigung, der Widerruf oder die Abänderung des o.a. Vertrags

bedarf der vorherigen Genehmigung der Gesellschafterversammlung, während deren mindestens drei Viertel des Ge-
sellschaftskapitals vertreten sind.

VI. Jahresrechnung - Ausschüttung der gewinne

Art. 16. Geschäftsjahr.
16.1. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres.
16.2. Am Ende jedes Geschäftsjahres am 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und der

oder die Geschäftsführer stellen die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar der Aktiva und
Passiva der Gesellschaft auf.

16.3. Das Inventar sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung stehen am Gesellschaftssitz zur Einsicht

jedes Gesellschafters zur Verfügung.

Art. 17. Gewinnausschüttung.
17.1. Unter dem spezifischen Genussrechtsvertrag, wird das Genussrecht der Kommanditgesellschaft Anspruch geben

auf die Erträge und Gewinne von der Gesellschaft, einschliesslich die von MEIF III bezogenen Erträge und Gewinne, im
Einklang mit den am Genussrecht verbundenen Vermögenswerten, jedoch mit Ausnahme von den Erträgen und Gewin-
nen,  die  von  dem  Investment  der  Mittel  der  Gesellschaft  stammen,  und  die  nicht  dem  spezifischen  Genussrecht
entsprechen. In der Praxis werden die von MEIF III über das Portfolio bezogenen Erträge (nach Abzug der entsprechenden
Kosten) an die Gesellschaft als fällig aufgrund der Vermögenswerte gezahlt. Die Gesellschaft wird die von MEIF III bezo-
genen Erträge und Erlöse der Kommanditgesellschaft übergeben gemäss des von ihr gehaltenen Genussrechts.

Die von der Gesellschaft als Gegenleistung an die Kommanditgesellschaft gezahlten Gewinne werden prorata temporis

berechnet, d.h. sie werden vom ersten bis zum letzten Tag des Geschäftsjahrs (einschliesslich des ersten und letzten Tags
des Zeitraums) während dessen das Genussrecht aussteht, berechnet

Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, minus die allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den Reingewinn

der Gesellschaft. Aus diesem Reingewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung eines gesetzlichen Reservefonds zurück-
zustellen, bis dieser Reservefonds zehn Prozent (10%) des nominellen Gesellschaftskapitals erreicht hat.

17.2. Mit freiem Ermessen entscheidet die Generalversammlung über die Verwendung des verbleibenden Reingewinns.

Der Gewinn kann als Dividend an die Gesellschafter ausgeschüttet, für die Bildung eines gesetzlichen Reservefonds zu-
rückgestellt  oder  vorgetragen  werden.  Die  Dividendenausschüttung  kann  als  Sachleistung  ausgezahlt  werden,  zum
Gutdünken der Generalversammlung.

17.3. Zwischendividende können jederzeit zu folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden, falls:
(i) ein Abrechnungsverzeichnis bzw. ein Inventar oder ein Bericht von dem Geschäftsführerrat erstellt wird;
(ii) das o.e. Abrechnungsverzeichnis, Inventar bzw. Bericht zeigt, dass für eine Ausschüttung genügende Mittel zur

Verfügung stehen. Der auszuschüttende Betrag darf den seit Ende des letzten Geschäftsjahres realisierten, durch vorge-
tragene Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen erhöhten jedoch durch vorgetragene Verluste und für die Bildung
des gesetzlichen Reservefonds bestimmten Mitteln verminderten Gewinne nicht überschreiten.

Zwischendividende mögen als Sachleistung ausgezahlt werden, zum Gutdünken des Geschäftsführers oder des Ge-

schäftsführerrats.

VII. Auflösung - Liquidierung

Art. 18. Auflösung - Liquidierung.
18.1. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft, über welche entschieden wird wenn die Gesellschaft über keine der

Vermögenswerte verfügt oder im Falle die Gesellschaft das Genussrecht völlig zurückgezahlt oder gekündigt hat, wird
die  Liquidierung  der  Gesellschaft  durch  einen  oder  mehreren  Liquidatoren  vorgenommen.  Die  Liquidatoren  können
Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein. Sie werden von der Gesellschafterversammlung ernannt, die ihre Rechte
und ihr Gehalt festlegt. Wenn nicht anders von einem Beschluss der Gesellschafter oder vom Gesetz vorgesehen, verfügen
die Liquidatoren über die weitgehenden Befugnisse für die Veräusserung der Vermögenswerte und Zahlung der Schulden
der Gesellschaft

70197

18.2. Nach Veräusserung der Vermögenswerte und Zahlung der Schulden der Gesellschaft wird den Restbetrag an

den Gesellschafter gezahlt, bzw. wenn mehrere Gesellschafter bestehen, an die Gesellschafter proportional zu den An-
teilen, die jeder Gesellschafter besitzt.

Art. 19. Allgemeine Bestimmungen. Für alle Punkte, die in der Satzung nicht festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen

des Gesetzes, sowie abgeändert, verwiesen.

<i>Vorübergehende Bestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft, und wird am 31. Dezember 2008 enden.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:

Anteile

MIF Holdings S.àr.l., vorbenannt, Fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Gesamt: Fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Alle 500 Gesellschaftsanteile wurden in bar eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 15.000 (fünfzehntausend euros)

der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar, der dies ausdrücklich feststellt, der Nachweis
erbracht wurde.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer

Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise EUR 2.000.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Als Geschäftsführer werden auf unbestimmte Dauer ernannt:
(a) A-Geschäftsführer:
- Herr Heribert Geistler, geboren am 23. Januar 1971 in Wien (Österreich), wohnhaft in 1-3 Herrengasse, A-1010

Wien (Österreich);

(b) B-Geschäftsführer:
- Herr Philippe Salpetier, Firmenleiter, geboren am 19. August 1970 in Libramont (Belgien), wohnhaft in 5, rue Guil-

laume Kroll, L-1882 Luxembourg

- Herr Frank Przygodda, Firmenleiter, geboren am 28. Februar 1968 in Bochum (Deutschland), wohnhaft in 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich am 28 Boulevard Royal, Level 3, L-2449 Luxembourg.
Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt, auf Antrag der Erschienenen,

dass vorliegende Urkunde in Englisch gefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle von Unterschieden
zwischen der englischen und der deutschen Fassung ist die englische Fassung maßgebend.

Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Erschienenen, dem Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat diese mit dem Notar die gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. BRAQUET und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2008, Relation: LAC/2008/20231. — Reçu soixante-quinze euros (0,50% =

75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 23. Mai 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008068564/242/505.
(080076966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2008.

Logica Holdings Luxfive S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 42.886.050,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activité Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 135.677.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'Associé unique prise en date du 7 mai 2008 les décisions suivantes:

70198

- Monsieur Gabriel THIERCELIN, Gérant de catégorie B est nommé dorénavant Gérant de catégorie A de la Société

pour un mandat à durée indéterminée;

- Monsieur Jan RIDDERHOF, né à Rotterdam, Pays-Bas, le 20 octobre 1948 avec adresse professionnelle au Prof. W.H.

Keesomlaan 14, 1183 DJ Amstelven, Pays-Bas est nommé Gérant de catégorie B de la Société pour un mandat à durée
indéterminée.

Luxembourg, le 9 mai 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Gérant

Référence de publication: 2008067899/1337/22.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ04793. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080076416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Astringo Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 67.996.

Il y a lieu de rectifier les informations suivantes concernant l'associée suivante de la Société.
Nom: Tapper Brandberg
Prénom: Lina
Date de naissance: 7 novembre 1962
Lieu de naissance: M Lund, Suède
Adresse: 23, rue Le Olivier, L-2225 Luxembourg
Par ailleurs, il résulte d'un acte sous seing privé de cession de parts sociales, que Pearl Invest &amp; Trade Limited, ayant

son siège social au 35A, Regent Street, P.O. Box 1777, Jasmine Court, Belize City, Belize, a cédé, avec effet au 8 novembre
2007, 1 (une) part sociale de Astringo Holdings S.à r.l. à Lina Tapper Brandberg, demeurant 23, rue Le Olivier, L-2225
Luxembourg.

Au 8 novembre 2007, Lina Tapper Brandberg est devenue l'associée unique de la société et détient les 1.000 parts

sociales représentant l'intégralité du capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 8 mai 2008.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Le Gérant

Référence de publication: 2008067900/1337/27.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ04800. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Commercial Real Estate Investments S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Capital social: USD 724.490,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 113.699.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société tenue au siège social le 8 mai 2008 que

les mandats suivants ont été reconduits pour une période d'un an courant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2009:

<i>Administrateurs de classe A:

- Olivier Dorier, Directeur de sociétés, demeurant professionnellement au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Muns-

bach;

70199

- Stewart Kam-Cheong, Réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365

Munsbach; et

<i>Administrateurs de classe B:

- Hamid Yunis, Avocat, demeurant professionnellement 50 Victoria Embankment, London EC4Y 0DX, United-King-

dom.

A noter que les adresses des trois Administrateurs, Mr. Olivier Dorier, Mr. Kam-Cheong Stewart et Mr. Hamid Yunis

ont été modifiées et qu'il y a lieu de retenir les adresses ci-dessus comme seules adresses valables.

Munsbach, le 8 mai 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Administrateur

Référence de publication: 2008067901/1337/29.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ04802. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080076402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Imbrex Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 25.238.

Le bilan au 31-12-2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28-05-2008.

LUCOS COMPANY SERVICES
5, rue Prince Jean, L-4740 PETANGE - LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008067902/1656/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2008, réf. LSO-CQ01370. - Reçu 44,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Agria Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 82.194.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 2 novembre 2007

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2007:

- ERNST &amp; YOUNG S.A., 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008067891/534/15.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2008, réf. LSO-CP10167. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Bocimar Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 51.277.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle tenue au siège social en date du 10 avril 2008

- L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide de renouveler le mandat de KPMG Audit, Luxembourg en tant que

réviseur d'entreprises pour une année jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2009.

70200

- L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide de renouveler le mandat de Messieurs Marc Saverys, Ludwig Criel,

Benoît  Timmermans  et  Dirk  Van  Meer  en  tant  qu'administrateurs  pour  deux  années  jusqu'à  l'issue  de  l'  Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2008.

BOCIMAR LUX S.A.
Ludo Beersmans
<i>Directeur Général

Référence de publication: 2008067892/1095/20.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05046. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080076581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Logica General Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 137.500.000,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activité Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 122.142.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'Associé unique prise en date du 7 mai 2008 les modifications suivantes:
- Monsieur Gabriel THIERCELIN, Gérant de catégorie B, est nommé dorénavant Gérant de catégorie A de la Société

pour un mandat à durée indéterminée;

- Monsieur Jan RIDDERHOF, Gérant de catégorie A est nommé dorénavant Gérant de catégorie B de la Société pour

un mandat à durée indéterminée.

Luxembourg, le 9 mai 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Gérant

Référence de publication: 2008067893/1337/21.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ04755. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Novo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 97.902.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2008067908/560/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ04805. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

PPG Luxembourg Finance S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 97.149.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal des résolutions prises par l'associé unique le 22 avril 2008 que:
- Catherine L. Garfinkel a démissionné en tant que Gérant A avec effet au 23 avril 2008;

70201

- Aziz Giga, né le 21 décembre 1947 à Kisumu, Kenya et résidant au 549, Harrogate Road, Pittsburgh, PA 15241, USA

et Kim Edvardsson, née le 26 septembre 1962 à East Liverpool Ohio, USA et résidant au 689, Valleyview Road, Pittsburgh,
PA 15243, USA ont été nommés Gérants A avec effet au 22 avril 2008.

A noter que Stewart Kam-Cheong, Gérant B, réside au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Luxembourg, le 6 mai 2008.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Gérant

Référence de publication: 2008067895/1337/21.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ04760. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080076435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Logica Holdings Luxtwo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 1.993.560.375,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activité Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 137.448.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'Associé unique prise en date du 7 mai 2008 les décisions suivantes:

- Monsieur Gabriel THIERCELIN, Gérant de catégorie B est nommé dorénavant Gérant de catégorie A de la Société

pour un mandat à durée indéterminée;

- Monsieur Jan RIDDERHOF, né à Rotterdam, Pays-Bas, le 20 octobre 1948 avec adresse professionnelle au Prof. W.H.

Keesomlaan 14, 1183 DJ Amstelven, Pays-Bas est nommé Gérant de catégorie B de la Société pour un mandat à durée
indéterminée.

Luxembourg, le 9 mai 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Gérant

Référence de publication: 2008067896/1337/22.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ04777. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Logica Holdings Luxfour S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.621.950,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activité Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 137.447.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'Associé unique prise en date du 7 mai 2008 les décisions suivantes:

- Monsieur Gabriel THIERCELIN, Gérant de catégorie B est nommé dorénavant Gérant de catégorie A de la Société

pour un mandat à durée indéterminée;

- Monsieur Jan RIDDERHOF, né à Rotterdam, Pays-Bas, le 20 octobre 1948 avec adresse professionnelle au Prof. W.H.

Keesomlaan 14, 1183 DJ Amstelven, Pays-Bas est nommé Gérant de catégorie B de la Société pour un mandat à durée
indéterminée.

70202

Luxembourg, le 9 mai 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Gérant

Référence de publication: 2008067898/1337/22.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ04786. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Europay Luxembourg, Société coopérative, Société Coopérative.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 30.764.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage en date du 30

mai 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n 

o

 295 du 16 octobre 1989.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2008.

<i>Pour EUROPAY LUXEMBOURG, Société Coopérative
Sonja Streicher

Référence de publication: 2008067903/9032/16.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2008, réf. LSO-CQ07756. - Reçu 115,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Logica Holdings Luxthree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 943.548.600,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activité Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 135.678.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'Associé unique prise en date du 7 mai 2008 les décisions suivantes:
- Monsieur Gabriel THIERCELIN, Gérant de catégorie B est nommé dorénavant Gérant de catégorie A de la Société

pour un mandat à durée indéterminée;

- Monsieur Jan RIDDERHOF, né à Rotterdam, Pays-Bas, le 20 octobre 1948 avec adresse professionnelle au Prof. W.H.

Keesomlaan 14, 1183 DJ Amstelven, Pays-Bas est nommé Gérant de catégorie B de la Société pour un mandat à durée
indéterminée.

Luxembourg, le 9 mai 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Gérant

Référence de publication: 2008067897/1337/22.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ04780. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Centre de Transferts Electroniques, Société Coopérative.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 23.562.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch en date du

30 mai 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n 

o

 383 du 30 décembre 1985.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

70203

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2008.

<i>Pour le CENTRE DE TRANSFERTS ELECTRONIQUES, Société Coopérative
Sonja Streicher

Référence de publication: 2008067904/9032/16.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2008, réf. LSO-CQ07745. - Reçu 119,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

ATEEL S.à r.l., ATEEL - Allied Technology Experts. Enterprise of Luxembourg S.à r.l., Société à respon-

sabilité limitée.

Siège social: L-6914 Roodt-sur-Syre, 8B, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 138.685.

STATUTS

L'an deux mille huit, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach.

A COMPARU:

Monsieur Dieter SAFFRAN, ingénieur, demeurant à L-6914 Roodt-sur-Syre, 8c, rue du Moulin.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée qu'il entend constituer:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933

telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou

plusieurs coassociés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uniper-
sonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet:
- la réalisation de travaux techniques et/ou administratifs en vue de l'homologation de toutes catégories de véhicules

terrestres et de leurs équipements, ou plus généralement tous produits industriels mobiles selon les lois, règlements ou
directives nationales ou internationales;

- la prestation de services techniques ou administratifs tels que: études, recherches, essais, certifications, contrôles ou

audits, dans le cadre de la législation ou la normalisation de produits industriels mobiles et plus spécifiquement de véhicules
et appareils utilisés pour le transport de personnes et de marchandises;

- la réalisation d'essais nécessitant l'accès aux installations ou compétences de laboratoires externes, ou la mise à

disposition de ces installations au profit d'utilisateurs externes.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille ainsi que la détention et la mise en valeur
de brevets.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de ATEEL - Allied Technology Experts. Enterprise of Luxembourg S.à r.l., en

abrégé ATEEL S.à r.l..

Art. 5. Le siège social est établi à Roodt-sur-Syre.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision

de l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (€ 50.000.-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de CENT EUROS (€ 100.-) chacune, qui ont été entièrement souscrites par Monsieur Dieter SAF-
FRAN, ingénieur, demeurant à L-6914 Roodt-sur-Syre, 8c, rue du Moulin.

70204

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de CIN-

QUANTE MILLE EUROS (€ 50.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-

dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à

partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne

pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé

unique ou par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du
ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Le gérant peut donner des procurations spéciales à des tiers, associés ou non, pour agir au nom de la société.

Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal

ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 15. En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre

de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant  l'indication  des  valeurs  actives  et  passives  de  la  société,  le  bilan  et  le  compte  de  profits  et  pertes,  le  tout
conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2008.

<i>Evaluation

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille trois cents Euros (€ 1.300.-).

70205

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social, a pris en outre les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Dieter SAFFRAN, ingénieur, demeurant à L-6914 Roodt-sur-Syre, 8c, rue du Moulin.
2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-6914 Roodt-sur-Syre, 8b, rue du Moulin.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. SAFFRAN, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 20 mai 2008. Relation: ECH/2008/665. — Reçu deux cent cinquante euros 50.000.- à 0,5%

= €250.-.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): D. SPELLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 26 mai 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008068184/201/116.
(080076176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Carspaze Services G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 138.716.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, den zehnten April,
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile SCHLESSER, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame,

Ist erschienen:

Die einfache Kommanditgesellschaft "Science in Motion GmbH &amp; Co. KG", mit Sitz in L-2314 Luxemburg, 2a, place de

Paris, gegründet auf Grund einer Urkunde, aufgenommen durch unterzeichneten Notar, am heutigen Tage,

hier vertreten durch Herrn Dr. Romain LUTGEN, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in L-2314 Luxemburg, 2a,

place de Paris,

auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift seitens der geschäftsführenden Komplementärin, vertreten

durch ihren Geschäftsführer, Herr Holger HAHN, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-82319 Starnberg, Prinzenweg 25.

Die Vollmacht, vom Komparenten und dem instrumentierenden Notar «ne varietur» paraphiert, bleibt gegenwärtiger

Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Dieser Komparent, handelnd wie erwähnt, hat den instrumentierenden Notar ersucht, nachfolgende Satzung einer

von seiner Mandantin zu gründenden Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden.

Titel I.- Zweck, Firmennamen, Dauer, Sitz

Art. 1. Hiermit wird vom Inhaber der hiermit geschaffenen Anteile eine Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung

gegründet, die den sich daraufbeziehenden Gesetzen sowie der folgenden Satzung unterliegt.

Die Gesellschafterin kann jederzeit einen oder mehrere Mitgesellschafter aufnehmen, wobei die zukünftigen Gesell-

schafter auch jederzeit die zur Wiederherstellung des ursprünglichen Einmann-Charakters der Gesellschaft geeigneten
Maßnahmen treffen können.

Art. 2. Gesellschaftszweck ist die Vermarktung und Verwertung des sogenannten Carspaze-Konzeptes einschließlich

aller von der Gesellschaft in diesem Zusammenhang gehaltenen Lizenzrechte betreffend Patente und Leistungsschutz-
rechte.

Die Gesellschaft ist berechtigt, gleiche oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, und sich an solchen zu beteiligen

oder deren Vertretung zu übernehmen. Sie kann sich im besonderen als unbeschränkt haftender Komplementär an der
Kommanditgesellschaft "Carspaze Services G.m.b.H &amp; Co. KG" beteiligen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Der Gesellschaftsname lautet "CARSPAZE SERVICES G.m.b.H".

Art. 5. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.

70206

Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in irgendeine andere Ortschaft innerhalb des Großherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen an anderen Orten des In- und Auslandes errichten.

Titel II.- Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00), aufgeteilt in ein tausend (1.000)

Anteile von je zwölf Euro und fünfzig Cents (EUR 12,50).

Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen sowie außerordentlichen Generalversammlungen.
Sämtliche Anteile wurden von der Gesellschafterin "Science in Motion GmbH &amp; Co. KG", gezeichnet.
Die Gesellschafterin hat ihre EinZahlungsverpflichtung in bar erfüllt, sodass das gesamte Kapital der Gesellschaft zur

Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit geändert werden durch Beschluss der alleinigen Gesellschafterin

oder durch einstimmigen Beschluss aller Gesellschafter.

Art. 8.  Jeder  Anteil  gibt  im  Verhältnis  zu  der  Summe  der  bestehenden  Anteile  ein  Recht  auf  einen  Bruchteil  des

Gesellschaftskapitals sowie der Gewinne.

Art. 9. Die Anteile sind nicht teilbar gegenüber der Gesellschaft, die nur einen Inhaber für jeden Anteil anerkennt.

Steht ein Gesellschaftsanteil mehreren Mitberechtigten gemeinschaftlich zu, so können sie die Rechte aus diesem nur
durch einen gemeinsamen Vertreter ausüben.

Art. 10. Die Gesellschaftsanteile können frei veräußert werden an Gesellschafter, unter Berücksichtigung der Bestim-

mungen von Artikel 1690 des Code civil. Die Anteile können aber nicht veräußert werden unter Lebenden an Dritte, die
nicht Gesellschafter sind, ohne Einverständnis aller Gesellschafter. Der Übergang von Gesellschaftsanteilen von Todes
wegen regelt sich nach derselben Bestimmung des Einverständnisses aller Gesellschafter. In diesem letzten Fall jedoch ist
das Einverständnis nicht erfordert, wenn der Übergang auf die Kinder, Ehe- oder Lebenspartner oder auf eine von einem
Gesellschafter eingesetzte Stiftung erfolgt.

Art. 11. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch den Tod, durch Entziehung der Rechte, Konkurs oder Zahlung-

sunfähigkeit eines Gesellschafters.

Art. 12. Die Gläubiger, Interessenten und Erben haben nicht das Recht, mit gleichwelcher Begründung es auch sei, auf

die Güter und Dokumente der Gesellschaft Siegel anlegen zu lassen oder ein Inventar der Firmenaktiva zu veranlassen.

Titel III.- Verwaltung und Vertretung

Art. 13. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die gegenüber Drittpersonen die

ausgedehntesten Befugnisse haben, um im Namen der Gesellschaft in allen Fällen zu handeln und um sämtliche Akte und
Geschäfte zu genehmigen, soweit sie im Rahmen des Zweckes der Gesellschaft sind.

Für die Gesellschaft zeichnet in allen Fällen rechtsverbindlich der Geschäftsführer oder, wenn mehrere bestellt sind,

zwei Geschäftsführer gemeinsam.

Art. 14. Der Tod des Geschäftsführers oder sein Austreten aus der Gesellschaft, aus gleich welchem Grund, zieht

nicht die Auflösung der Gesellschaft mit sich.

Art. 15. Jeder Gesellschafter darf an der Beschlussnahme teilnehmen, was auch immer die Zahl seiner Anteile ist. Jeder

Gesellschafter hat soviel Stimmen abzugeben, als er Anteile besitzt oder vertritt.

Art. 16. Die gemeinsamen Beschlüsse sind nur dann rechtsgültig, wenn sie gefasst wurden von Gesellschaftern, die

mehr als die Mehrheit des anwesenden Gesellschaftskapitals vertreten, soweit das Gesetz nicht zwingend eine größere
Mehrheit vorschreibt.

Art. 17. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für die Verpflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft form-

richtig  eingegangen  sind.  Als  bloße  Bevollmächtigte  müssen  sie  nur  ihre  Verpflichtungen  ordnungsgemäß  nach  den
gesetzlichen Vorschriften ausüben.

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr

beginnt am Gründungstage und endet am 31. Dezember 2008.

Art. 19. Jedes Jahr zum 31. Dezember wird ein Jahresabschluss der Gesellschaft, bestehend aus Bilanz, Gewinn-und

Verlustrechnung sowie Anhang, durch die Geschäftsführung erstellt.

Jeder Gesellschafter kann am Sitz der Gesellschaft vom Jahresabschluss Kenntnis nehmen.

Art. 20. Der Jahresüberschuss der Gesellschaft, wie er aus dem jährlichen Jahresabschluss hervorgeht, nach Abzug der

Kosten, der Belastungen und der notwendigen Abschreibungen, ergibt den Reingewinn.

Von dem Reingewinn werden fünf Prozent (5%) zurückgehalten zur Bildung des gesetzlichen Reservefonds, bis derselbe

zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht. Das Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

70207

Titel IV.- Auflösung, Liquidation

Art. 21. Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, Gesellschafter

oder Drittpersonen, ernannt von den Gesellschaftern, welche ihre Befugnisse und Entschädigungen festlegen.

Art. 22. Für alle nicht durch vorliegende Satzung geregelten Punkte gelten die sich in Kraft befindenden gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen ungefähr ein-

tausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,00).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann trifft die Gründerin, wie oben vertreten, als alleinige Gesellschafterin folgende Beschlüsse:
1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich vorläufig in L-2314 Luxemburg, 2a, place de Paris.
2.- Zum Geschäftsführer wird ernannt, auf unbestimmte Dauer:
Herrn Holger HAHN, Diplomkaufmann, geboren in Aalen (Deutschland), am 16. März 1968, wohnhaft in D-82319

Starnberg, Prinzenweg 25.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden hat der vorbenannte Komparent, zusammen mit dem amtierenden Notar, die

vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Lutgen, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 avril 2008, LAC/2008/15136. — Reçu à 0,50%: soixante-deux euros cinquante

cents (€ 62,50).

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 14. Mai 2008.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2008068200/227/112.
(080076721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Carspaze Services GmbH &amp; Co. KG, Société en Commandite simple.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 138.717.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, den zehn April,
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile SCHLESSER, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame,

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft "CARSPAZE SERVICES G.m.b.H.", eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-2314

Luxemburg, 2a, place de Paris, gegründet am heutigen Tage auf Grund einer Urkunde, aufgenommen durch den unter-
zeichneten Notar,

hier vertreten durch Herrn Dr. Romain LUTGEN, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in L-2314 Luxemburg, 2a,

place de Paris,

auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift durch ihren alleinigen Geschäftsführer, mit Einzelunters-

chriftbefugnis, Herrn Holger HAHN, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-82319 Starnberg, Prinzenweg 25,

hiernach "Komplementärin" genannt.
2.- Die Gesellschaft "Science in Motion G.m.b.H. &amp; Co. KG", eine einfache Kommanditgesellschaft, mit Sitz in L-2314

Luxemburg, 2a, place de Paris, gegründet am heutigen Tag auf Grund einer Urkunde, aufgenommen durch den unter-
zeichneten Notar,

hier vertreten durch Herrn Dr. Romain LÜTGEN, vorbenannt,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift durch ihren alleinigen Geschäftsführer mit Einzelunters-

chriftbefugnis, Herrn Holger HAHN, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-82319 Starnberg, Prinzenweg 25,

hiernach "Kommanditistin" genannt.
Die Vollmachten, von dem vorbenannten Komparenten und dem amtierenden Notar "ne varietur" paraphiert, bleiben

gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Vorbenannter Vertreter der Komparentinen ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von seinen Man-

danten zu gründenden einfachen Kommanditgesellschaft zu erstellen, die hiermit wie folgt aufgesetzt wird:

70208

Art. 1. Firma, Sitz, Geschäftsjahr.
1. Es besteht zwischen "CARSPAZE SERVICES G.m.b.H", einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die dem Lu-

xemburger Recht unterliegt, mit Sitz in Luxemburg, 2a, place de Paris, als Gesellschafterin mit unbeschränkter Haftung
(der "Komplementärin") und dem andern Zeichner, der Gesellschaft "Science in Motion GmbH &amp; Co. KG", als Gesell-
schafter mit beschränkter Haftung (der "Kommanditist") eine einfache Kommanditgesellschaft ("société en commandite
simple") (die "Gesellschaft"), die den Gesetzen des Grossherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung und der vorliegenden Satzung unterliegt.

2. Die Gesellschaft trägt den Namen "Carspaze Services GmbH &amp; Co. KG".
3. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Der Sitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an jeden

anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Rumpfgeschäftsjahr endet am 31. Dezember 2008.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
1. Gesellschaftszweck ist die Vermarktung und Verwertung des sogenannten Carspaze-Konzeptes einschließlich aller

von der Gesellschaft in diesem Zusammenhang gehaltenen Lizenzrechte betreffend Patente und Leistungsschutzrechte.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, gleiche oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen oder

deren Vertretung zu übernehmen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu begründen. Die Gesellschafter sind
sich darüber einig, dass unverzüglich nach Eintragung dieser Gesellschaft eine Zweigniederlassung in der Schweiz errichtet
wird.

Art. 3. Gesellschaftskapital, Anteile.
1. Das Gesellschaftskapital beträgt einhunderttausend Euro (EUR 100.000,00), eingeteilt in zehntausend (10.000) An-

teile von je zehn Euro (EUR 10,00) Nennwert.

Das Kapital wurde folgendermassen gezeichnet:

Komplementär "CARSPAZE SERVICES G.m.b.H.", vorbenannt, zehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Kommanditist "Science in Motion GmbH &amp; Co. KG", vorbenannt, neuntausendneunhundertneunzig Anteile

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.990

Total: zehntausend Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Das  Komplementärkapital  beträgt  also  einhundert  Euro  (EUR  100,00),  bestehend  aus  zehn  (10)  Anteilen  und  das

Kommanditkapital beträgt neunundneunzigtausendneunhundert Euro (EUR 99.900,00), bestehend aus neuntausendneun-
hundertneunzig (9.990) Anteilen.

3. Das Gesamtkapital wurde voll eingezahlt, wie dem Notar nachgewiesen wurde.
4. Nach den Kapitaleinlagen der Gesellschafter richten sich, sofern dieser Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt,

die Rechte der Gesellschafter, insbesondere die Beteiligung am Unternehmen, die Gewinnbeteiligung und das Stimmrecht.

Art. 4. Konten der Gesellschafter.
1. Die Einlagen werden auf für jeden Gesellschafter eingerichteten gesonderten Konten (Festkapitalkonten) gebucht.

Die Höhe der Kapitalkonten der Kommanditisten entspricht höchstens ihren zum Handelsregister angemeldeten Kapi-
taleinlagen. Die Festkapitalkonten werden nicht verzinst.

2. Etwaige Verluste der Gesellschafter werden auf Verlustvortragskonten verbucht, die im Bedarfsfall für jeden Ge-

sellschafter eingerichtet werden. Die Verlustvortragskonten werden nicht verzinst.

3. Neben dem Festkapitalkonto ist für jeden Gesellschafter ein Darlehenskonto zu führen; hierauf sind die ihm zufal-

lenden Zinsen und Gewinnanteile mit Wert Ende des Geschäftsjahres gutzuschreiben, soweit diese nicht zum Ausgleich
von Verlustvortragskonten verwendet werden.

4. Die Guthaben der Gesellschafter auf Darlehenskonten werden nach dem in Luxemburg gültigen gesetzlichen Zinssatz

verzinst.

5. Über ihr Guthaben können die Gesellschafter jederzeit frei verfügen.
6. Die Überziehung von Darlehenskonten ist unzulässig. Entstehen gleichwohl vorübergehend Verbindlichkeiten auf

Darlehenskonten, so sind diese mit drei Prozent (3 %) über dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen.

Art. 5. Geschäftsführung und Vertretung.
1. Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist die Komplementärin allein berechtigt und verpflichtet.
2. Die Komplementärin der Gesellschaft bedarf zu folgenden Geschäften und Tätigkeiten der vorherigen Zustimmung

der Gesellschafterversammlung:

a) Unternehmensplanung und -Strategie;
b)  Verabschiedung  der  detaillierten  Jahresplanung,  die  für  das  jeweils  kommende  Geschäftsjahr  vom/von  den  Ge-

schäftsführer(n) der Komplementärin möglichst bis zum 30.November für das nachfolgende Jahr aufzustellen ist. Kommt
keine Einigung über die Jahresplanung zustande, so gilt die Jahresplanung des Vorjahres unverändert fort;

c) Aufnahme neuer oder Aufgabe bestehender Tätigkeitsgebiete;

70209

d) Gründung, Veräußerung oder Auflösung von Tochtergesellschaften;
e) Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Beteiligungen an anderen Unternehmen;
f) Errichtung und Schließung von Zweigniederlassungen;
g) Ankauf, Veräußerung und/oder Aufgabe von Patenten und Leistungsschutzrechten aller Art;
h) Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, deren jährliche Summe die in der Jahresplanung (Artikel 5 Absatz 2 lit.

b) dieses Gesellschaftsvertrags) genannten Wertansätze überschreitet;

i) Kreditaufnahmen, Kreditgewährungen und Übernahme von Bürgschaften sowie Eingehung von Wechselverbindlich-

keiten;

j) Spekulationsgeschäfte aller Art;
k) Zusagen von Umsatzprovisionen und Gewinntantiemen gegenüber Angestellten der Gesellschaft;
I) Versorgungszusagen aller Art;
m)Erteilung von Prokuren oder Handlungsvollmachten;
n)Abschluss, Änderung oder Beendigung von Anstellungsverträgen, soweit nicht in der Jahresplanung (Artikel 5 Absatz

2. lit. b) dieser Satzung) vorgesehen;

o)Abschluss von Pacht-, Miet- oder ähnlichen ein Dauerschuldverhältnis begründeten Verträgen, soweit deren jährliche

Summe die in der Jahresplanung (Artikel 5 Absatz 2 lit. b) dieser Satzung) genannten Wertansätze überschritten werden;

p)Abschluss, Änderung oder Beendigung von Beratungs- oder ähnlichen Verträgen;
q) Investitionen, die Ansätze der Jahresplanung (Artikel 5 Absatz. 2. lit. b) dieser Satzung) überschreiten;
r) Wahrnehmung aller Gesellschafterrechte, insbesondere der Stimmrechte, aus der Beteiligung an anderen Gesell-

schaften, soweit es sich um Gegenstände im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 und 3 dieser Satzung handelt;

s) Abschluss von wesentlichen Franchise- und Lizenzverträgen, also von Verträgen, die Durchführung von Projekten,

die unter den Unternehmensgegenstand (Artikel 2 dieser Satzung) fallen, unmittelbar betreffen.

Art. 6. Gesellschafterversammlung.
1. Die von den Gesellschaftern zu treffenden Entscheidungen erfolgen durch Beschlussfassung der Gesellschafterver-

sammlung. Der Abhaltung einer Gesellschafterversammlung bedarf es nicht, wenn sich alle Gesellschafter schriftlich mit
einer zu treffenden Entscheidung oder mit der schriftlichen, per Post, Telefax oder E-Mail erfolgenden Abgabe der Stim-
men einverstanden erklären.

2. Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet in den ersten acht Monaten nach Ablauf eines jeden Geschäfts-

jahres statt. Der Bestimmung der ordentlichen Gesellschafterversammlung unterliegen

a) die Feststellung des Jahresabschlusses;
b) die Verwendung des Bilanzgewinns;
c) die Entlastung der Komplementärin;
d) alle sonstigen Angelegenheiten, bei denen dieser Gesellschaftsvertrag oder das Gesetz die Zustimmung und/oder

die Entscheidung der Gesellschafterversammlung vorsieht.

3. Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung findet statt, wenn es das Wohl und Interesse der Gesellschaft

erforderlich erscheinen lassen und ein Gesellschafter, der mit mindesten zehn Prozent (10%) am festen Kapital der Ge-
sellschaft beteiligt ist, dies verlangt.

Art. 7. Einberufung der Gesellschafterversammlung und Beschlussfassung.
1. Die Gesellschafterversammlung wird vom/von den Geschäftsführer/n der Komplementärin einberufen, wobei jeder

Geschäftsführer der Komplementärin allein einberufungsberechtigt ist. Die Einladung hat unter Mitteilung von Tagesord-
nung und Tagungsort durch eingeschriebenen Brief jeweils an die letzte vom Gesellschafter benannte Anschrift zu erfolgen.
Zwischen der Aufgabe dieses Briefs zur Post und dem Versammlungstermin muss eine Frist von mindestens zwei Wochen
liegen. Die Gesellschafterversammlung wählt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen einen Vorsitzenden; dieser
leitet die Gesellschafterversammlung.

2. Jeder Gesellschafter kann sich aufgrund schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Gesellschafter oder einen zur

Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten vertreten lassen. Die Zurückweisung eines Bevollmächtigten kann nur aus
wichtigem Grund erfolgen.

3. Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der in der Gesellschafterversammlung abgegebenen Stim-

men gefasst, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

4. Die Gesellschafter stimmen auch in eigenen Angelegenheiten mit ab, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes

bestimmt.

5. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des festen Gesellschaftskapitals vertreten

ist.

Ist die Gesellschafterversammlung hiernach nicht beschlussfähig, so ist unter Einhaltung einer Frist von 14 Kalender-

tagen eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese ist in jedem Fall beschluss-
fähig, wenn auf diese rechtsfolgende Einladung ausdrücklich hingewiesen worden ist.

70210

6.  Die  Gesellschafter  können  auch  unter  Verzicht  auf  Förmlichkeiten  der  Einberufung  zu  einer  Gesellschafterver-

sammlung zusammentreten, falls sich alle Gesellschafter damit einverstanden erklären. Unter dieser Voraussetzung sind
auch mündliche und fernmündliche sowie schriftliche (per Post, Telefax oder E-Mail erfolgende) Beschlussfassungen der
Gesellschafter möglich.

7. Die Gesellschafter haben je vollen Anteil ihrer festen Kapitaleinlage eine Stimme.
8. Über jede Gesellschafterversammlung und jede Beschlussfassung außerhalb von Gesellschafterversammlungen ist

eine Niederschrift zu fertigen und vom (bei Beschlussfassung außerhalb von Gesellschafterversammlungen: letzten) Vor-
sitzenden  der  Gesellschafterversammlung  zu  unterzeichnen.  Die  Niederschrift  ist  den  Gesellschaftern  binnen  eines
Monats abschriftlich mitzuteilen.

9. Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschriften müssen innerhalb eines Monats nach Absendung der Nie-

derschriften  schriftlich  beim  (letzten)  Vorsitzenden  der  Gesellschafterversammlung  erhoben  werden,  sofern  sie  der
(letzte) Vorsitzende der Gesellschafterversammlung nicht als berechtigt anerkennt und die Niederschrift entsprechend
berichtigt.

Art. 8. Rechnungslegung.
1. Die Komplementärin hat innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und,

soweit erforderlich, einen Lagebericht nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und den für die Gesellschaft
geltenden handelsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen, sofern sie nicht zu einem früheren Zeitpunkt den Jahresabs-
chluss und, soweit erforderlich, deren Lagebericht aufzustellen hat.

2. Der Jahresabschluss und, soweit erforderlich, der Lagebericht, sind unverzüglich den Gesellschaftern zuzuleiten. Die

Komplementärin hat sodann die Gesellschafterversammlung alsbald zur Beschlussfassung über die Feststellung des Jah-
resabschlusses, die Verwendung des Bilanzgewinns sowie die Entlastung der Komplementärin einzuberufen.

3. Die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Entlastung der Geschäftsführung der Komplementärin gelten durch

die Unterzeichnung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafter, die dem aufgestellten Jahresabschluss zugestimmt
haben, als erfolgt.

Art. 9. Gewinnverwendung.
1. Ohne Rücksicht darauf, ob die Gesellschaft Gewinne oder Verluste erzielt hat, erhält die Komplementärin Ersatz

aller ihr durch die Geschäftsführung erwachsenen Aufwendungen einschließlich etwaiger Mehrwertsteuer; die steuerlich
nicht abzugsfähigen persönlichen Steuern der Komplementärin werden nicht erstattet. Außerdem erhält die Komple-
mentärin  eine  Haftungsvergütung  in  Höhe  von  fünf  Prozent  (5  %)  ihres  zu  Beginn  des  Geschäftsjahres  eingezahlten
Stammkapitals.

2. Ein Verlust der Gesellschaft wird von den Gesellschaftern getragen, und zwar anteilig im Verhältnis ihrer Beteiligung

am festen Gesellschaftskapital, jedoch unter Aufrechterhaltung der beschränkten Haftung der Kommanditisten und ohne
Verpflichtung, die Komplementärin von ihrer Haftung freizustellen. Die danach auf die Gesellschafter entfallenden Ver-
lustanteile werden auf den für jeden Gesellschafter einzurichtenden Verlustvortragskonten gebucht. Die Gewinne des
folgenden Jahres sind zunächst voll zur Tilgung der Verlustvortragskonten zu verwenden, bevor Artikel 9 Absätze 3 bis
5 Anwendung findet.

3. Einzelnen Gesellschaften kann an dem danach verbleibenden Reingewinn mit Zustimmung der anderen Gesellschaf-

ten ein (auch laufender) Vorabgewinn zugebilligt werden.

4. An dem danach noch verbleibenden Reingewinn der Gesellschaft sind die Gesellschafter anteilig im Verhältnis ihrer

Beteiligung am festen Kapital der Gesellschaft beteiligt.

5. Die Gewinnanteile der Gesellschafter sind ihnen nach Feststellung des Jahresabschlusses auf ihre Darlehenskonten

(Artikel 4 Absatz. 3. dieser Satzung) gutzuschreiben.

Art. 10. Entnahmen. Die Komplementärin ist berechtigt, die zur Deckung ihrer Kosten benötigten Mittel (vgl. Artikel

9 Absatz 1.) nach Bedarf zu entnehmen.

Art. 11. Dauer der Gesellschaft, Kündigung.
1. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. Sie kann von einem Gesellschafter nur aus wichtigem Grund gekündigt

werden.

2. Die Kündigung hat durch eingeschriebenen Brief an die Gesellschaft zu erfolgen. Die Komplementärin hat alle Ge-

sellschafter hiervon unverzüglich zu unterrichten, und zwar wiederum durch eingeschriebenen Brief an die letzte vom
jeweiligen Gesellschafter angegebene Anschrift.

Art. 12. Verfügung über Gesellschaftsanteile. Die Übertragung eines Gesellschaftsanteils oder eines Teils eines solchen

an einen Mitgesellschafter ist ohne Zustimmung der Gesellschafterversammlung zulässig und wirksam. Im übrigen bedarf
jede wirksame Verfügung über einen Gesellschaftsanteil oder über einen Teil eines Gesellschaftsanteils eines zustimmen-
den Gesellschafterbeschlusses der Gesellschafterversammlung.

Art. 13. Entgelt bei Ausscheiden eines Gesellschafters.
1. Im Falle des völligen oder teilweisen Ausscheidens eines Gesellschafters steht ihm ein Entgelt zu, das sich zusam-

mensetzt aus:

70211

a) einem Betrag in Höhe der Festeinlage zuzüglich einem etwaigen Guthaben auf seinem Darlehenskonto abzüglich

etwaiger Lastschriften auf seinem Darlehens- und/oder Verlustvortragskonto;

b) einem Bonus, der sich wie folgt bestimmt:
Fünfzig Prozent (50 %) des Anteils des Gesellschafters am Reingewinn der Gesellschaft im ersten auf den Zeitpunkt

des Ausscheidens erfolgenden vollen Geschäftsjahr, der auf seine Beteiligung entfallen würde, falls er nicht ausgeschieden
wäre; das gleiche gilt für die folgenden vier Geschäftsjahre nach Maßgabe folgender Prozentsatz:

- Geschäftsjahr 2 = vierzig Prozent (40 %),
- Geschäftsjahr 3 = dreissig Prozent (30 %),
- Geschäftsjahr 4 = zwanzig Prozent (20 %),
- Geschäftsjahr 5 = zehn Prozent (10 %).
2. Unter "Reingewinn eines Geschäftsjahres" ist der unter Aufrechterhaltung der Bilanzierungs- und Bewertungsme-

thoden  des  letzten  Jahres  vor  dem  Ausscheiden  und  unter  Berücksichtigung  eventueller  Änderungen  aufgrund  einer
steuerlichen Außenprüfung ermittelte Jahresüberschuss zu verstehen.

3. Das Entgelt gemäß Artikel 14 Absatz 1. lit. a) dieser Satzung ist in fünf gleichen Jahresraten nach dem Zeitpunkt des

Ausscheidens fällig und mit zwei Prozent (2%) über dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen. Die Zinsen sind jeweils am
Ende eines Kalenderjahres fällig. Die Gesellschaft hat jederzeit das Recht zur vorzeitigen Auszahlung des Entgelts.

4. Der (anteilige) Bonus gemäß Artikel 14 Absatz 1. lit. b) dieser Satzung wird mit der fristgemäßen Feststellung des

jeweiligen Jahresabschlusses fällig.

5. Sicherheitsleistungen kann der ausscheidende Gesellschafter nicht verlangen.
6. Die Anteile des ausgeschiedenen Gesellschafters werden auf die verbleibenden Gesellschafter verteilt, an jeden im

Verhältnis zu den bereits gehaltenen Anteilen, es sei denn die verbleibenden Gesellschafter einigen sich einstimmig auf
einen andern Verteilungsmodus. Sollte eine verhältnismäßige Aufteilung von allen vollen Anteilen rechnerisch nicht mö-
glich sein und keine Einigung zu einer abweichenden Verteilung erzielt werden, bleiben die nicht verteilbaren Anteile das
ungeteilte gemeinsame Eigentum ohne Stimmrecht der verbleibenden Gesellschafter.

Art. 14. Auflösung der Gesellschaft.
1. Für die Auflösung der Gesellschaft gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
2. Liquidatorin ist die Komplementärin oder, falls auch sie aufgelöst ist, deren frühere(r) Geschäftsführer. Der/die

Liquidator/en  ist/sind  berechtigt,  das  Unternehmen  als  ganzes  mit  Zustimmung  der  Gesellschafterversammlung  zu
veräußern.

3. Das nach Befriedigung der Gläubiger und Ausgleich der Darlehenskonten / Verlustvortragskonten verbleibende

Vermögen der Gesellschaft ist im Verhältnis der Nennbeträge der Kapitaleinlagen unter den Gesellschaftern zu verteilen.
Der/die Liquidator/en hat/haben die Bücher und Schriften der Gesellschaft für die Dauer von fünf Jahren an einem von
der Gesellschaftern bestimmten Ort in Luxemburg-Stadt aufzubewahren bzw. aufbewahren zu lassen.

Art. 15. Erfüllungsort und Gerichtsstand.
1. Erfüllungsort für alle Rechte und Pflichten aus dieser Satzung ist der Sitz der Gesellschaft.
2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Satzung ist das für den Sitz der Gesellschaft zuständige Gericht.

Art. 16. Schlussbestimmungen.
1. Änderungen oder Zusätze zu dieser Satzung bedürfen einer notariellen Beurkundung, ausgenommen die Ausschei-

dungen oder Neuzulassungen von Gesellschaftern gemäss den in der vorliegenden Satzung vorgesehenen Bestimmungen.

2. Sollten Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollten sich in diesem

Gesellschaftsvertrag Lücken herausstellen, so wird hierdurch die Gültigkeit der Satzung im übrigen nicht berührt. Anstelle
der unwirksamen Bestimmungen und/oder zur Ausfüllung von Lücken gilt eine angemessene Regelung, die, soweit recht-
lich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragschließenden gemäß Sinn und Zweck dieser Satzung gewollt haben
oder gewollt hätten, sofern sie den fraglichen Punkt bedacht hätten.

Beruht die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem in ihr angegebenen Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder

Termin), so soll das der Bestimmung am nächsten kommende rechtlich zulässige Maß an dessen Stelle treten.

3. Die mit dieser Urkunde und ihrer Durchführung verbundenen Kosten gehen zu Lasten der Gesellschaft.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

entstehen, werden auf ungefähr zweitausendsechshundert Euro (EUR 2.600,00) geschätzt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2008.

Woraufhin vorliegende Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

70212

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden hat der vorbenannte Komparent einvertreter zusammen mit dem amtierenden

Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Lutgen, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 avril 2008. LAC/2008/15137. - Reçu à 0,50%: cinq cents euros (€ 500.-).

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 26. Mai 2008.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2008068201/227/260.
(080076742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

BVP II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 100.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 129.657.

Par résolutions signées en date du 14 avril 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Donna Wagner, avec adresse professionnelle au 500, Chesterfield Parkway, PA-19355

Malvern, Etats-Unis, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.

- nomination de George J. Alburger Jr., avec adresse professionnelle au 500, Chesterfield Parkway, PA-19355 Malvern,

Etats-Unis, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008068312/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06377. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Macquarie Luxembourg Gas S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 24.850,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 101.699.

Par résolution prise en date du 16 avril 2008, les associés ont pris la décision d'accepter la démission de Bruno Bagnouls

avec adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2008.

Référence de publication: 2008068313/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06386. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

ZBI SCAIAP Opportunity Real Estate Fund One S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous

la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 127.856.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 31 mars 2008, les actionnaires ont pris la décision de renouveler

le mandat de réviseur de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg pour une
période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

70213

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008068314/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06366. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

QLux Aviation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 138.693.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the seventh of May.
Before Us M 

e

 Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

QAV Cayman Holdings, Ltd., an exempted company incorporated with limited liability under the laws of the Cayman

Islands, having its registered office at Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman,
KY1-9002, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies in the Cayman Islands under number WK-205989,

Here represented by Xavier Borremans, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):

Chapter I.- Form, name, registered office, object, duration

Art. 1. Form - Corporate name. There is formed a private limited liability company under the name "QLux Aviation

S.à r.l." which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by
the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present
articles of incorporation (hereafter the "Articles").

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised

to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would

prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole
Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.

2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 3. Object.
3.1 The Company's object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Lu-

xembourg  or  foreign  entities,  by  any  means  and  to  administrate,  develop  and  manage  such  holding  of  interests  or
participations.

3.2  The  Company  may  make  real  estate  related  investments  through  indirect  participations  in  subsidiaries  of  the

Company owning such investments.

3.3 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means.
3.4 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries

or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the
Company  or  any  company  belonging  to  the  same  group  as  the  Company  (hereafter  referred  to  as  the  "Connected
Companies"), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged
in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

70214

3.5 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will

not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments
convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits
of and in accordance with the provisions of Luxembourg Law;

3.6 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital, shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at thirty thousand US Dollars (USD 30,000.-) represented by thirty thousand (30,000)

shares each having a par value of one US Dollars (USD 1.-) (hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the
Shares are together referred to as the "Shareholders".

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is

admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

Chapter III.- Management

Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

one manager, he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board
of managers ("conseil de gérance") (hereafter the "Board of Managers")

8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by

a resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have

all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound

by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the sole signature of any manager or by
the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or,
in case of plurality of managers, by any two managers.

Art. 11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers.
11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two managers may delegate its/their powers for specific

tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two managers will determine any such agent's respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.

70215

Art. 12. Meeting of the board of managers.
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board

of Managers shall appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by any two managers present or represented

at the meeting.

12.8 Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the

Board of Managers.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - votes.
13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders'

meeting and takes the decisions in writing.

13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights.

13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can

be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be

convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken

and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt

them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of
nationality of the Company requires unanimity.

Chapter V.- Business year

Art. 14. Business year.
14.1 The Company's financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.
14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of

plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Distribution right of shares.
15.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted

and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve
fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.

15.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the

Shareholders in accordance with the provisions of Article 13.7 above.

70216

15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of

Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Chapter VI.- Liquidation

Art. 16. Dissolution and liquidation.
16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable

legal provisions.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 17. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31

December 2008.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows:
Shares:

Shares

QAV Cayman Holdings, Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of thirty thousand US Dollars (USD 30,000.-) corresponding

to a share capital of thirty thousand US Dollars (USD 30,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has
been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,800.- (One thousand eight hundred
euro).

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, QAV Cayman Holdings, Ltd., repre-

senting the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following
resolutions:

1) Are appointed as Managers of the Company for an undetermined period:
- Mrs Séverine Canova, legal and operational supervisor, born on July 16, 1975 in Creutzwald, France, whose address

is at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg; and

- QAV07 Barnstorming, LLC, a Delaware limited liability company, registered with Secretary of the State of the State

of Delaware under number 4427320, having its registered office at 301 Commerce Street, Suite 3200, Forth Worth,
Texas 76102.

2) The Company shall have its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (Grand Duchy

of Luxembourg).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le sept mai.

70217

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

QAV Cayman Holdings, Ltd., une exempted company incorporated with limited liability selon les lois des Iles Caymans,

ayant son siége social au Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002,
Cayman Islands, enregistrée auprès du Registrar of Companies in the Cayman Islands sous le numéro WK-205989,

Ici représentée par Xavier Borremans, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 .- Forme, nom, siège social, objet, durée

Art. 1 

er

 . Forme - dénomination.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "QLux

Aviation S.à r.l" qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10
août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que par les présents statuts de
la Société (ci-après les "Statuts").

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société

dans la Ville de Luxembourg.

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-

promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être  transféré  provisoirement  à  l'étranger  jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales;  cette  mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou le
Conseil de Gérance de la Société.

2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations

dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces intérêts
et participations.

3.2 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, à travers la détention indirecte de participations dans

des filiales de la Société détenant ces investissements.

3.3 La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes

d'avoirs par tous moyens.

3.4 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés,
qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe
que la Société (ci-après reprises comme les "Sociétés Apparentées"), étant entendu que la Société n'entrera dans aucune
opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du
secteur financier.

3.5 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera

dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments
convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de

dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par
la loi luxembourgeoise;

70218

3.6 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital, parts

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente mille US Dollars (USD 30.000,-) représenté par trente mille (30.000)

parts sociales (les "Parts Sociales"), chacune ayant une valeur nominale de un US Dollar (USD 1,-). Les détenteurs de
Parts Sociales sont définis ci-après les "Associés".

5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime

d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

Art. 6. Indivisibilité des parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par

Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la
Société.

Art. 7. Transfert des parts.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

Titre II.- Gérance

Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associé(s). Dans le

cas d'un seul gérant, il est défini ci-après comme le Gérant Unique. En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un
conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec

ou sans motif, par décision des Associé(s).

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous

pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Art. 10. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée

par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de tout gérant ou
par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique
ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants.

Art. 11. Délégation et agent du gérant unique et du conseil de gérance.
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou

plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants déterminent les responsabilités et la rémuné-

ration quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur
mandat.

Art. 12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant. Le Conseil

de Gérance nommera un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les

gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre gérant,

pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une
lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter, moyennant confirmation
écrite ultérieure.

70219

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d'entendre et d'être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du

Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou
dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par deux Gérants présents ou représentés

aux réunions.

12.8 Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant ou lors de

la réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV.- Assemblée générale des associes

Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associes - votes.
13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale

des Associés et prend les décisions par écrit.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion

peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer

conformément aux dispositions légales applicables.

13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner

son vote part écrit.

13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou

par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du

capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par
une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres
dispositions légales. Le changement de nationalité de la Société requière l'unanimité.

Titre V.- Exercice social

Art. 14. Exercice social.

14.1 L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas

de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 15. Droit de distribution des parts.
15.1 Le bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent (5%) seront

prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-
ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des

Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds dispo-
nibles soient distribués.

15.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec

les dispositions de l'Article 13.7 ci-dessus.

15.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance

peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation
de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à
distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve
établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices
effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).

70220

Titre VI.- Liquidation

Art. 16. Dissolution et liquidation.
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite

de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales

applicables.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII.- Loi applicable

Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:
Parts Sociales:

Parts

Sociales

QAV Cayman Holdings, Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

trente mille US Dollars (US Dollars 30.000,-) correspondant à un capital de trente mille US Dollars (US Dollars 30.000,-)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.800,- (mille huit cents euros).

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, QAV Cayman Holdings, Ltd., représentant

la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1- Sont nommés Gérants de la Société pour une période indéterminée:
- Madame Séverine Canova, legal and operational supervisor, née le 16 juillet 1975 à Creutzwald, France, dont l'adresse

est à 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg; et

- QAV07 Barnstorming, LLC, une Delaware limited liability company, enregistrée auprès du Secretary of State of the

State of Delaware sous le numéro 4427320, ayant son siège social au 301 Commerce Street, Suite 3200, Forth Worth,
Texas 76102.

2- Le siège social de la Société est établi à 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: X. BORREMANS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 mai 2008. Relation: LAC/2008/19057. — Reçu quatre-vingt-dix-sept euros vingt-

et-un cents (0,50% = 97,21.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008068224/242/427.
(080076350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

70221

NTR Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 87.548.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NTR FINANCE LUXEMBOURG S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Manager / Manager

Référence de publication: 2008068057/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ06864. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080076392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

NTR Treasury Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 94.225.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NTR Treasury Luxembourg S.à R.L.
Signature / Signature
<i>Manager / Manager

Référence de publication: 2008068056/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ06869. - Reçu 38,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Savizor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 51.355.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SAVIZOR S.A.
Services Généraux de Gestion S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008068046/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ06871. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Nordica Administration S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 77.107.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le mercredi 21 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008068097/4235/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2008, réf. LSO-CQ07752. - Reçu 99,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

70222

WPP Luxembourg Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.793.243.400,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 90.028.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Lennart Stenke / Signature
<i>Manager / -

Référence de publication: 2008068060/5499/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ07134. - Reçu 208,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080076369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Aliunde S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 115.597.

Le bilan au 31 DECEMBRE 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2008.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2008068029/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05529. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Degussa Re, Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 18.707.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008068001/2094/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2008, réf. LSO-CP08584. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Entreprise Applications and services Integration Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 55, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 83.464.

Le bilan au 31 juillet 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28.05.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008068004/4376/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08424. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

70223

Zurich Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 69.748.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008068002/2094/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2008, réf. LSO-CP08593. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080076635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Zurich Group Funding Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 104.156.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008068000/2094/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2008, réf. LSO-CP08589. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

The Swatch Group Re (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5835 Alzingen, 10, rue Hondsbreck.

R.C.S. Luxembourg B 108.652.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008067999/2094/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2008, réf. LSO-CP08587. - Reçu 42,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Sword Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 105, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 71.238.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 28 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008068003/4376/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2008, réf. LSO-CQ03798. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

70224


Document Outline

Agria Finance S.A.

Aliunde S.A.

Astringo Holdings S.à r.l.

ATEEL - Allied Technology Experts. Enterprise of Luxembourg S.à r.l.

Beauty Case, s.à r.l.

Bocimar Lux S.A.

BVP II S.à r.l.

Capital Ventures (Australasia) Sàrl

Carspaze Services G.m.b.H.

Carspaze Services GmbH &amp; Co. KG

Centre de Transferts Electroniques

Commercial Real Estate Investments S.A.

CVI GVF Luxembourg Seven S.à r.l.

CVI GVF Luxembourg Six S.à r.l.

Degussa Re

Entreprise Applications and services Integration Luxembourg

Europay Luxembourg, Société coopérative

Imbrex Holding S.A.

Info-Logement a.s.b.l.

ITW Alpha Sàrl

Logica General Holdings S.à r.l.

Logica Holdings Luxfive S.à r.l.

Logica Holdings Luxfour S.à r.l.

Logica Holdings Luxthree S.à r.l.

Logica Holdings Luxtwo S.à r.l.

Macquarie Luxembourg Gas S. à r.l.

MEIF Germany Eight S.àr.l.

Nordica Administration S.à r.l.

Novo S.A.

NTR Finance Luxembourg S.à r.l.

NTR Treasury Luxembourg S.à r.l.

PPG Luxembourg Finance S.àr.l.

QLux Aviation S.à r.l.

Randstad Holding Luxembourg S.à r.l.

Sàrl Wilmes &amp; Söhne

Savizor S.A.

Sodema S.A.

Stodiek Beteiligung II S.à r.l.

Stryker Luxembourg S.à r.l.

Sword Technologies S.A.

The Swatch Group Re (Luxembourg) S.A.

WPP Luxembourg Holdings S.àr.l.

ZBI SCAIAP Opportunity Real Estate Fund One S.C.A., SICAR

Zurich Finance (Luxembourg) S.A.

Zurich Group Funding Luxembourg S.A.