This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1383
5 juin 2008
SOMMAIRE
Aintree Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
66340
Am Bistrot S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66378
Assurances Consultances Services S.A. . .
66383
Astor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66338
Aztec Financial Services (Luxembourg)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66369
Bavaria (BC) Luxco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66344
Beckmann & Jörgensen Holding S.A. . . . . .
66339
Canisse S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66340
Carolus Investment Corporation . . . . . . . .
66384
Carolus Investment Corporation . . . . . . . .
66384
Colony Capital s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66381
Compagnie PIM, Participations Immobiliè-
res et Mobilières S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66338
DeA Capital Investments S.A. . . . . . . . . . . .
66339
DEFILUX (Développement et Finance Lu-
xembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66365
Den Holzspiecht S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
66383
Eldrige S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66338
FCT Electronics Europe S.à r.l. . . . . . . . . . .
66378
Findexa Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
66342
First Euro Industrial Properties III S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66384
Frisky S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66378
Gapi Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66382
ID Concept S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66378
International Consultance Services S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66383
Isolutions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66383
KEV Germany Fuhrbergerstrasse S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66344
KEV Germany Nikolaistrasse S.à r.l. . . . . .
66371
Kikkolux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66338
Lexi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66339
Life Annuity Company . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66341
Lockdale Lux, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66374
Lucos Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
66382
Lucos Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
66344
Mond S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66343
M.S. International Finance S.A. . . . . . . . . . .
66343
Natixis Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
66340
Nova Troisième S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66339
Onion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66342
Paris Express Service-European Sales et
Coordination S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66383
Patron Lepo VIII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
66376
Patron Lepo V S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66343
Patron Weghell Holding S.à r.l. . . . . . . . . .
66372
Power Transmission Finance S.A. . . . . . . .
66363
ProLogis UK CCXVI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
66364
ProLogis UK CCXVI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
66367
Stratis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66341
SwissCaps Holding (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66357
Terualent Lux s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66374
VDV Invest Luxemburg S.A. . . . . . . . . . . . .
66375
Zermatt International S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
66365
66337
Astor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 11.300.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008063755/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2008, réf. LSO-CQ01987. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080071030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.
Compagnie PIM, Participations Immobilières et Mobilières S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 55.804.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008063756/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2008, réf. LSO-CQ01981. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080071031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.
Eldrige S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 87.177.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008063757/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2008, réf. LSO-CP09650. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080071062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.
Kikkolux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 104.333.925,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 109.992.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance de la Société tenue le 31 janvier 2008i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance du 31 janvier 2008 que Séverine Michel, ayant son
adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, a été nommée déléguée à la gestion journalière
de la Société.
Séverine Michel
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2008063792/3794/16.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04142. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080071546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.
66338
Beckmann & Jörgensen Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 43.101.
Il résulte de la décision des Associés tenue au siège social en date du 17 avril 2008 de la société BECKMANN &
JÖRGENSEN HOLDING S.A. que les associés ont pris les décisions suivantes:
1 - Démission de l'Administrateur suivant.:
Monsieur Hans Nakken né le 14 novembre 1970 à Rotterdam, au Pays-Bas, et résidant 17, Nazarethdreef, 2970 Schilde,
en Belgique.
2 - Election du nouvel Administrateur B pour une durée indéterminée avec effet immédiat au 17 avril 2008.:
Madame Louise Hanna Marie Nakken, née le 30 avril 1968 à Rotterdam, Pays-Bas, et résidant 15 Salhusveien, 5529
Haugesund, en Norvège.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>BECKMAN & JÖRGENSEN HOLDING S.A.
i>Equity Trust Co (Luxembourg) S.A.
<i>Agent domiciliaire
i>Signatures
Référence de publication: 2008063759/683/22.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2008, réf. LSO-CP10054. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080071621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.
Nova Troisième S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 129.593.
Le bilan au 31/12/07 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008063763/7663/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2008, réf. LSO-CQ02807. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080071172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.
DeA Capital Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 127.685.
Le bilan au 31/12/07 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008063764/7663/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2008, réf. LSO-CQ02808. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080071175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.
Lexi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 57.956.
Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
66339
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008063772/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2008, réf. LSO-CQ02921. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080071085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.
Aintree Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 89.925.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 23 avril 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs et
du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Marc KOEUNE
- Madame Nicole THOMMES
- Madame Andrea DANY
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2014.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2008064080/693/23.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2008, réf. LSO-CQ02015. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080071435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.
Canisse S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 75.168.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 14 mai 2008.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Pour Maître Jean SECKLER
<i>Notaire
i>Par délégation Monique GOERES
Référence de publication: 2008064079/231/15.
(080072159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Natixis Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 35.141.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 15 avril 2008i>
En date du 15 avril 2008, l'Assemblée Générale a décidé:
- d'accepter la démission de Madame Roberte Marchal Chapoulart, née le 25 mai 1957 à Vittel avec adresse profes-
sionnelle au 26/28, rue Neuve Tolbiac, 75013 Paris et de Monsieur Vincent Gontier, né le 29 juillet 1954 à Lyon avec
adresse professionnelle au 21, Quai d'Austerlitz, 75013 Paris, de leur poste d'administrateur avec effet au 15 avril 2008;
- de nommer:
66340
* Monsieur José-Maria Iceta, né le 27 mai 1957 à Madrid (Espagne) avec adresse professionnelle 68/76, Quai de la
Rapée, 75012 Paris et,
* Monsieur Jean-Erwin Nizet, né le 10 janvier 1963 à Monthey (Suisse) avec adresse professionnelle 68/76, Quai de la
Rapée, 75012 Paris,
en remplacement de Madame Roberte Marchal Chapoulart et Monsieur Vincent Gontier, démissionnaires et,
* Monsieur Emmanuel Strauss, né le 3 octobre 1961 à Dijon avec adresse professionnelle 26/28, rue Neuve Tolbiac,
75013 Paris,
pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes de 2013;
- de renouveler les mandats de:
* Mademoiselle Evelyne Etienne, née le 15 juin 1954 à Paris 12
ème
avec adresse professionnelle au 51, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg,
* Monsieur François Casassa, né le 5 février 1956 à Manosque avec adresse professionnelle au 30, avenue Pierre
Mendès-France, 75013 Paris,
* Monsieur Jean-Louis Delvaux, né le 23 mars 1946 à Paris 14
ème
avec adresse professionnelle au 5/7, rue de Montessuy,
75007 Paris,
* Monsieur Bruno Martin, né le 4 juin 1950 à Paris 9
ème
, avec adresse professionnelle au 68/76, Quai de la Rapée,
75012 Paris,
* Monsieur André-Jean Olivier, né le 29 septembre 1953 à Paris 15
ème
, avec adresse professionnelle au 30, avenue
Pierre Mendès-France, 75013 Paris, et,
* Monsieur Jean-Michel Strasser, né le 10 septembre 1950 à Paris 17
ème
, avec adresse professionnelle au 30, avenue
Pierre Mendès-France, 75013 Paris,
pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes de 2013.
Signature.
Référence de publication: 2008064078/66/38.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2008, réf. LSO-CQ04524. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080071431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.
Life Annuity Company, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 131.869.
Il résulte des transferts de parts sociales en date du 6 décembre 2007 que:
- M. Richard L. RODEN, résidant à 54, rue de Colinet, 1380, Lasne, Belgique, a transféré 124 parts sociales à Mme
Pollyanna WAN, résidante à 42A, Arbor Lane, Winnersh, Berkshire, RG41 5JD, Grande-Bretagne.
Luxembourg, le 7 mai 2008.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008064081/2249/18.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2008, réf. LSO-CQ02300. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080071445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.
Stratis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 75.094.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 18 avril 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs et
du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
66341
- Monsieur Marc KOEUNE
- Madame Nicole THOMMES
- Madame Andrea DANY
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2014.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2008064077/693/23.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2008, réf. LSO-CQ02022. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080071414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.
Onion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 83.177.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 5 mai 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs et du
commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Marc KOEUNE
- Madame Nicole THOMMES
- Madame Andrea DANY
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est FIDEREVISA S.A., avec siège social à 14, via G.B. Pioda, CH-6901 Lugano.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2014.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2008064076/693/23.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2008, réf. LSO-CQ02652. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080071411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.
Findexa Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: NOK 68.769.600,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 100.546.
Par résolutions signées en date du 23 avril 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Tomas Franzén, avec adresse professionnelle au 40, Gustav III boulevard, 169 87
Stockholm, Suède, de son mandat de gérant avec effet au 7 mai 2008.
- nomination de Mattias Lundqvist, avec adresse professionnelle au 40, Gustav III boulevard, 169 87 Stockholm, Suède,
au mandat de gérant, avec effet au 7 mai 2008 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008064048/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2008, réf. LSO-CQ02881. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080071106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.
66342
Mond S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 63.794.
<i>Extrait des résolutions prises lors du procès-verbal du conseil d'administration tenue au siège social en date du 18 avril 2008i>
Monsieur BRAVI TONOSSI Gabriele Mario, avocat, né le 24.02.1940 à Milan (Italie), domicilié à Altamira Suites, 1,
avenida con 1 transversal de Los Palos Grandes, Caracas, Venezuela, est coopté comme nouvel administrateur. Son
mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008. L'Assemblée Générale des Actionnaires,
lors de sa prochaine réunion, procédera à l'élection définitive.
Luxembourg, le 18 avril 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>MOND S.A.
i>HEITZ Jean-Marc / REGGIORI Robert
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008064060/545/19.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2008, réf. LSO-CQ03077. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080071261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.
M.S. International Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 69.704.
<i>Résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinairei>
<i>tenue à Luxembourg en date du 21 décembre 2007i>
Le mandat des administrateurs étant arrivé à leur terme, l'assemblée a nommé en qualité de nouveaux administrateurs
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010:
- M. Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,
- M. Mario Scudellari, administrateur de société, domicilié au 8, via Chiaratti A., Adria (Rovigo), Italie,
- Director S.à r.l., une société ayant son siège Social au 16, rue de Nassau, L- 2213 Luxembourg, en qualité d'Admi-
nistrateur.
Le mandat de l'administrateur-délégué étant arrivé à son terme, l'assemblée a nommé M. Mario Scudellari, préqualifié,
aux fonctions d'Administrateur-délégué, ayant tous pouvoirs aux fins d'engager la société jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2007.
LUXFIDUCIA S.à r.l., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008064059/1629/24.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08375. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080071226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.
Patron Lepo V S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 123.342.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 51699 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Joseph ELVINGER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008064098/211/11.
(080072306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
66343
KEV Germany Fuhrbergerstrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 130.841.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 14 mai 2008.
Jean-Joseph WAGNER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008064167/239/12.
(080071940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Lucos Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 111.768.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008064172/236/11.
(080072281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Bavaria (BC) Luxco, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 130.824.
In the year two thousand and eight, on the eleventh of April.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
is held an extraordinary general meeting of shareholders of Bavaria (BC) Luxco, a société en commandite par actions
incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9A, Parc
d'Activité Syrdall, L-5365, Munsbach, urban district of Schuttrange, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies' register under registration number B 130824, incorporated pursuant to a deed of
Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 25 June 2007, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, on 22 September 2007 under number 2066 (hereafter the "Company"). The articles of incor-
poration of the Company were last amended by a deed of Maître Joseph Elvinger dated 31 July 2007, published in the
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 2220 on 6 October 2007 (the "Company").
The meeting is opened at 2.30 p.m., with Mrs Caroline Streiff, maître en droit, professionally residing in Luxembourg,
in the chair,
who appoints as secretary Mrs Flora Gibert, notary clerk, with professional address in Luxembourg, who was also
designated as scrutineer.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of the "Definitions" Section of the Company's articles of association:
a. Introduction of the following new definitions which shall have the following wording:
i. "Accretion Start Date": means (i) in the case of an Existing Executive, 1 August 2007 and (ii) in the case of any other
Executive, the date of commencement of such Executive's employment with the Company or any of its Subsidiaries.
ii. "Existing Executive": means any Executive who was employed by the Company or one of its Subsidiaries on 1 August
2007.
iii. "Outstanding Loan Amount": means, with respect to any loan that any Subsidiary of the Company that is not
organized under the laws of Luxembourg has made to a holder of Executive Securities to fund the acquisition of Executive
Securities, the outstanding amount of such loan (including any accrued but unpaid interest) as at the nearest practicable
date to the date on which closing of the transactions contemplated by Section 6.14 takes place.
66344
iv. "Policies": means the written policies of the Company or any of its Subsidiaries regarding significant matters such
as theft, fraud, dishonesty, discrimination, harassment, substance abuse or the prohibition of other conduct of a degree
of seriousness similar to the foregoing, as well as the policy on reserved matters (Geschäftsordnung) which in each case
have been formally approved by the board of directors or other governing body of the relevant company.
b. Amendment of the following existing definitions in order for them to read as follows:
i. "Bad Leaver": means any Executive (i) whose employment by, or (ii) whose appointment to the office to which he
was appointed in respect of, the Company or any of its Subsidiaries is terminated for Cause.
ii. "Cause": means (i) fraud or material misappropriation with respect to the business or assets of the Company or any
of its Subsidiaries, (ii) commission of a felony or crime involving moral turpitude, commission of any other act or omission
involving material dishonesty or fraud, or commission of any act that constitutes a breach of the Policies, (iii) continued
failure to accept and cooperate with actions and initiatives assigned to the Executive by the Company or any of its
Subsidiaries which are consistent with the duties of an officer of a company of similar size and in a similar business to that
of the Company, and which actions and initiatives do not breach or violate any applicable law or the terms of such
Employee's employment contract, for 15 days following receipt of written notice by the Executive of such failure, (iv)
gross negligence or willful breach of contractual duties with respect to the Company or any of its Subsidiaries, (v) any
breach of sections 3, 5 and 7 of any subscription or Securityholders agreement to which the Executive may be a party,
or (vi) any material breach of any employment agreement which may be entered into between the Company or any of
its Subsidiaries and the Executive; provided that, in the case of (v) and (vi) above, such breach shall not have been cured
by the Executive within 15 days following receipt of written notice by the Executive of such breach.
iii. "Executive": means (i) any natural Person employed by, or party to a consultancy agreement with, the Company or
any of its Subsidiaries and (ii) any holder of Executive Securities of which only an Executive or members of his Family
Group are the beneficial owners.
iv. "Executive Securities": means, with respect to an Executive, the Class A Ordinary Shares directly or indirectly
subscribed, purchased, or held by such Executive or such Executive's Permitted Transferees.
v. "Fair Market Value": means, with respect to any Security or Securities, the fair market value of such Securities as
determined by the Manager acting in good faith, including, for the avoidance of doubt, the Unvested Distribution Portion
for each such Security.
vi. "Family Group": means, with respect to any Executive, such Executive's parents (whether natural or by adoption),
spouse (for so long as such Person remains a spouse of that Executive), children (whether natural or by adoption), the
personal representatives of a deceased Executive and heir or beneficiary of such Executive.
vii. "Good Leaver": means any Executive who is a Leaver due to death, permanent disability or voluntary resignation
for Good Reason, or whose employment by, or appointment to office with, the Company or any of its Subsidiaries is
terminated without Cause or whose employment has expired and not been renewed (irrespective of the reason for the
non-renewal).
viii. "Good Leaver Accretion Percentage": means, in relation to the Executive Securities, vesting in the following
amounts over the following periods so long as the Executive continues to be employed by the Company or any of its
Subsidiaries:
Relevant Anniversary
Executive
Securities
Before 1st anniversary of Accretion Start Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0%
On or after 1st anniversary but before the 2nd anniversary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
On or after 2nd anniversary but before the 3rd anniversary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40%
On or after 3rd anniversary but before the 4th anniversary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60%
On or after 4th anniversary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80%
provided that, if the Executive's employment with the Company or any of its Subsidiaries ends on a Relevant Anni-
versary or on the day before such Relevant Anniversary, the respective Executive's employment shall be deemed, for the
purposes of calculating the Good Leaver Accretion Percentage, to have continued in existence until the end of the day
of the respective Relevant Anniversary.
Notwithstanding the time vesting set out above, in the event of (i) a Sale of the Company or (ii) a Public Sale or any
sale of Securities to an Independent Third Party in one transaction or a series of related transactions following which the
Bain Investors (x) shall own less than 15% of the Shares issued to them on 31 July 2007 and (y) shall no longer Control
the Company, all of the Executive Securities that remain unvested shall become vested and the Good Leaver Accretion
Percentage shall be deemed to be 100%.
ix. "Leaver": means an Executive who has ceased to (i) be an employee of the Company or any of its Subsidiaries or
(ii) hold the office to which he was appointed in respect of the Company or any of its Subsidiaries (otherwise than as a
result of being appointed to another office with the Company or any of its Subsidiaries).
x. "Medium Leaver": means any Executive who voluntarily resigns without Good Reason.
66345
xi. "Medium Leaver Accretion Percentage": means, in relation to an Executive's Securities, vesting in the following
amounts over the following periods so long as the Executive continues to be employed by the Company or any of its
Subsidiaries:
Relevant Anniversary
Executive
Securities
Before 1st anniversary of Accretion Start Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0%
On or after 1st anniversary but before the 2nd anniversary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10%
On or after 2nd anniversary but before the 3rd anniversary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
On or after 3rd anniversary but before the 4th anniversary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30%
On or after 4th anniversary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40%
provided that, if the Executive's employment with the Company or any of its Subsidiaries ends on a Relevant Anni-
versary or on the day before such Relevant Anniversary, the respective Executive's employment shall be deemed, for the
purposes of calculating the Medium Leaver Accretion Percentage, to have continued in existence until the end of the day
of the respective Relevant Anniversary.
Notwithstanding the time vesting set out above, in the event of (i) a Sale of the Company or (ii) a Public Sale or any
sale of Securities to an Independent Third Party in one transaction or a series of related transactions following which the
Bain Investors (x) shall own less than 15% of the Shares issued to them on 31 July 2007 and (y) shall no longer Control
the Company, all of the Executive Securities that remain unvested shall become vested and the Medium Leaver Accretion
Percentage shall be deemed to be 100%.
xii. "New Executive": any Executive employed by the Company or any of its Subsidiaries who is not (i) an Existing
Executive or (ii) a holder of Shares as at 31 January 2008.
xiii. "Permitted Trust": of a holder of Shares shall mean a trust or a comparable corporate entity of which the relevant
Executive and/or his Family Group is a beneficiary but only for as long as such holder(s) remain(s) a beneficiary.
xiv. "Relevant Anniversary": means, in respect of Executive Securities, an anniversary of the Accretion Start Date.
2. Amendment of Section 6.14 "Right to Purchase Certain Class A Ordinary Shares" of the Company's articles of
association:
a. Amendment of Section 6.14 a) "Call Option" which shall now read as follows:
"a) Call Option. In the event that (i) the Company or any of its Subsidiaries shall deliver to an Executive a notice of
termination of employment or a notice of termination of a consultancy agreement (a "Termination Notice") or (ii) an
Executive is no longer employed by, or party to any consulting agreement with, the Company or any of its Subsidiaries
for any reason or (iii) an Executive ceases to hold the office to which he or she was appointed (such as that of Managing
Director or proxy holder (Prokurist)) in respect of the Company or any of its Subsidiaries, whether due to termination
of employment, resignation, removal from such office or for any reason other than appointment to another office with
the Company or any of its Subsidiaries (the earlier of (x) the date of delivery of such Termination Notice, (y) the date of
such Executive's termination of employment and (z) the date the Executive ceases to hold such office being referred to
herein as the "Termination Date") in any of the circumstances specified in Sections 6.14b), 6.14c) and 6.14d) below, such
Executive's Executive Securities, whether held by such Executive or by one or more of his or her Permitted Transferees,
will be subject to purchase by either the Company, or at the Manager's discretion, the Bain Investors, or by such other
Persons as the Bain Investors may identify, pursuant to the terms and conditions set forth in this Section 6.14 (the "Call
Option")."
b. Amendment of Section 6.14 d) "Bad Leaver" which shall now read as follows:
"d) Bad Leaver. If an Executive is a Bad Leaver, then the Bain Investors or the Company shall have the right to acquire
some or all of the Executive Securities held by such Executive (or his Permitted Transferees) at the lower of Original
Cost and Adjusted Fair Market Value.
PROVIDED, that, where there remains an Outstanding Loan Amount with respect to the Executive, the consideration
that would otherwise be payable to the Executive in accordance with Section 6.14b), Section 6.14c) or Section 6.14d) (as
the case may be) pursuant to the exercise of the Call Option shall be reduced by an amount equal to any Outstanding
Loan Amount that remains once all sums that are permitted under the Executive's employment contract to be set-off
against the Outstanding Loan Amount have been so set-off."
c. Amendment of the first sentence of Section 6.14 e) "Call Option Exercise Procedures" which shall now read as
follows:
"e) Call Option Exercise Procedures". In the event that the Manager decides in its sole discretion in accordance with
this Section 6.14 that the Bain Investors shall have the right to purchase the Executive Securities subject to the Call
Option, it shall, within 45 days of the Termination Date of the relevant Executive, deliver written notice to the Bain
Investors setting forth the name of such Executive and the Termination Date."
d. Amendment of Section 6.14 f) "Closing" which shall now read as follows:
"f) Closing. The closing of the transactions contemplated by this Section 6.14 will take place on the date designated
by the Company or the Bain Investors. The Bain Investors, the New Executives and/or the Company, as the case may
66346
be, will pay for the Executive Securities to be purchased pursuant to the Call Option by delivery of a check or a wire
transfer of immediately available funds payable to the holder of such Executive Securities in the aggregate amount equal
to the purchase price for such Executive Securities less the Outstanding Loan Amount, if applicable. The Bain Investors,
the New Executives and/or the Company, as the case may be, shall receive customary representations and warranties
from each seller regarding the sale of the Executive Securities to the relevant purchaser, including but not limited to the
representation that such seller has good and marketable title to the Executive Securities to be transferred free and clear
of all liens, claims and other encumbrances. If the Company purchases any Executive Securities subject to the Call Option
allocated to it, the Securities so acquired shall be redeemed in accordance with the provisions of Article 49-8 of the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended."
3. Amendment of Section 6.16 "Liquidation Rights" of the Company's articles of association which shall now read as
follows:
"In the event of a liquidation, after payment of all debts and liabilities of the Company, the residual assets of the Company
will be distributed to the Shareholders in the manner set forth in these Articles. Neither a merger nor consolidation of
the Company into or with any other entity or entities, nor a merger or consolidation of any other entity or entities into
or with the Company, nor a sale, transfer, lease or exchange (for cash, securities or other consideration) of all or any
part of the assets of the Company shall be deemed to be a liquidation within the meaning of this Section 6.16, unless such
merger, consolidation, sale, transfer, lease or exchange shall be in connection with or intended to be a plan of complete
liquidation, dissolution or winding up of the Company."
4. Amendment of Section 7.3 b) "Limitation on Transfer" of the Company's articles of association which shall now read
as follows:
"b) Limitations on Transfer. Prior to the tenth Relevant Anniversary, or during such shorter period as may be consistent
with applicable law, the Shareholders may not validly transfer the Shares without the prior written approval of the Manager
or unless otherwise permitted pursuant to this Section 7.3."
5. Amendment of Article XIII "Accounting Year" of the Company's articles of association which shall now read as
follows:
" Art. 13. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on 1 August and shall terminate on 31
July."
II. - That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties will also remain annexed to the present deed.
III. - That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to add new definitions in "Definitions" Section of the articles of association which shall
have the following wording:
i. "Accretion Start Date": means (i) in the case of an Existing Executive, 1 August 2007 and (ii) in the case of any other
Executive, the date of commencement of such Executive's employment with the Company or any of its Subsidiaries.
ii. "Existing Executive": means any Executive who was employed by the Company or one of its Subsidiaries on 1 August
2007.
iii. "Outstanding Loan Amount": means, with respect to any loan that any Subsidiary of the Company that is not
organized under the laws of Luxembourg has made to a holder of Executive Securities to fund the acquisition of Executive
Securities, the outstanding amount of such loan (including any accrued but unpaid interest) as at the nearest practicable
date to the date on which closing of the transactions contemplated by Section 6.14 takes place.
iv. "Policies": means the written policies of the Company or any of its Subsidiaries regarding significant matters such
as theft, fraud, dishonesty, discrimination, harassment, substance abuse or the prohibition of other conduct of a degree
of seriousness similar to the foregoing, as well as the policy on reserved matters (Geschäftsordnung) which in each case
have been formally approved by the board of directors or other governing body of the relevant company.
The general meeting further resolves to amend certain definitions in "Definitions" Section of the articles of association
which shall now read as follows:
i. "Bad Leaver": means any Executive (i) whose employment by, or (ii) whose appointment to the office to which he
was appointed in respect of, the Company or any of its Subsidiaries is terminated for Cause.
66347
ii. "Cause": means (i) fraud or material misappropriation with respect to the business or assets of the Company or any
of its Subsidiaries, (ii) commission of a felony or crime involving moral turpitude, commission of any other act or omission
involving material dishonesty or fraud, or commission of any act that constitutes a breach of the Policies, (iii) continued
failure to accept and cooperate with actions and initiatives assigned to the Executive by the Company or any of its
Subsidiaries which are consistent with the duties of an officer of a company of similar size and in a similar business to that
of the Company, and which actions and initiatives do not breach or violate any applicable law or the terms of such
Employee's employment contract, for 15 days following receipt of written notice by the Executive of such failure, (iv)
gross negligence or willful breach of contractual duties with respect to the Company or any of its Subsidiaries, (v) any
breach of sections 3, 5 and 7 of any subscription or Securityholders agreement to which the Executive may be a party,
or (vi) any material breach of any employment agreement which may be entered into between the Company or any of
its Subsidiaries and the Executive; provided that, in the case of (v) and (vi) above, such breach shall not have been cured
by the Executive within 15 days following receipt of written notice by the Executive of such breach.
iii. "Executive": means (i) any natural Person employed by, or party to a consultancy agreement with, the Company or
any of its Subsidiaries and (ii) any holder of Executive Securities of which only an Executive or members of his Family
Group are the beneficial owners.
iv. "Executive Securities": means, with respect to an Executive, the Class A Ordinary Shares directly or indirectly
subscribed, purchased, or held by such Executive or such Executive's Permitted Transferees.
v. "Fair Market Value": means, with respect to any Security or Securities, the fair market value of such Securities as
determined by the Manager acting in good faith, including, for the avoidance of doubt, the Unvested Distribution Portion
for each such Security.
vi. "Family Group": means, with respect to any Executive, such Executive's parents (whether natural or by adoption),
spouse (for so long as such Person remains a spouse of that Executive), children (whether natural or by adoption), the
personal representatives of a deceased Executive and heir or beneficiary of such Executive.
vii. "Good Leaver": means any Executive who is a Leaver due to death, permanent disability or voluntary resignation
for Good Reason, or whose employment by, or appointment to office with, the Company or any of its Subsidiaries is
terminated without Cause or whose employment has expired and not been renewed (irrespective of the reason for the
non-renewal).
viii. "Good Leaver Accretion Percentage": means, in relation to the Executive Securities, vesting in the following
amounts over the following periods so long as the Executive continues to be employed by the Company or any of its
Subsidiaries:
Relevant Anniversary
Executive
Securities
Before 1st anniversary of Accretion Start Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0%
On or after 1st anniversary but before the 2nd anniversary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
On or after 2nd anniversary but before the 3rd anniversary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40%
On or after 3rd anniversary but before the 4th anniversary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60%
On or after 4th anniversary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80%
provided that, if the Executive's employment with the Company or any of its Subsidiaries ends on a Relevant Anni-
versary or on the day before such Relevant Anniversary, the respective Executive's employment shall be deemed, for the
purposes of calculating the Good Leaver Accretion Percentage, to have continued in existence until the end of the day
of the respective Relevant Anniversary.
Notwithstanding the time vesting set out above, in the event of (i) a Sale of the Company or (ii) a Public Sale or any
sale of Securities to an Independent Third Party in one transaction or a series of related transactions following which the
Bain Investors (x) shall own less than 15% of the Shares issued to them on 31 July 2007 and (y) shall no longer Control
the Company, all of the Executive Securities that remain unvested shall become vested and the Good Leaver Accretion
Percentage shall be deemed to be 100%.
ix. "Leaver": means an Executive who has ceased to (i) be an employee of the Company or any of its Subsidiaries or
(ii) hold the office to which he was appointed in respect of the Company or any of its Subsidiaries (otherwise than as a
result of being appointed to another office with the Company or any of its Subsidiaries).
x. "Medium Leaver": means any Executive who voluntarily resigns without Good Reason.
xi. "Medium Leaver Accretion Percentage": means, in relation to an Executive's Securities, vesting in the following
amounts over the following periods so long as the Executive continues to be employed by the Company or any of its
Subsidiaries:
Relevant Anniversary
Executive
Securities
Before 1st anniversary of Accretion Start Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0%
On or after 1st anniversary but before the 2nd anniversary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10%
On or after 2nd anniversary but before the 3rd anniversary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
66348
On or after 3rd anniversary but before the 4th anniversary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30%
On or after 4th anniversary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40%
provided that, if the Executive's employment with the Company or any of its Subsidiaries ends on a Relevant Anni-
versary or on the day before such Relevant Anniversary, the respective Executive's employment shall be deemed, for the
purposes of calculating the Medium Leaver Accretion Percentage, to have continued in existence until the end of the day
of the respective Relevant Anniversary.
Notwithstanding the time vesting set out above, in the event of (i) a Sale of the Company or (ii) a Public Sale or any
sale of Securities to an Independent Third Party in one transaction or a series of related transactions following which the
Bain Investors (x) shall own less than 15% of the Shares issued to them on 31 July 2007 and (y) shall no longer Control
the Company, all of the Executive Securities that remain unvested shall become vested and the Medium Leaver Accretion
Percentage shall be deemed to be 100%.
xii. "New Executive": any Executive employed by the Company or any of its Subsidiaries who is not (i) an Existing
Executive or (ii) a holder of Shares as at 31 January 2008.
xiii. "Permitted Trust": of a holder of Shares shall mean a trust or a comparable corporate entity of which the relevant
Executive and/or his Family Group is a beneficiary but only for as long as such holder(s) remain(s) a beneficiary.
xiv. "Relevant Anniversary": means, in respect of Executive Securities, an anniversary of the Accretion Start Date.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to amend Section 6.14 "Right to Purchase Certain Class A Ordinary Shares" of the
Company's articles of association as follows:
a. The general meeting resolves to amend Section 6.14 a) "Call Option" which shall now read as follows:
"a) Call Option. In the event that (i) the Company or any of its Subsidiaries shall deliver to an Executive a notice of
termination of employment or a notice of termination of a consultancy agreement (a "Termination Notice") or (ii) an
Executive is no longer employed by, or party to any consulting agreement with, the Company or any of its Subsidiaries
for any reason or (iii) an Executive ceases to hold the office to which he or she was appointed (such as that of Managing
Director or proxy holder (Prokurist)) in respect of the Company or any of its Subsidiaries, whether due to termination
of employment, resignation, removal from such office or for any reason other than appointment to another office with
the Company or any of its Subsidiaries (the earlier of (x) the date of delivery of such Termination Notice, (y) the date of
such Executive's termination of employment and (z) the date the Executive ceases to hold such office being referred to
herein as the "Termination Date") in any of the circumstances specified in Sections 6.14b), 6.14c) and 6.14d) below, such
Executive's Executive Securities, whether held by such Executive or by one or more of his or her Permitted Transferees,
will be subject to purchase by either the Company, or at the Manager's discretion, the Bain Investors, or by such other
Persons as the Bain Investors may identify, pursuant to the terms and conditions set forth in this Section 6.14 (the "Call
Option")."
b. The general meeting resolves to amend Section 6.14 d) "Bad Leaver" which shall now read as follows:
"d) Bad Leaver. If an Executive is a Bad Leaver, then the Bain Investors or the Company shall have the right to acquire
some or all of the Executive Securities held by such Executive (or his Permitted Transferees) at the lower of Original
Cost and Adjusted Fair Market Value.
PROVIDED, that, where there remains an Outstanding Loan Amount with respect to the Executive, the consideration
that would otherwise be payable to the Executive in accordance with Section 6.14b), Section 6.14c) or Section 6.14d) (as
the case may be) pursuant to the exercise of the Call Option shall be reduced by an amount equal to any Outstanding
Loan Amount that remains once all sums that are permitted under the Executive's employment contract to be set-off
against the Outstanding Loan Amount have been so set-off."
c. The general meeting resolves to amend the first sentence of Section 6.14 e) "Call Option Exercise Procedures"
which shall now read as follows:
"e) Call Option Exercise Procedures". In the event that the Manager decides in its sole discretion in accordance with
this Section 6.14 that the Bain Investors shall have the right to purchase the Executive Securities subject to the Call
Option, it shall, within 45 days of the Termination Date of the relevant Executive, deliver written notice to the Bain
Investors setting forth the name of such Executive and the Termination Date."
d. The general meeting resolves to amend of Section 6.14 f) "Closing" which shall now read as follows:
"f) Closing. The closing of the transactions contemplated by this Section 6.14 will take place on the date designated
by the Company or the Bain Investors. The Bain Investors, the New Executives and/or the Company, as the case may
be, will pay for the Executive Securities to be purchased pursuant to the Call Option by delivery of a check or a wire
transfer of immediately available funds payable to the holder of such Executive Securities in the aggregate amount equal
to the purchase price for such Executive Securities less the Outstanding Loan Amount, if applicable. The Bain Investors,
the New Executives and/or the Company, as the case may be, shall receive customary representations and warranties
from each seller regarding the sale of the Executive Securities to the relevant purchaser, including but not limited to the
representation that such seller has good and marketable title to the Executive Securities to be transferred free and clear
of all liens, claims and other encumbrances. If the Company purchases any Executive Securities subject to the Call Option
66349
allocated to it, the Securities so acquired shall be redeemed in accordance with the provisions of Article 49-8 of the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended."
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to amend Section 6.16 "Liquidation Rights" of the Company's articles of association which
shall now read as follows:
"In the event of a liquidation, after payment of all debts and liabilities of the Company, the residual assets of the Company
will be distributed to the Shareholders in the manner set forth in these Articles. Neither a merger nor consolidation of
the Company into or with any other entity or entities, nor a merger or consolidation of any other entity or entities into
or with the Company, nor a sale, transfer, lease or exchange (for cash, securities or other consideration) of all or any
part of the assets of the Company shall be deemed to be a liquidation within the meaning of this Section 6.16, unless such
merger, consolidation, sale, transfer, lease or exchange shall be in connection with or intended to be a plan of complete
liquidation, dissolution or winding up of the Company."
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolves to amend Section 7.3 b) "Limitation on Transfer" of the Company's articles of association
which shall now read as follows:
"b) Limitations on Transfer. Prior to the tenth Relevant Anniversary, or during such shorter period as may be consistent
with applicable law, the Shareholders may not validly transfer the Shares without the prior written approval of the Manager
or unless otherwise permitted pursuant to this Section 7.3."
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article XIII of the articles of association of the Company which shall now read
as follows:
" Art. 13. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on 1 August and shall terminate on 31
July."
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing persons,
this deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,
civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Textes:
Im Jahr zweitausendacht, am elften April.
Vor dem unterzeichneten, Maître Joseph Elvinger, Notar mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
fand die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von Bavaria (BC) Luxco, eine société en commandite par
actions, bestehend nach den Gesetzen von Luxemburg, mit Sitz in 9A, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Bezirk
Schuttrange, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 130824,
gegründet durch Gründungsakte vom 25. Juni 2007 von Maître Martine Schaeffer, Notar mit Sitz in Luxemburg, Groß-
herzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 22. September 2007,
Nummer 2006 (nachfolgend die "Gesellschaft"). Die Gesellschaftssatzung wurde zum letzten Mal durch notarielle Urkunde
von Maître Joseph Elvinger vom 31. Juni 2007 geändert und im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 6.
Oktober 2007, Nummer 2220 veröffentlicht (die "Gesellschaft").
Die Hauptversammlung wird um 14 Uhr 30, mit Frau Caroline Streiff, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg als
Vorsitzende eröffnet,
die als Sekretärin Frau Flora Gibert, wohnhaft in Luxemburg, ernennt, welche sie ebenfalls als Stimmzählerin ernennt.
Das Büro der Hauptversammlung ist damit bestellt und die Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar, Folgendes zu
beurkunden.
I. - Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt ist:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung des Abschnitts "Definitionen" des Gesellschaftervertrages:
a. Einführung der folgenden neuen Definitionen, welche folgenden Wortlaut haben sollen:
i. "Anfangsdatum des Zuwachs" bezeichnet (i) im Falle einer vorhandenen Führungskraft, zum 1. August 2007 und (ii)
im Falle jeglicher anderen Führungskraft, das Anfangsdatum der Ausübung einer solchen Führungskraft der Gesellschaft
oder ihrer Filialen.
ii. "Vorhandene Führungskraft" bezeichnet jegliche Führungskraft, die durch die Gesellschaft oder ihre Filialen am 1.
August 2007 angestellt war.
66350
iii. "Ausstehende Darlehenssummen" bezeichnet, bezüglich jeglicher Darlehen, die von einer der Filialen der Gesell-
schaft, die nicht der luxemburgischen Gesetzgebung unterliegt, an Eigentümer von Exekutivaktien, oder zur Finanzierung
des Erwerbs von Exekutivaktien erteilt wird, die ausstehende Darlehenssumme (inklusive jeglichen angehäuften, aber
ungezahlten Dividenden) am nächstmöglichen Datum, womit das Datum des Abschlusses der Transaktion, wie unter
Abschnitt 6.14 vorgesehen, gemeint ist.
iv. "Richtlinien" bezeichnet schriftliche Richtlinien der Gesellschaft oder einer ihrer Filialen bezüglich erheblicher An-
gelegenheiten, wie Diebstahl, Betrug, Unredlichkeit, Diskriminierung, Belästigung, Drogenmissbrauch oder das Verbot
anderen ähnlich schwerwiegenden Verhaltens wie dem vorgenannten, genauso wie die Richtlinien der Geschäftsordnung,
welche im Einzelfall vom Geschäftsführerrat oder jeglichen anderem Führungsgremium der Gesellschaft ausdrücklich
bestätigt wurden.
b. Änderung der existierenden Definitionen die nunmehr folgenden Wortlaut haben sollen:
i. "Schlechter Abgänger "Bad Leaver" bezeichnet eine Führungskraft (i), deren Anstellung durch die Gesellschaft oder
(ii) deren Bestellung für einen Posten, für den sie ernannt wurde, im Hinblick auf die Gesellschaft oder jegliche Filiale mit
Begründung beendet wird.
ii. "Grund" bedeutet (i) Betrug oder erhebliche Unterschlagung in Verbindung mit der Tätigkeit oder dem Vermögen
der Gesellschaft oder deren Filialen, (ii) eine Straftat in Verbindung mit einem schwerwiegenden Verstoß gegen die guten
Sitten, jegliche Tat oder Unterlassung durch erhebliche Unredlichkeit oder Betrug oder eine Tat, die eine Missachtung
der Richtlinien darstellt (iii) fortgesetztes Unterlassen, Initiativen und Maßnahmen anzunehmen und mitzutragen, die der
Führungskraft durch die Gesellschaft oder deren Filiale auferlegt werden und die den Aufgaben einer Führungskraft einer
Gesellschaft von gleichem Umfang und Tätigkeit entsprechen, und welche keine Zuwiderhandlung gegen eine geltende
Gesetzgebung oder eine Regelung des Arbeitsvertrags mit dem Mitarbeiter darstellen, welche bis 15 Tage nach Erhalt
einer schriftlichen Mitteilung durch die Führungskraft über eine solche Unterlassung, (iv) grober willentlicher schwer-
wiegender Vertragsbruch oder grobe Fahrlässigkeit gegenüber der Gesellschaft oder deren Filialen, (v) jegliche Missach-
tung der Abschnitte 3, 5 und 7 jeglicher Zeichnungs- oder Sicherheiteninhabervereinbarungen, an denen die Führungskraft
gegebenenfalls beteiligt ist oder (vi) jegliche erhebliche Missachtung einer Arbeitsvereinbarung zwischen der Gesellschaft
oder einer ihrer Filialen und der Führungskraft; sofern im Fall von (v) und (vi), wie oben aufgeführt, eine solche Missachtung
von der Führungskraft nicht binnen 15 Tagen ab Erhalt der schriftlichen Mitteilung über den Vertragsbruchs eingestellt
wurde.
iii. "Führungskraft" bezeichnet (i) jegliche natürliche Person, die durch einen Beratungsvertrag mit der Gesellschaft
oder einer ihrer Filialen eingestellt wurde oder Partei eines solchen Vertrages ist, und (ii) jeglichen Inhaber von Exeku-
tivaktien, von denen nur eine Führungskraft, oder ein Mitglied ihrer Familiengruppe, der wirtschaftlich Berechtigte ist.
iv. "Exekutivaktien" bezeichnen in Verbindung mit einer Führungskraft oder eines zugelassenen Begünstigten der Or-
dentlichen Aktien der Klasse A die direkt oder indirekt von dieser Führungskraft gezeichnet, gekauft oder gehalten
werden.
v. "Fairer Marktwert" bezeichnet in Verbindung mit Wertpapieren den fairen Marktwert dieser Wertpapiere wie dieser
von dem Verwalter in gutem Glauben bestimmt wird, welche, um Missverständnisse auszuschließen, den Nicht Zugeteilten
Verteilungsanteil für jede Sicherheit beinhaltet.
vi. "Familiengruppe" bezeichnet in Verbindung mit einer Führungskraft, die Eltern dieser Führungskraft (ob natürliche
Eltern oder durch Adoption), Ehepartner (so lange wie diese Person Ehegatte der Führungskraft ist), Kinder (sowohl
leibliche als auch adoptierte), die Vertreter der verstorbenen Führungskraft und deren Nachfolgen und Erben.
vii. "Guter Abgänger" "Good Leaver" bezeichnet eine Führungskraft, die Abgänger auf Grund Todes, Invalidität oder
freiwilliger Kündigung aus gutem Grunde ist, oder deren Anstellung, oder Bestellung für einen Posten durch die Gesell-
schaft oder ihrer Filialen ohne Grund beendet wurde, oder deren Arbeitsverhältnis ausläuft, oder nicht verlängert wurde
(ungeachtet der Gründe der Nichtverlängerung).
viii. "Abgangsanwachssatz für gute Abgänger" bezeichnet in Verbindung mit den Exekutivaktien für die Dauer, während
der die Führungskraft Mitarbeiter der Gesellschaft oder einer ihrer Filialen war, folgende Beträge:
Dauer
Exekutivaktien
Vor dem 1. Jahrestag des Anfangsdatum des Zuwachs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0%
An oder nach dem 1. Jahrestag aber vor dem 2. Jahrestag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
An oder nach dem 2. Jahrestag aber vor dem 3. Jahrestag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40%
An oder nach dem 3. Jahrestag aber vor dem 4. Jahrestag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60%
An dem 4. Jahrestag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80%
wobei, soweit das Arbeitsverhältnis der Führungskraft mit der Gesellschaft oder einer ihrer Filialen mit Ablauf der
Dauer endet oder an deren Vortag zum Zweck der Berechnung des Abgangsanwachssatz für gute Abgänger vermutet
wird, dass das jeweilige Arbeitsverhältnis der Führungskraft bis zum Ende des Tages des Ablaufs einer solchen Dauer
weiter besteht.
Unbeschadet der angeführten Dauer werden (i) bei einem Verkauf der Gesellschaft oder (ii) einem Öffentlichen Ver-
kauf, oder bei einem Verkauf von Wertpapieren an einen Unabhängigen Dritten in einer Transaktion oder in einer Reihe
von Transaktionen, welche dazu führt, dass die Bain Investoren (x) weniger als 15% der Aktien halten, die ihnen am 31.
66351
Juli 2007 ausgegeben wurden, und (y) nicht länger die Gesellschaft kontrollieren, alle noch nicht zugeteilten Exekutivaktien
zugeteilt und der Abgangsanwachssatz für gute Abgänger bei 100% festgesetzt.
ix. "Abgänger" bezeichnet eine Führungskraft die nicht mehr (i) Mitarbeiter der Gesellschaft oder einer ihrer Filialen
ist, oder (ii) einen Posten ausübt, zu der sie durch die Gesellschaft oder eine ihrer Filialen ernannt wurde (außer aufgrund
der Ernennung zu einem anderen Posten durch die Gesellschaft oder einer ihrer Filialen).
x. "Mittlerer Abgänger" bezeichnet eine Führungskraft die willentlich kündigt, aber ohne Gute Gründe.
xi. "Abgangsanwachssatz für mittlere Abgänger" bezeichnet in Verbindung mit den Exekutivaktien folgende Beträge
über die Dauer während der die Führungskraft Mitarbeiter der Gesellschaft oder einer ihrer Filialen war:
Dauer
Exekutivaktien
Vor dem 1. Jahrestag des Anfangsdatum des Zuwachs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0%
An oder nach dem 1. Jahrestag aber vor dem 2. Jahrestag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10%
An oder nach dem 2. Jahrestag aber vor dem 3. Jahrestag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
An oder nach dem 3. Jahrestag aber vor dem 4. Jahrestag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30%
An dem 4. Jahrestag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40%
wobei, soweit das Arbeitsverhältnis der Führungskraft mit der Gesellschaft oder einer ihrer Filialen mit Ablauf der
Dauer endet oder an deren Vortag zum Zweck der Berechnung des Abgangsanwachssatz für gute Abgänger vermutet
wird, dass das jeweilige Arbeitsverhältnis der Führungskraft bis zum Ende des Tages des Ablaufs einer solchen Dauer
weiter besteht.
Unbeschadet des oben angeführten Zuteilungsschemas werden (i) bei einem Verkauf der Gesellschaft oder (ii) einem
Öffentlichen Verkauf, oder bei einem Verkauf von Wertpapieren an einen Unabhängigen Dritten in einer oder in einer
Reihe von Transaktionen, welche dazu führt, dass die Bain Investoren (x) weniger als 15% der Aktien halten, die ihnen
am 31. Juli 2007 ausgegeben wurden, und (y) nicht länger die Gesellschaft kontrollieren, werden alle noch nicht zugeteilten
Exekutivaktien zugeteilt und der Zuwachsanteil für gute Ausscheidende auf 100% festgesetzt.
xii. "Neue Führungskraft" eine Führungskraft die von der Gesellschaft oder einer ihrer Filialen eingestellt wird und (i)
nicht eine ausübende Führungskraft, oder (ii) kein Inhaber von Aktien am 31. Januar 2008 ist.
xiii. "Zugelassener Treuhänder" eines Inhabers von Aktien bezeichnet einen Treuhänder oder vergleichbare Gesell-
schaftseinheit deren Begünstigter die entsprechende Führungskraft und/oder seine Familiengruppe ist und solange dies
der Fall ist.
xiv. "Dauer" bezeichnet in Verbindung mit den Exekutivaktien den Jahrestag des Anfangsdatums des Zuwachses.
2. Änderung des Abschnitts 6.14 "Das Recht bestimmte Ordentliche Aktien der Klasse A zu kaufen" des Gesellschaf-
tervertrages:
a. Änderung des Abschnitts 6.14a) "Kaufoption" welcher nunmehr folgenden Wortlaut haben soll:
"a) Kaufoption. Im Falle dass (i) die Gesellschaft oder eine ihrer Filialen einer Führungskraft die Kündigung des Ar-
beitsvertrags oder Beratervertrags mitteilt (ein "Kündigungsschreiben ") oder (ii) eine Führungskraft nicht länger von der
Gesellschaft angestellt ist oder eine Partei in einem Beratervertrag mit der Gesellschaft ist, wird die Gesellschaft oder
eine ihrer Filialen aus welchem Grund auch immer oder (iii) eine Führungskraft, die ein Posten niederlegt, zu dessen
Ausübung sie ernannt wurde (wie zum Beispiel der Geschäftsführer oder Prokurist der Gesellschaft oder einer ihrer
Filialen), ob dies auf Grund der Entlassung, Kündigung, Entfernung von einem solchen Posten, oder aus jeglichem anderen
Grund als der Ernennung für einen anderen Posten der Gesellschaft oder einer ihrer Filialen passiert, ist der früheste
Zeitpunkt (x) der der Zustellung eines solchen Entlassungsschreibens, (y) das Datum der Entlassung der Führungskraft,
und (z) das Datum an dem eine Führungskraft ein Amt niederlegt zu dessen Ausübung sie ernannt wurde, hier als "Kün-
digungsdatum" bezeichnet) in jeglichen in Abschnitt 6.14(b), 6.14(c) und 6.14(d) angeführten Umständen, sind die
Exekutivaktien dieser Führungskraft, ob diese Aktien von dieser Führungskraft oder von einem oder mehreren seiner
zugelassenen Begünstigten gehalten werden, Gegenstand eines Rückkaufes, durch die Gesellschaft selbst oder nach Er-
messen des Verwalters durch den Bain Investor, oder durch eine anderer Person wie durch den Bain Investor gemäß den
Bestimmungen dieses Abschnitts 6.14 (die "Kaufoption")."
b. Änderung des Abschnitts 6.14d) "Guter Abgänger" welcher nunmehr folgenden Wortlaut haben soll:
"d) Schlechter Abgänger. Wenn eine Führungskraft ein schlechter Abgänger ist werden die Bain Investoren oder die
Gesellschaft das Recht haben einen Teil oder den gesamten Abgangsanwachssatz für schlechte Abgänger der Exekuti-
vaktien dieser Führungskraft (oder deren zugelassenen Begünstigten) zu dem niedrigsten Preis der anfänglichen Kosten
und dem Angepassten Marktwert.
SOFERN, noch Ausstehende Darlehenssummen im Bezug auf die Führungskraft vorliegen, wird das Entgelt, welches
ansonsten der Führungskraft entsprechend dem Abschnitt 6.14b), Abschnitt 6.14c) oder Abschnitt 6.14d) (beziehungs-
weise) im Bezug auf die Ausübung von Kaufoptionen zu zahlen wäre, um eine Summe gemindert, die der ausstehenden
Darlehenssumme, nach Abzug der laut dem Arbeitsvertrag der Führungsperson zur Aufrechnung zugelassenen Beträge
und nach deren Aufrechnung mit der ausstehenden Darlehenssumme entspricht."
c. Änderung des ersten Satzes des Abschnitts 6.14e) "Ausführungsverfahren für Kaufsoptionen" welcher nunmehr
folgenden Wortlaut haben soll:
66352
"e) Ausführungsverfahren für Kaufsoptionen. Sollte der Verwalter beschließen, auf eigenes Ermessen und in Einklang
mit diesem Abschnitt 6.14 dass der Bain Investors das Recht hat die Exekutivaktien zu kaufen, für die eine Kaufoption
besteht, wird er binnen 45 Tagen nach dem Kündigungsdatum der entsprechenden Führungskraft eine schriftliche Mit-
teilung an den Bain Investor schicken mit dem Namen dieser Führungskraft und dem Kündigungsdatum."
d. Änderung des Abschnitts 6.14f) "Abschluss" welcher nunmehr folgenden Wortlaut haben soll:
"f) Abschluss. Der Abschluss der von diesem Abschnitt 6.14 beabsichtigten Transaktionen erfolgt am Datum, welches
von der Gesellschaft oder dem Bain Investor bestimmt wird. Der Bain Investor, die neuen Führungskräfte und/oder die
Gesellschaft, je nachdem was der Fall ist, zahlen für die laut der Kaufoption zu kaufenden Exekutivaktien mittels Schecks
oder per Banküberweisung mit sofort verfügbaren Geldern, die an den Inhaber dieser Exekutivaktien zu entrichten sind
den Gesamtbetrag der dem Kaufpreis dieser Exekutivaktien entspricht, gemindert um die gegebenenfalls Ausstehende
Darlehenssumme. Der Bain Investor, die neuen Führungskräfte und/oder die Gesellschaft, je nachdem was der Fall ist,
erhalten die betriebsüblichen Zusicherungen und Gewährleistungen von jedem Verkäufer bezüglich des Verkaufs von
Exekutivaktien an den entsprechenden Käufer, welche unter anderem die Zusicherung einschließt, dass der Verkäufer
über einen gültigen oder übertragbaren Rechtstitel an den Exekutivaktien verfügt und dass diese frei von jeglichen Pfand-
rechten, Rechtsansprüchen und Lasten sind. Falls die Gesellschaft Exekutivaktien kauft die einer ihr zugeteilten Kaufoption
unterliegen, werden die so erworbenen Wertpapiere gemäß den Bestimmungen von Artikel 49-8 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Fassung zurück gekauft."
3. Änderung des Abschnitts 6.16 "Auflösungsrechte" des Gesellschaftervertrages welcher nunmehr folgenden Wortlaut
haben soll:
"Im Falle einer Auflösung, nach dem alle Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt wurden wird das
restliche Vermögen der Gesellschaft an die Aktionäre in Einklang mit den Bestimmungen dieser Satzung ausbezahlt. Kein
Zusammenschluss oder Konsolidierung der Gesellschaft in eine oder mehrere andere Einheiten weder noch ein Zusam-
menschluss oder eine Konsolidierung von einer oder mehreren Einheiten mit der Gesellschaft, noch ein Verkauf, Übertrag,
Vermietung oder Austausch (gegen Bar, Wertpapiere oder sonst wie) von dem gesamten oder einem Teil des Vermögens
der Gesellschaft gilt als Auflösung im Sinne von diesem Abschnitt 6.16, außer ein solcher Zusammenschluss, Konsolidie-
rung, Verkauf, Übertrag, Vermietung oder Austausch ist in Verbindung oder vorgesehen als ein Plan für die vollständige
Auflösung und Liquidation der Gesellschaft."
4. Änderung des Abschnitts 7.3b) "Begrenzung von Überträgen" des Gesellschaftervertrages welcher nunmehr fol-
genden Wortlaut haben soll:
"b) Begrenzung von Überträgen. Vor dem zehnten Jahrestag der Dauer oder während einer kürzeren Dauer die mit
den gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmt, kann der Aktionär die Aktien nicht gültig übertragen ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung des Verwalters, außer anders in Abschnitt 7.3. vorgesehen."
5. Änderung des Paragraphen XIII "Geschäftsjahr" des Gesellschaftervertrages welcher nunmehr folgenden Wortlaut
haben soll:
"Paragraph XIII Geschäftsjahr Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. August und endet am 31. Juli."
II.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachtsinhaber der vertretenen Aktionäre und die Anzahl
ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste erscheinen, diese Anwesenheitsliste von den Aktionären, den Vollmachtsinha-
bern der vertretenen Aktionäre und dem Büro der Versammlung unterschrieben wurde, die sich im Anhang an die
vorliegende Urkunde befindet und die gleichzeitig mit dieser bei den Registerbehörden eingereicht werden soll. Die
Vollmachten der vertretenen Aktionäre, mit dem Vorsatz "ne varietur" versehen, werden ebenfalls an die vorliegende
Urkunde angefügt.
III.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und das alle Aktionäre
die anwesend oder vertreten sind, erklären dass sie von der folgenden Tagesordnung in Kenntnis gesetzt wurden und sie
zur Kenntnis genommen haben, sodass keine Vorladung notwendig war.
IV.- Dass die Hauptversammlung, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß gebildet ist und
wirksam über alle Tagesordnungspunkte beschließen kann.
Dann fasste die Hauptversammlung nach Beratung einstimmig die folgenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt folgende Definitionen dem Abschnitt "Definitionen" des Gesellschaftervertrages
hinzuzufügen, welche folgenden Wortlaut haben sollen:
i. "Anfangsdatum des Zuwachs" bezeichnet (i) im Falle einer vorhandenen Führungskraft, zum 1. August 2007 und (ii)
im Falle jeglicher anderen Führungskraft, das Anfangsdatum der Ausübung einer solchen Führungskraft der Gesellschaft
oder ihrer Filialen.
ii. "Vorhandene Führungskraft" bezeichnet jegliche Führungskraft, die durch die Gesellschaft oder ihre Filialen am 1.
August 2007 angestellt war.
iii. "Ausstehende Darlehenssummen" bezeichnet, bezüglich jeglicher Darlehen, die von einer der Filialen der Gesell-
schaft, die nicht der luxemburgischen Gesetzgebung unterliegt, an Eigentümer von Exekutivaktien, oder zur Finanzierung
des Erwerbs von Exekutivaktien erteilt wird, die ausstehende Darlehenssumme (inklusive jeglichen angehäuften, aber
66353
ungezahlten Dividenden) am nächstmöglichen Datum, womit das Datum des Abschlusses der Transaktion, wie unter
Abschnitt 6.14 vorgesehen, gemeint ist.
iv. "Richtlinien" bezeichnet schriftliche Richtlinien der Gesellschaft oder einer ihrer Filialen bezüglich erheblicher An-
gelegenheiten, wie Diebstahl, Betrug, Unredlichkeit, Diskriminierung, Belästigung, Drogenmissbrauch oder das Verbot
anderen ähnlich schwerwiegenden Verhaltens wie dem vorgenannten, genauso wie die Richtlinien der Geschäftsordnung,
welche im Einzelfall vom Geschäftsführerrat oder jeglichen anderem Führungsgremium der Gesellschaft ausdrücklich
bestätigt wurden.
Die Hauptversammlung beschließt weiterhin, einige Definitionen des Abschnitts "Definitionen" des Gesellschafter-
vertrages zu ändern, welche nunmehr folgenden Wortlaut haben sollen:
i. "Schlechter Abgänger "Bad Leaver" bezeichnet eine Führungskraft (i), deren Anstellung durch die Gesellschaft oder
(ii) deren Bestellung für einen Posten, für den sie ernannt wurde, im Hinblick auf die Gesellschaft oder jegliche Filiale mit
Begründung beendet wird.
ii. "Grund" bedeutet (i) Betrug oder erhebliche Unterschlagung in Verbindung mit der Tätigkeit oder dem Vermögen
der Gesellschaft oder deren Filialen, (ii) eine Straftat in Verbindung mit einem schwerwiegenden Verstoß gegen die guten
Sitten, jegliche Tat oder Unterlassung durch erhebliche Unredlichkeit oder Betrug oder eine Tat, die eine Missachtung
der Richtlinien darstellt (iii) fortgesetztes Unterlassen, Initiativen und Maßnahmen anzunehmen und mitzutragen, die der
Führungskraft durch die Gesellschaft oder deren Filiale auferlegt werden und die den Aufgaben einer Führungskraft einer
Gesellschaft von gleichem Umfang und Tätigkeit entsprechen, und welche keine Zuwiderhandlung gegen eine geltende
Gesetzgebung oder eine Regelung des Arbeitsvertrags mit dem Mitarbeiter darstellen, welche bis 15 Tage nach Erhalt
einer schriftlichen Mitteilung durch die Führungskraft über eine solche Unterlassung, (iv) grober willentlicher schwer-
wiegender Vertragsbruch oder grobe Fahrlässigkeit gegenüber der Gesellschaft oder deren Filialen, (v) jegliche Missach-
tung der Abschnitte 3, 5 und 7 jeglicher Zeichnungs- oder Sicherheiteninhabervereinbarungen, an denen die Führungskraft
gegebenenfalls beteiligt ist oder (vi) jegliche erhebliche Missachtung einer Arbeitsvereinbarung zwischen der Gesellschaft
oder einer ihrer Filialen und der Führungskraft; sofern im Fall von (v) und (vi), wie oben aufgeführt, eine solche Missachtung
von der Führungskraft nicht binnen 15 Tagen ab Erhalt der schriftlichen Mitteilung über den Vertragsbruchs eingestellt
wurde.
iii. "Führungskraft" bezeichnet (i) jegliche natürliche Person, die durch einen Beratungsvertrag mit der Gesellschaft
oder einer ihrer Filialen eingestellt wurde oder Partei eines solchen Vertrages ist, und (ii) jeglichen Inhaber von Exeku-
tivaktien, von denen nur eine Führungskraft, oder ein Mitglied ihrer Familiengruppe, der wirtschaftlich Berechtigte ist.
iv. "Exekutivaktien" bezeichnen in Verbindung mit einer Führungskraft oder eines zugelassenen Begünstigten der Or-
dentlichen Aktien der Klasse A die direkt oder indirekt von dieser Führungskraft gezeichnet, gekauft oder gehalten
werden.
v. "Fairer Marktwert" bezeichnet in Verbindung mit Wertpapieren den fairen Marktwert dieser Wertpapiere wie dieser
von dem Verwalter in gutem Glauben bestimmt wird, welche, um Missverständnisse auszuschließen, den Nicht Zugeteilten
Verteilungsanteil für jede Sicherheit beinhaltet.
vi. "Familiengruppe" bezeichnet in Verbindung mit einer Führungskraft, die Eltern dieser Führungskraft (ob natürliche
Eltern oder durch Adoption), Ehepartner (so lange wie diese Person Ehegatte der Führungskraft ist), Kinder (sowohl
leibliche als auch adoptierte), die Vertreter der verstorbenen Führungskraft und deren Nachfolgen und Erben.
vii. "Guter Abgänger" "Good Leaver" bezeichnet eine Führungskraft, die Abgänger auf Grund Todes, Invalidität oder
freiwilliger Kündigung aus gutem Grunde ist, oder deren Anstellung, oder Bestellung für einen Posten durch die Gesell-
schaft oder ihrer Filialen ohne Grund beendet wurde, oder deren Arbeitsverhältnis ausläuft, oder nicht verlängert wurde
(ungeachtet der Gründe der Nichtverlängerung).
viii. "Abgangsanwachssatz für gute Abgänger" bezeichnet in Verbindung mit den Exekutivaktien für die Dauer, während
der die Führungskraft Mitarbeiter der Gesellschaft oder einer ihrer Filialen war, folgende Beträge:
Dauer
Exekutivaktien
Vor dem 1. Jahrestag des Anfangsdatum des Zuwachs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0%
An oder nach dem 1. Jahrestag aber vor dem 2. Jahrestag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
An oder nach dem 2. Jahrestag aber vor dem 3. Jahrestag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40%
An oder nach dem 3. Jahrestag aber vor dem 4. Jahrestag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60%
An dem 4. Jahrestag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80%
wobei, soweit das Arbeitsverhältnis der Führungskraft mit der Gesellschaft oder einer ihrer Filialen mit Ablauf der
Dauer endet oder an deren Vortag zum Zweck der Berechnung des Abgangsanwachssatz für gute Abgänger vermutet
wird, dass das jeweilige Arbeitsverhältnis der Führungskraft bis zum Ende des Tages des Ablaufs einer solchen Dauer
weiter besteht.
Unbeschadet der angeführten Dauer werden (i) bei einem Verkauf der Gesellschaft oder (ii) einem Öffentlichen Ver-
kauf, oder bei einem Verkauf von Wertpapieren an einen Unabhängigen Dritten in einer Transaktion oder in einer Reihe
von Transaktionen, welche dazu führt, dass die Bain Investoren (x) weniger als 15% der Aktien halten, die ihnen am 31.
Juli 2007 ausgegeben wurden, und (y) nicht länger die Gesellschaft kontrollieren, alle noch nicht zugeteilten Exekutivaktien
zugeteilt und der Abgangsanwachssatz für gute Abgänger bei 100% festgesetzt.
66354
ix. "Abgänger" bezeichnet eine Führungskraft die nicht mehr (i) Mitarbeiter der Gesellschaft oder einer ihrer Filialen
ist, oder (ii) einen Posten ausübt, zu der sie durch die Gesellschaft oder eine ihrer Filialen ernannt wurde (außer aufgrund
der Ernennung zu einem anderen Posten durch die Gesellschaft oder einer ihrer Filialen).
x. "Mittlerer Abgänger" bezeichnet eine Führungskraft die willentlich kündigt, aber ohne Gute Gründe.
xi. "Abgangsanwachssatz für mittlere Abgänger" bezeichnet in Verbindung mit den Exekutivaktien folgende Beträge
über die Dauer während der die Führungskraft Mitarbeiter der Gesellschaft oder einer ihrer Filialen war:
Dauer
Exekutivaktien
Vor dem 1. Jahrestag des Anfangsdatum des Zuwachs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0%
An oder nach dem 1. Jahrestag aber vor dem 2. Jahrestag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10%
An oder nach dem 2. Jahrestag aber vor dem 3. Jahrestag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
An oder nach dem 3. Jahrestag aber vor dem 4. Jahrestag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30%
An dem 4. Jahrestag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40%
wobei, soweit das Arbeitsverhältnis der Führungskraft mit der Gesellschaft oder einer ihrer Filialen mit Ablauf der
Dauer endet oder an deren Vortag zum Zweck der Berechnung des Abgangsanwachssatz für gute Abgänger vermutet
wird, dass das jeweilige Arbeitsverhältnis der Führungskraft bis zum Ende des Tages des Ablaufs einer solchen Dauer
weiter besteht.
Unbeschadet des oben angeführten Zuteilungsschemas werden (i) bei einem Verkauf der Gesellschaft oder (ii) einem
Öffentlichen Verkauf, oder bei einem Verkauf von Wertpapieren an einen Unabhängigen Dritten in einer oder in einer
Reihe von Transaktionen, welche dazu führt, dass die Bain Investoren (x) weniger als 15% der Aktien halten, die ihnen
am 31. Juli 2007 ausgegeben wurden, und (y) nicht länger die Gesellschaft kontrollieren, werden alle noch nicht zugeteilten
Exekutivaktien zugeteilt und der Zuwachsanteil für gute Ausscheidende auf 100% festgesetzt.
xii. "Neue Führungskraft" eine Führungskraft die von der Gesellschaft oder einer ihrer Filialen eingestellt wird und (i)
nicht eine ausübende Führungskraft, oder (ii) kein Inhaber von Aktien am 31. Januar 2008 ist.
xiii. "Zugelassener Treuhänder" eines Inhabers von Aktien bezeichnet einen Treuhänder oder vergleichbare Gesell-
schaftseinheit deren Begünstigter die entsprechende Führungskraft und/oder seine Familiengruppe ist und solange dies
der Fall ist.
xiv. "Dauer" bezeichnet in Verbindung mit den Exekutivaktien den Jahrestag des Anfangsdatums des Zuwachses.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt den Abschnitt 6.14 "Das Recht bestimmte Ordentliche Aktien der Klasse A zu
kaufen" des Gesellschaftervertrages zu ändern welcher nunmehr folgenden Wortlaut haben soll:
a. Die Hauptversammlung beschließt den Abschnitt 6.14a) "Kaufoption" des Gesellschaftervertrages zu ändern welcher
nunmehr folgenden Wortlaut haben soll:
"a) Kaufoption. Im Falle dass (i) die Gesellschaft oder eine ihrer Filialen einer Führungskraft die Kündigung des Ar-
beitsvertrags oder Beratervertrags mitteilt (ein "Kündigungsschreiben ") oder (ii) eine Führungskraft nicht länger von der
Gesellschaft angestellt ist oder eine Partei in einem Beratervertrag mit der Gesellschaft ist, wird die Gesellschaft oder
eine ihrer Filialen aus welchem Grund auch immer oder (iii) eine Führungskraft, die ein Posten niederlegt, zu dessen
Ausübung sie ernannt wurde (wie zum Beispiel der Geschäftsführer oder Prokurist der Gesellschaft oder einer ihrer
Filialen), ob dies auf Grund der Entlassung, Kündigung, Entfernung von einem solchen Posten, oder aus jeglichem anderen
Grund als der Ernennung für einen anderen Posten der Gesellschaft oder einer ihrer Filialen passiert, ist der früheste
Zeitpunkt (x) der der Zustellung eines solchen Entlassungsschreibens, (y) das Datum der Entlassung der Führungskraft,
und (z) das Datum an dem eine Führungskraft ein Amt niederlegt zu dessen Ausübung sie ernannt wurde, hier als "Kün-
digungsdatum" bezeichnet) in jeglichen in Abschnitt 6.14(b), 6.14(c) und 6.14(d) angeführten Umständen, sind die
Exekutivaktien dieser Führungskraft, ob diese Aktien von dieser Führungskraft oder von einem oder mehreren seiner
zugelassenen Begünstigten gehalten werden, Gegenstand eines Rückkaufes, durch die Gesellschaft selbst oder nach Er-
messen des Verwalters durch den Bain Investor, oder durch eine anderer Person wie durch den Bain Investor gemäß den
Bestimmungen dieses Abschnitts 6.14 (die "Kaufoption")."
b. Die Hauptversammlung beschließt den Abschnitt 6.14d) "Schlechter Abgänger" des Gesellschaftervertrages zu än-
dern welcher nunmehr folgenden Wortlaut haben soll:
"d) Schlechter Abgänger. Wenn eine Führungskraft ein schlechter Abgänger ist werden die Bain Investoren oder die
Gesellschaft das Recht haben einen Teil oder den gesamten Abgangsanwachssatz für schlechte Abgänger der Exekuti-
vaktien dieser Führungskraft (oder deren zugelassenen Begünstigten) zu dem niedrigsten Preis der anfänglichen Kosten
und dem Angepassten Marktwert.
SOFERN, noch Ausstehende Darlehenssummen im Bezug auf die Führungskraft vorliegen, wird das Entgelt, welches
ansonsten der Führungskraft entsprechend dem Abschnitt 6.14b), Abschnitt 6.14c) oder Abschnitt 6.14d) (beziehungs-
weise) im Bezug auf die Ausübung von Kaufoptionen zu zahlen wäre, um eine Summe gemindert, die der ausstehenden
Darlehenssumme, nach Abzug der laut dem Arbeitsvertrag der Führungsperson zur Aufrechnung zugelassenen Beträge
und nach deren Aufrechnung mit der ausstehenden Darlehenssumme entspricht."
66355
c. Die Hauptversammlung beschließt den Abschnitt 6.14e) "Ausführungsverfahren für Kaufsoptionen" des Gesellschaf-
tervertrages zu ändern welcher nunmehr folgenden Wortlaut haben soll:
"e) Ausführungsverfahren für Kaufsoptionen. Sollte der Verwalter beschließen, auf eigenes Ermessen und in Einklang
mit diesem Abschnitt 6.14 dass der Bain Investors das Recht hat die Exekutivaktien zu kaufen, für die eine Kaufoption
besteht, wird er binnen 45 Tagen nach dem Kündigungsdatum der entsprechenden Führungskraft eine schriftliche Mit-
teilung an den Bain Investor schicken mit dem Namen dieser Führungskraft und dem Kündigungsdatum."
d. Die Hauptversammlung beschließt den Abschnitt 6.14f) "Abschluss" des Gesellschaftervertrages zu ändern welcher
nunmehr folgenden Wortlaut haben soll:
"f) Abschluss. Der Abschluss der von diesem Abschnitt 6.14 beabsichtigten Transaktionen erfolgt am Datum, welches
von der Gesellschaft oder dem Bain Investor bestimmt wird. Der Bain Investor, die neuen Führungskräfte und/oder die
Gesellschaft, je nachdem was der Fall ist, zahlen für die laut der Kaufoption zu kaufenden Exekutivaktien mittels Schecks
oder per Banküberweisung mit sofort verfügbaren Geldern, die an den Inhaber dieser Exekutivaktien zu entrichten sind
den Gesamtbetrag der dem Kaufpreis dieser Exekutivaktien entspricht, gemindert um die gegebenenfalls Ausstehende
Darlehenssumme. Der Bain Investor, die neuen Führungskräfte und/oder die Gesellschaft, je nachdem was der Fall ist,
erhalten die betriebsüblichen Zusicherungen und Gewährleistungen von jedem Verkäufer bezüglich des Verkaufs von
Exekutivaktien an den entsprechenden Käufer, welche unter anderem die Zusicherung einschließt, dass der Verkäufer
über einen gültigen oder übertragbaren Rechtstitel an den Exekutivaktien verfügt und dass diese frei von jeglichen Pfand-
rechten, Rechtsansprüchen und Lasten sind. Falls die Gesellschaft Exekutivaktien kauft die einer ihr zugeteilten Kaufoption
unterliegen, werden die so erworbenen Wertpapiere gemäß den Bestimmungen von Artikel 49-8 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Fassung zurück gekauft."
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt den Abschnitt 6.16 "Auflösungsrechte" des Gesellschaftervertrages zu ändern wel-
cher nunmehr folgenden Wortlaut haben soll:
"Im Falle einer Auflösung, nach dem alle Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt wurden wird das
restliche Vermögen der Gesellschaft an die Aktionäre in Einklang mit den Bestimmungen dieser Satzung ausbezahlt. Kein
Zusammenschluss oder Konsolidierung der Gesellschaft in eine oder mehrere andere Einheiten weder noch ein Zusam-
menschluss oder eine Konsolidierung von einer oder mehreren Einheiten mit der Gesellschaft, noch ein Verkauf, Übertrag,
Vermietung oder Austausch (gegen Bar, Wertpapiere oder sonst wie) von dem gesamten oder einem Teil des Vermögens
der Gesellschaft gilt als Auflösung im Sinne von diesem Abschnitt 6.16, außer ein solcher Zusammenschluss, Konsolidie-
rung, Verkauf, Übertrag, Vermietung oder Austausch ist in Verbindung oder vorgesehen als ein Plan für die vollständige
Auflösung und Liquidation der Gesellschaft."
<i>Vierter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt den Abschnitt 7.3b) "Begrenzung von Überträgen" des Gesellschaftervertrages zu
ändern welcher nunmehr folgenden Wortlaut haben soll:
"b) Begrenzung von Überträgen. Vor dem zehnten Jahrestag der Dauer oder während einer kürzeren Dauer die mit
den gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmt, kann der Aktionär die Aktien nicht gültig übertragen ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung des Verwalters, außer anders in Abschnitt 7.3. vorgesehen."
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt den Paragraphen XIII des Gesellschaftervertrages zu ändern welcher nunmehr fol-
genden Wortlaut haben soll:
"Paragraph XIII Geschäftsjahr Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. August und endet am 31. Juli."
Da keine weiteren Angelegenheiten zu besprechen sind, wird die Hauptversammlung geschlossen.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, bescheinigt auf Anfrage der erschienenen Person,
dass diese Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Ebenfalls auf Antrag
der erschienenen Person bescheinigt der Notar dass bei Unstimmigkeiten zwischen der englischen und deutschen Fassung
die englische Fassung ausschlaggebend ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung des Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienen Parteien, der dem Notar
nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, haben diese Personen mit dem Notar
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: C. STREIFF, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 avril 2008, Relation LAC/2008/15625. — Reçu douze euros (12,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): FRANCIS SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
66356
Luxembourg, le 24 AVRIL 2008.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2008064288/211/724.
(080072318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
SwissCaps Holding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 110.638.
In the year two thousand and eight, on the thirty-first of March.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
"Dragenopharm Holding S.à r.l.", a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 24, rue Beaumont L-1219
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 122.756,
here represented by Mrs Linda KORPEL, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under
private seal on 7th March 2008.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of "SwissCaps Holding (Luxembourg) S.à r.l.", a société à responsabilité
limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 24, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 110.638, incor-
porated pursuant to a notarial deed dated 31 August 2005, whose articles of association have been published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations dated 06 January 2006, number 40. The Company's articles of
incorporation have been amended pursuant to a notarial deed on 07 October 2005, published in the Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations dated 22 February 2006, number 391.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to create one sole and unique ordinary class of shares referred to as the ordinary shares
and to convert all the existing classes of shares of the Company, referred to as the class A shares, the class B shares, the
class C shares, the class D shares, the class E shares, the class F shares, the class G shares and the class H shares into
four thousand (4,000) ordinary shares, each having a nominal value of fifty Swiss Francs (CHF 50.-).
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend and fully restate the articles of incorporation of the Company without changing
the purpose of the Company, which shall now be read as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the "Company") which
shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present
articles of incorporation.
Art. 2. The Company's object is to hold, directly or indirectly, interests in any form whatsoever, in other Luxembourg
or foreign entities, to acquire by way of purchase, subscription or acquisition, any securities and rights of any kind through
participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or to acquire financial
debt instruments in any form whatsoever, and to possess, administrate, develop, manage and dispose of such holding of
interests.
2.1 The Company may also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter
into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity
of the financial sector:
- To borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments on a private basis, the use
of financial derivatives or otherwise;
- To render assistance in any form, including but not limited to advances, loans, money deposits, credits, guarantees
or granting of security to its affiliates or other companies.
2.2 The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to
enhance the above-mentioned objectives and to effect all transactions which are necessary or useful to fulfil its object as
well as operations directly or indirectly described in this article.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
66357
Art. 4. The Company exists under the name of "SwissCaps Holding (Luxembourg) S.à r.l."
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-
tered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers,
by the board of managers.
5.1 Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in
case of several managers, by the board of managers.
5.2 In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social
developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.
B. Share Capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at two hundred thousand Swiss Francs (CHF 200,000.-) represented by four
thousand (4,000) ordinary shares (the "Shares"), each having a nominal value of fifty Swiss Francs (CHF 50.-).
Each Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three-
quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's Shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new shareholder
is subject to the approval of such transfer given by the other shareholders, at a majority of three-quarters of the share
capital.
9.1 In the event of death, the Shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the Shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders.
11.1 In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with
the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the share-
holders, who fix(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole shareholder,
or as the case may be, the shareholders.
11.2 The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than
one, by the joint signature of any two managers.
Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
12.1 The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
12.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
12.3 No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a
meeting of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of
the board of managers.
66358
12.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram,
telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may
represent more than one of his colleagues.
12.5 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
12.6 The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or
represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
12.7 The managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes
giving evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of Shares which he owns.
Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents Shares.
Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
18.1 The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any
other amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 19. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as
amended.
E. Financial year - Annual Accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on January 1st, and ends on December 31st.
Art. 21. Each year on December 31, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an
indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation
of the assets and payment of the liabilities of the Company.
23.1 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the Shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
66359
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the restatement of the articles of incorporation of the Company decided above and for the
avoidance of doubt, article 11.2 in relation to the power of signatures of the Company shall be read as follows:
"The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the joint signature of any two managers."
Furthermore, the A and B management classes are removed.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by her name, first name, civil status and
residence, the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le trente et un mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
"Dragenopharm Holding S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 24, rue Beaumont L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, imma-
triculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.756,
ici représentée par Madame Linda KORPEL, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous
seing privé donnée en date du 7 mars 2008.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'associé unique de "SwissCaps Holding (Luxembourg) S.à r.l.", une société à respon-
sabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 24, rue
Beaumont L-1219 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 110.638, constituée suivant acte notarié en date du 31 août 2005, dont les statuts ont été publiés au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 06 janvier 2006, numéro 40. Les statuts de la Société ont été
modifiés pour la dernière fois le 07 octobre 2005, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en
date du 22 février 2006, numéro 391.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de créer une seule et unique catégorie de parts sociales désignées comme les parts sociales
ordinaires et de convertir toutes les parts sociales existantes de la Société, désignées comme les parts sociales de catégorie
A, les parts sociales de catégorie B, les parts sociales de catégorie C, les parts sociales de catégorie D, les parts sociales
de catégorie E, les parts sociales de catégorie F, les parts sociales de catégorie G et les parts sociales de catégorie H en
quatre mille (4.000) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires"), ayant chacune une valeur nominale de
cinquante Francs Suisse (CHF 50,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier et de refondre dans leur intégralité les statuts de la Société sans changer l'objet
de la Société, qui auront dés lors désormais la teneur suivante:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la détention, directe ou indirecte, de tous intérêts, sous quelque forme que ce soit,
dans d'autres entités luxembourgeoises ou étrangères, et l'acquisition, par voie de cession, souscription ou acquisition,
de tous titres et droits de toute nature, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d'acquérir des instruments financiers de dettes, sous quelque forme
que ce soit, ainsi que de posséder, administrer, développer, gérer et disposer de ces intérêts.
2.1 La Société pourra également conclure les transactions suivantes, étant entendu que la Société n'entrera dans aucune
opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier:
66360
- emprunter sous toute forme ou obtenir toute forme de crédit et lever des fonds, et notamment mais non exclusi-
vement, par l'émission d'obligations, de titres de dettes ("notes"), de billets à ordre ("promissory notes") et autres
instruments de dette ou titres de capital sur une base privée, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- apporter une assistance financière, sous toute forme quelconque, et notamment mais non exclusivement par voie
d'avances, de prêts, de dépôts de fonds, de crédits, de garanties ou de sûretés accordées à des sociétés affiliées ou autres.
2.2 La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont
de manière à faciliter l'accomplissement de l'objet pré mentionné nécessaire ou utile à la réalisation de son objet ainsi
que les opérations tel que précédemment décrit,
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de "SwissCaps Holding (Luxembourg) S.à r.l."
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré
dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y aurait plusieurs gérants, par décision du conseil de
gérance.
5.1 Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y aurait plusieurs gérants, par le conseil de
gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
5.2 Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique,
économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce
siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège
social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembour-
geoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de deux cent mille Francs Suisse (CHF 200.000,-), représenté par quatre
mille (4.000) parts sociales ordinaires (ci-après les "Parts Sociales"), ayant chacune une valeur nominale de cinquante
Francs Suisse (CHF 50,-).
Chaque Part Sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les Parts Sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés. Les Parts Sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
9.1 En cas de décès d'un associé, les Parts Sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
C. Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
11.1 Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
11.2 La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par
la signature conjointe de deux de ses gérants.
Art. 12. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres
un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a
pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
12.1 Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de
convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation
n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.
66361
12.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit,
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
12.3 Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du
conseil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de
gérance.
12.4 Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
12.5 Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
12.6 Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents
ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
12.7 Les gérants pourront, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant leur approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.
Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
18.1 Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications
des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 20. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
66362
23.1 L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des Parts Sociales détenues dans
la Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la consolidation des statuts de la Société décidée ci-dessus et pour éviter tout doute, l'article 11.2,
lié au pouvoir de signature de la Société sera désormais lu comme suit:
" La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature conjointe de deux de ses gérants."
Les catégories de gérants A et B sont supprimées.
DONT ACTE, Passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. KORPEL, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 2 avril 2008. Relation: EAC/2008/4501. — Reçu douze Euros (12,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Belvaux, le 14 MAI 2008.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2008064297/239/347.
(080071974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Power Transmission Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 56.517.
L'an deux mille huit, le deux avril.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «POWER TRANSMISSION FINANCE
S.A.», établie et ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie, constituée suivant acte reçu par
le notaire Maître Jacques DELVAUX, alors de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 26 septembre 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 650 du 14 décembre 1996, dont les statuts ont été modifiés à
plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph ELVINGER, de résidence à Luxembourg
en date du 14 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 485 du 25 juin 1999.
L'assemblée est présidée par Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie DUPONT, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Monsieur le président déclare et requiert le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste
de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être sou-
mises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
66363
<i>Ordre du jour:i>
1) Annulation des catégories d'administrateur A et B de la Société et modification en conséquence de l'article 12 des
statuts;
2) Acceptation de la démission d'un (1) administrateur et nomination d'un (1) nouvel administrateur;
3) Divers.
IV. Que la présente assemblée représentant la totalité du capital social est régulièrement constituée et pourra vala-
blement délibérer suivant l'ordre du jour.
Après avoir discuté de ces motifs et après avoir dûment délibéré, l'assemblée, à l'unanimité, décide des résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'annuler les catégories d'administrateur A et B de la Société et décide en conséquent
de modifier l'article 12 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée accepte la démission de:
- Monsieur Alain RUKAVINA, avec effet immédiat et l'assemblée lui donne décharge pour l'exécution de son mandat
jusqu'à ce jour.
L'assemblée nomme en remplacement un nouvel administrateur, à savoir:
- Monsieur Vincent CORMEAU, directeur, né à Verviers (Belgique) le 29 août 1960, demeurant professionnellement
à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2013.
En conséquent le Conseil d'Administration et désormais constitué comme suit:
- Monsieur Herman MOORS;
- Monsieur Riccardo MORALDI;
- Monsieur Vincent CORMEAU;
- Monsieur Stefano RAGUZZONI;
- Monsieur Gian Luca RAGUZZONI.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à neuf cents euros (900.- EUR) sont à charge de la
Société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénoms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. Petit, R. Thill, S. Dupont et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 avril 2008. LAC/2008/14492. — Reçu douze euros (12.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008064278/5770/74.
(080071833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
ProLogis UK CCXVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 109.222.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
66364
Luxembourg, le 19 mai 2008.
Gérard LECUIT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008064151/220/12.
(080072067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Zermatt International S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 122.542.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2008.
CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.
P.O. Box 156 LU-2011 LUXEMBOURG, 60, Grand-Rue / Niveau 2
<i>International Tax Planners
i>Signature
Référence de publication: 2008064276/816/16.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03466. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080071913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
DEFILUX (Développement et Finance Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5652 Mondorf-les-Bains, 1, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 102.298.
L'an deux mille huit, le trois avril.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DEFILUX (Développement et
Finance Luxembourg) S.A. (ci-après «la Société»), ayant son siège social à L-8057 Bertrange, 15, rue du Chemin de Fer,
inscrite sous le numéro B 102.298 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par le notaire Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 15 juillet 2004, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
o
1056, du 21 octobre 2004. Les statuts n'ont jusqu'à ce jour pas été
modifiés.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Laurence BIHR, administrateur-délégué, avec adresse profes-
sionnelle à Mondorf-les-Bains.
Madame le président désigne comme secrétaire de l'assemblée Madame Corinne PETIT, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie DUPONT, avec même adresse professionnelle.
Madame le Président expose ensuite:
I. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de transférer le siège social vers une autre commune, avec modification concomitante de l'adresse du siège
2. Modification subséquente de l'alinéa 2 de l'article 1
er
des statuts
3. Décision de modifier l'objet social
4. Modification subséquente de l'article 3, premier alinéa, des statuts
5. Décision de changer le pouvoir de signature des administrateurs délégués
6. Modification subséquente du dernier alinéa de l'article 8 des statuts
7. Décision de changer la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle et statutaire de la Société
8. Modification subséquente de l'alinéa 1
er
de l'article 14 des statuts
9. Constatation que la société DEFILUX S.A., ayant acquis la marque IDENTIFIA, pourra faire commerce sous la marque
IDENTIFIA partenaire d'image ou IDENTIFIA LUXEMBOURG (facture d'achat n
o
2006.12.085 du 31 décembre 2006)
10. Divers
11. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont renseignés sur
une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au
66365
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregis-
trement.
Les actionnaires présents, respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à des
convocations spéciales et préalables, ayant reçu une parfaite connaissance de l'ordre du jour.
L'assemblée a approuvé l'exposé de Madame le président et, après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée
et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, sans abstentions, et par votes séparés les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en
assemblée générale ordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l'unanimité, ils ont pris par votes
séparés les résolutions suivantes:
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société à L-5653 Mondorf-les-Bains, 1, rue Michel
Rodange, et de modifier par conséquent l'alinéa 2 de l'article premier des statuts de la Société en fixant dorénavant le
siège social dans la commune de Mondorf-les-Bains.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède l'assemblée générale décide que l'alinéa 2 de l'article premier des statuts
sociaux est modifié pour avoir à partir de la date de la présente assemblée générale, la teneur suivante:
« Art. 1
er
. alinéa 2. Le siège social est établi à Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg).»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide de procéder à une modification de l'objet social principal en y intégrant notamment les
activités d'installation d'enseignes lumineuses et de fabrication de panneaux de signalisation, et de modifier par conséquent
l'article 3, premier alinéa, des statuts de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide que l'article 3, premier alinéa, des statuts
sociaux est modifié pour avoir dorénavant et, à partir de la date de la présente assemblée générale, la teneur suivante:
« Art. 3. premier alinéa. La société a pour objet l'étude, la conception, l'installation et la vente d'enseignes et de
signalisations lumineuses et non lumineuses ainsi que la fabrication d'enseignes et de panneaux de signalisation. La société
peut agir et accomplir son objet social sous les marques enregistrées «IDENTIFIA» ou «IDENTIFIA LUXEMBOURG» ou
marques similaires, ou marques composées comprenant le mot «IDENTIFIA» ou «IDENTIFIA LUXEMBOURG», ou sous
toute autre marque, de même que la société peut acquérir, prendre en licence, ou autrement utiliser toute autre marque,
ou toute autre propriété intellectuelle, servant à l'accomplissement de son objet social.»
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale décide de procéder à une modification de l'article 8 des statuts de la Société en réglementant le
pouvoir de signature en cas de pluralité d'administrateurs délégués. Plus spécifiquement l'assemblée décide de créer deux
catégories d'administrateurs délégués, à savoir des administrateurs délégués de la catégorie A et de la catégorie B. L'as-
semblée générale décide que la Société ne se trouve valablement engagée que par la signature individuelle d'un
administrateur délégué de la catégorie A ou par la signature conjointe d'un administrateur délégué de la catégorie A et
d'un administrateur délégué de la catégorie B, de sorte que la Société ne se trouve jamais et en aucun cas engagée par la
signature individuelle d'un administrateur délégué de la catégorie B.
<i>Septième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède l'assemblée générale décide qu'il est ajouté une phrase au dernier alinéa
de l'article 8 des statuts sociaux, de sorte que dorénavant et à partir de la date de la présente assemblée générale, le
dernier alinéa de cet article 8 se lisant dorénavant comme suit:
« Art. 8. dernier alinéa. La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs. En cas de
nomination d'un administrateur délégué, en ce qui concerne la gestion journalière, ce dernier est seul apte à engager la
société par sa signature individuelle. Toutefois en cas de nomination de deux ou de plusieurs administrateurs délégués,
en ce qui concerne la gestion journalière, la société n'est engagée que par la signature individuelle d'un administrateur
délégué de la catégorie A ou par la signature conjointe d'un administrateur délégué de la catégorie A et d'un administrateur
délégué de la catégorie B, de sorte que la société ne se trouve jamais et en aucun cas engagée par la seule signature
individuelle d'un administrateur délégué de la catégorie B.»
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée générale décide que l'assemblée générale statutaire annuelle doit se réunir de plein droit le quatrième
vendredi du mois de juin à 14.00 heures au siège social et de modifier par conséquent l'alinéa 1
er
de l'article 14 des
statuts de la Société.
66366
<i>Neuvième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède l'assemblée générale décide que l'alinéa 1
er
de l'article 14 des statuts
sociaux est modifié pour avoir dorénavant et, à partir de la date de la présente assemblée générale, la teneur suivante:
« Art. 14. alinéa 1
er
. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois de juin
à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»
<i>Dixième résolutioni>
L'assemblée générale constate que la société DEFILUX S.A., ayant acquis la marque IDENTIFIA, pourra faire commerce
sous la marque IDENTIFIA partenaire d'image ou IDENTIFIA LUXEMBOURG (facture d'achat n
o
2006.12.085 du 31
décembre 2006).
<i>Onzième résolutioni>
L'assemblée générale décide que la durée du mandant de tous les administrateurs en place est fixée de manière à
prendre fin à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'année 2009.
<i>Douzième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'autoriser le conseil d'administration à nommer deux administrateurs délégués à la
gestion journalière au lieu d'un seul, et de nommer comme deuxième administrateur délégué:
Monsieur Stéphane ORDENER, employé privé, né en France à Creutzwald en date du 27 décembre 1971, demeurant
à L-5651 Mondorf-les-Bains, 20, rue Paul Eyschen.
<i>Treizième résolutioni>
L'assemblée générale décide de conférer à Madame Laurence BIHR la qualité d'administrateur délégué de la catégorie
A et à Monsieur Stéphane ORDENER la qualité d'administrateur délégué de la catégorie B.
L'assemblée générale décide, conformément à l'article 8 des statuts, et en ce qui concerne la gestion journalière, que
la Société n'est valablement engagée pour le futur que par la signature individuelle de Madame Laurence BIHR, adminis-
trateur délégué de la catégorie A, ou par la signature conjointe de Monsieur Stéphane ORDENER, administrateur délégué
de la catégorie B, et de Madame Laurence BIHR, de sorte que la Société ne se trouve jamais engagée par la signature
individuelle de Monsieur Stéphane ORDENER.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille euros (EUR 1.000).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Bihr, C. Petit, S. Dupont et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2008, LAC/2008/14498. — Reçu douze euros Eur 12.-.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 avril 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008064275/5770/127.
(080071858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
ProLogis UK CCXVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 109.222.
In the year two thousand eight, on the twenty-third day of April.
Before us Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ProLogis UK Holdings S.A., a limited liability company organized under the laws of Luxembourg, having its registered
office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg B 65.769),
duly represented by Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by a virtue proxy given in Luxembourg on April 21, 2008, which, signed "ne varietur" by the appearing person and the
undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
66367
Such appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of "ProLogis UK CCXVI S.à r.l.", a limited liability
company, having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 109.222) (the
"Company"), incorporated under the law of the Grand-Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned
notary on July 1, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 1266 of November 24,
2005 has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of FOUR HUNDRED
NINETY THOUSAND POUNDS (490,000.-GBP) so as to raise it from its present amount of TEN THOUSAND
POUNDS (10,000.-GBP) to FIVE HUNDRED THOUSAND POUNDS (500,000.-GBP) by the issuing of TWENTY-FOUR
THOUSAND FIVE HUNDRED (24,500) new shares with a par value of TWENTY POUNDS (20.-GBP) having the same
rights and obligations as the existing shares.
The increase of the share capital is subscribed by the sole shareholder ProLogis UK Holdings S.A. and entirely paid up
in cash so that the sum of FOUR HUNDRED NINETY THOUSAND POUNDS (490,000.-GBP) is at the free disposal of
the Company, as has been proved to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a result of the foregoing resolution, Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company shall henceforth read
as follows:
"The Company's share capital is fixed at FIVE HUNDRED THOUSAND POUNDS (500,000.-GBP) represented by
TWENTY-FIVE THOUSAND (25,000) shares with a nominal value of TWENTY POUNDS (20.-GBP) each. Each share
is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings".
<i>Estimate of costsi>
For the purpose of registration the amount of GBP 490,000 is estimated at EUR 611,934.
The person appearing estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which
shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this increase of capital at FIVE THOUSAND
EURO (5.000.- EUR.)
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at
the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the
present deed.
Follows the French translation:
L'an deux mil huit, le vingt trois avril.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
ProLogis UK Holdings S.A., une société anonyme créée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social à 18, boulevard Royal, 2449 Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg B 65769),
dûment représentée, par Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 21 avril 2008, qui, après avoir été signé "ne varietur" par le
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Laquelle société comparante, agissant en sa qualité d'associée unique de "ProLogis UK CCXVI S.à r.l.", une société à
responsabilité limitée, ayant son siège social à 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 109.222)
(la "Société"), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte notarié en date du 1
er
juillet 2005,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1266 du 24 novembre 2005, a requis le notaire soussigné
de constater les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de QUATRE CENT QUATRE
VINGT DIX MILLE LIVRES STERLING (490,000.- GBP) pour le porter de son montant actuel de DIX MILLE LIVRES
STERLING (10,000.-GBP) à CINQ CENT MILLE LIVRES STERLING (500,000.-GBP), par l'émission de VINGT QUATRE
MILLE CINQ CENTS (24.500) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de VINGT LIVRES STERLING (20.-GBP)
chacune ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
L'augmentation du capital social est souscrite et entièrement libérée en espèces par l'associée unique ProLogis UK
Holdings S.A. de sorte que la somme de QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX MILLE LIVRES STERLING (490,000.-
GBP) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.
66368
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'Article 6 des Statuts est modifiée et aura désormais la teneur suivante:
"Le capital social est fixé à CINQ CENT MILLE LIVRES STERLING (500,000.-GBP), représenté par VINGT CINQ
MILLE (25.000) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT LIVRES STERLING (20.-GBP) chacune. Chaque part sociale
donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires."
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l'enregistrement le montant de GBP 490.000 est estimé à EUR 611,934.
Le comparant évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de cette augmentation de capital à CINQ MILLE EURO (5.000.-
EUR)
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. BECKER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 avril 2008. LAC/2008/17875. - Reçu à 0,50%: trois mille quarante-neuf euros
trente-cinq cents (EUR 3.049,35).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2008.
Gérard LECUIT.
Référence de publication: 2008064300/220/92.
(080072065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 131.192.
In the year two thousand eight, on the eighteenth day of April.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of "Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.", a société
anonyme, having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on August 7, 2007,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 2223 of 6 October 2007. The articles of Asso-
ciation have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary, on 3 October 2007, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 2745 of 28 November 2007.
The meeting was opened by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, residing in Russange (F), being in the chair,
who appointed as secretary Ms Maggy STRAUSS, employee, residing in Garnich.
The meeting elected as scrutineer Mrs Anke JAGER, employee, residing in Grimburg (D).
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of the corporate object and amendment of article 4 of the articles of association which will henceforth
have the following wording:
" Art. 4. Corporate objects. The object of the Company is to render
- Registrar agency services including administrative and client communication services within the meaning of articles
25, 29-1 and 29-2 of the law of April 5, 1993 regarding the financial sector,
- domiciliary services and administrative services related thereto to companies within the meaning of article 29 of the
law of April 5, 1993 regarding the financial sector,
- Services of setting up and management of companies within the meaning of article 29-5 of the law of April 5, 1993
regarding the financial sector.
The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The
corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not
inconsistent with the foregoing enumerated objects."
2. Miscellaneous.
66369
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The general meeting decides to change the object of the Company, and to amend article 4 of the articles of association,
which will henceforth have the following wording:
" Art. 4. Corporate objects. The object of the Company is to render
- Registrar agency services including administrative and client communication services within the meaning of articles
25, 29-1 and 29-2 of the law of April 5, 1993 regarding the financial sector,
- domiciliary services and administrative services related thereto to companies within the meaning of article 29 of the
law of April 5, 1993 regarding the financial sector,
- Services of setting up and management of companies within the meaning of article 29-5 of the law of April 5, 1993
regarding the financial sector.
The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The
corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not
inconsistent with the foregoing enumerated objects."
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately ONE THOUSAND EUROS
(1,000.- EUR).
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil huit, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Aztec Financial Services (Luxembourg)
S.A.", avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 août 2007,
publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2223 du 6 octobre 2007. Les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant du 3 octobre 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2745 du 28 novembre 2007.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F),
qui désigne comme secrétaire, Madame Maggy STRAUSS, employée privée, demeurant à Garnich.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Anke JAGER, employée privé, demeurant à Grimburg (D).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'objet social de la société et modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. Objet Social. L'objet de la Société est de rendre
- des services d'agent teneur de registre et de communication à la clientèle dans le sens des articles 25, 29-1 et 29-2
de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; et
- des services de domiciliation et des services administratifs en rapport avec des sociétés dans le sens de l'article 29
de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; et
66370
- des services en constituant et en gérant des sociétés dans le sens de l'article 29-4 de la loi du 5 avril 1993 relative
au secteur financier.
La description dont question ci avant doit être entendu dans son sens le plus large et l'énumération n'est pas limitative.
L'objet social devra comporter toute transaction ou accord dans lequel la Société entrera à condition qu'il ne soit pas
incompatible avec l'énumération dont question ci avant."
2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la société et de modifier l'article 4 des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
" Art. 4. Objet Social. L'objet de la Société est de rendre
- des services d'agent teneur de registre et de communication à la clientèle dans le sens des articles 25, 29-1 et 29-2
de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; et
- des services de domiciliation et des services administratifs en rapport avec des sociétés dans le sens de l'article 29
de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; et
- des services en constituant et en gérant des sociétés dans le sens de l'article 29-4 de la loi du 5 avril 1993 relative
au secteur financier.
La description dont question ci-avant doit être entendu dans son sens le plus large et l'énumération n'est pas limitative.
L'objet social devra comporter toute transaction ou accord dans lequel la Société entrera à condition qu'il ne soit pas
incompatible avec l'énumération dont question ci-avant."
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ MILLE EUROS (1.000,- EUR).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire par leurs
nom, prénoms usuels, état et demeure, les comparants ont signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: M. NEZAR, M. STRAUSS, A. JAGER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 avril 2008, LAC/2008/16830. — Reçu douze euros (EUR 12,-).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2008.
Gérard LECUIT.
Référence de publication: 2008064302/220/129.
(080072071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
KEV Germany Nikolaistrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 130.842.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
66371
Belvaux, le 15 mai 2008.
Jean-Joseph WAGNER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008064155/239/12.
(080071944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Patron Weghell Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 124.400.
In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth of April.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of "PATRON WEGHELL HOLDING S.à r.l.", a "société
à responsabilité limitée" (limited liability company), having its registered office in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe,
registered with the Luxembourg register of commerce and companies RCS B 124.400, incorporated by deed of Maître
Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, dated February 2nd, 2007, published in the
Mémorial C N
o
689, dated April 24th, 2007.
The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg,
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing professionally in
Luxembourg,
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list. That
attendance list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 500 shares, representing the whole capital of the company, are represented
so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole partner has been beforehand
informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Modification of the current fiscal year, which shall start on the 1st January and shall end on the 31st December of
the same year.
2.- Amendment of the Articles 20 and 21 which shall read as follows:
" Art. 20. The Company's year start on the first of January and end the thirty-first of December of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the sole manager or the board of
management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office".
3.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The meeting resolved to approve the amendment of the current fiscal year, which shall now start on the 1st January
of each year and shall end on the 31st December of the same year.
The financial year started on February 2nd, 2007 has ended on December 31st, 2007.
In consequence Articles 20 and 21 of the Articles of Incorporation shall be read as follows:
" Art. 20. The Company's year start on the first of January and end the thirty-first of December of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the sole manager or the board of
management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office".
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, they signed with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
66372
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zwei tausend acht, den fünfundzwanzigsten des Monates April.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, mit Amtssitz in Luxemburg.
Wird die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PATRON WEGHELL
HOLDING S.à r.l.", mit Sitz in L-1116 Luxemburg, 6, rue Adolphe, registriert im Handelsregister in Luxemburg unter der
Nummer RCS B 124.400 gemäss notarieller Urkunde vom Notarin Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Remich,
Großherzogtum Luxemburg, aufgenommen am 2. Februar 2007, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 689 vom 24.
April 2007, abgehalten.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Régis Galiotto, Jurist, geschäftsansässig in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführerin und die Versammlung wählt zum Stimmenzählerin Frau Flora Gibert,
Juristin, geschäftsansässig in Luxemburg.
Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:
I) Dass aus einer Anwesenheitsliste, unterzeichnet von den Vertretern der Gesellschaft und Anteilinhabern, hervor-
geht, dass sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind;
diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt der gegen-
wärtigen Urkunde angeheftet um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
II) Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Anteilinhaber, rechtmäßig zusammen-
gesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.
III) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Änderung des Geschäftsjahres, welches am ersten Januar des Jahres anfängt und am einunddreissigsten Dezember
des selben Jahres aufhält.
2.- Änderung des Artikels 20 und 21, wie folgt:
" Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einundreissigsten Dezember jedes Jahres.
Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder
die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen."
3.- Verschiedenes.
Nach Beschluß der Tagesordnung faßt die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluß:
<i>Einziger Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern, welches am ersten Januar des
Jahres anfängt und am einunddreissigsten Dezember des selben Jahres aufhält.
Das Geschäftsjahr, welches am 2. Februar 2007 begann, hat am 31. Dezember 2007 augehört.
Infolgedessen beschliesst die Generalversammlung Artikels 20 und 21 der Satzung wie folgt abzuändern:
" Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jedes Jahres.
Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder
die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen."
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, gibt hiermit zu Protokoll, dass auf Anfrage
der obengenannten erschienenen Personen, die hier vorliegende Ausfertigung in Englisch ausgedrückt ist, welcher eine
deutsche Übersetzung beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienenen Personen und im Falle einer Abweichung zwischen
dem englischen und dem deutschen Text, wird der englische Text massgebend sein.
WORÜBER URKUNDE, hierauf wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg aufgesetzt an dem Tag wie
anfangs in diesem Dokument eingetragen.
Nachdem das Dokument den erschienenen Personen vorgelesen wurde, die dem Notar bekannt sind durch ihre
Namen, Vornamen, zivilen Status und ihrer Herkunft, haben diese Personen zusammen mit uns, Notar, die hier vorlie-
gende Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 30 avril 2008. Relation LAC/2008/17931. — Reçu douze euros (12,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): FRANCIS SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
66373
Luxembourg, le 14 MAI 2008.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2008064305/211/103.
(080071928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Terualent Lux s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 129.004.
L'an deux mille huit, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Gerhard CRAUWELS, consultant, né à Mechelen (Belgique) le 10 avril 1967, demeurant à B-2800 Me-
chelen, Antwerpsesteenweg, 104,
détenteur de vingt-cinq (25) parts sociales de catégorie B.
2.- La société de droit chypriote "TERUALENT LIMITED", avec siège social à P.C. 1082 Nicosia (Chypre), 16, Kyriakou
Matsi Avenue, 3rd Floor, inscrite au RCS Nicosia (Chypre) sous le numéro HE 197643,
détentrice de soixante-quinze (75) parts sociales de catégorie A.
Tous deux ici représentés par Monsieur Gérard LUSATTI, chef comptable, demeurant à Audun-le-Tiche (France), en
vertu de deux procurations données le 20 mars 2008.
Les prédites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire ins-
trumentant, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée "TERUALENT
LUX s. à r.l." (numéro d'identité 2007 24 27 506), avec siège social à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, inscrite au R.C.S.L.
sous le numéro B 129.004, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 juin 2007, publié au
Mémorial C, numéro 1604 du 31 juillet 2007,
ont requis le notaire instrumentant de documenter la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de L-8287 Kehlen, Zone Industrielle à L-4740 Pétange, 5, rue Prince
Jean et de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 2. 1
er
alinéa. Le siège de la société est établi à Pétange."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, est évalué sans nul préjudice à sept cent cinquante euros (€ 750.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: LUSATTI, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 29 avril 2008, Relation: CAP/2008/1322. — Reçu douze euros (12.-).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 14 mai 2008.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2008064337/236/40.
(080072238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Lockdale Lux, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 117.815.
L'an deux mille huit, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Johan BRUYNEEL, directeur sportif, né à Izegem (Belgique) le 23 août 1964, demeurant à B-9500 Ge-
raardsbergen, 120, Groteweg, boîte 3,
détenteur de vingt-cinq (25) parts sociales de catégorie B.
66374
2.- La société de droit chypriote chypriote "LOCKDALE LIMITED", avec siège social à Nicosia, 7, Ifigeneias, 4th Floor,
Strovolos, P.C. 2007, inscrite au RCS Nicosia (Chypre) sous le numéro HE 169940,
détentrice de soixante-quinze (75) parts sociales de catégorie A.
Tous deux ici représentés par Monsieur Gérard LUSATTI, chef comptable, demeurant à Audun-le-Tiche (France), en
vertu de deux procurations données le 7 avril 2008.
Les prédites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire ins-
trumentant, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée "LOCKDALE LUX,
S. à r.l." (numéro d'identité 2006 24 25 580), avec siège social à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, inscrite au R.C.S.L.
sous le numéro B 117.815, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 juillet 2006, publié au
Mémorial C, numéro 1732 du 16 septembre 2006,
ont requis le notaire instrumentant de documenter la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de L-8287 Kehlen, Zone Industrielle à L-4740 Pétange, 5, rue Prince
Jean et de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 2. 1
er
alinéa. Le siège de la société est établi à Pétange."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, est évalué sans nul préjudice à sept cent cinquante euros (€ 750.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: LUSATTI, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 29 avril 2008. Relation: CAP/2008/1321. - Reçu douze euros (12.-).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 14 mai 2008.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2008064338/236/40.
(080072250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
VDV Invest Luxemburg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 130.817.
L'an deux mille huit, le vingt-quatre avril.
Par devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "VDV INVEST LUXEMBURG
S.A." (numéro d'identité 2007 22 24 400), avec siège social à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, inscrite au R.C.S.L. sous
le numéro B 130.817, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 août 2007, publié au Mémorial
C, numéro 2107 du 26 septembre 2007.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gérard LUSATTI, chef comptable, demeurant à Audun-le-
Tiche (France),
qui désigne comme secrétaire Madame Miranda JANIN, employée privée, demeurant à Belvaux.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Au-
bange (Belgique).
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
Transfert du siège social de L-8287 Kehlen, Zone Industrielle à L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean et modification
subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
66375
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abs-
traction des convocations d'usage.
IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution unique suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée décide de transférer le siège social de L-8287 Kehlen, Zone Industrielle à L-4740 Pétange, 5, rue Prince
Jean et de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 2. 1
er
alinéa. Le siège de la société est établi à Pétange."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, est évalué sans nul préjudice à sept cent cinquante euros (€ 750.-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.
Signé: LUSATTI, JANIN, J.M. WEBER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 29 avril 2008, Relation: CAP/2008/1320. — Reçu douze euros (12.-).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 14 mai 2008.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2008064339/236/49.
(080072258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Patron Lepo VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 123.326.
In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth of April.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of "PATRON LEPO VIII S.à r.l.", a "société à responsabilité
limitée" (limited liability company), having its registered office in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, registered with the
Luxembourg register of commerce and companies RCS B 123.326, incorporated by deed of Maître André Jean-Joseph
Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, dated December 15th, 2006, published in the Mémorial C N
o
338, dated
March 9th, 2007.
The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg,
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing professionally in
Luxembourg,
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list. That
attendance list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 500 shares, representing the whole capital of the company, are represented
so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole partner has been beforehand
informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Modification of the current fiscal year, which shall start on the 1st January and shall end on the 31st December of
the same year.
2.- Amendment of the Articles 20 and 21 which shall read as follows:
" Art. 20. The Company's year start on the first of January and end the thirty-first of December of the same year.
66376
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the sole manager or the board of
management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office".
3.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The meeting resolved to approve the amendment of the current fiscal year, which shall now start on the 1st January
of each year and shall end on the 31st December of the same year.
The financial year started on December 15th, 2006 has ended on December 31st, 2006.
In consequence Article 20 of the Articles of Incorporation shall be read as follows:
" Art. 20. The Company's year start on the first of January and end the thirty-first of December of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the sole manager or the board of
management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office".
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, they signed with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing,
the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zwei tausend acht, den fünfundzwanzigsten des Monates April.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, mit Amtssitz in Luxemburg.
Wird die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PATRON LEPO VIII S.à
r.l.", mit Sitz in L-1116 Luxemburg, 6, rue Adolphe, registriert im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer RCS
B 123.326 gemäss notarieller Urkunde vom Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, zu der Zeit Notar in Luxemburg,
aufgenommen am 15. Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 338 vom 9. März 2007, abgehalten.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Régis Galiotto, Jurist, geschäftsansässig in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführerin und die Versammlung wählt zum Stimmenzählerin Frau Flora Gibert,
Juristin, geschäftsansässig in Luxemburg.
Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:
I) Dass aus einer Anwesenheitsliste, unterzeichnet von den Vertretern der Gesellschaft und Anteilinhabern, hervor-
geht, dass sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind;
diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt der gegen-
wärtigen Urkunde angeheftet um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
II) Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Anteilinhaber, rechtmäßig zusammen-
gesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.
III) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Änderung des Geschäftsjahres, welches am ersten Januar des Jahres anfängt und am einunddreissigsten Dezember
des selben Jahres aufhält.
2.- Änderung des Artikels 20 und 21, wie folgt:
" Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einundreissigsten Dezember jedes Jahres.
Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder
die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen."
3.- Verschiedenes.
Nach Beschluß der Tagesordnung faßt die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluß:
<i>Einziger Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern, welches am ersten Januar des
Jahres anfängt und am einunddreissigsten Dezember des selben Jahres aufhält.
Das Geschäftsjahr, welches am 15. Dezember 2006 begann, hat am 31. Dezember 2006 augehört.
Infolgedessen beschliesst die Generalversammlung Artikels 20 und 21 der Satzung wie folgt abzuändern:
66377
" Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jedes Jahres.
Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder
die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen."
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, gibt hiermit zu Protokoll, dass auf Anfrage
der obengenannten erschienenen Personen, die hier vorliegende Ausfertigung in Englisch ausgedrückt ist, welcher eine
deutsche Übersetzung beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienenen Personen und im Falle einer Abweichung zwischen
dem englischen und dem deutschen Text, wird der englische Text massgebend sein.
WORÜBER URKUNDE, hierauf wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg aufgesetzt an dem Tag wie
anfangs in diesem Dokument eingetragen.
Nachdem das Dokument den erschienenen Personen vorgelesen wurde, die dem Notar bekannt sind durch ihre
Namen, Vornamen, zivilen Status und ihrer Herkunft, haben diese Personen zusammen mit uns, Notar, die hier vorlie-
gende Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 30 avril 2008, Relation LAC/2008/17930. — Reçu douze euros (12,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): FRANCIS SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 14 mai 2008.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2008064307/211/102.
(080071966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Am Bistrot S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5366 Munsbach, 197, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 59.419.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008064320/1420/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2008, réf. LSO-CQ01685. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080072054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
ID Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7570 Mersch, 90, rue Nicolas Welter.
R.C.S. Luxembourg B 121.990.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008064321/1420/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2008, réf. LSO-CQ01687. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080072055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
FCT Electronics Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Frisky S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 128.004.
In the year two thousand and seven, on the sixteenth day of April,
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,
66378
There appeared:
FCT Electronics Group, Inc., a company incorporated in the State of Delaware, having its registered office at 615
Dupont Highway, Dover, Kent, Delaware, United States of America,
represented by M
e
Michaël Meylan, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on April 13, 2007, Luxembourg.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to enact the following:
I. Further to the purchase by the appearing party, on April 16 2007, of five hundred (500) shares of FRISKY S.A.R.L, a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized under the laws of the Grand-Duchy of Lu-
xembourg, with registered office at 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, in the process of
being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (the Company), incorporated pursuant to a deed
of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, on April 12, 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et des Associations, previously held by the company Gralberg S.A, the appearing party is the sole shareholder
of the Company (the Sole Shareholder).
II. The agenda is the following:
1. change the name of the Company from "Frisky S.à.r.l" into "FCT Electronics Europe S.à.r.l" and subsequently, amend
article 1 of the articles of association of the Company (the Articles);
2. dismiss the sole manager of the Company and grant discharge;
3. appoint Kevin Scott Penn, born May 1, 1961 in Washington, having his address 1085 Park Avenue, 8B New York,
N.Y. 10128 USA, working as Businessman, as sole manager of the Company for an unlimited duration;
4. amend article 14.1 of the Articles, so that the accounting year of the Company shall close on 31 July of each year
and as a result the current accounting year of the Company, having started on 12 April 2007, shall be closed on 31 July
2007;
5. Miscellaneous
III. The Sole Shareholder then took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from "Frisky S.à.r.l" into "FCT Electronics Europe
S.à.r.l"
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Articles which shall
now read as follows:
" Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "FCT
Electronics Europe S.à.r.l" (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by
the law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles)."
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to dismiss, with effect as of today, Mr Carlo Schneider, as manager of the Company
and to grant him full discharge for the exercise of his mandate.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint for an unlimited duration, with effect as of today, Kevin Scott Penn, born
May 1, 1961 in Washington, having his address 1085 Park Avenue, 8B New York, N.Y. 10128 USA, working as Business-
man, as sole manager of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the accounting year of the Company so as to have it begin on the first of
August of each year and end on the thirty-first of July of the following year. Consequently, the current accounting year
of the Company which has begun on the twelveth of April 2007 shall end on the thirty-first of July 2007.
<i>Sixth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 14.1 of the Articles,
which will henceforth have the following wording:
" Art. 14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of August of each year and end on thirty first
of July of the following year."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will be borne by the Company as a result of the
present deed, are estimated at approximately EUR 2,300.- Euros.
66379
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed
is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will prevail.
The document, having been read to the proxyholder of the appearing party, was signed together with the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le seize avril
Par-devant Nous Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg
A comparu:
FCT Electronics Group, Inc., une société constituée dans l'Etat du Delaware, ayant son siège social à 615 South Dupont
Highway, Dover, Kent, Delaware, Etats-Unis
représenté par M
e
Michaël Meylan, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxem-
bourg, le 13 avril 2007.
La procuration, signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Suite à l'achat par la partie comparante, le 16 avril 2007, des cinq cents (500) parts sociales de la société à respon-
sabilité limitée Frisky S.à.r.l., ayant son siège social 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, en cours d'immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés (la Société), constituée suivant acte notarié par Maître Martine Schaeffer, notaire
de résidence à Remich, le 12 avril 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations,
détenues jusqu'alors par la société Gralberg S.A, la partie comparante est l'associé unique de la Société (l'Associé Unique).
II. L'ordre du jour est le suivant:
1. modification de la dénomination sociale de la Société de "Frisky S.à.r.l" en "FCT Electronics Europe S.à.r.l" et sub-
séquemment, modification de l'article 1
er
des statuts de la Société (les Statuts);
2. révocation du gérant unique de la Société et quitus;
3. nomination de Kevin Scott Penn, né le 1
er
mai 1961 à Washington, ayant son adresse 1085 Park Avenue, 8B New
York, N.Y. 10128 USA, et pour profession Homme d'affaires, en qualité de gérant unique de la Société pour une durée
indéterminée;
4. modification de l'article 14.1 des Statuts, afin que l'exercice social de la Société prenne fin le 31 juillet de chaque
année et que, en conséquence, le présent exercice social, ayant débuté le 12 avril 2007, soit clos le 31 juillet 2007;
5. Divers
III. L'Associé Unique a pris les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de «Frisky S.à.r.l» en «FCT Electronics
Europe S.à.r.l».
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la première résolution, l'Associé Unique décide de modifier l'article 1
er
des Statuts comme suit:
« Art. 1
er
. Il est formé une société responsabilité limitée sous la dénomination «FCT Electronics Europe S.à.r.l» (ci-
après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier, par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) ainsi que par les présents statuts (ci-après les Statuts).»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de révoquer, avec effet ce jour, M. Carlo Schneider, gérant unique de la Société, et de lui
donner plein et entier quitus pour l'accomplissement de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer pour une durée indéterminée, avec effet ce jour, Kevin Scott Penn, né le 1
er
mai
1961 à Washington, ayant son adresse 1085 Park Avenue, 8B New York, N.Y. 10128 USA, et pour profession Homme
d'affaires, en qualité de gérant unique de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide modifier l'exercice social de la Société afin qu'il commence désormais le 1
er
août de chaque
année et prenne fin le 31 juillet de l'année suivante. En conséquence, l'exercice social qui a débuté le 12 avril 2007 se
terminera le 31 juillet 2007.
66380
<i>Sixième résolutioni>
Afin de prendre en compte la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 14.1 des Statuts
comme suit:
Art. 14.1. L'exercice social de la Société commence le 1
er
août de chaque année et se termine le 31 juillet de l'année
suivante».
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, quels qu'ils soient, mis à la charge de la Société du fait du
présent acte s'élèvent à approximativement 2.300.- Euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au fondé de pouvoir du comparant, celui-ci a signé avec le notaire le
présent acte en original.
Signé: M. MEYLAN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 avril 2007, Relation: LAC/2007/5387. — Reçu douze euros (12.-€).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 14 mai 2007.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2008064351/211/138.
(080072315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Colony Capital s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 129.035.
L'an deux mille huit, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Eric BAART, gestionnaire d'entreprises, né à Anvers (Belgique) le 1
er
avril 1966, demeurant à B-2640
Mortsel, Blauwbroederstraat, 10,
détenteur de vingt-cinq (25) parts sociales de catégorie B.
2.- La société de droit chypriote "MORTICAL DEVELOPMENT LTD", avec siège social à Griva Digeni 84, Savvides
Building, Flat/Office 201, P.C. 3101 Limassol (Chypre), inscrite au RCS Nicosia (Chypre) sous le numéro HE 198722,
détentrice de soixante-quinze (75) parts sociales de catégorie A.
Tous deux ici représentés par Monsieur Gérard LUSATTI, chef comptable, demeurant à Audun-le-Tiche (France), en
vertu de deux procurations données le 17 mars 2008.
Les prédites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire ins-
trumentant, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée "COLONY CA-
PITAL s. à r.l." (numéro d'identité 2007 24 27 689), avec siège social à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, inscrite au R.C.S.L.
sous le numéro B 129.035, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 juin 2007, publié au
Mémorial C, numéro 1605 du 31 juillet 2007,
ont requis le notaire instrumentant de documenter la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de L-8287 Kehlen, Zone Industrielle à L-4740 Pétange, 5, rue Prince
Jean et de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
'' Art. 2. 1
er
alinéa. Le siège de la société est établi à Pétange."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, est évalué sans nul préjudice à sept cent cinquante euros (€ 750.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
66381
Signé: LUSATTI, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 29 avril 2008, Relation: CAP/2008/1323. — Reçu douze euros (12.-).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 14 mai 2008.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2008064336/236/40.
(080072232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Gapi Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4562 Niedercorn, Zone Industrielle Haneboesch.
R.C.S. Luxembourg B 61.924.
Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20/05/2008.
EASIT SA
Signature
Référence de publication: 2008064309/3579/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2008, réf. LSO-CQ01860. - Reçu 42,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080072044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Lucos Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 111.768.
L'an deux mille huit, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
A COMPARU:
Monsieur Jan VANDEN ABEELE, administrateur de société, né à Oostrozebeke (Belgique), le 31 août 1952, demeurant
à B-8670 Koksijde, Zeedijk, 45/101,
détenteur de vingt-cinq (25) parts sociales,
ici représenté par Monsieur Gérard LUSATTI, chef comptable, demeurant à Audun-le-Tiche (France), en vertu d'une
procuration donnée le 31 mars 2008.
La prédite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée "LUCOS CONSULTING,
S.à r.l." (numéro d'identité 2006 24 14 368), avec siège social à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, inscrite au R.C.S.L. sous
le numéro B 111.768, constituée sous la forme d'une société anonyme et sous la dénomination de "LUCOS CONSULT-
ING S.A." suivant acte reçu par le notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, en date du 3 novembre 2005,
publié au Mémorial C, numéro 324 du 14 février 2006 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit
notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, en date du 11 avril 2006, publié au Mémorial C, numéro 1288 du
4 juillet 2006, ledit acte contenant notamment transformation de la forme juridique de la société en société à responsabilité
limitée et modification de la dénomination sociale en "LUCOS CONSULTING, S. à r.l.",
a requis le notaire instrumentant de documenter la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social de L-8287 Kehlen, Zone Industrielle à L-4740 Pétange, 5, rue Prince
Jean et de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 5. 1
er
alinéa. Le siège social est établi à Pétange."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, est évalué sans nul préjudice à sept cent cinquante euros (€ 750.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
66382
Signé: LUSATTI, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 29 avril 2008, Relation: CAP/2008/1314. — Reçu douze euros (12.-).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bascharage, le 14 mai 2008.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2008064342/236/41.
(080072279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Assurances Consultances Services S.A., Société Anonyme,
(anc. International Consultance Services S.A.).
Siège social: L-7257 Helmsange, 16, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 62.235.
Le bilan au 31/12/2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 20/05/2008.
Signature.
Référence de publication: 2008064323/3220/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008, réf. LSO-CN07664. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080072164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Paris Express Service-European Sales et Coordination S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2124 Luxembourg, 109, rue des Maraîchers.
R.C.S. Luxembourg B 51.629.
Le bilan au 31/12/2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20/05/2008.
Signature.
Référence de publication: 2008064324/3220/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2008, réf. LSO-CP09994. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080072166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Isolutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2317 Howald, 21A, rue Général Patton.
R.C.S. Luxembourg B 84.137.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008064319/1420/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2008, réf. LSO-CQ01684. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080072053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Den Holzspiecht S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3932 Mondercange, 14, rue de Limpach.
R.C.S. Luxembourg B 90.753.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
66383
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008064322/1420/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2008, réf. LSO-CQ01688. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080072056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
First Euro Industrial Properties III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.267.800,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 104.016.
First Euro Industrial Properties II S.à r.l., associé unique de la Société, a depuis le 30 mai 2007, son siège social au 6,
Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 2 mai 2008.
Pour avis conforme
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2008064538/1337/18.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2008, réf. LSO-CQ01380. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080072308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Carolus Investment Corporation, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 16.100.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2008064399/1267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2008, réf. LSO-CQ04328. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080072116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Carolus Investment Corporation, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 16.100.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2008064400/1267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2008, réf. LSO-CQ04325. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080072121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
66384
Aintree Investments S.A.
Am Bistrot S.à r.l.
Assurances Consultances Services S.A.
Astor S.A.
Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.
Bavaria (BC) Luxco
Beckmann & Jörgensen Holding S.A.
Canisse S.A.
Carolus Investment Corporation
Carolus Investment Corporation
Colony Capital s.à r.l.
Compagnie PIM, Participations Immobilières et Mobilières S.A.
DeA Capital Investments S.A.
DEFILUX (Développement et Finance Luxembourg) S.A.
Den Holzspiecht S.à.r.l.
Eldrige S.A.
FCT Electronics Europe S.à r.l.
Findexa Luxembourg S.à r.l.
First Euro Industrial Properties III S.à r.l.
Frisky S.à r.l.
Gapi Europe S.A.
ID Concept S.à r.l.
International Consultance Services S.A.
Isolutions S.à r.l.
KEV Germany Fuhrbergerstrasse S.à r.l.
KEV Germany Nikolaistrasse S.à r.l.
Kikkolux S.àr.l.
Lexi S.A.
Life Annuity Company
Lockdale Lux, s.à r.l.
Lucos Consulting S.à r.l.
Lucos Consulting S.à r.l.
Mond S.A.
M.S. International Finance S.A.
Natixis Luxembourg S.A.
Nova Troisième S.A.
Onion S.A.
Paris Express Service-European Sales et Coordination S.A.
Patron Lepo VIII S.à r.l.
Patron Lepo V S. à r.l.
Patron Weghell Holding S.à r.l.
Power Transmission Finance S.A.
ProLogis UK CCXVI S.à r.l.
ProLogis UK CCXVI S.à r.l.
Stratis S.A.
SwissCaps Holding (Luxembourg) S.à r.l.
Terualent Lux s.à r.l.
VDV Invest Luxemburg S.A.
Zermatt International S.à r.l.