logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1377

4 juin 2008

SOMMAIRE

Alves Constructions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

66052

Archangel Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .

66093

ARM Asset Backed Securities S.A. . . . . . . .

66056

Bonnac S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66051

Burdes S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66050

CACEIS Bank Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

66062

Canisse S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66091

Didogra s.a.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66093

E.C. Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66091

«E.F.M.STEEL S.àr.l.»  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66053

«Elysée Concept S.àr.l.»  . . . . . . . . . . . . . . . .

66053

Euro Asiabiotech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66093

Europe Voyager Holdings S.à r.l.  . . . . . . . .

66089

FCT Electronics Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . .

66057

Financière Eyschen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

66051

Freo Germany II Partners (SCA) SICAR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66076

Frisky S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66057

Genescor Investment Holding S.A.  . . . . . .

66096

Jeffell S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66096

JMV Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66054

Jupiter International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

66093

Kronos Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66056

Lafin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66056

LSREF Lux Japan Holdings I S. à r.l. . . . . . .

66057

Lux Estates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66055

LUX-Investment Partners S.A.  . . . . . . . . . .

66059

Maiora S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66093

MIH Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66096

Mold-Masters Luxembourg Acquisitions

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66080

Neurochem Luxco I S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . .

66051

New Tan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66051

Patron Lepo Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

66074

Patron Lepo III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66072

Patron Lepo II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66064

Patron Lepo IV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66089

Patron Lepo V S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66076

Patron Weghell IV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

66050

Patron Weghell V S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . .

66070

Pomelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66053

Richardson Investments Barberino S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66050

Salusam AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66066

Société des Ateliers Nic. Olinger S.A. . . . .

66054

Socom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66053

SPC Lux IV, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66050

Sud Promolux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66054

Sud Promolux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66054

Team Trade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66052

Tishman Speyer French Core Holdings S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66094

Tishman Speyer French Core III S.à r.l.  . .

66095

Tishman Speyer French Core II S.à r.l.  . . .

66095

Tishman Speyer French Core I S.à r.l.  . . .

66095

Tishman Speyer French Core IV S.à r.l.  . .

66095

Tishman Speyer French Core VI S.à r.l.  . .

66096

Tishman Speyer French Core V S.à r.l. . . .

66095

Tishman Speyer French Venture IV S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66094

Tishman Speyer French Venture VI S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66094

Tishman Speyer French Venture V S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66094

Toscaninvest Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

66055

TS Metropolis I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66078

Tusken S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66055

Utility Corporate Services S.à r.l. . . . . . . . .

66055

66049

SPC Lux IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 138.047.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 13 mai 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008063717/239/12.
(080071456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Burdes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 114.099.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008063718/5770/12.
(080071450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Patron Weghell IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 124.591.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 51707 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008063719/211/11.
(080071428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Richardson Investments Barberino S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 100.987.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des associés tenue en date du 23 avril 2008

1. M. Robin Simon Charles RUSSIAN a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. M. Ian James BROUGH, né à West Bromwich (Royaume-Uni), le 25 juin 1944, demeurant professionnellement à

GB-WR5 2BH Worcester (Royaume-Uni), 6, Battenhall Road, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée
illimitée.

Luxembourg, le 15 mai 2008.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour RICHARDSON INVESTMENTS BARBERINO S.a r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008063872/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03506. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080071027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

66050

Financière Eyschen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1480 Luxembourg, 8, boulevard Paul Eyschen.

R.C.S. Luxembourg B 10.624.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008063873/1682/13.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03410. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080070978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Neurochem Luxco I S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 94.026.

Veuillez noter que l'associé commanditaire NEUROCHEM INC. a changé de dénomination sociale en BELLUS Health

Inc.

Luxembourg, le 9 mai 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour NEUROCHEM LUXCO I S.C.S.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008063875/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2008, réf. LSO-CQ02950. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080071043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Bonnac S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 86.015.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>BONNAC S.A.
FINDI SARL / LOUV Sàrl
<i>Administrateur / Administrateur
Signature / Signature

Référence de publication: 2008063876/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03212. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080070979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

New Tan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 101.207.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i>qui s'est tenue le 14 mai 2008

L'assemblée générale extraordinaire a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
- Les actionnaires révoquent les administrateurs préexistants:
a) Monsieur Paulo Dos Santos Jorge, né à Figueira da Foz (Portugal), le 4 février 1967, demeurant à L-3321 Berchem,

38, rue Hans Adam;

66051

b) Madame Teresa Dos Santos Duarte, employée privée, née à Luxembourg, le 17 juin 1970, demeurant à L-3321

Berchem, 38, rue Hans Adam;

c) Madame Deolinda Dos Santos Roque, employée, née à Figueira Da Foz (Portugal), le 7 mai 1947, demeurant à L-5819

Alzingen, 5, rue de l'Eglise.

- Les actionnaires nomment en remplacement:
1. Monsieur André Alfred BEAURAIN, retraité, demeurant en France à F-69007 Lyon, 60, rue Georges Conti, comme

administrateur et administrateur-délégué de la société;

2. Monsieur Jean-Yves GIRAUD, employé privé, demeurant à Luxembourg, 9, rue Louvigny;
3. la société LUX-INGENIERIE SA, avec siège social à Luxembourg, 241, route d'Arlon.
- Les actionnaires décident de révoquer le commissaire aux comptes: la société anonyme Auxiliaire Generale d'En-

treprises S.A., et de le remplacer par Monsieur René Cillien, demeurant 19, rue Gehschelt à Flaxweiler L-6925.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.
Les actionnaires décident du transfert du siège social à l'adresse suivante: 2, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2008063984/8990/33.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2008, réf. LSO-CQ04581C. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080071531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Alves Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8708 Useldange, 18, Um Reebou.

R.C.S. Luxembourg B 104.256.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2008063985/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 14 mai 2008, réf. DSO-CQ00094. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080071200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Team Trade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 90.162.

<i>Extrait de la réunion de l'Assemblée Générale du 11 avril 2008

1. L'Assemblée Générale Extraordinaire révoque le Commissaire aux comptes Barral Benoît 15, Croix Castel, F-78600

Maison Lafitte avec effet au 1 

er

 janvier 2006.

2. L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer en son remplacement la société Mazars, 10A, rue Henri

M. Schnadt, L-2530 Luxembourg jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2009.

Pour réquisition
<i>Team TRADE S.A.
Signature

Référence de publication: 2008063967/1682/17.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03409. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080071095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

66052

Socom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 49.898.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2008063983/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 14 mai 2008, réf. DSO-CQ00095. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080071198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

«E.F.M.STEEL S.àr.l.», Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 7, Zone Industrielle In den Allern.

R.C.S. Luxembourg B 113.123.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053, ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2008063982/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 14 mai 2008, réf. DSO-CQ00096. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080071196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

«Elysée Concept S.àr.l.», Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 7, Zone Industrielle In den Allern.

R.C.S. Luxembourg B 113.124.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053, ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2008063981/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 14 mai 2008, réf. DSO-CQ00097. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080071194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Pomelo, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activité.

R.C.S. Luxembourg B 130.367.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CAPELLEN, le 16/05/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008063976/825/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03301. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080071189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

66053

Société des Ateliers Nic. Olinger S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 11, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 18.760.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2008063979/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 14 mai 2008, réf. DSO-CQ00098. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080071192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Sud Promolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 90.577.

Le bilan au 31.12.2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature
<i>L'Administrateur Délégué

Référence de publication: 2008063915/2741/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00451. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080070970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Sud Promolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 90.577.

Le bilan au 31.12.2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature
<i>L'administrateur-délégué

Référence de publication: 2008063913/2741/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00450. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080070969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

JMV Aviation, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 115.540.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CAPELLEN, le 16/05/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008063973/825/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03300. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080071188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

66054

Tusken S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 102.540.

Le bilan au 30.06.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008063999/43/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2008, réf. LSO-CQ02781. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080071244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Toscaninvest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 65.597.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mai 2008.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2008063901/535/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2008, réf. LSO-CQ02513. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080070966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Lux Estates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 93.359.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2008.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signatures

Référence de publication: 2008063895/535/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2008, réf. LSO-CQ02517. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080070965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Utility Corporate Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 105.264.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Utility Corporate Services S.à r.l.
Représentée par Stéphane Hépineuze
<i>Gérant

Référence de publication: 2008064020/1084/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03222. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080071285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

66055

Kronos Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 102.839.

Le bilan au 31 décembre 2007 ainsi que l'affectation du résultat ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 2008.

<i>Pour KRONOS FUND
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
Jean-Michel GELHAY / Martine VERMEERSCH
<i>Directeur / Sous-Directeur

Référence de publication: 2008064019/34/18.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2008, réf. LSO-CQ01784. - Reçu 44,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080071281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

ARM Asset Backed Securities S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 111.830.

Le bilan et l'affectation des résultats au 30 juin 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 mai 2008.

ARM Asset Backed Securities S.A.
M.C.J. Weijermans
<i>Administrator

Référence de publication: 2008064018/683/16.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03223. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080071274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Lafin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 83.258.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue anticipativement le 29 juin 2007

- Les démissions des sociétés FINDI S.à r.l., LOUV S.à r.l. et MADAS S.à r.l., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg

sont acceptées.

- Madame Nicole THIRION, Monsieur Philippe DUCATE, et Monsieur Jean-François DETAILLE, employés privés,

résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommés nouveaux administrateurs.
Leurs mandats viendront à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Luxembourg, le 29 juin 2007.

Pour copie conforme
<i>LAFIN S.A.
P. DUCATE / N. THIRION
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008063888/795/20.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03213. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080071208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

66056

FCT Electronics Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Frisky S.à r.l.).

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 128.004.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 47224 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008064226/211/12.
(080072317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

LSREF Lux Japan Holdings I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.875,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 136.828.

In the year two thousand and eight, on the second of April.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

Lone Star Capital Investments S. à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stumper, L-2557

Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, here represented
by Ms Josiane Meissener, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,
given in Luxembourg on 2 April 2008,

(the Sole Shareholder).
Which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents

the entire share capital of LSREF Lux Japan Holdings I S. à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg,
incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 21 January 2008, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B
136.828, and that has been amended by a deed of Maître Martine Schaeffer dated 20 March 2008, not yet registered nor
published.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that

it may validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 15,750 by an amount of

EUR 125 to an amount of EUR 15,875 by the issuance of 1 new share with a par value of EUR 125 each and to pay a share
premium of EUR 12.88; and

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company.
This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions

unanimously:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 15,750

(fifteen thousand seven hundred and fifty euro) represented by 126 (one hundred twenty-six) shares with a nominal value
of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) by an amount of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) to an
amount of EUR 15,875 (fifteen thousand eight hundred and seventy-five euro) by the issuance of 1 (one) new share with
a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each and to pay a share premium of EUR 12.88 (twelve euro
and eighty-eight cent).

The 1 (one) new share to be issued has been fully subscribed and paid up in cash and the share premium has been paid

by Lone Star Capital Investments S. à r.l. so that the amount of EUR 137.88 (one hundred and thirty-seven euro and
eighty-eight cent) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly
bears witness to it.

66057

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association

of the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:

Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 15,875 (fifteen thousand eight hundred and seventy-

five euro), represented by 127 (one hundred and twenty-seven) shares having a nominal value of EUR 125 (one hundred
and twenty-five euro) each."

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove

mentioned.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le deux avril.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Lone Star Capital Investments S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 7, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 91.796, ici représentée par Josiane Meissener, employée privée, en vertu d'une procuration
donnée à Luxembourg, le 2 avril 2008,

(l'Associé Unique).
Ladite procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social

de la société à responsabilité limitée dénommée LSREF Lux Japan Holdings I S. à r.l. (la Société), société de droit luxem-
bourgeois, non encore immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, selon acte de
Maître Martine Schaeffer du 21 janvier 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
modifié depuis cette date par un acte de Maître Martine Schaeffer en date du 20 mars 2008, non encore enregistré.

L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peuvent

valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation de capital de la Société de son montant actuel de EUR 15.750 à conséquence d'un montant de EUR

125 à un montant de EUR 15,875 par voie d'émission d'1 nouvelle part sociale ordinaire ayant une valeur nominale de
EUR 125 chacune, et le paiement d'une prime d'émission de EUR 12,88 et

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société.
Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci avant, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR

15.750 (quinze mille sept cent cinquante euros) représenté par 126 (cent vingt-six) parts sociales, ayant une valeur no-
minale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune par le biais d'une augmentation de EUR 125 (cent vingt-cinq euros)
à un montant de EUR 15.875 (quinze mille huit cent soixante-quinze euros) par voie d'émission d'1 (une) nouvelle part
sociale ordinaire ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros), et de payer une prime d'émission d'un
montant de EUR 12,88 (douze euros et quatre-vingt-huit cents).

La nouvelle part sociale ordinaire à émettre a été intégralement souscrite et libérée en numéraire et la prime d'émission

a été payée par Lone Star Capital Investments S. à r.l., de sorte que la somme de EUR 137,88 (cent trente-sept euros et
quatre-vingt-huit cents) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

<i>Seconde résolution

Suite à la première résolution, l'Associé Unique de la Société décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société,

dont la version française aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 15.875 (quinze mille huit cent soixante-quinze euros)

représenté par 127 (cent vingt-sept) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune."

66058

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celle-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 avril 2008, LAC/2008/14487. - Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008064225/5770/111.
(080071396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

L.I.P. S.A., LUX-Investment Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 76.424.

L'an deux mille huit, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LUX-Investment Partners

S.A." (numéro d'identité 2000 22 16 702), avec siège social à L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz, inscrite au R.C.S.L.
sous le numéro B 76.424, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 mai 2000, publié au
Mémorial C, numéro 772 du 21 octobre 2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude BETTENDORFF, employé de banque, demeurant

professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Laurent PIERRARD, employé de banque, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jeff SCHMIT, employé de banque, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Refonte des statuts.
2) Démission et nomination d'administrateurs.
3) Démission du commissaire aux comptes.
4) Nomination d'un réviseur d'entreprises.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents

ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abs-
traction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte des statuts de la société qui auront désormais la teneur suivante:

"STATUTS

Titre I 

er

 .- Dénomination, siège social, objet, durée

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par les présents statuts. La société existe sous la dénomination

66059

de "Lux-Investment Partners S.A." (la "Société"), en abrégé L.I.P. S.A. La Société pouvant utiliser à son gré soit la déno-
mination entière, soit la dénomination en abrégé.

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de Lu-
xembourg, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société a pour objet d'agir en tant qu'associé commandité et assumer la gestion de Lux-Investment Partners

SICAV-FIS S.C.A., une société en commandite par actions régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales ainsi que toutes celles

liées directement ou indirectement à son objet.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, en effectuant

toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Titre II.- Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000.- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions d'une

valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

Les actions de la Société sont et resteront nominatives.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

Art. 6. La Société doit être administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration. Dans un tel cas son représentant permanent

sera nommé ou confirmé en conformité avec la loi.

Les Administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans

et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en
fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

Art. 7. Le Conseil d'Administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues
par la loi.

Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 9. Envers les tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux adminis-

trateurs  ou  par  la  signature  unique  de  toute  personne  à  qui  le  pouvoir  de  signature  aura  été  délégué  par  deux
administrateurs, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. Envers les tiers, en toutes circonstances la Société sera
engagée en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la gestion et les opérations courantes de la Société et pour la
représentation de la Société dans la gestion et les opérations courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué,
mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

66060

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil

d'Administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. Les données comptables de la Société seront examinées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés

qui sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires et seront rémunérés par la Société.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
Société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.
Toute assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales.

Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés ou s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé
à voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunication permettant leur identification et sont considérés comme présents pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée. Lorsque la Société a un
actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires
convoquée aux fins de modifier une disposition des statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du
capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première
de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée dans les formes prévues par les statuts
ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.
La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées,
les résolutions pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des actionnaires présents ou
représentés.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin, à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S'il existe des titres faisant l'objet d'usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l'usufruitier, tantôt au nu-propriétaire,

selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l'usufruitier ou du nu-propriétaire.

Titre VI.- Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Titre VII.- Dissolution, liquidation

Art. 17. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales et les modifications ultérieures."

66061

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter les démissions de Messieurs Jean-Claude FINCK et Michel BIREL comme administra-

teurs de la société et leur donne décharge de leurs fonctions.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de procéder à la nomination des membres suivants au conseil d'administration:
a) Monsieur Paolo VINCIARELLI, sous-directeur de banque, né à Esch-sur-Alzette le 25 juin 1971, demeurant profes-

sionnellement à L-2954 Luxembourg, 1, place de Metz, Président;

b) Madame Michèle FOHL, employée de banque, née à Luxembourg le 1 

er

 décembre 1977, demeurant profession-

nellement à L-2954 Luxembourg, 1, place de Metz;

c) Monsieur Michel KIEFFER, employé de banque, né à Luxembourg le 26 septembre 1969, demeurant professionnel-

lement à L-2954 Luxembourg, 1, place de Metz;

d) Monsieur Alain UHRES, employé de banque, né à Esch-sur-Alzette le 29 août 1977, demeurant professionnellement

à L-2954 Luxembourg, 1, Place de Metz;

e) Monsieur Claude WURTH, employé de banque, né à Luxembourg le 2 octobre 1970, demeurant professionnelle-

ment à L-2954 Luxembourg, 1, place de Metz.

Leurs mandats viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Norbert NICKELS comme commissaire aux comptes de la

société et lui donne décharge de sa fonction.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité de réviseur d'entreprises la société anonyme "ERNST &amp; YOUNG S.A.",

ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, parc d'Activité Syrdall, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 47.771.

Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille deux cents euros (€ 1.200.-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, 1, rue Zithe, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: BETTENDORFF, PIERRARD, SCHMIT, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 29 avril 2008, Relation: CAP/2008/1294. — Reçu douze euros (12.-).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 5 mai 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008064232/236/184.
(080072254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

CACEIS BL, CACEIS Bank Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 91.985.

L'an deux mille huit, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est  réunie  l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires de  la  société  anonyme  CACEIS  BANK LUXEM-

BOURG, en abrégé CACEIS BL, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 91.985,
constituée aux termes d'un acte de scission reçu par le notaire instrumentant en date du 28 février 2003, publié au

Mémorial C numéro 340 du 28 mars 2003,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 23 mai 2003, publié au Mémorial C numéro 653 du 16 juin 2003,
- en date du 18 juin 2004, publié au Mémorial C, numéro 847 du 18 août 2004 et

66062

- en date du 03 octobre 2 005, publié au Mémorial C, numéro 192 du 27 janvier 2006
La séance est ouverte à 14h30 heures sous la présidence de Madame Vanessa BOUTHINON-DUMAS, employée

privée, avec adresse professionnelle à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Gaëlle ZUCCARO, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Alexandre KLETHI, employé privé, avec adresse profes-

sionnelle à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

Madame la Présidente expose ensuite:
1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les DIX-HUIT

MILLE (18.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de CINQUANTE-
QUATRE MILLIONS D'EUROS (€ 54.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-
après reproduits, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres
formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de CACEIS BL à concurrence de 32 Mio € pour le porter de son montant actuel de

54 Mio € à un montant total de 86 Mio € par incorporation d'une partie du bénéfice individualisé dans le rapport de
gestion du conseil d'administration, inclus dans les comptes annuels de 2007 qui seront approuvés lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 24 avril 2008 sous la rubrique "Proposition de dividende sous forme d'actions", soit 32 Mio €,
sans création d'actions nouvelles.

2. Augmentation du capital autorisé de 37 Mio € pour le porter de son montant actuel de 58 Mio € à un montant

total, y non inclus le capital souscrit, de 95 Mio €, pour une période expirant le 24 avril 2013.

3. Modification de l'Article 6 des statuts comme suit: Le capital social est fixé à QUATRE-VINGT-SIX MILLIONS

D'EUROS (€ 86.000.000,-), représenté par DIX HUIT MILLE (18.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

"Le capital autorisé, y non inclus le capital souscrit, est fixé à QUATRE-VINGT-QUINZE MILLIONS D'EUROS (€

95.000.000,-).

Dans la limite de ce capital autorisé, le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs

fois et à déterminer les modalités de souscription et de libération en numéraire ou par apport en nature. L'augmentation
de capital peut également s'opérer par incorporation de réserves, de primes d'émission ou de bénéfices reportés, avec
ou sans émissions d'actions nouvelles.

Le Conseil d'Administration est autorisé à fixer le prix de souscription, avec ou sans prime d'émission, la date d'entrée

en  jouissance  ainsi  que  toutes  les  autres  conditions  et  modalités  d'émission,  de  souscription  et  de  libération.  Cette
autorisation est valable, sauf renouvellement, pour une période expirant le 24 avril 2013."

Les dispositions suivantes de l'article 6 des statuts restent inchangés.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de CACEIS BL à concurrence de TRENTE-DEUX MILLIONS D'EU-

ROS  (€  32.000.000,-),  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  CINQUANTE-QUATRE  MILLIONS  D'EUROS  (€
54.000.000,-) à un montant total de QUATRE-VINGT-SIX MILLIONS D'EUROS (€ 86.000.000,-) par incorporation d'une
partie du bénéfice individualisé dans le rapport de gestion du conseil d'administration, inclus dans les comptes annuels de
2007 qui ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en date de ce jour sous la rubrique "Proposition de
dividende sous forme d'actions", soit TRENTE-DEUX MILLIONS D'EUROS (€ 32.000.000,-).

Cette augmentation de capital se fait sans émission d'actions nouvelles.
Il résulte du bilan arrêté au 31 décembre 2007 que les fonds propres sont suffisants pour réaliser cette augmentation

de capital.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital autorisé de TRENTE-SEPT MILLIONS D'EUROS (€ 37.000.000,-) pour le

porter de son montant actuel de CINQUANTE-HUIT MILLIONS D'EUROS (€ 58.000.000,-) à un montant total, y non
inclus le capital souscrit, de QUATRE-VINGT-QUINZE MILLIONS D'EUROS (€ 95.000.000,-), pour une période expirant
le 24 avril 2013.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les alinéas 1 

er

 à 4 de l'article six (6) des statuts

comme suit:

"Le capital social est fixé à QUATRE-VINGT-SIX MILLIONS D'EUROS (€ 86.000.000,-), représenté par DIX-HUIT

MILLE (18.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

66063

Le capital autorisé, y non inclus le capital souscrit, est fixé à QUATRE-VINGT-QUINZE MILLIONS D'EUROS (€

95.000.000,-).

Dans la limite de ce capital autorisé, le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs

fois et à déterminer les modalités de souscription et de libération en numéraire ou par apport en nature. L'augmentation
de capital peut également s'opérer par incorporation de réserves, de primes d'émission ou de bénéfices reportés, avec
ou sans émissions d'actions nouvelles.

Le Conseil d'Administration est autorisé à fixer le prix de souscription, avec ou sans prime d'émission, la date d'entrée

en  jouissance  ainsi  que  toutes  les  autres  conditions  et  modalités  d'émission,  de  souscription  et  de  libération.  Cette
autorisation est valable, sauf renouvellement, pour une période expirant le 24 avril 2013."

<i>Frais

Madame la Présidente fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque

forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital
est évalué à environ six mille euros (€ 6.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales telle que modifiée.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Bouthinon-Dumas, Zuccaro, Klethi, Kesseler.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 30 AVRIL 2008. Relation: EAC/2008/5913. — Reçu douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 07 mai 2008.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2008064234/219/98.
(080072266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

Patron Lepo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 123.339.

In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth of April.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of "PATRON LEPO II S.à r.l.", a "société à responsabilité

limitée" (limited liability company), having its registered office in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, registered with the
Luxembourg register of commerce and companies RCS B 123.339, incorporated by deed of Maître André Jean-Joseph
Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, dated December 15th, 2006, published in the Mémorial C N 

o

 339, dated

March 9th, 2007.

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg,
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing professionally in

Luxembourg,

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list. That

attendance list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 shares, representing the whole capital of the company, are represented

so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole partner has been beforehand
informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Modification of the current fiscal year, which shall start on the 1st January and shall end on the 31st December of

the same year.

2.- Amendment of the Articles 20 and 21 which shall read as follows:
Art. 20. The Company's year start on the first of January and end the thirty-first of December of the same year.

66064

Art. 21.  Each  year  on  the  last  day  of  December,  the  accounts  are  closed  and  the  sole  manager  or  the  board  of

management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."

3.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolution:

<i>Sole resolution

The meeting resolved to approve the amendment of the current fiscal year, which shall now start on the 1st January

of each year and shall end on the 31st December of the same year.

The financial year started on December 15th, 2006 has ended on December 31st, 2006.
In consequence Articles 20 and 21 of the Articles of Incorporation shall be read as follows:
Art. 20. The Company's year start on the first of January and end the thirty-first of December of the same year.

Art. 21.  Each  year  on  the  last  day  of  December,  the  accounts  are  closed  and  the  sole  manager  or  the  board  of

management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, they signed with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing,

the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zwei tausend acht, den fünfundzwanzigsten des Monates April.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Wird die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PATRON LEPO II S.à

r.l.", mit Sitz in L-1116 Luxemburg, 6, rue Adolphe, registriert im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer RCS
B 123.339 gemäss notarieller Urkunde vom Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, zu der Zeit Notar in Luxemburg,
aufgenommen am 15. Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 339 vom 9. März 2007, abgehalten.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Régis Galiotto, Jurist, geschäftsansässig in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführerin und die Versammlung wählt zum Stimmenzählerin Frau Flora Gibert,

Juristin, geschäftsansässig in Luxemburg.

Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:
I) Dass aus einer Anwesenheitsliste, unterzeichnet von den Vertretern der Gesellschaft und Anteilinhabern, hervor-

geht, dass sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind;

diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt der gegen-

wärtigen Urkunde angeheftet um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

II) Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Anteilinhaber, rechtmäßig zusammen-

gesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

III) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

<i>Tagesordnung:

1.- Änderung des Geschäftsjahres, welches am ersten Januar des Jahres anfängt und am einunddreissigsten Dezember

des selben Jahres aufhält.

2.- Änderung des Artikels 20 und 21, wie folgt:
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einundreissigsten Dezember jedes Jahres.

Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder

die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen."

3.- Verschiedenes.
Nach Beschluß der Tagesordnung faßt die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluß:

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern, welches am ersten Januar des

Jahres anfängt und am einunddreissigsten Dezember des selben Jahres aufhält.

Das Geschäftsjahr, welches am 15. Dezember 2006 begann, hat am 31. Dezember 2006 augehört.
Infolgedessen beschliesst die Generalversammlung Artikels 20 und 21 der Satzung wie folgt abzuändern:

66065

Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jedes Jahres.

Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder

die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen."

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, gibt hiermit zu Protokoll, dass auf Anfrage

der obengenannten erschienenen Personen, die hier vorliegende Ausfertigung in Englisch ausgedrückt ist, welcher eine
deutsche Übersetzung beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienenen Personen und im Falle einer Abweichung zwischen
dem englischen und dem deutschen Text, wird der englische Text massgebend sein.

WORÜBER URKUNDE hierauf wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg aufgesetzt an dem Tag wie

anfangs in diesem Dokument eingetragen.

Nachdem  das  Dokument  den  erschienenen  Personen  vorgelesen  wurde,  die  dem  Notar  bekannt  sind  durch  ihre

Namen, Vornamen, zivilen Status und ihrer Herkunft, haben diese Personen zusammen mit uns, Notar, die hier vorlie-
gende Urkunde unterzeichnet.

Signé: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg AC le 3 avril 2008. LAC/2008/17924. - Reçu douze euros (12 euros).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 14 MAI 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008064235/211/102.
(080072273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

Salusam AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 130.110.

Im Jahre zwei tausend acht, den sechsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,

der anonymen Gesellschaft SALUSAM AG, mit Sitz in L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss, eingetragen beim Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 130.110 (NIN 2007 2221 320),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Roger ARRENSDORFF, mit dem Amtssitze in Bad-Mondorf,

am 19. Juli 2007, veröffentlicht im Mémorial G Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1944 vom 11. September
2007, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Roger ARRENS-
DORFF, am 11. Dezember 2007, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 470 vom
23. Februar 2008.

Das Gesellschaftskapital beläuft sich augenblicklich auf DREIUNDDREISSIG TAUSEND EURO (€ 33.000.-) und ist

eingeteilt in sechzehn tausend fünf hundert (16.500) Aktien mit einem Nominalwert von je ZWEI EURO (€ 2.-).

Den  Vorsitz  der  Generalversammlung  führt  Herr  Erwin  PAUPERS,  Kaufmann,  wohnhaft  in  D-67346  Speyer,  Im

Lammsbauch 24.

Er beruft zum Schriftführer Frau Ulrike SCHUBACH, Kauffrau, wohnhaft in D-67134 Birkenheide, Hundertmorgenstr.

12,

und zum Stimmzähler Frau Svitlana KOLOSOVSKA, Ingenieurin, wohnhaft in D-67657 Kaiserslautern, Am Schittweg

4.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
1.- Schaffung von zwei Kategorien von Aktien, nämlich Stammaktien (A Aktien) welche über ein Stimmrecht verfügen

und Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (B Aktien) mit Ausnahme der im Artikel 46 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erschöpfend aufgezählten Umstände.

2.- Festlegung des Ausgabeaufschlages für die neuauszugebenden Aktien.

66066

3.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von VIER HUNDERT EURO (€ 400,-) um es von seinem der-

zeitigen  Betrag  von  DREIUNDDREISSIG  TAUSEND  EURO  (€  33.000,-)  auf  den  Betrag  von  DREIUNDDREISSIG
TAUSEND VIER HUNDERT EURO (€ 33.400,-) zu erhöhen, durch die Ausgabe von zwei hundert (200) neuen Aktien
mit einem Nennwert von je ZWEI EURO (€ 2,-) welche mit den gleichen Rechten und Pflichten wie die bestehenden
Aktien ausgestattet sind, sowie durch Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von NEUNUNDDREISSIG TAUSEND
SECHS HUNDERT EURO (€ 39.600,-).

4.- Zeichnung und Einzahlung der zwei hundert (200) neu geschaffenen Aktien wie folgt:
- ein hundert fünfzig (150) neue Aktien durch den, durch die bestehenden Aktionäre zugelassenen, neuen Aktionär

Herr Jürgen BASTRON, selbständig, wohnhaft in D-38518 Giffhorn, Beckerstr. 18.

- fünfundzwanzig (25) neue Aktien durch den, durch die bestehenden Aktionäre zugelassenen, neuen Aktionär Herr

Arthur EISTETTER, Schlosser, wohnhaft in D-38518 Giffhorn, Jahnweg 13.

- dreizehn (13) neue Aktien durch den, durch die bestehenden Aktionäre zugelassenen, neuen Aktionär Herr Jürgen

JERIN, Rentner, wohnhaft in D-86343 Königsbrunn, Auguststr. 50.

- zwölf (12) neue Aktien durch den, durch die bestehenden Aktionäre zugelassenen, neuen Aktionär Frau Paulina JERIN,

Lehrerin, wohnhaft in D-86343 Königsbrunn, Auguststr. 50.

5.- Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 5 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
deutsche Fassung

Art. 5. (Absatz 1). Das gezeichnete Aktienkapital beträgt DREIUNDDREISSIG TAUSEND VIER HUNDERT EURO (€

33.400,-), eingeteilt in sechzehn tausend fünf hundert (16.500) ordentliche Aktien der Klasse A, mit einem Nominalwert
von je ZWEI EURO (€ 2,-) und zwei hundert (200) Vorzugsaktien der Klasse B mit einem Nennwert von je ZWEI EURO
(€ 2,-).

Jede ordentliche Aktie verleiht eine Stimme.
Die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht verleihen kein Stimmrecht mit Ausnahme der im Artikel 46 des Gesetzes vom

10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erschöpfend aufgezählten Umstände.

englische Fassung

Art. 5 (paragraph 1). The corporate capital is set at THIRTY-THREE THOUSAND FOUR HUNDRED EURO (€

33.400,-), divided into sixteen thousand five hundred (16.500) ordinary shares of class A and two hundred (200) privileged
shares of class B, having a par value of TWO EURO (€ 2,-).

Each ordinary share gives one voting right.
The privileged shares without voting right have no voting right except for the matters listed under article 46 of the

law of 10th August 1915 on commercial companies.

6.- Abänderung von Artikel 13 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
deutsche Fassung

Art. 13. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft interes-

sieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.

Aus dem jährlichen Bilanzgewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) in die gesetzliche Rücklage eingestellt.

Diese Zuweisung ist nicht mehr zwingend soweit die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Grundkapitals erreicht hat.

Vorbehaltlich der Bestimmungen des vorhergehenden Absatzes steht der jährliche Bilanzgewinn sowie die anderen

eventuellen Rücklagen gemäß und unter Vorbehalt der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung der
Generalversammlung wie folgt zur Verfügung:

(a) die Vorzugsaktien verleihen bei Gewinnausschüttung ein Recht auf nachzuzahlende Vorzugsdividende, vor jeglicher

Zahlung an die ordentlichen Aktien.

Die Vorzugsdividende beträgt fünf Prozent (5%) des rechnerischen Kapitalwertes;
(b) bei weiteren Gewinnausschüttungen sollen, nachdem die Ausschüttung der Vorzugsdividende bezüglich der Vor-

zugsaktien getätigt wurde, die ordentlichen Aktien Recht auf die gleiche Zahlung geben;

(c) falls nach diesen Zahlungen noch weitere Ausschüttungen getätigt werden, nehmen alle Aktien gleichmässig an

diesen Verteilungen teil. Der Liquidationserlös wird wie folgt unter den Anteilinhabern aufgeteilt:

(i) die Vorzugsaktien verleihen ein Vorzugsrecht auf die Rückzahlung des eingebrachten Kapitals und jeglicher nach-

zuzahlender Vorzugsdividende;

(ii) bei weiteren Rückzahlungen, nachdem die Rückzahlung des eingebrachten Kapitals an die Vorzugsaktien getätigt

wurde, haben die ordentlichen Aktien Recht auf die gleiche Zahlung;

(iii) der nach diesen Rückzahlungen verbleibende Liquidationserlös wird gleichmässig unter den Aktien aufgeteilt.
englische Fassung

Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides

how the net profit is allocated and distributed.

66067

From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the law.

This allocation shall cease to be required as soon as such surplus reserve exceeds ten per cent (10%) of the subscribed
capital.

With regards to the provisions of the preceding paragraph, the annual net profits as well as the other reserves not

required by the law are at the disposal of the general meeting as follows:

(i) the privileged shares have a first right to an additional privileged dividend in case of a distribution of profits, before

payment to the ordinary shares.

The privileged dividend amounts to five per cent (5%) of the capital value.
(ii) in case of further distributions of profits, after the payout of the privileged dividend in relation with the privileged

shares, the ordinary shares are entitled to the same payment.

((iii) in case of any further payouts, all the shares participate equally in these distributions.
The liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders as follows:
(i) the privileged shares are entitled to a preferential right to the reimbursement of the paid-in capital and to any

privileged dividend that has not yet been paid

(ii) in case of further reimbursements, after the reimbursement of the paid-in capital to the privileged shares has been

done, the ordinary shares are entitled to the same payment.

(iii) the liquidation proceeds, after all the reimbursements, will be distributed equally among all the shares.
7.- Mandat an den Verwaltungsrat vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
IV.- Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der An-

wesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für Richtig
befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertreter und den Mitglie-
dern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt um zusammen einregistriert zu werden.

V.- Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die sechzehn tausend fünf hundert (16.500) Aktien mit einem No-

minalwert von je ZWEI EURO (€ 2.-), welche das gesamte Kapital von DREIUNDDREISSIG TAUSEND EURO (€ 33.000.-)
darstellen, bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind. Diese Generalversammlung ist
somit rechtmässig zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Tagesordnungspunkte beraten
und beschliessen.

Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag des Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie

rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig folgende Bes-
chlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Schaffung von zwei Kategorien von Aktien, nämlich Stammaktien (A Aktien)

welche über ein Stimmrecht verfügen und Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (B Aktien) mit Ausnahme der im Artikel 46
des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erschöpfend aufgezählten Umstände.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Ausgabeaufschlag für die neuauszugebenden Aktien (B Aktien) auf den Betrag

von EIN HUNDERT ACHTUNDNEUNZIG EURO (€ 198,-) pro Aktie festzulegen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um den Betrag von VIER HUNDERT EURO (€ 400,-) zu

erhöhen um es von seinem derzeitigen Betrag von DREIUNDDREISSIG TAUSEND EURO (€ 33.000,-) auf den Betrag
von  DREIUNDDREISSIG  TAUSEND  VIER  HUNDERT  EURO  (€  33.400,-)  zu  erhöhen,  durch  die  Ausgabe  von  zwei
hundert (200) neuen Aktien der Klasse B mit einem Nennwert von je ZWEI EURO (€ 2,-) sowie durch Zahlung eines
Ausgabeaufschlages in Höhe von NEUNUNDDREISSIG TAUSEND SECHS HUNDERT EURO (€ 39.600,-).

<i>Vierter Beschluss

Die zwei hundert (200) neu geschaffenen Aktien der Klasse B werden wie folgt gezeichnet:
- ein hundert fünfzig (150) neue Aktien durch den, durch die bestehenden Aktionäre zugelassenen, neuen Aktionär

Herr Jürgen BASTRON, selbständig, wohnhaft in D-38518 Giffhorn, Beckerstr. 18.

- fünfundzwanzig (25) neue Aktien durch den, durch die bestehenden Aktionäre zugelassenen, neuen Aktionär Herr

Arthur EISTETTER, Schlosser, wohnhaft in D-38518 Giffhorn, Jahnweg 13.

- dreizehn (13) neue Aktien durch den, durch die bestehenden Aktionäre zugelassenen, neuen Aktionär Herr Jürgen

JERIN, Rentner, wohnhaft in D-86343 Königsbrunn, Auguststr. 50.

- zwölf (12) neue Aktien durch den, durch die bestehenden Aktionäre zugelassenen, neuen Aktionär Frau Paulina JERIN,

Lehrerin, wohnhaft in D-86343 Königsbrunn, Auguststr. 50.

Sämtliche neu geschaffenen Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass der Betrag von VIER HUNDERT EURO

(€ 400,-) respektive der Betrag des Ausgabeaufschlages in Höhe von NEUNUNDDREISSIG TAUSEND SECHS HUN-

66068

DERT  EURO  (€  39.600.-)  der  Gesellschaft  von  heute  an  zur  Verfügung  steht,  wie  dies  dem  unterzeichneten  Notar
ausdrücklich nachgewiesen wurde.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den ersten Absatz von Artikel 5 der Statuten abzuändern um ihm folgenden

Wortlaut zu geben:

deutsche Fassung

Art. 5. (Absatz 1). Das gezeichnete Aktienkapital beträgt DREIUNDDREISSIG TAUSEND VIER HUNDERT EURO (€

33.400,-), eingeteilt in sechzehn tausend fünf hundert (16.500) ordentliche Aktien der Klasse A mit einem Nominalwert
von je ZWEI EURO (€ 2,-) und zwei hundert (200) Vorzugsaktien der Klasse B mit einem Nennwert von je ZWEI EURO
(€ 2,-).

Jede ordentliche Aktie verleiht eine Stimme.
Die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht verleihen kein Stimmrecht mit Ausnahme der im Artikel 46 des Gesetzes vom

10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erschöpfend aufgezählten Umstände.

englische Fassung

Art. 5. (paragraph 1). The corporate capital is set at THIRTY-THREE THOUSAND FOUR HUNDRED EURO (€

33.400,-), divided into sixteen thousand five hundred (16.500) ordinary shares of class A and two hundred (200) privileged
shares of class B, having a par value of TWO EURO (€ 2,-).

Each ordinary share gives one voting right.
The privileged shares without voting right have no voting right except for the matters listed under article 46 of the

law of 10th August 1915 on commercial companies.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 13 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben: deut-

sche Fassung

Art. 13. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft interes-

sieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.

Aus dem jährlichen Bilanzgewinn der Gesellschaft werden 5% in die gesetzliche Rücklage eingestellt. Diese Zuweisung

ist nicht mehr zwingend soweit die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Grundkapitals erreicht hat.

Vorbehaltlich der Bestimmungen des vorhergehenden Absatzes steht der jährliche Bilanzgewinn sowie die anderen

eventuellen Rücklagen gemäß und unter Vorbehalt der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung der
Generalversammlung wie folgt zur Verfügung:

(a) die Vorzugsaktien verleihen bei Gewinnausschüttung ein Recht auf nachzuzahlende Vorzugsdividende, vor jeglicher

Zahlung an die ordentlichen Aktien.

Die Vorzugsdividende beträgt fünf Prozent (5%) des rechnerischen Kapitalwertes;
(b) bei weiteren Gewinnausschüttungen sollen, nachdem die Ausschüttung der Vorzugsdividende bezüglich der Vor-

zugsaktien getätigt wurde, die ordentlichen Aktien Recht auf die gleiche Zahlung geben;

(c) falls nach diesen Zahlungen noch weitere Ausschüttungen getätigt werden, nehmen alle Aktien gleichmässig an

diesen Verteilungen teil.

Der Liquidationserlös wird wie folgt unter den Anteilinhabern aufgeteilt:
(i) die Vorzugsaktien verleihen ein Vorzugsrecht auf die Rückzahlung des eingebrachten Kapitals und jeglicher nach-

zuzahlender Vorzugsdividende;

(ii) bei weiteren Rückzahlungen, nachdem die Rückzahlung des eingebrachten Kapitals an die Vorzugsaktien getätigt

wurde, haben die ordentlichen Aktien Recht auf die gleiche Zahlung;

(iii) der nach diesen Rückzahlungen verbleibende Liquidationserlös wird gleichmässig unter den Aktien aufgeteilt.
englische Fassung

Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides

how the net profit is allocated and distributed.

From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the law.

This allocation shall cease to be required as soon as such surplus reserve exceeds ten per cent (10%) of the subscribed
capital.

With regards to the provisions of the preceding paragraph, the annual net profits as well as the other reserves not

required by the law are at the disposal of the general meeting as follows:

(i) the privileged shares have a first right to an additional privileged dividend in case of a distribution of profits, before

payment to the ordinary shares.

The privileged dividend amounts to five percent (5%) of the capital value.

66069

(ii) in case of further distributions of profits, after the payout of the privileged dividend in relation with the privileged

shares, the ordinary shares are entitled to the same payment.

((iii) in case of any further payouts, all the shares participate equally in these distributions.
The liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders as follows:
(i) the privileged shares are entitled to a preferential right to the reimbursement of the paid-in capital and to any

privileged dividend that has not yet been paid

(ii) in case of further reimbursements, after the reimbursement of the paid-in capital to the privileged shares has been

done, the ordinary shares are entitled to the same payment.

(iii) the liquidation proceeds, after all the reimbursements, will be distributed equally among all the shares.

<i>Siebter Beschluss

Dem Verwaltungsrat wird Mandat erteilt vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. PAUPERS, U. SCHUBACH, S. KOLOSOVSKA, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 07 mai 2008, Relation: ECH/2008/612. — Reçu deux cents euros 40.000.- à 0,5% = € 200.-.

<i>Le Receveur (signé): MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Echternach, den 09. Mai 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008064194/201/222.
(080071453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Patron Weghell V S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 124.592.

In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth of April.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of "PATRON WEGHELL V S.à r.l.", a "société à respon-

sabilité limitée" (limited liability company), having its registered office in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, registered
with the Luxembourg register of commerce and companies RCS B 124.592, incorporated by deed of Maître Martine
Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître André Schwachtgen,
notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily absent, dated February 2nd, 2007, published
in the Mémorial C N 

o

 735, dated April 27th, 2007.

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg,
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing professionally in

Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list. That

attendance list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 shares, representing the whole capital of the company, are represented

so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole partner has been beforehand
informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Modification of the current fiscal year, which shall start on the 1st January and shall end on the 31st December of

the same year.

2.- Amendment of the Articles 20 and 21 which shall read as follows:

Art. 20. The Company's year start on the first of January and end the thirty-first of December of the same year.

66070

Art. 21.  Each  year  on  the  last  day  of  December,  the  accounts  are  closed  and  the  sole  manager  or  the  board  of

management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office".

3.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolution:

<i>Sole resolution

The meeting resolved to approve the amendment of the current fiscal year, which shall now start on the 1st January

of each year and shall end on the 31st December of the same year.

The financial year started on February 2nd, 2007 has ended on December 31st, 2007.
In consequence Articles 20 and 21 of the Articles of Incorporation shall be read as follows:

Art. 20. The Company's year start on the first of January and end the thirty-first of December of the same year.

Art. 21.  Each  year  on  the  last  day  of  December,  the  accounts  are  closed  and  the  sole  manager  or  the  board  of

management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office".

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, they signed with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendacht, den fünfundzwanzigsten des Monates April.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Wird die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PATRON WEGHELL V

S.à r.l.", mit Sitz m L-1116 Luxemburg, 6, rue Adolphe, registriert im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer
RCS B 124.592 gemäss notarieller Urkunde vom Notarin Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Remich, Großherzogtum
Luxemburg, aufgenommen am 2. Februar 2007, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 735 vom 27. April 2007,abgehalten.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Régis Galiotto, Jurist, geschäftsansässig in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführerin und die Versammlung wählt zum Stimmenzählerin Frau Flora Gibert,

Juristin, geschäftsansässig in Luxemburg.

Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:
I) Dass aus einer Anwesenheitsliste, unterzeichnet von den Vertretern der Gesellschaft und Anteilinhabern, hervor-

geht, dass sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind;

diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt der gegen-

wärtigen Urkunde angeheftet um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

II) Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Anteilinhaber, rechtmäßig zusammen-

gesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

III) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

<i>Tagesordnung:

1.- Änderung des Geschäftsjahres, welches am ersten Januar des Jahres anfängt und am einunddreissigsten Dezember

des selben Jahres aufhält.

2.- Änderung des Artikels 20 und 21, wie folgt:

„ Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einundreissigsten Dezember jedes Jahres.

Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder

die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen."

3.- Verschiedenes.
Nach Beschluß der Tagesordnung faßt die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluß:

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern, welches am ersten Januar des

Jahres anfangt und am einunddreissigsten Dezember des selben Jahres aufhält.

Das Geschäftsjahr, welches am 2. Februar 2007 begann, hat am 31. Dezember 2007 aufgehört.
Infolgedessen beschliesst die Generalversammlung Artikels 20 und 21 der Satzung wie folgt abzuändern:

66071

„ Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jedes Jahres.

Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder

die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen."

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, gibt hiermit zu Protokoll, dass auf Anfrage

der obengenannten erschienenen Personen, die hier vorliegende Ausfertigung in Englisch ausgedrückt ist, welcher eine
deutsche Übersetzung beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienenen Personen und im Falle einer Abweichung zwischen
dem englischen und dem deutschen Text, wird der englische Text massgebend sein.

WORÜBER URKUNDE
Hierauf wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg aufgesetzt an dem Tag wie anfangs in diesem Doku-

ment eingetragen.

Nachdem  das  Dokument  den  erschienenen  Personen  vorgelesen  wurde,  die  dem  Notar  bekannt  sind  durch  ihre

Namen, Vornamen, zivilen Status und ihrer Herkunft, haben diese Personen zusammen mit uns, Notar, die hier vorlie-
gende Urkunde unterzeichnet.

Signé: R. Galiotto, F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 30 avril 2008, LAC/2008/17936. — Reçu € 12.- (douze euros).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008064195/211/104.
(080071167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Patron Lepo III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 123.340.

In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth of April.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of "PATRON LEPO III S.à r.l.", a "société à responsabilité

limitée" (limited liability company), having its registered office in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, registered with the
Luxembourg register of commerce and companies RCS B 123.340, incorporated by deed of Maître André Jean-Joseph
Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, dated December 15th, 2006, published in the Mémorial C N 

o

 333, dated

March 8th, 2007.

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg,
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing professionally in

Luxembourg,

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list. That

attendance list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 shares, representing the whole capital of the company, are represented

so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole partner has been beforehand
informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Modification of the current fiscal year, which shall start on the 1st January and shall end on the 31st December of

the same year.

2.- Amendment of the Articles 20 and 21 which shall read as follows:
Art. 20. The Company's year start on the first of January and end the thirty-first of December of the same year.

Art. 21.  Each  year  on  the  last  day  of  December,  the  accounts  are  closed  and  the  sole  manager  or  the  board  of

management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."

3.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolution:

66072

<i>Sole resolution

The meeting resolved to approve the amendment of the current fiscal year, which shall now start on the 1st January

of each year and shall end on the 31st December of the same year.

The financial year started on December 15th, 2006 has ended on December 31st, 2006.
In consequence Articles 20 and 21 of the Articles of Incorporation shall be read as follows:
Art. 20. The Company's year start on the first of January and end the thirty-first of December of the same year.

Art. 21.  Each  year  on  the  last  day  of  December,  the  accounts  are  closed  and  the  sole  manager  or  the  board  of

management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, they signed with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing,

the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zwei tausend acht, den fünfundzwanzigsten des Monates April.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Wird die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PATRON LEPO III S.à

r.l.", mit Sitz in L-1116 Luxemburg, 6, rue Adolphe, registriert im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer RCS
B 123.340 gemäss notarieller Urkunde vom Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, zu der Zeit Notar in Luxemburg,
aufgenommen am 15. Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 333 vom 8. März 2007, abgehalten.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Régis Galiotto, Jurist, geschäftsansässig in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführerin und die Versammlung wählt zum Stimmenzählerin Frau Flora Gibert,

Juristin, geschäftsansässig in Luxemburg.

Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:
I) Dass aus einer Anwesenheitsliste, unterzeichnet von den Vertretern der Gesellschaft und Anteilinhabern, hervor-

geht, dass sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind;

diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt der gegen-

wärtigen Urkunde angeheftet um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

II) Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Anteilinhaber, rechtmäßig zusammen-

gesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

III) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

<i>Tagesordnung:

1.- Änderung des Geschäftsjahres, welches am ersten Januar des Jahres anfängt und am einunddreissigsten Dezember

des selben Jahres aufhält.

2.- Änderung des Artikels 20 und 21, wie folgt:
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einundreissigsten Dezember jedes Jahres.

Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder

die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen."

3.- Verschiedenes.
Nach Beschluß der Tagesordnung faßt die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluß:

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern, welches am ersten Januar des

Jahres anfängt und am einunddreissigsten Dezember des selben Jahres aufhält.

Das Geschäftsjahr, welches am 15. Dezember 2006 begann, hat am 31. Dezember 2006 augehört.
Infolgedessen beschliesst die Generalversammlung Artikels 20 und 21 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jedes Jahres.

Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder

die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen."

66073

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, gibt hiermit zu Protokoll, dass auf Anfrage

der obengenannten erschienenen Personen, die hier vorliegende Ausfertigung in Englisch ausgedrückt ist, welcher eine
deutsche Übersetzung beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienenen Personen und im Falle einer Abweichung zwischen
dem englischen und dem deutschen Text, wird der englische Text massgebend sein.

WORÜBER URKUNDE, hierauf wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, aufgesetzt an dem Tag wie

anfangs in diesem Dokument eingetragen.

Nachdem  das  Dokument  den  erschienenen  Personen  vorgelesen  wurde,  die  dem  Notar  bekannt  sind  durch  ihre

Namen, Vornamen, zivilen Status und ihrer Herkunft, haben diese Personen zusammen mit uns, Notar, die hier vorlie-
gende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg AC, le 30 avril 2008, LAC/2008/17925. — Reçu douze euros (12 euros).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 14 mai 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008064236/211/102.
(080072286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

Patron Lepo Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 122.759.

In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth of April.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "PATRON LEPO HOLDING S.à r.l.", a "société

à responsabilité limitée" (limited liability company), having its registered office in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe,
registered with the Luxembourg register of commerce and companies RCS B 122.759, incorporated by deed of Maître
André Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, dated December 15th, 2006, published in the Mémorial
C N 

o

 212, dated February 20th, 2007.

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg,
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing professionally in

Luxembourg,

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list.

That attendance list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be
registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 shares, representing the whole capital of the company, are represented

so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder has been beforehand
informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Modification of the current fiscal year, which shall start on the 1st January and shall end on the 31st December of

the same year.

2.- Amendment of the Article 20 which shall read as follows:
Art. 20. The Company's year start on the first of January and end the thirty-first of December of the same year."
3.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolution:

<i>Sole resolution

The meeting resolved to approve the amendment of the current fiscal year, which shall now start on the 1st January

of each year and shall end on the 31st December of the same year.

The financial year started on December 15th, 2006 has ended on December 31st, 2007.
In consequence Article 20 of the Articles of Incorporation shall be read as follows:
Art. 20. The Company's year start on the first of January and end the thirty-first of December of the same year.".
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

66074

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, they signed with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zwei tausend acht, den fünfundzwanzigsten des Monates April.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Wird die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PATRON LEPO HOL-

DING S.à r.l.", mit Sitz in L-1116 Luxemburg, 6, rue Adolphe, registriert im Handelsregister in Luxemburg unter der
Nummer RCS B 122.759 gemäss notarieller Urkunde vom Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, zu der Zeit Notar in
Luxemburg, aufgenommen am 15. Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 212 vom 20. Februar 2007,ab-
gehalten.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Régis Galiotto, Jurist, geschäftsansässig in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführerin und die Versammlung wählt zum Stimmenzählerin Frau Flora Gibert,

Juristin, geschäftsansässig in Luxemburg.

Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:
I) Dass aus einer Anwesenheitsliste, unterzeichnet von den Vertretern der Gesellschaft und Anteilinhabern, hervor-

geht, dass sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind;

diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt der gegen-

wärtigen Urkunde angeheftet um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

II) Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Anteilinhaber, rechtmäßig zusammen-

gesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

III) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

<i>Tagesordnung:

1.- Änderung des Geschäftsjahres, welches am ersten Januar des Jahres anfängt und am einunddreissigsten Dezember

des selben Jahres aufhält.

2.- Änderung des Artikels 20, wie folgt:
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einundreissigsten Dezember jedes Jahres."
3.- Verschiedenes.
Nach Beschluß der Tagesordnung faßt die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluß:

<i>Einziger beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern, welches am ersten Januar des

Jahres anfängt und am einunddreissigsten Dezember des selben Jahres aufhält.

Das Geschäftsjahr, welches am 15. Dezember 2006 begann, hat am 31. Dezember 2007 augehört.
Infolgedessen beschliesst die Generalversammlung Artikel 20 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jedes Jahres."
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, gibt hiermit zu Protokoll, dass auf Anfrage

der obengenannten erschienenen Personen, die hier vorliegende Ausfertigung in Englisch ausgedrückt ist, welcher eine
deutsche Übersetzung beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienenen Personen und im Falle einer Abweichung zwischen
dem englischen und dem deutschen Text, wird der englische Text massgebend sein.

WORÜBER URKUNDE hierauf wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg aufgesetzt an dem Tag wie

anfangs in diesem Dokument eingetragen.

Nachdem  das  Dokument  den  erschienenen  Personen  vorgelesen  wurde,  die  dem  Notar  bekannt  sind  durch  ihre

Namen, Vornamen, zivilen Status und ihrer Herkunft, haben diese Personen zusammen mit uns, Notar, die hier vorlie-
gende Urkunde unterzeichnet.

Signé: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg AC, le 25 Avril 2008. LAC/2008/17921. - Reçu douze euros (12 euros).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 13 MAI 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008064240/211/91.
(080072312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

66075

Freo Germany II Partners (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société

d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 123.906.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008064219/5770/13.
(080072240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

Patron Lepo V S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 123.342.

In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth of April.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of "PATRON LEPO V S.à r.l.", a "société à responsabilité

limitée" (limited liability company), having its registered office in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, registered with the
Luxembourg register of commerce and companies RCS B 123.342, incorporated by deed of Maître André Jean-Joseph
Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, dated December 15th, 2006, published in the Mémorial C N 

o

 338, dated

March 9th, 2007.

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg,
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing professionally in

Luxembourg,

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list. That

attendance list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 shares, representing the whole capital of the company, are represented

so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole partner has been beforehand
informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Modification of the current fiscal year, which shall start on the 1st January and shall end on the 31st December of

the same year.

2.- Amendment of the Articles 20 and 21 which shall read as follows:
Art. 20. The Company's year start on the first of January and end the thirty-first of December of the same year.

Art. 21.  Each  year  on  the  last  day  of  December,  the  accounts  are  closed  and  the  sole  manager  or  the  board  of

management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."

3.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolution:

<i>Sole resolution

The meeting resolved to approve the amendment of the current fiscal year, which shall now start on the 1st January

of each year and shall end on the 31st December of the same year.

The financial year started on December 15th, 2006 has ended on December 31st, 2006.
In consequence Article 20 of the Articles of Incorporation shall be read as follows:
Art. 20. The Company's year start on the first of January and end the thirty-first of December of the same year.

Art. 21.  Each  year  on  the  last  day  of  December,  the  accounts  are  closed  and  the  sole  manager  or  the  board  of

management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."

66076

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, they signed with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zwei tausend acht, den fünfundzwanzigsten des Monates April.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Wird die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PATRON LEPO V S.à

r.l.", mit Sitz in L-1116 Luxemburg, 6, rue Adolphe, registriert im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer RCS
B 123.342 gemäss notarieller Urkunde vom Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, zu der Zeit Notar in Luxemburg,
aufgenommen am 15. Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 338 vom 9. März 2007, abgehalten.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Régis Galiotto, Jurist, geschäftsansässig in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführerin und die Versammlung wählt zum Stimmenzählerin Frau Flora Gibert,

Juristin, geschäftsansässig in Luxemburg.

Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:
I) Dass aus einer Anwesenheitsliste, unterzeichnet von den Vertretern der Gesellschaft und Anteilinhabern, hervor-

geht, dass sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind;

diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt der gegen-

wärtigen Urkunde angeheftet um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

II) Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Anteilinhaber, rechtmäßig zusammen-

gesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

III) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

<i>Tagesordnung:

1.- Änderung des Geschäftsjahres, welches am ersten Januar des Jahres anfängt und am einunddreissigsten Dezember

des selben Jahres aufhält.

2.- Änderung des Artikels 20 und 21, wie folgt:
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einundreissigsten Dezember jedes Jahres.

Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder

die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen."

3.- Verschiedenes.
Nach Beschluß der Tagesordnung faßt die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluß:

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern, welches am ersten Januar des

Jahres anfängt und am einunddreissigsten Dezember des selben Jahres aufhält.

Das Geschäftsjahr, welches am 15. Dezember 2006 begann, hat am 31. Dezember 2006 augehört.
Infolgedessen beschliesst die Generalversammlung Artikel 20 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jedes Jahres.

Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder

die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen."

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, gibt hiermit zu Protokoll, dass auf Anfrage

der obengenannten erschienenen Personen, die hier vorliegende Ausfertigung in Englisch ausgedrückt ist, welcher eine
deutsche Übersetzung beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienenen Personen und im Falle einer Abweichung zwischen
dem englischen und dem deutschen Text, wird der englische Text massgebend sein.

WORÜBER URKUNDE, hierauf wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg aufgesetzt an dem Tag wie

anfangs in diesem Dokument eingetragen.

Nachdem  das  Dokument  den  erschienenen  Personen  vorgelesen  wurde,  die  dem  Notar  bekannt  sind  durch  ihre

Namen, Vornamen, zivilen Status und ihrer Herkunft, haben diese Personen zusammen mit uns, Notar, die hier vorlie-
gende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER.

66077

Enregsitré à Luxembourg AC, le 30 avril 2008. LAC/2008/17927. — Reçu douze euros (12 euros).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 MAI 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008064239/211/102.
(080072302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

TS Metropolis I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 914.425,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.135.

In the year two thousand and eight, on the twenty-eighth of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

There appears:

TS Metropolis Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 34-38,

avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and
Companies register, section B, under number 125.052,

here represented by Mrs. Solange Wolter, private employee, with professional address at 101, rue Cents, L-1319

Luxembourg, by virtue of a proxy established on April 18, 2008.

The said proxy, signed "ne varietur"' by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée")

existing in Luxembourg under the name of "TS Metropolis I S.à r.l.", having its registered office at 34-38, avenue de la
Liberté,  L-1930  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies
Register, section B, under number 135.135, incorporated by a deed of M 

e

 Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

dated December 19th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 295 dated Feb-
ruary 5th, 2008.

II. The Company's share capital is fixed at twenty thousand Euro (€ 20,000.-) divided into eight hundred (800) shares

of twenty-five Euro (€ 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company's corporate capital to the extent of eight hundred ninety-

four thousand four hundred and twenty-five Euro (€ 894,425.-) to raise it from its present amount of twenty thousand
Euro (€ 20,000.-) to nine hundred fourteen thousand four hundred and twenty-five Euro (€ 914,425.-) by creation and
issue of thirty-five thousand seven hundred and seventy-seven (35,777) new shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each,
vested with the same rights and obligations as the existing shares.

IV. The sole shareholder, here represented as aforementioned, resolves to subscribe for the thirty-five thousand seven

hundred and seventy-seven (35,777) new shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each, and to fully pay them up in the amount
of eight hundred ninety-four thousand four hundred and twenty-five Euro (€ 894,425.-) by contribution in kind in the
amount of eight hundred ninety-four thousand four hundred forty-eight Euro and twenty-seven cents (€ 894,448.27)
consisting in the conversion of a receivable in the same amount held by the sole shareholder towards the Company.

Proof of the existence and value of such receivable has been given to the undersigned notary.
V. The sole shareholder resolves to allocate the excess contribution in the amount of twenty-three Euro and twenty-

seven cents (€ 23.27) to the legal reserve of the Company.

VI. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company's articles of association is amended and shall

henceforth read as follows:

Art. 6. The share capital is fixed at nine hundred fourteen thousand four hundred and twenty-five Euro (€ 914,425.-)

represented by thirty-six thousand five hundred and seventy-seven (36,577) shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately eight thousand Euro (€ 8,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

66078

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-huit avril.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TS Metropolis Holdings S.à r.l., une société a responsabilité limitée, ayant son siège social aux 34-38, avenue de la

Liberté,  L-1930  Luxembourg,  Grand  Duché  de  Luxembourg,  enregistrée  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de
Luxembourg, section B, numéro 125.052,

ici représentée par Madame Solange Wolter, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 101, rue Cents,

L-1319 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 18 avril 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

"TS Metropolis I S.à r.l.", ayant son siège social aux 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de
Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
135.135 (la «Société»), constituée par un acte de M 

e

 Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, reçu en date

du 19 décembre 2007, oublié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 295 du 5 février 2008.

II. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille Euro (€ 20,000,-) divisé en huit cents (800) parts sociales d'une

valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de huit cent quatre-vingt-quatorze

mille quatre cent vingt-cinq Euro (€ 894.425,-) pour le porter de son montant actuel de vingt mille Euro (€ 20.000,-) à
neuf cent quatorze mille quatre cent vingt-cinq Euro (€ 914.425,-) par la création et l'émission de trente-cinq mille sept
cent soixante-dix-sept (35.777) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune, in-
vesties des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

IV. L'associé unique, ici représenté comme il est dit, décide de souscrire aux trente-cinq mille sept cent soixante-dix-

sept (35.777) nouvelles parts sociales de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune et de les libérer intégralement en valeur nominale
au montant de huit cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent vingt-cinq Euro (€ 894.425,-), par apport en nature d'un
montant de huit cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quarante-huit Euro et vingt-sept cents (€ 894.448,27) con-
sistant en la conversion d'une créance du même montant détenue par l'associé unique sur la Société.

Preuve de l'existence et de la valeur de cette créance a été donnée au notaire instrumentant.
V. L'associé unique décide d'allouer l'apport excédentaire d'un montant de vingt-trois Euro et vingt-sept cents (€

23.27) à la réserve légale de la Société.

VI. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à neuf cent quatorze mille quatre cent vingt-cinq Euro (€ 914.425,-) représenté par

trente-six mille cinq cent soixante-dix-sept (36.577) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-)
chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit mille Euro (€ 7.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom et prénom, état

et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte,

Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.

66079

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 mai 2008, Relation: LAC/2008/18280. — Reçu quatre mille quatre cent soixante

douze euros vingt quatre cents (4472,24€).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008064247/242/109.
(080071916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

Mold-Masters Luxembourg Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 72.238,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 130.200.

In the year two thousand and seven, on the eleventh of October.
Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Mold-Masters Luxembourg Acqui-

sitions S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office
at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 130.200 (the Company), incorporated on 16 July 2007 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Association N 

o

 C-1923

on 7 September 2007.

THERE APPEARED:

(1) Mold-Masters Luxembourg Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité

limitée), having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade
and Companies Register under number B 130.205, here represented by Olivier Too, attorney at law, residing professio-
nally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney described hereinafter;

(2) 3i U.S. Growth Partners L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the United States, with its

registered office at 375 Park Avenue, Suite 3001, New York, New York 10152, here represented by Olivier Too, attorney
at law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney described hereinafter;

(3) 3i Group Plc, a public limited company registered with the Company registry of England and Wales (registered

number LP 1142830), with its registered office at 16 Palace Street, London SW1E 5JD, here represented by Olivier Too,
attorney at law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney described hereinafter;

(4) 3i Pan European Buyouts 2006-08A L.P., a limited partnership incorporated under the laws of England, registered

under the Limited Partnerships Act 1907 (registered number LP 11276), with its registered office at 16, Palace Street,
London SW1E 5JD, here represented by Olivier Too, attorney at law, residing professionally in Luxembourg, by virtue
of a power of attorney described hereinafter;

(5) 3i Pan European Buyouts 2006-08B L.P., a limited partnership incorporated under the laws of England, registered

under the Limited Partnerships Act 1907 (registered number LP 11277), with its registered office at 16, Palace Street,
London SW1E 5JD, here represented by Olivier Too, attorney at law, residing professionally in Luxembourg, by virtue
of a power of attorney described hereinafter;

(6) 3i Pan European Buyouts 2006-08C L.P., a limited partnership incorporated under the laws of England, registered

under the Limited Partnerships Act 1907 (registered number LP 11278), with its registered office at 16 Palace Street,
London SW1E 5JD, here represented by Olivier Too, attorney at law, residing professionally in Luxembourg, by virtue
of a power of attorney described hereinafter;

(7)  Pan  European  Buyouts  Co-invest  2006-08  L.P.,  a  limited  partnership  incorporated  under  the  laws  of  England,

registered under the Limited Partnerships Act 1907 (registered number LP 11279), with its registered office at 16 Palace
Street, London SW1E 5JD, here represented by Olivier Too, attorney at law, residing professionally in Luxembourg, by
virtue of a power of attorney described hereinafter;

(8) Pan European Buyouts (Nordic) Co-invest 2006-08 L.P., a limited partnership incorporated under the laws of

England, registered under the Limited Partnerships Act 1907 (registered number LP 11553), with its registered office at
16 Palace Street, London SW1E 5JD, here represented by Olivier Too, attorney at law, residing professionally in Lu-
xembourg, by virtue of a power of attorney described hereinafter;

(9) Pan European Buyouts (Dutch) A Co-invest 2006-08 L.P., a limited partnership incorporated under the laws of

England, registered under the Limited Partnerships Act 1907 (registered number LP 11874), with its registered office at
16 Palace Street, London SW1E 5JD, here represented by Olivier Too, attorney at law, residing professionally in Lu-
xembourg, by virtue of a power of attorney described hereinafter;

66080

(10) Société Générale Investment Corporation, a company incorporated under the laws of the State of Delaware,

United States of America, established at 1221, avenue of the Americas, New York, NY 10020, USA, here represented
by Olivier Too, attorney at law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney described he-
reinafter;

(11) 1147646 Ontario Limited, a limited liability company incorporated under the laws of Canada, established at 233

Armstrong Avenue, Georgetown, Ontario L7G4X5, here represented by Olivier Too, attorney at law, residing profes-
sionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney described hereinafter;

(12) 1003059 Ontario Limited, a limited liability company incorporated under the laws of Canada, established at 233

Armstrong Avenue, Georgetown, Ontario L7G4X5, here represented by Olivier Too, attorney at law, residing profes-
sionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney described hereinafter.

The appearing party referred to under item (1) above is the current shareholder of the Company and is hereafter

referred as to the Sole Shareholder.

The appearing parties referred to under items (2) to (9) above intervene to the present Meeting in order to subscribe

to new shares to be issued by the Company and are hereafter collectively referred to as 3i Growth Capital.

The appearing parties referred to under items (2) to (12) above intervene to the present Meeting in order to subscribe

to new shares to be issued by the Company and are hereafter referred to as the Subscribers and each of them is referred
to as a Subscriber.

The power of attorney from the Sole Shareholder and the Contribution and Subscription agreement dated 11 October

2007 containing the power of attorney of each Subscriber represented at the present Meeting after having been initialled
"ne varietur" by the holder of the power of attorney acting on its behalf and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the 12,500 shares of EUR 1 each and that the entirety of the share capital is thus

duly represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the
agenda, here above reproduced.

II. That the agenda of the meeting is the following:
1. Waiver of the convening notices;
2. Acknowledgment of the resignation of Mr Bruce Alan Keith, Mr Mark Beckett and Mr Thijs Van Ingen as managers

of the Company and discharge for the performance of their duties from the date of their appointment to the date of their
resignation;

3. Decision to (i) set the number of managers at five and (ii) appoint Mr Hamdi Conger, Mr Jonathon Fischer, Mrs

Petra Fischer, Mr Ken Hanau and Mr UIf Van Haacke as new managers of the Company for a term which will expire at
the annual general meeting of the shareholders to be held in 2008;

4. Reduction of the par value of the shares of the Company from their current par value of one Euro (EUR 1) to a

thousandth of an Euro (EUR 0.001) and subsequent increase of the number of shares of the Company from 12,500 (twelve
thousand five hundred) shares to 12,500,000 (twelve million five hundred thousand) shares while at the same time main-
taining the share capital of the Company at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500);

5. Approval, and to the extent as necessary, ratification of the issuance of two non interest bearing convertible notes

in an aggregate amount of CAD 115,000,000 convertible into shares of the Company (the Convertible Note and the
Luxco Buyer Note) and;

6. Increase of the nominal share capital of the Company by a nominal amount of fifty-nine thousand seven hundred

and thirty-eight Euro (EUR 59,738) in order to bring the share capital from its present amount of twelve thousand five
hundred Euro (EUR 12,500), divided into 12,500,000 (twelve million five hundred thousand) shares with a par value of a
thousandth of an Euro (EUR 0.001) each to an amount of seventy-two thousand two hundred and thirty-eight Euros (EUR
72,238), represented by seventy-two million two hundred and thirty-eight thousand (72,238,000) shares (the Shares)
having each a par value of a thousandth of an Euro (EUR 0.001);

7. Subscription to and payment of the share capital increase specified under item 5. above by way of (i) a contribution

in cash (ii) contributions in kind and (iii) conversion of the Convertible Note into 29,810,000 Shares;

8. Subsequent amendment of articles 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the above

changes;

9. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any manager of the Company and any lawyer of Allen &amp; Overy Luxembourg to proceed on behalf of the Company
to the registration of the newly issued shares and the deposit of Company's shares in the share register of the Company
as per the above items; and

10. Miscellaneous.
III. That the Meeting, after deliberation, passed the following resolutions:

66081

<i>First resolution

The entirety of the voting share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the Sole Shareholder represented considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to him in advance.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept the resignation effective as of the date of the Meeting of Mr Bruce Alan Keith,

Mr Mark Beckett and Mr Thijs Van Ingen as managers of the Company as of the date of this meeting and gives them
discharge for the performance of their duties from the date of their appointment to the date of their resignation.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to:
(i) set the number of managers at five; and
(ii) appoint effective as of the date of the Meeting Mr Hamdi Conger, Mr Jonathon Fischer, Mrs Petra Fischer, Mr Ken

Hanau and Mr Ulf Van Haacke as new managers of the Company for a term which will expire at the annual general meeting
of the shareholders to be held in 2008.

As a consequence of the above appointments, the board of managers of the Company will be composed as follows:
- Mr Hamdi Conger, with private address in 7 Briar Road, Newthorpe, Nottinghamshire NG16 2BN, United Kingdom;
- Mr Jonathon Fischer, with professional address at 233 Armstrong Ave, Georgetown, ON L7G 4X5, Ontario, Canada;
- Mrs Petra Fischer, with professional address at 233 Armstrong Ave, Georgetown, ON L7G 4X5, Ontario, Canada;
- Mr Ken Hanau, with professional address at 375 Park Ave, Suite 3001 New York, NY 10152, United States of America;

and

- Mr Ulf Von Haacke, with professional address at 3i Deutschland GmbH, Bockenheimer Landstrasse 55, D-60325

Frankfurt am Main, Germany.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to reduce the par value of the shares of the Company from its current par value of one Euro

(EUR 1) to a thousandth of an Euro (EUR 0.001) and, as a result, to increase the number of shares of the Company from
12,500 (twelve thousand five hundred) shares to 12,500,000 (twelve million five hundred thousand) shares so that the
share capital of the Company is maintained at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500).

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to increase the nominal share capital of the Company by a nominal amount of fifty-nine thousand

seven hundred and thirty-eight Euro (EUR 59,738) in order to bring its share capital from its present amount of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500), divided into twelve million five hundred thousand (12,500,000) shares with a
par value of a thousandth of an Euro (EUR 0.001) each to an amount of seventy-two thousand two hundred and thirty-
eight Euros (EUR 72,238), divided into seventy-two million two hundred and thirty-eight thousand (72,238,000) Shares
of the Company by way of the issue of fifty-nine million seven hundred and thirty eight thousand (59,738,000) shares
having each a par value of a thousandth of an Euro (EUR 0.001).

<i>Sixth resolution

The  Meeting  resolves  to  approve,  and  to  the  extent  necessary  to  ratify,  the  issuance  by  the  Company  of  (i)  the

Convertible Note in an amount of twenty-one million five hundred and two thousand Euro (EUR 21,502,000) and (ii) the
Luxco Buyer Note in an amount of sixty-one million four hundred and forty-eight thousand Euro (EUR 61,448,000), both
entitling the holders thereof to subscribe for shares in the Company in accordance with the relevant provisions of the
Non Interest Convertible Notes as approved by the board of managers of the Company and the Meeting hereby approves
the conversion of the Convertible Note into twenty-nine million eight hundred and ten thousand (29,810,000) Shares of
the Company.

<i>Seventh resolution

The Meeting approves and accepts the subscription of the newly issued Shares as follows:

<i>Intervention - subscription - paiements

The Subscribers listed in the table below declare to subscribe to the increase of the share capital of the Company

represented by way of the issue of fifty-nine million seven hundred and thirty eight thousand (59,738,000) shares having
each a par value of a thousandth of an Euro (EUR 0.001), and to pay them up in full by means of:

(A) as for Société Générale Investment Corporation (the Subscriber identified under item (10) above) by way of a

contribution in cash amounting to three million six hundred and seven thousand Euro (EUR 3,607,000);

(B) a contribution in kind consisting in:
(i) one thousand (1,000) common shares in Alta Holdings Inc., a company incorporated under the laws of Delaware,

United States of America, registered under company number 2614062 and having its registered office at Corporation
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware 19801,

66082

(ii) thirty thousand (30,000) shares having a par value of one pound sterling (GBP 1) each in Mold-Masters (U.K.) Ltd.,

a limited company incorporated under the laws of the United Kingdom, registered under company number 1912861 and
having its registered office at Stoughton House, Harborough Road, Oadby, Leicester, LE2 4LP, Great Britain; and

(iii) a share having a par value of one million Deutsch Mark (DEM 1,000,000) in Mold-Masters Europa GmbH, a company

incorporated under the laws of Germany, registered in the commercial register of Mannheim under company number
HRB 201109 and having its registered office at Neumattring 1, 76532 Baden-Baden (the shares subscribed as per item
(B) above altogether, the Shares); and

(C) the conversion of the Convertible Note into twenty-nine million eight hundred and ten thousand (29,810,000)

Shares of the Company.

Such subscriptions and contributions in kind are made as indicated in the table below and in the sequence as set out

in a tax structure memorandum dated 11 October 2007 prepared by Ernst &amp;Young.

The contributions in kind made by the Subscribers other than Société Générale Investment Corporation consisting in

the Shares, the conversion of the Convertible Note and the contribution in cash of EUR 3,607,000 (the Contribution in
Cash) which is made by the Subscribers indicated in the table below shall be allocated to the extent of fifty-nine thousand
seven hundred and thirty-eight Euro (EUR 59,738) to the nominal share capital account of the Company and the balance
in an aggregate amount of forty three million thirty thousand two hundred and sixty-two Euro (EUR 43,030,262) shall be
allocated to the premium reserve of the Company.

The contribution in Cash is documented by a blocking certificate issued by Société Générale which confirms the

availability of the cash (the Blocking Certificate).

The aggregate value and transferability of the shares contributed to the Company are supported by certificates issued

by the management of each of the Subscribers having contributed the shares and which are countersigned by the mana-
gement of the Company (the Transferability Certificates) which confirm inter alia that the aggregate total value of the
Shares amounts to seventeen million nine hundred and eighty-one thousand Euro (EUR 17,981,000) and that the Shares
are freely transferable to the Company.

The conversion of the Convertible Note is documented by the delivery of the Convertible Note from the Subscribers

having contributed the Convertible Note.

A copy of the Transferability Certificates, a copy of the Blocking Certificate and a copy of the Convertible Note, after

having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed for registration purposes.

On the basis of the Transferability Certificate, the Contribution and Subscription Agreement, the Blocking Certificate,

the Convertible Note, the notary witnesses the payment of the nominal capital and issue premium of the Company of
the share capital increase being the object of the current shareholder meeting.

Subscribers

Number of

Number of

Number of Convertible Contribution

Number of Allocation

Shares in

Shares in

Shares in Note of the

in cash

Shares

in shares

Alta

Mold-

Mold-

Company

(in EUR)

Subscribed in

premium

Holdings

Masters

Masters

Converted

the Company

(in EUR)

Inc

(U.K.) ltd. Europa Gmbh

into shares

Contributed Contributed Contributed

of the

Company

Société Géné-

rale Investment
Corporation . . .

3,607,000

5,000,000 3,602,000

3i U.S. Growth

Partners L.P. . . .

22,357,500

22,357,500

3i Group plc

. . . . . . . . . . .

3,282,245

3,282,245

3i Pan Euro-

pean Buyouts
2006-08A LP . . .

3,306,727

3,306,727

3i Pan Euro-

pean Buyouts
2006-08B LP . . .

251,000

251,000

3i Pan Euro-

pean Buyouts
2006-08C LP . . .

544,428

544,428 21,472,190

Pan European

Buyouts Co-in-

57,235

57,235

66083

vest 2006-08 LP
. . . . . . . . . . .

Pan European

Buyouts (Nordic)
Co-invest
2006-08 LP . . . .

7,035

7,035

Pan European

*  . . . . . . . . . . .

<i>Eighth resolution

The Meeting resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

the above resolutions so that it reads henceforth as follows:

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed and paid in share capital is fixed at EUR 72,238 (seventy-two thousand

two hundred and thirty-eight Euros ), represented by 72,238,000 (seventy-two million two hundred and thirty-eight
thousand ) shares having a nominal value of 0.001 EUR (a thousandth of an Euro) per share each."

<i>Ninth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby

empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen &amp; Overy Luxembourg to
proceed on behalf of the Company to the registration in the share capital register of the Company (including for the
avoidance of any doubts, the signature of the said register) (i) the increase of the share capital of the Company and (ii)
to see any formalities in connection therewith, if any.

<i>Capital duty

In respect of the contributions in kind consisting of respectively at least 65% of the shares of Mold-Masters (U.K) Ltd

having its registered office and place of effective management in the European Union and therefore the Company refers
to Article 4-2 of the law of 29 December 1971, which provides for capital duty exemption. Capital duty of 1% will be
payable in respect of the remainder of the capital increase.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately forty-two thousand

euro (EUR 42,000).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le onze octobre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Mold-Masters Luxembourg

Acquisitions S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 20, rue de la
Poste, à L-2346 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 130.200 (la Société), constituée le 16 juillet 2007 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de
résidence à Luxembourg au Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C

o

 1923 du 7 septembre 2007.

ONT COMPARU:

(1) Mold-Masters Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son

siège social au 20, rue de la Poste, à L-2346 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 130.205, ci-après représentée par Olivier Too, juriste, résidant professionnellement à
Luxembourg, en vertu d'une procuration décrite ci-après;

(2) 3i U.S. Growth Partners L.P., une société en commandite (limited partnership) de droit des Etats-Unis d'Amérique,

ayant son siège social à 375 Park Avenue, Suite 3001, New York, New York 10152, Etats-Unis d'Amérique, ci-après
représentée par Olivier Too, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration décrite ci-
après;

(3) 3i Group Plc, une société anonyme de droit britannique immatriculée sous le numéro LP 1142830, ayant son siège

social au 16 Palace Street, Londres SW1E 5JD, Royaume-Uni, représentée par son gérant 3i Investments Plc, ci-après

66084

représentée par Olivier Too, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration décrite ci-
après;

(4) 3I PAN EUROPEAN BUYOUTS 2006-08A L.P., une société en commandite (limited partnership) de droit britan-

nique enregistrée en vertu du Limited Partnership Act de 1907 (numéro LP 11276) ayant son siège social au 16, Palace
Street, Londres, SW1E 5JD, Royaume-Uni, représentée par son gérant 3i Investments Plc, ci-après représentée par Olivier
Too, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration décrite ci-après;

(5) 3I PAN EUROPEAN BUYOUTS 2006-08B L.P., une société en commandite (limited partnership) de droit britan-

nique enregistrée en vertu du Limited Partnership Act de 1907 (numéro LP 11277) ayant son siège social au 16, Palace
Street, Londres, SW1E 5JD, Royaume-Uni, représentée par son gérant 3i Investments Plc, ci-après représentée par Olivier
Too, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration décrite ci-après;

(6) 3I PAN EUROPEAN BUYOUTS 2006-08C L.P., une société en commandite (limited partnership) de droit britan-

nique enregistrée en vertu du Limited Partnership Act de 1907 (numéro LP 11278) ayant son siège social au 16, Palace
Street, Londres, SW1E 5JD, Royaume-Uni, représentée par son gérant 3i Investments Plc, ci-après représentée par Olivier
Too, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration décrite ci-après;

(7) PAN EUROPEAN BUYOUTS CO-INVEST 2006-08 L.P., une société en commandite (limited partnership) de droit

britannique enregistrée en vertu du Limited Partnership Act de 1907 (numéro LP 11279) ayant son siège social au 16,
Palace Street, Londres, SW1E 5JD, Royaume-Uni, représentée par son gérant 3i Investments Plc, ci-après représentée
par Olivier Too, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration décrite ci-après;

(8) PAN EUROPEAN BUYOUTS (NORDIC) CO-INVEST 2006-08 L.P., une société en commandite (limited part-

nership) de droit britannique enregistrée en vertu du Limited Partnership Act de 1907 (numéro LP 11553) ayant son
siège social au 16, Palace Street, Londres, SW1E 5JD, Royaume-Uni, représentée par son gérant 3i Investments Plc, ci-
après  représentée  par  Olivier  Too,  juriste,  résidant  professionnellement  à  Luxembourg,  en  vertu  d'une  procuration
décrite ci-après;

(9) PAN EUROPEAN BUYOUTS (DUTCH) A CO-INVEST 2006-08 L.P., une société en commandite (limited part-

nership) de droit britannique enregistrée en vertu du Limited Partnership Act de 1907 (numéro LP 11874) ayant son
siège social au 16, Palace Street, Londres, SW1E 5JD, Royaume-Uni, représentée par son gérant 3i Investments Plc, ci-
après  représentée  par  Olivier  Too,  juriste,  résidant  professionnellement  à  Luxembourg,  en  vertu  d'une  procuration
décrite ci-après;

(10) Société Générale Investment Corporation, une société régie par le la loi en vigueur dans l'Etat de Delaware, Etats-

Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1221, avenue of the Americas, New York, NY 10020, Etats-Unis d'Amérique,
ci-après représentée par Olivier Too, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration
décrite ci-après;

(11) 1147646 Ontario Limited, une société en commandite (limited partnership) de droit du Canada, ayant son siège

social à 233 Armstrong Avenue, Georgetown, Ontario L7G4X5, ci-après représentée par Olivier Too, juriste, résidant
professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration décrite ci-après;

(12) 1003059 Ontario Limited, une société en commandite (limited partnership) de droit du Canada, ayant son siège

social à 233 Armstrong Avenue, Georgetown, Ontario L7G4X5, ci-après représentée par Olivier Too, juriste, résidant
professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration décrite ci-après;

La partie comparante mentionnée au point (1) ci-dessus est l'associé actuel de la Société et sera ci-après désignée en

tant que l'Associé Unique.

Les parties comparantes mentionnées sous les points (2) à (9) comparaissent à la présente Assemblée pour y souscrire

à de nouvelles parts sociales devant être émises par la Société et seront ci-après désignées ensemble en tant que 3i
Growth Capital.

Les parties comparantes mentionnées sous les points (2) à (12) comparaissent à la présente Assemblée pour y souscrire

à de nouvelles parts sociales devant être émises par la Société, et seront ci-après désignées ensemble en tant que les
Souscripteurs, et individuellement le Souscripteur.

Les procurations de l'Associé Unique et le Contrat d'Apport et de Souscription daté du 11 octobre 2007 contenant

les procurations pour chaque Souscripteur représenté à la présente Assemblée, après avoir été paraphées «ne varietur»
par le mandataire agissant en leur nom et par le notaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même
temps que celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient l'ensemble des 12.500 parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 1 chacune et

que l'intégralité du capital social étant dûment représentée à l'Assemblée, l'Assemblée est par conséquent constituée et
apte à délibérer des points de l'ordre du jour mentionnés ci-dessous.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Acceptation de la démission de messieurs Bruce Alan Keith, Mark Beckett et Thijs Van Ingen en tant que gérants

de la Société et décharge pour l'exercice de leurs mandats respectifs depuis la date de leur nomination jusqu'à la date de
leur démission;

66085

3. Décision de (i) établir le nombre de gérants à cinq et (ii) nommer M. Hamdi Conger, M. Jonathon Fischer, Mme

Petra Fischer, M. Ken Hanau et M. Ulf Van Haacke en tant que nouveaux gérants de la Société pour un mandat qui expirera
à l'assemblée générale annuelle des associés devant avoir lieu en 2008;

4. Réduction de la valeur nominale des parts sociales de la Société de leur valeur actuelle de un Euro (EUR 1) à un

millième d'Euro (EUR 0,001) et augmentation consécutive du nombre de parts sociales de la Société actuellement établi
à 12.500 (douze mille cinq cents), à un nombre de parts sociales de 12.500.000 (douze millions cinq cent mille), tout en
conservant un capital social de la Société s'élevant à EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euros);

5. Approbation et, dans la mesure du nécessaire, ratification de l'émission de deux convertible notes sans intérêt d'un

montant total de CAD 115.000.000 pouvant être converties sous forme de parts sociales de la Société (la Convertible
Note et la Luxco Buyer Note); et

6. Augmentation du capital social nominal de la Société d'un montant nominal de cinquante-neuf mille sept cent trente-

huit Euros (EUR 59.738) afin de porter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR
12.500), divisé en douze millions cinq cent mille (12.500.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un millième
d'Euro (EUR 0,001) chacune, à un montant de soixante-douze mille deux cent trente-huit Euros (EUR 72.238), divisé en
soixante-douze millions deux cent trente- huit mille(72.238.000) parts sociales de la Société ayant chacune une valeur
nominale de un millième d'Euro (EUR 0,001);

7. Souscription et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 6. ci-dessus au moyen (i) d'un

apport en numéraire, (ii) d'apports en nature et (iii) de la conversion de Convertible Notes en 29.810.000 Parts Sociales;

8. Modification consécutive de l'article 5 des statuts de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus;
9. Modification du registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, et pouvoir et

autorisation accordés à tout gérant de la Société et à tout avocat de Allen &amp; Overy Luxembourg de procéder pour le
compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises de la Société dans le registre des parts sociales
de la Société, conformément aux point ci-dessus; et

10. Divers.
III. Après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social avec droit de vote étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de

renoncer aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté s'estimant dûment convoqué et déclarant avoir pris
connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L'associé Unique décide d'accepter la démission de messieurs Bruce Alan Keith, Mark Beckett et Thijs Van Ingen en

tant que gérants de la Société à compter de la date de la présente Assemblée et de leur accorder décharge pour l'exercice
de leurs mandats respectifs depuis la date de leur nomination jusqu'à la date de leur démission.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide:
(i) d'établir le nombre de gérants à cinq, et
(ii) de nommer M. Hamdi Conger, M. Jonathon Fischer, Mme Petra Fischer, M. Ken Hanau et M. Ulf Van Haacke en

tant que nouveaux gérants de la Société à compter de la date de la présente Assemblée pour un mandat qui expirera à
l'assemblée générale annuelle des associés devant avoir lieu en 2008.

En conséquence des nominations ci-dessus, le conseil de gérance de la Société sera composé des membres suivants:
- M. Hamdi Conger, avec adresse privée au 7 Briar Road, Newthorpe, Nottinghamshire NG16 2BN, Royaume-Uni;
- M. Jonathon Fischer, avec adresse professionnelle au 233 Armstrong Ave, Georgetown, ON L7G 4X5, Ontario,

Canada;

-  Mme  Petra  Fischer,  avec  adresse  professionnelle  au  233  Armstrong  Ave,  Georgetown,  ON  L7G  4X5,  Ontario,

Canada;

- M. Ken Hanau, avec adresse professionnelle au 375 Park Ave, Suite 3001 New York, NY 10152, Etats-Unis d'Amé-

rique; et

- M. Ulf Von Haacke, avec adresse professionnelle à 3i Deutschland GmbH, Bockenheimer Landstrasse 55, D 60325

Frankfurt am Main, Allemagne.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de réduire la valeur nominale des parts sociales de la Société de leur valeur actuelle de un

Euro (EUR 1) à un millième d'Euro (EUR 0,001) et, par conséquent d'augmenter le nombre de parts sociales de la Société
actuellement établi à 12.500 (douze mille cinq cents), à un nombre de parts sociales de 12.500.000 (douze millions cinq
cent mille), tout en conservant un capital social de la Société s'élevant à EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euros).

66086

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social nominal de la Société d'un montant nominal de cinquante-neuf mille

sept cent trente-huit Euros (EUR 59.738) afin de porter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents
Euros (EUR 12.500), divisé en douze millions cinq cent mille (12.500.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un
millième d'Euro (EUR 0,001) chacune, à un montant de soixante-douze mille deux cent trente-huit Euros (EUR 72.238),
divisé en soixante-douze millions deux cent trente-huit mille(72.238.000) parts sociales de la Société, par voie de l'émission
de cinquante-neuf millions sept cent trente-huit mille (59.738.000) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de
un millième d'Euro (EUR 0,001).

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide d'approuver, et dans la mesure du nécessaire, de ratifier l'émission par la Société (i) d'une Con-

vertible Note d'un montant total de vingt et un million cinq cent deux mille Euros (EUR 21.502.000), et (ii) d'une Luxco
Buyer Note d'un montant de soixante-et-un millions quatre cent quarante-huit mille Euros (EUR 61.448.000), ces deux
notes permettant à leurs détenteurs de souscrire à des parts sociales de la Société, conformément aux dispositions des
Convertible Notes Sans Intérêt approuvées par le conseil de gérance de la Société, et l'Assemblée approuve par les
présentes la conversion de la Convertible Note en vingt-neuf millions huit cent dix mille (29.810.000) Parts Sociales de
la Société.

<i>Septième résolution

L'Assemblée approuve et accepte la souscription des nouvelles Parts Sociales émises de la manière suivante:

<i>Intervention - souscription - libération

Les Souscripteurs mentionnés dans le tableau ci-dessous déclarent souscrire à l'augmentation de capital social de la

Société, effectuée au moyen de l'émission de cinquante-neuf millions sept cent trente-huit mille (59.738.000) parts sociales
ayant une valeur nominale de un millième d'Euro (EUR 0,001) chacune, et les libérer entièrement au moyen,

(A) pour Société Générale Investment Corporation (Souscripteur identifié sous le point (10) ci-dessus), d'un apport

en numéraire d'un montant de trois millions six cent sept mille Euros (EUR 3.607.000); et

(B) d'un apport en nature consistant en
(i) mille (1.000) parts sociales ordinaires détenues dans Alta Holdings Inc., une société de droit du Delaware aux Etats-

Unis d'Amérique, immatriculée sous le numéro 2614062 et ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique;

(ii) trente mille (30.000) parts sociales d'une valeur nominale de une livre Sterling (£1) chacune détenues dans Mold-

Masters (U.K.) Ltd., une société de droit britannique immatriculée sous le numéro 1912861 ayant son siège social à
Stoughton House, Harborough Road, Oadby, Leicester, LE2 4LP, Royaume-Uni; et

(iii) une part d'une valeur de un million de Deutsche Mark (DEM 1.000.000) détenue dans Mold-Masters Europa GmbH,

une société de droit allemand immatriculée auprès du registre de commerce de Mannheim sous le numéro HRB 201109,
et ayant son siège social à Neumattring 1, 76532 Baden-Baden (les parts sociales souscrites selon le point (B) ci-dessus
sont désignées ensemble comme les Parts Sociales); et

(C) la conversion de la Convertible Note en vingt-neuf millions huit cent dix mille (29.810.000) Parts Sociales de la

Société.

Lesdits apports en nature et souscriptions s'effectuent selon la répartition ci-dessous et selon l'ordre indiqué dans le

Tax structure memorandum du 11 octobre 2007 préparé par Ernst &amp; Young.

Les apports en nature effectués par les Souscripteurs autres que la Société Générale Investment Corporation consis-

tant en les Parts Sociales, la conversion de la Convertible Note et l'apport en numéraire d'un montant de EUR 3.607.000
(l'Apport en Numéraire) effectué par les Souscripteurs indiqués dans le tableau ci-dessous seront attribués pour un
montant de cinquante-neuf mille sept cent trente-huit Euros (EUR 59.738) au compte de capital social nominal de la
Société, et le solde d'un montant total de EUR 43.030.262 (quarante-trois millions trente mille deux cent soixante-deux
Euros) sera attribué à la réserve de prime d'émission de la Société.

L'Apport en Numéraire est attesté par un certificat de blocage émis par Société Générale, qui confirme la disponibilité

des fonds (le Certificat de Blocage).

La valeur totale et la cessibilité des parts sociales apportées à la Société sont attestées par des certificats émis par les

conseils de gérance de chaque Souscripteur ayant apporté les parts, et contresignés par le conseil de gérance de la Société
(les Certificats de Cessibilité), et confirment entre autres que la valeur totale des Parts Sociales s'élève à dix-sept millions
neuf cent quatre-vingt-un mille Euros (EUR 17.981.000) et que les Parts Sociales sont librement cessibles à la Société.

La conversion de la Convertible Note est attestée par la mise à disposition de la Convertible Note par les Souscripteurs

l'ayant apportée.

Un exemplaire des Certificat de Cessibilité, Certificat de Blocage et de la Convertible Note, après avoir été signés «

ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et par le notaire instrumentaire restera annexé aux présentes en
vue de l'enregistrement.

66087

Sur la base du Certificat de Cessibilité, du Contrat d'Apport et de Souscription, du Certificat de Blocage, et de la

Convertible Note, le notaire témoigne du paiement du capital social nominal et de la prime d'émission de la Société, suite
à l'augmentation de capital effectuée lors de la présente Assemblée.

Souscripteurs

Nombre de

Nombre de Nombre de Convertible

Apport en Nombre de

Prime

parts

parts

parts

Note de la

Numéraire

parts d'émission

sociales

sociales

sociales

Société

(en Euros)

sociales (en Euros)

détenues

détenues

détenues

converties

dans la

dans Alta

dans Mold-

dans Mold-

en parts

Société

Holdings Inc.

Masters

Masters

sociales de

apportées

(U.K) Ltd. Europa Gmbh

la Société

CAD

apportées

apportées

CAD

DEM

Société Générale

Investment Corpo-
ration . . . . . . . . . .

3,607,000

5,000,000 3,602,000

3i U.S. Growth

Partners L.P. . . . . .

22,357,500

22,357,500

3i Group plc . . .

3,282,245

3,282,245

3i Pan European

Buyouts 2006-08A
LP . . . . . . . . . . . . .

3,306,727

3,306,727

3i Pan European

Buyouts 2006-08B
LP . . . . . . . . . . . . .

251,000

251,000

3i Pan European

Buyouts 2006-08C
LP . . . . . . . . . . . . .

544,428

544,428 21,472,190

Pan European

Buyouts Co-invest
2006-08 LP . . . . . .

57,235

57,235

Pan European

Buyouts (Nordic)
Co-invest 2006-08
LP . . . . . . . . . . . . .

7,035

7,035

Pan European

Buyouts (Dutch)
Co-invest 2006-08
LP . . . . . . . . . . . . .

3.830

3.830

1003059 Onta-

rio Limited . . . . . .

30.000 (pour

GBP 1 par

parts sociales

1 (pour DEM

1.000.000 par

parts sociales

21.428.000 15.434.572

1147646 Onta-

rio Limited . . . . . . 1.000

3.500.000 2.521.500

Total: . . . . . . . . 3.500.000

2.210.000

1.000.000

29.810.000

3.607.000 59.738.000 43.030.262

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y refléter les modifications

décidées dans les résolutions précédentes, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est établi à un montant EUR 72.238 (soixante-douze

mille deux cent trente-huit Euros), représenté par 72.238.000 (soixante-douze millions deux cent quarante mille) parts
sociales ayant une valeur nominale de EUR 0,001 (un millième d'Euro) chacune."

<i>Dixième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus,

et accorde pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen &amp; Overy Luxembourg
de procéder pour le compte de la Société à l'inscription au registre des parts sociales de la Société (y inclus afin d'éviter
tout doute, la signature dudit registre de parts sociales) de (i) l'augmentation de capital social de la Soc et (ii) de procéder
à toutes formalités afférentes, le cas échéant.

66088

<i>Droit d'apport

Les apports en nature consistant respectivement en un minimum de 65% des parts sociales de Mold-Masters (U.K.)

Ltd., une société ayant son siège social et son lieu principal d'administration en Union Européenne, la Société se réfère à
l'Article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exonération du droit d'apport. Un droit d'apport de 1% sera
versé pour le reste de l'augmentation de capital.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations, et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés à un montant d'environ quarante-deux mille euros (EUR 42.000).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de distorsions
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants, les comparants ont signé avec le notaire l'original du présent acte.
Signé: O. Too et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, LAC/2007/31809. — Reçu quatre cent quatorze mille neuf cent soixante-

dix euros Eur 1% = 414.970.-.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 avril 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008064271/5770/520.
(080071774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

Europe Voyager Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 134.469.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008064218/5770/12.
(080071788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

Patron Lepo IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 123.341.

In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth of April.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of "PATRON LEPO IV S.à r.l.", a "société à responsabilité

limitée" (limited liability company), having its registered office in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, registered with the
Luxembourg register of commerce and companies RCS B 123.341, incorporated by deed of Maître André Jean-Joseph
Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, dated December 15th, 2006, published in the Mémorial C N 

o

 338, dated

March 9th, 2007.

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg,
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing professionally in

Luxembourg,

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list. That

attendance list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

66089

II.- As appears from the attendance list, the 500 shares, representing the whole capital of the company, are represented

so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole partner has been beforehand
informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Modification of the current fiscal year, which shall start on the 1st January and shall end on the 31st December of

the same year.

2.- Amendment of the Articles 20 and 21 which shall read as follows:
Art. 20. The Company's year start on the first of January and end the thirty-first of December of the same year.

Art. 21.  Each  year  on  the  last  day  of  December,  the  accounts  are  closed  and  the  sole  manager  or  the  board  of

management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

3.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolution:

<i>Sole resolution

The meeting resolved to approve the amendment of the current fiscal year, which shall now start on the 1st January

of each year and shall end on the 31st December of the same year.

The financial year started on December 15th, 2006 has ended on December 31st, 2006.
In consequence Articles 20 and 21 of the Articles of Incorporation shall be read as follows:
Art. 20. The Company's year start on the first of January and end the thirty-first of December of the same year.

Art. 21.  Each  year  on  the  last  day  of  December,  the  accounts  are  closed  and  the  sole  manager  or  the  board  of

management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, they signed with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing,

the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Es folgt die Deutsche Übersetzung:

Im Jahre zwei tausend acht, den fünfundzwanzigsten des Monates April.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Wird die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PATRON LEPO IV S.à

r.l.", mit Sitz in L-1116 Luxemburg, 6, rue Adolphe, registriert im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer RCS
B 123.341 gemäss notarieller Urkunde vom Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, zu der Zeit Notar in Luxemburg,
aufgenommen am 15. Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 338 vom 9. März 2007,abgehalten.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Régis Galiotto, Jurist, geschäftsansässig in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführerin und die Versammlung wählt zum Stimmenzählerin Frau Flora Gibert,

Juristin, geschäftsansässig in Luxemburg.

Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:
I) Dass aus einer Anwesenheitsliste, unterzeichnet von den Vertretern der Gesellschaft und Anteilinhabern, hervor-

geht, dass sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind;

diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt der gegen-

wärtigen Urkunde angeheftet um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

II) Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Anteilinhaber, rechtmäßig zusammen-

gesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

III) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

<i>Tagesordnung:

1.- Änderung des Geschäftsjahres, welches am ersten Januar des Jahres anfängt und am einunddreissigsten Dezember

des selben Jahres aufhält.

2.- Änderung des Artikels 20 und 21, wie folgt:
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einundreissigsten Dezember jedes Jahres.

66090

Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder

die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

3.- Verschiedenes.
Nach Beschluß der Tagesordnung faßt die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluß:

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern, welches am ersten Januar des

Jahres anfängt und am einunddreissigsten Dezember des selben Jahres aufhält.

Das Geschäftsjahr, welches am 15. Dezember 2006 begann, hat am 31. Dezember 2006 augehört.
Infolgedessen beschliesst die Generalversammlung Artikels 20 und 21 der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jedes Jahres.

Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder

die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen."

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, gibt hiermit zu Protokoll, dass auf Anfrage

der obengenannten erschienenen Personen, die hier vorliegende Ausfertigung in Englisch ausgedrückt ist, welcher eine
Deutsche Übersetzung beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienenen Personen und im Falle einer Abweichung zwischen
dem englischen und dem deutschen Text, wird der englische Text massgebend sein.

WORÜBER URKUNDE hierauf wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg aufgesetzt an dem Tag wie

anfangs in diesem Dokument eingetragen.

Nachdem  das  Dokument  den  erschienenen  Personen  vorgelesen  wurde,  die  dem  Notar  bekannt  sind  durch  ihre

Namen, Vornamen, zivilen Status und ihrer Herkunft, haben diese Personen zusammen mit uns, Notar, die hier vorlie-
gende Urkunde unterzeichnet.

Signé: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg AC, le 30 avril 2008. LAC/2008/17926. - Reçu douze euros (12 euros).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 14 MAI 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008064237/211/102.
(080072293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

E.C. Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 30.397.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2008.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2008064238/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03419. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080071948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

Canisse S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 75.168.

L'an deux mille huit, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CANISSE S.A.", ayant son

siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de  Luxembourg,  section  B,  sous  le  numéro  75168,  constituée  suivant  acte  reçu  par  Maître  André-Jean-Joseph

66091

SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 3 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 528 du 24 juillet 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Monique GOERES, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La  Présidente  désigne  comme  secrétaire  et  l'assemblée  choisit  comme  scrutateur  Monsieur  Christian  DOSTERT,

employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La Présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Luxembourg-Kirchberg à L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, et modification

afférente de la 2 

ème

 phrase de l'article 1 

er

 des statuts.

2. Modification de l'article 11 des statuts.
3. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg-Kirchberg à L-8070 Bertrange, 10B, rue des Méro-

vingiens, et de modifier en conséquence la deuxième phrase de l'article 1 

er

 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

 Art. 1 

er

 . deuxième phrase.  Le siège social est établi à Bertrange, (Grand-Duché de Luxembourg)."

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 11

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1 

er

 du mois de juin à 15.00 heures au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit."

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide:
- de supprimer le dernier alinéa de l'article 6, et
- de modifier le deuxième alinéa de l'article 6 des statuts comme suit:

Art. 6. (deuxième alinéa). Le conseil d'administration élira en son sein un président. Le conseil se réunira sur la

convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera
toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence le conseil d'administration pourra désigner à la majorité
des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: GOERES - DOSTERT - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 mai 2008, Relation GRE/2008/1963. — Reçu Douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

66092

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 15 mai 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008064252/231/68.
(080072156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

Jupiter International S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 122.498.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2008.

CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.
P.O. Box 156, LU-2011 LUXEMBOURG, 60, Grand-Rue / Niveau 2
<i>International Tax Planners
Signature

Référence de publication: 2008064255/816/16.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03472. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080071906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

Archangel Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 132.646.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008064217/5770/12.
(080071920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

Didogra s.a., Société Anonyme,

(anc. Maiora S.A.).

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 117.677.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 12 mai 2008.

Paul BETTINGEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2008063725/202/13.
(080071275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Euro Asiabiotech, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 76.576.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 13 mai 2008.

Pour copie conforme

66093

<i>Pour la société
Pour Maître Jean SECKLER
Notaire
Par délégation Monique GOERES

Référence de publication: 2008063724/231/15.
(080071552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Tishman Speyer French Venture IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.599.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 11 mai 2008.

Paul BETTINGEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2008063729/202/12.
(080071360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Tishman Speyer French Venture V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.596.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 9 mai 2008.

Paul BETTINGEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2008063730/202/12.
(080071358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Tishman Speyer French Venture VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.598.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 11 mai 2008.

Paul BETTINGEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2008063731/202/12.
(080071356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Tishman Speyer French Core Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.950.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 11 mai 2008.

Paul BETTINGEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2008063732/202/12.
(080071353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

66094

Tishman Speyer French Core I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.946.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 11 mai 2008.

Paul BETTINGEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2008063733/202/12.
(080071351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Tishman Speyer French Core II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.947.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 11 mai 2008.

Paul BETTINGEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2008063734/202/12.
(080071347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Tishman Speyer French Core III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.080.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 11 mai 2008.

Paul BETTINGEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2008063735/202/12.
(080071339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Tishman Speyer French Core IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.948.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 11 mai 2008.

Paul BETTINGEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2008063736/202/12.
(080071331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Tishman Speyer French Core V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.949.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

66095

Senningerberg, le 11 mai 2008.

Paul BETTINGEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2008063737/202/12.
(080071320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Tishman Speyer French Core VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.079.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 11 mai 2008.

Paul BETTINGEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2008063738/202/12.
(080071312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

MIH Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 116.908.

Les comptes annuels pour la période du 1 

er

 janvier 2007 au 31 mars 2007 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008063770/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2008, réf. LSO-CQ02915. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080071080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Genescor Investment Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 88.553.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008063747/534/10.
(080071066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Jeffell S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 108.062.

Le Bilan au 30 novembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008063748/534/10.
(080071068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

66096


Document Outline

Alves Constructions S.à r.l.

Archangel Investments S.à r.l.

ARM Asset Backed Securities S.A.

Bonnac S.A.

Burdes S.à r.l.

CACEIS Bank Luxembourg

Canisse S.A.

Didogra s.a.

E.C. Holdings S.A.

«E.F.M.STEEL S.àr.l.»

«Elysée Concept S.àr.l.»

Euro Asiabiotech

Europe Voyager Holdings S.à r.l.

FCT Electronics Europe S.à r.l.

Financière Eyschen S.A.

Freo Germany II Partners (SCA) SICAR

Frisky S.à r.l.

Genescor Investment Holding S.A.

Jeffell S.à r.l.

JMV Aviation

Jupiter International S.à r.l.

Kronos Fund

Lafin S.A.

LSREF Lux Japan Holdings I S. à r.l.

Lux Estates S.A.

LUX-Investment Partners S.A.

Maiora S.A.

MIH Luxembourg S.A.

Mold-Masters Luxembourg Acquisitions S.à r.l.

Neurochem Luxco I S.C.S.

New Tan S.A.

Patron Lepo Holding S.à r.l.

Patron Lepo III S.à r.l.

Patron Lepo II S.à r.l.

Patron Lepo IV S.à r.l.

Patron Lepo V S. à r.l.

Patron Weghell IV S.à r.l.

Patron Weghell V S. à r. l.

Pomelo

Richardson Investments Barberino S.à r.l.

Salusam AG

Société des Ateliers Nic. Olinger S.A.

Socom S.A.

SPC Lux IV, S.à r.l.

Sud Promolux S.A.

Sud Promolux S.A.

Team Trade S.A.

Tishman Speyer French Core Holdings S.à r.l.

Tishman Speyer French Core III S.à r.l.

Tishman Speyer French Core II S.à r.l.

Tishman Speyer French Core I S.à r.l.

Tishman Speyer French Core IV S.à r.l.

Tishman Speyer French Core VI S.à r.l.

Tishman Speyer French Core V S.à r.l.

Tishman Speyer French Venture IV S.à r.l.

Tishman Speyer French Venture VI S.à r.l.

Tishman Speyer French Venture V S.à r.l.

Toscaninvest Holding S.A.

TS Metropolis I S.à r.l.

Tusken S.A.

Utility Corporate Services S.à r.l.