logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1223

20 mai 2008

SOMMAIRE

Accounting Partners S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

58676

Alia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58674

Aquatrans Shipping A.G. . . . . . . . . . . . . . . . .

58675

Brixton Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58694

CB Richard Ellis Investors DR Co-Invest S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58693

Century Financière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

58673

Chauffage Mimmo & Rocco S.à.r.l. . . . . . . .

58701

CI CEL I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58680

Clarity S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58674

Colt Financial Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

58694

Commerzbank International S.A.  . . . . . . .

58679

Compagnie Luxembourgeoise d'Investis-

sement Direct S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58698

Compagnie Luxembourgeoise d'Investis-

sement Direct S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58678

Compagnie Luxembourgeoise d'Investis-

sement Direct S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58700

Compagnie Luxembourgeoise d'Investis-

sement Direct S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58699

Empebe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58699

Ersel Gestion Internationale S.A.  . . . . . . . .

58672

euroscript international S.A.  . . . . . . . . . . . .

58697

euroscript Luxembourg Gesellschaft mit

beschränkter Haftung  . . . . . . . . . . . . . . . . .

58698

Fund-Market S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58679

GenCap I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58680

GKM Ingenieure Lux Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

58658

HGSC 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58659

Huacheng Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

58701

Informatique et Gestion S.à.r.l. . . . . . . . . . .

58699

Invex Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58697

I.P.F. - CA Gaz et Eau s.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

58694

IPSE Dixit Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

58673

Jumeva S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58695

Kilimanjaro International S.à r.l. . . . . . . . . .

58696

LBREM NW Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

58704

Maroquinerie du Centre Sàrl  . . . . . . . . . . . .

58700

Mayriwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58681

Mecanical Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

58677

Mediainvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58695

M.I.E. (Matériels d'Installation Electrique)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58699

Minimercado Portugal S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

58681

Minimercado Portugal S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

58700

New Star Global Property Management

(Luxembourg One) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

58678

Nostos Holdings Co S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

58694

Octagone Luxembourg 1 S.à r.l.  . . . . . . . . .

58672

Octagone Luxembourg 2 S.à r.l.  . . . . . . . . .

58672

Octagone Luxembourg 3 S.à.r.l.  . . . . . . . . .

58673

Perseus Real Estate Investment S.à r.l. . . .

58681

Pizzeria Beim Rocco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

58701

Pro Cons S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58675

Promobilia Cursum S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

58674

Raynor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58658

RHIC Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58695

Savic S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58697

Scan-Project S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58704

Seabird S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58695

Sea International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58678

Tailo Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58698

Toled S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58700

Trimontana S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58679

Vigamat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58696

Vigamat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58696

Vigamat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58697

Voyages Zanier William S.à.r.l.  . . . . . . . . . .

58704

Waterlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58696

Whitesorg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58701

Xenios Holdings Co S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

58694

58657

Raynor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.482.

At the Extraordinary General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on December

27th, 2007, it has been resolved the following:

1. To accept the resignation of Mrs. Nadine GLOESENER as director of the company;
2. To accept the resignation of Mr. Mikael HOLMBERG as director of the company;
3. To accept the resignation of Mr. Gilles WECKER as auditor of the company;
4. To appoint Mr. Gilles WECKER residing professionally at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg as new director

of the company replacing Mrs. Nadine GLOESENER;

5. To appoint Mr. Peter ENGELBERG residing professionally at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg as new

director of the company replacing Mr. Mikael HOLMBERG;

6. To appoint MODERN TREUHAND S.A. situated 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg as new statutory auditor

of the company replacing Mr. Gilles WECKER.

7. To re-elect Mrs. Anne WILBY as director of the board.

Fiona FINNEGAN / Gilles WECKER.

Lors de l'Assemblée Extraordinaire des actionnaires tenue le 27 décembre 2007, il a été résolu ce qui suit:
1. D'approuver la démission de Mme. Nadine GLOESENER comme administrateur au conseil d'administration;
2. D'approuver la démission de M. Mikael HOLMBERG comme administrateur au conseil d'administration;
3. D'approuver la démission de M. Gilles WECKER comme commissaire aux comptes de la société;
4. D'élire M. Gilles WECKER demeurant professionnellement au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg comme

administrateur au conseil d'administration en remplacement de Mme. Nadine GLOESENER;

5. D'élire M. Peter ENGELBERG demeurant professionnellement au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg comme

administrateur au conseil d'administration en remplacement de M. Mikael HOLMBERG;

6. D'élire MODERN TREUHAND S.A. située au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg comme commissaire aux

comptes de la société en remplacement de M. Gilles WECKER;

7. De ré-élire Mme. Anne WILBY comme administrateur au Conseil d'Administration.

Fiona FINNEGAN / Gilles WECKER.

Référence de publication: 2008055001/1369/34.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02590. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080060182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2008.

GKM Ingenieure Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 135.951.

Nach mehreren Abtretungsverträgen unter Privatschrift vom 6.2.2008 sind die Gesellschaftsanteile der Gesellschaft

wie folgt verteilt:

Gesellschaftsanteile

Gioacchino FABBELLA, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250

Horst GRUB, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250

Martin GRUB, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250

Roman HEMMER, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.250

Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

Référence de publication: 2008056521/607/20.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2008, réf. LSO-CP06978. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

58658

HGSC 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 116.820.

In the year two thousand and eight, on the thirteenth of March.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Cognetas II Bridgeco Limited, a company incorporated in Guernsey, whose registered office is at 13-15 Victoria Road,

St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 3ZD, registered with the Register of Companies of Guernsey under
number 43380, hereby duly represented by Gregory Beltrame, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
on March 11, 2008.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing party is the sole member of HGSC 2 S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité

limitée), incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register on Trade and Companies under
the number B 116.820, incorporated by a deed received by Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in
Luxembourg, on May, 30 2006, published in the Memorial, Recueil des Sociétés et Associations number 1502 on August
5, 2006 (the Company).

II. The agenda of the meeting is as follows:
1. Conversion of the five hundred (500) shares of the Company with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each

into twelve thousand and five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each;

2. Increase of the Company's capital by an amount of eighteen thousand five hundred euros (EUR 18,500.-) in order

to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand
and five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each, to thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-),
represented by thirty-one thousand (31,000) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each;

3. Issuance of eighteen thousand five hundred (18,500) new shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each, having

the same rights and obligations as the twelve thousand and five hundred (12,500) existing shares;

4. Subscription for and payment of the Company's capital increase specified in item 2. above;
5. Amendment of the article 2 of the articles of association of the Company (the Articles) relating to the purpose of

the Company;

6. Acknowledgement of the resignation of the current sole manager of the Company;
7. Conversion of the Company into a public limited liability company (société anonyme) with immediate effect;
8. Full restatement of the Articles in order to reflect the above items of the agenda;
9. Amendment to the shareholders' register of the Company in order to reflect the above items of the agenda with

power and authority given to any director of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of
the newly issued shares in the shareholders' register of the Company;

10. Transfer of the registered office of the Company;
11. Appointment of Mrs Mireille A. Fervail, Mr Franck Welman and Mr Bart Zech as directors of the Company;
12. Appointment of PricewaterhouseCoopers as auditor of the Company;
13. Miscellaneous.
III. The sole member has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole member resolves to convert the five hundred (500) shares of the Company with a par value of twenty-five

euros (EUR 25.-) each into twelve thousand and five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

<i>Second resolution

The sole member resolves to increase the Company's capital by an amount of eighteen thousand five hundred euros

(EUR 18,500.-) in order to bring it from its present amount of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-),
represented by twelve thousand and five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each, to thirty-
one thousand euros (EUR 31,000.-), represented by thirty-one thousand (31,000) shares with a par value of one euro
(EUR 1.-) each.

58659

<i>Third resolution

The sole member resolves to issue eighteen thousand five hundred (18,500) new shares with a par value of one euro

(EUR 1.-) each, having the same rights and obligations as the twelve thousand and five hundred (12,500) existing shares.

<i>Subscription - payment

The sole member hereby declares that it subscribes for the eighteen thousand five hundred (18,500) new shares with

a par value of one euro (EUR 1.-) each and fully pays up such shares by a contribution in cash of eighteen thousand five
hundred euros (EUR 18,500.-) together with a share premium amounting to nineteen thousand euros (EUR 19,000.-).

The amount of thirty seven thousand five hundred euros (EUR 37,500.-) is forthwith at the free disposal of the Com-

pany, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

The sole member resolves to amend the article 2 of the Articles relating to the purpose of the Company so that it

shall henceforth be read as follows:

Art. 2.
2.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

2.2 The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The

Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated com-
panies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise
create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company,
and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company
may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

2.3 The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

2.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly, favour or relate to its corporate object."

<i>Fifth resolution

The sole member acknowledges the resignation of the current sole manager of the Company.

<i>Sixth resolution

The sole member resolves to change the legal form of the Company, without interruption of its legal personality, and

to adopt the form of a public limited liability company (société anonyme) in accordance with the provisions of article 3
of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"). As a consequence of the foregoing,
the sole shareholder decides to change the name of the Company to "HGSC 2 S.A.".

The change of legal form is made on the basis of a report in satisfaction of articles 26-1 and 31-1 of the Law and

established by PricewaterhouseCoopers, independent auditor in Luxembourg, dated March 12, 2008.

The conclusions of this report are the following:
"Based on the work performed as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that

the value of the net asset of the Company will not be, after the capital increase together with the share premium as
described in section I of the present report, at least equal to the capital and to the number of shares representing the
subscribed share capital of the new "Société Anonyme"."

This report will remain attached to the present deed.
Following the conversion of the Company into a public limited liability company ("société anonyme"), the existing

shares, the number and the par value of which remaining unchanged, are attributed to the sole member considering of
its participation in the transformed private limited liability company ("société à responsabilité limitée") HGSC 2 S.à r.l.

<i>Seventh resolution

As a consequence of the above resolutions, the sole member resolves to fully restate the Articles in order to reflect

among others the above conversion into a public limited liability company ("société anonyme") and the drawing up of
new articles of association to be read as follows:

"I. Name - registered office - object - duration

Art. 1. Name. The name of the company is "HGSC 2 S.A." (the Company). The Company is a public company limited

by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of
August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the Articles).

58660

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of directors (the Board) The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders
(the General Meeting), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The

Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated com-
panies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise
create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company,
and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company
may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), represented by thirty-one thousand (31,000)

shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the General Meeting

acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.2. A register of shares is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.3. A share transfer is carried out by entering in the register of shares, a declaration of transfer, duly dated and signed

by the transferor and the transferee or by their authorised representatives and following a notification to, or acceptance
by, the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code. The Company may also accept as evidence of a share
transfer other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.

6.4. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - representation

Art. 7. Board of directors.
7.1. Composition of the board of directors (i) The Company is managed by a board of directors (the Board) composed

of at least three (3) members, who need not be shareholders.

(ii) The General Meeting appoints the director(s) and determines their number, remuneration and the term of their

office. Directors cannot be appointed for more than six (6) years and are re-eligible.

(iii) Directors may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting.

58661

(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative who represents such entity

in its duties as a director. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if
it had exercised its functions in its own name and on its own behalf, without prejudice to the joint and several liability of
the legal entity which it represents.

(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint

another permanent representative.

(vi) If the office of a director becomes vacant, the majority of the remaining directors may fill the vacancy on a provi-

sional basis until the final appointment is made by the next General Meeting.

7.2. Powers of the board of directors
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management and the power to represent the Company in this

respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either indi-
vidually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or several directors, the Board must report to the
annual General Meeting any salary, fees and/or any other advantages granted to such director(s) during the relevant
financial year.

7.3. Procedure
(i) The Board must appoint a chairman among its members and may choose a secretary, who need not be a director,

and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(ii) The Board meets upon the request of the chairman or any two (2) directors, at the place indicated in the notice

which, in principle, is in Luxembourg.

(iii) Written notice of any meeting of the Board is given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a director, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(v) A director may grant a power of attorney to any other director in order to be represented at any meeting of the

Board.

(vi) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the Board are validly taken by a majority of the votes of the directors present or represented. The resolutions of the
Board are recorded in minutes signed by the chairman or all the directors present or represented at the meeting or by
the secretary (if any).

(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(viii) Circular resolutions signed by all the directors are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened

and held and bear the date of the last signature.

(ix) Any director having an interest conflicting with that of the Company in a transaction carried out otherwise than

under normal conditions in the ordinary course of business, must advise the Board thereof and cause a record of his
statement to be mentioned in the minutes of the meeting. The director concerned may not take part in these deliberations.
A special report on the relevant transaction(s) is submitted to the shareholders before any vote, at the next General
Meeting.

7.4. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) directors.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom special

signatory powers have been delegated.

Art. 8. Sole director.
8.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the Company may be managed by a sole director until

the ordinary General Meeting following the introduction of an additional shareholder. In such case, any reference in the
Articles to the Board or the directors is to be read as a reference to such sole director, as appropriate.

8.2. The transactions entered into by the Company may be recorded in minutes and, unless carried out under normal

conditions in the ordinary course of business, must be so recorded when entered with its sole director having a conflicting
interest.

8.3 The Company is bound towards third parties by the signature of the sole director or by the joint or single signature

of any persons to whom special signatory powers have been delegated.

58662

Art. 9. Liability of the directors.
9.1. The directors may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made

by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 10. General meetings of shareholders.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at general meetings of shareholders (the General Meeting). The General

Meeting has the broadest powers to adopt and ratify all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Each share entitles to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings
(i) General Meetings are held at such place and time as specified in the notices.
(ii) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(iii) A shareholder may grant a written power of attorney to another person (who need not be a shareholder) in order

to be represented at any General Meeting.

(iv) Each shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference or by any other similar

means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

(v) Each shareholder may vote by way of voting forms provided by the Company. Voting forms contain the date, place

and agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each resolution, three boxes allowing to
vote in favour, against or abstain from voting. Voting forms must be sent back by the shareholders to the registered office.
Only voting forms received prior to the General Meeting are taken into account for the calculation of the quorum. Voting
forms which show neither a vote (in favour or against the proposed resolutions) nor an abstention are void.

(vi) Resolutions of the General Meeting are passed by a simple majority of the votes cast, regardless of the proportion

of the share capital represented.

(vii) The extraordinary General Meeting may amend the Articles only if at least one-half of the share capital is repre-

sented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles as well as the text of any proposed amendments
to the object or form of the Company. If this quorum is not reached, a second General Meeting may be convened by
means of notices published twice, at fifteen (15) days interval at least and fifteen (15) days before the meeting in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in two Luxembourg newspapers. Such notices reproduce the agenda
of the General Meeting and indicate the date and results of the previous General Meeting. The second General Meeting
deliberates validly regardless of the proportion of the capital represented. At both General Meeting, resolutions must be
adopted by at least two-thirds of the votes cast.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders and bondholders (if any).

Art. 11. Sole shareholder.
11.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

11.2. Any reference in the Articles to the General Meeting is to be read as a reference to such sole shareholder, as

appropriate.

11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes.

V. Annual accounts - allocation of profits -supervision

Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the officers, directors and statutory auditors towards the Company.

12.3. One month before the annual General Meeting, the Board provides documentary evidence and a report on the

operations of the Company to the statutory auditors, who then prepare a report setting forth their proposals.

12.4. The annual General Meeting is held at the address of the registered office or at such other place in the municipality

of the registered office, as may be specified in the notice, on the third Friday of June of each year at 10.00 a.m. If such
day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting is held on the following business day.

12.5. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional

circumstances so require.

Art. 13. Statutory auditors/Réviseurs d'entreprises.
13.1. The operations of the Company are supervised by one or several statutory auditors (commissaires).

58663

13.2. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by

law.

13.3. The General Meeting appoints the statutory auditors/ré viseurs d'entreprises and determines their number,

remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. Statutory auditors/réviseurs d'entreprises
may be re-appointed.

Art. 14. Allocation of profits.
14.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

14.2. The General Meeting determines how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such

balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

14.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends is taken by the Board within two (2) months from the date of the

interim accounts; and

(iv) in their report to the Board, as applicable, the statutory auditors or the réviseurs d'entreprises must verify whether

the above conditions have been satisfied.

VI. Dissolution - liquidation

15.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with

the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting appoints one or several liquidators,
who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determines their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay
the liabilities of the Company.

15.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provision

16.1. Notices and communications are made or waived and circular resolutions are evidenced in writing, by telegram,

telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions are affixed on one original or on several coun-
terparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same document.

16.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law and, subject

to any non waivable provisions of the Law, any agreement entered into by the shareholders from time to time."

<i>Eighth resolution

The sole member resolves to amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above reso-

lutions with power and authority given to any director of the Company to proceed on behalf of the Company to the
registration of the newly issued shares in the shareholders' register of the Company.

<i>Ninth resolution

The sole member resolves to transfer the registered office of the Company to 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxem-

bourg.

<i>Tenth resolution

The sole member resolves to appoint:
- Mrs Mireille A. Fervail, born on August 21, 1953 in Jemappes, Belgium, residing professionally in 14-16, rue Philippe

II, L-2340 Luxembourg;

- Mr Franck Welman, born on September 21, 1963 in Heerlen, The Netherlands, residing professionally in 46A, avenue

JF Kennedy, L-1855 Luxembourg; and

- Mr Bart Zech, born on September 5, 1969 in Putten, The Netherlands, residing professionally in 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg,

as directors of the Company for a term of six (6) years.

58664

<i>Eleventh resolution

The sole member resolves to appoint as statutory auditor of the Company for a period of six (6) years:
PricewaterhouseCoopers, a private limited liability company with registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Lu-

xembourg and registered with the Luxembourg Register on Trade and Companies under the number B 65.477.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euros (EUR 1,500).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le treize mars.
Par-devant Maître Martine SCAHEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Cognetas II Bridgeco Limited, une société constituée et régie par les lois de Guernsey, ayant son siège social au 13-15

Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 3ZD, immatriculée au registre des sociétés de Guernsey
sous le numéro 43380, dûment représentée par Grégory Beltrame, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration donnée le 11 mars 2008.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. La partie comparante est l'associée unique de HGSC 2 S. à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et

régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.820, constituée par un
acte passé devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 30 mai 2006, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1502, du 5 août 2006 (la Société).

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Conversion des cinq cents (500) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

chacune en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de dix-huit mille cinq cents euros (EUR 18.500,-) pour le

porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, à trente et un mille euros (EUR 31.000,-),
représenté par trente et un mille (31.000) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune;

3. Emission de dix-huit mille cinq cents (18.500) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-)

chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes;

4. Souscription et paiement de l'augmentation de capital mentionnée sous le point 2.;
5. Modification de l'Article 2 des statuts de la Société (les Statuts) relatif à l'objet social de la Société;
6. Constatation de la démission de l'actuel gérant unique de la Société;
7. Conversion de la Société en société anonyme avec effet à ce jour;
8. Refonte complète des Statuts afin de refléter les points susmentionnés;
9. Modification du registre d'actionnaires de la Société en vue d'y refléter les points susmentionnés de l'agenda avec

pouvoir et autorité donnés à tout administrateur de la Société, de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des
actions nouvellement émises dans le registre d'actionnaires de la Société;

10. Transfert du siège social de la Société;
11. Nomination de Mme Mireille A. Fervail, M. Franck Welman et M. Bart Zech comme administrateurs de la Société;
12. Nomination de PricewaterhouseCoopers comme commissaire aux comptes de la Société;
13. Divers.
III. L'associée unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide de convertir les cinq cents (500) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de vingt-

cinq euros (EUR 25,-) chacune en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR
1,-) chacune.

58665

<i>Deuxième résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de dix-huit mille cinq cents euros

(EUR 18.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, à trente et un mille
euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et un mille (31.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-)
chacune.

<i>Troisième résolution

L'associée unique décide d'émettre dix-huit mille cinq cents (18.500) nouvelles parts sociales de la Société, d'une valeur

nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales existantes.

<i>Souscription - paiement

L'associée unique déclare souscrire aux dix-huit mille cinq cents (18.500) nouvelles parts sociales de la Société d'une

valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et les payer intégralement par un apport en numéraire de dix-huit mille
cinq cents euros (EUR 18.500,-) ensemble avec une prime d'émission d'un montant de dix-neuf mille euros (EUR 19.000,-).

Le montant de trente sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) est par conséquent à la libre disposition de la Société

dont la preuve a été apportée au notaire soussigné.

<i>Quatrième résolution

L'associée unique décide de modifier l'article 2 des Statuts relatif à l'objet social de la Société qui doit désormais être

lu comme suit:

« Art. 2.
2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre,

d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment,
les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou
partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa
faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité
réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

2.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

2.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.»

<i>Cinquième résolution

L'associée unique reconnaît la démission de l'actuel gérant unique de la Société.

<i>Sixième résolution

L'associée unique décide de changer la forme légale de la Société, sans interruption de sa personnalité juridique, et

d'adopter la forme de société anonyme conformément à l'article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi»). En conséquence de qui précède, l'associée unique décide de modifier la dénomination de la
Société en «HGSC 2 S.A.».

Le changement de la forme légale est effectuée sur la base d'un rapport conformément aux articles 26-1 et 31-1 de la

Loi établi par PricewaterhouseCoopers, auditeur indépendant à Luxembourg, en date du 12 mars 2008.

Les conclusions du rapport sont les suivantes:
«Sur la base des vérifications effectuées comme décrit ci-dessus, aucun élément n'est venu à notre attention qui nous

permette de croire que la valeur nette ne sera pas après l'augmentation de capital ensemble avec la prime d'émission
comme décrit à la section I du présent rapport, au moins égale au capital et au nombre d'actions représentant le capital
social souscrit de la nouvelle Société Anonyme».

Ce rapport restera annexé au présent acte.

58666

Suite à la transformation de la Société en société anonyme, les actions existantes, leur nombre et la valeur nominale

de celles-ci restant inchangées, sont attribuées à l'actionnaire unique en fonction de sa participation dans la société à
responsabilité limitée HGSC 2 S.à r.l. convertie.

<i>Septième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'associée unique décide de procéder à une refonte complète des Statuts

afin d'y refléter entre autres la transformation en société anonyme et pour donner la teneur suivante aux nouveaux statuts
qui doivent désormais être lus comme suit:

«I. Dénomination - siège social - objet- durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est «HGSC 2 S.A.» (la Société). La Société est une société anonyme

régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil d'administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'Assemblée Générale),
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre,

d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment,
les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou
partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa
faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité
réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.

II. Capital - actions

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et un mille (31.000) actions

sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée

Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Actions.
6.1. Les actions sont et resteront sous forme nominative.

58667

6.2. Un registre des actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque actionnaire.
6.3. Une cession d'action(s) s'opère par la mention sur le registre des actions, d'une déclaration de transfert, valable-

ment datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires et suivant une notification à, ou une
acceptation par, la Société, conformément à j l'article 1690 du Code Civil. La Société peut également accepter comme
preuve du transfert d'actions, d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.

6.4. Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par action.
6.5. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

III. Gestion - représentation

Art. 7. Conseil d'administration.
7.1. Composition du conseil d'administration
(i) La Société est gérée par un conseil d'administration (le Conseil) composé d'au moins trois (3) membres, qui ne

doivent pas être actionnaires.

(ii) L'Assemblée Générale nomme le(s) administrateur(s) et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de

leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans et sont rééligibles.

(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l'Assemblée Générale.
(iv) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux
mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre
compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

(v) Si le représentant permanent se trouve dans l'incapacité d'exercer sa mission, la personne morale doit nommer

immédiatement un autre représentant permanent.

(vi) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, la majorité des administrateurs restants peut y pourvoir provisoi-

rement jusqu'à la nomination définitive, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.

7.2. Pouvoirs du conseil d'administration
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux actionnaires sont de la compétence

du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette

gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou
conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à
l'Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) adminis-
trateur(s) pendant l'exercice social en cause.

7.3. Procédure
(i) Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur,

et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.

(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou d'au moins deux (2) administrateurs au lieu indiqué dans l'avis

de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(iii) Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre

(24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées
dans la convocation à la réunion.

(iv) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également renoncer à la
convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas
exigées pour des réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixés dans un calendrier préalablement adopté par le
Conseil.

(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion

du Conseil.

(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le président ou par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le
secrétaire (s'il en existe un).

(vii) Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout

autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'en-
tendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion
valablement convoquée et tenue.

58668

(viii)Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et engagent la Société comme si elles

avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière
signature.

(ix) Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des

opérations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner
cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un
rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine
Assemblée Générale.

7.4. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par les signatures conjointes de deux (2) admi-

nistrateurs.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui

des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.

Art. 8. Directeur unique.
8.1. Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1), la Société peut être gérée par un administrateur

unique jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant l'introduction d'un actionnaire supplémentaire. Dans ce cas, toute
référence dans les Statuts au Conseil ou aux administrateurs doit être considérée, le cas échéant, comme une référence
à cet administrateur unique.

8.2. Les transactions conclues par la Société peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux et, sauf si elles con-

cernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales, doivent être ainsi mentionnées si elles sont
intervenues avec son administrateur unique ayant un intérêt opposé.

8.3. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de l'administrateur unique ou par la signature conjointe

ou unique de toutes personnes à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.

Art. 9. Responsabilité des administrateurs.
9.1. Les administrateurs ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux
Statuts et à la Loi.

IV. Actionnaire(s)

Art. 10. Assemblée générale des actionnaires.
10.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors des assemblées générales des actionnaires (l'Assemblée Géné-

rale). L'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et opérations conformes
à l'objet social.

(ii) Chaque action donne droit à un (1) vote.
10.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.
(ii) Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(iii) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas être un actionnaire)

afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(iv) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre

moyen de communication similaire permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de
s'entendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne
à une telle réunion.

(v) Tout actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société. Les formulaires de vote

indiquent la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, le texte des résolutions proposées ainsi que, pour chaque
résolution, trois cases permettant de voter en faveur, de voter contre ou de s'abstenir. Les formulaires de vote doivent
être renvoyés par les actionnaires au siège social. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires de
vote reçus par la Société avant la réunion de l'Assemblée Générale. Les formulaires de vote dans lesquels ne sont men-
tionnés ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention, sont nuls.

(vi) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la

proportion du capital social représenté.

(vii) L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social est

représenté et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui modifient
l'objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être
convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15) jours avant l'Assem-
blée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l'ordre du jour de la

58669

réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée Générale délibère valable-
ment quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent
être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un actionnaire dans

la Société exige le consentement unanime des actionnaires et des obligataires (s'il y a lieu).

Art. 11. Actionnaire unique.
11.1. Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1), l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés

par la Loi à l'Assemblée Générale.

11.2. Toute référence dans les Statuts à l'Assemblée Générale doit être doit être considérée, le cas échéant, comme

une référence à cet actionnaire unique.

11.3. Les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux.

V. Comptes annuels - affectation des bénéfices - contrôle

Art. 12. Exercice social et approbation des comptes annuels.
12.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un décembre (31) de chaque année.
12.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur

des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des
directeurs, administrateurs et commissaire(s) envers la Société.

12.3. Un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de

la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.

12.4. L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du

siège social, comme indiqué dans la convocation, le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 10 heures. Si
ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

12.5. L'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si, selon l'avis absolu et définitif du Conseil, des cir-

constances exceptionnelles le requièrent.

Art. 13. Commissaires /Réviseurs d'entreprises.
13.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires.
13.2. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, quand cela est requis

par la loi.

13.3. L'Assemblée Générale nomme les commissaires/réviseurs d'entreprises et détermine leur nombre, leur rému-

nération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les commissaires/réviseurs d'entreprises peuvent
être réélus.

Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

14.2. L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice

au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

14.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale ou statutaire;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la

date des comptes intérimaires; et

(iv) dans leur rapport au Conseil, selon le cas, les commissaires ou les réviseurs d'entreprises doivent vérifier si les

conditions prévues ci-dessous ont été remplies.

VI. Dissolution - liquidation

15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les

modalités requises pour la modification des Statuts. L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont
pas besoin d'être actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire de l'Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
actifs et payer les dettes de la Société.

15.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes est distribué aux actionnaires

proportionnellement aux actions détenues par chacun d'entre eux.

58670

VII. Dispositions générales

16.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions

circulaires sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

16.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

16.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques

remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les
signatures des résolutions circulaires peuvent être apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document,
qui ensemble, constituent un seul et unique document.

16.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légale d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les actionnaires.»

<i>Huitième résolution

L'associée unique décide de modifier le registre d'actionnaires de la Société en vue d'y refléter les points susmentionnés

de l'agenda avec pouvoir et autorité donnés à tout administrateur de la Société, de procéder au nom de la Société à
l'enregistrement des actions nouvellement émises dans le registre d'actionnaires de la Société.

<i>Neuvième résolution

L'associée unique décide de transférer le siège social de la Société au 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

<i>Dixième résolution

L'associée unique décide de nommer:

- Mme Mireille A. Fervail, née le 21 août 1953 in Jemmapes, Belgique, résidant professionnellement au 14-16, rue

Philippe II, L-2340 Luxembourg;

- M. Franck Welman, né le 21 septembre 1969 à Heerlen, Pays-Bas, résidant professionnellement au 46A, avenue JF

Kennedy, L-1855 Luxembourg; et

- M. Bart Zech, né le 5 septembre 1969 à Putten, Pays-Bas, résidant professionnellement au 12, rue Léon Thyes, L-2636

Luxembourg,

comme administrateurs de la Société pour une durée de six (6) ans.

<i>Onzième résolution

L'associée unique décide de nommer comme commissaire aux comptes de la Société pour une durée de six (6) ans:

PricewaterhouseCoopers, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471

Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

raison du présent acte sont estimés approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande de la personne comparante ci-dessus, le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: G. Beltrame et M, Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, LAC/2008/12073. — Reçu cent quatre-vingt-sept euros cinquante cents

Eur0,5% = 187,50.

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

POUR COPIE CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 avril 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008056467/5770/717.

(080062799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

58671

Octagone Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 130.905.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé unique du 1 

<i>er

<i> février 2008

L'associé de la Société, a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Marc Torbick en tant que Gérant B, et ce avec effet immédiat;
- de nommer Corinne Muller, née le 15 octobre 1976 à Seoul, Corée du Sud, résidant professionnellement au 20, rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que Gérante B de la société, et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 avril 2008.

Stijn Curfs
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008056266/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2008, réf. LSO-CP06819. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080061654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2008.

Ersel Gestion Internationale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 30.350.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2008

En date du 31 mars 2008, l'Assemblée Générale Ordinaire de la société a décidé:
- d'accepter la démission, avec effet au 30 novembre 2007, de Monsieur Andrea Nasce en qualité d'Administrateur
- de ratifier la cooptation, avec effet au 30 novembre 2007, de Monsieur Max Meyer en qualité d'administrateur, en

remplacement de Monsieur Andrea Nasce, démissionnaire

- de renouveler les mandats de Monsieur Alberto Pettiti, Monsieur Umberto Giraudo, Monsieur Max Meyer, de Mon-

sieur  Antoine  Gilson  de  Rouvreux  et  de  Madame  Francesca  De  Bartolomeo  en  qualité  d'Administrateurs  jusqu'à  la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2008.

Pour extrait sincère et conforme
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2008056281/1024/21.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2008, réf. LSO-CP04758. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2008.

Octagone Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 130.906.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé unique du 1 

<i>er

<i> février 2008

L'associé de la Société, a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Marc Torbick et ce avec effet immédiat;
- de nommer Corinne Muller, née le 15 octobre 1976 à Seoul, Corée du Sud, résidant professionnellement au 20, rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que Gérante B de la société, et ce avec effet immédiat.

58672

Luxembourg, le 15 avril 2008.

Stijn Curfs
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008056267/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2008, réf. LSO-CP06822. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080061653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2008.

Octagone Luxembourg 3 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 130.899.

<i>Extrait des résolutions de l'Associé unique du 1 

<i>er

<i> février 2008

L'associé de la Société, a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Marc Torbick en tant que Gérant B, et ce avec effet immédiat;
- de nommer Corinne Muller, née le 15 octobre 1976 à Seoul, Corée du Sud, résidant professionnellement au 20, rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que Gérante B de la société, et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 avril 2008.

Stijn Curfs
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008056269/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2008, réf. LSO-CP06825. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080061643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2008.

Century Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 87.301.

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 15 octobre 2007

Démission de Madame Maria Farias en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Catherine Roux, demeurant professionnellement au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535

Luxembourg, en remplacement de Madame Maria Farias, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle de 2008.

POUR EXTRAIT SINCERE ET CONFORME
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008056282/817/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2008, réf. LSO-CP07277. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2008.

IPSE Dixit Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 72.346.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 16 avril 2008 au siège social de la société, il a été décidé:
- D'accepter la démission de Monsieur Marco Bus né le 23.12.1964 à Genes, en Italie, employé privé, résident pro-

fessionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur, avec effet
au 16 avril 2008;

- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet au 16 avril 2008, Monsieur Sébastien Schaack, employé privé,

né le 22.07.1978 à Thionville en France, résident professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri, son mandat
ayant comme échéance celui de leur prédécesseur.

58673

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IPSE DIXIT HOLDING S.A., Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2008056277/24/19.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2008, réf. LSO-CP07689. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080061614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2008.

Clarity S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 69.622.

Constituée par-devant M 

e

 Paul FRIEDERS, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 23 avril 1999, acte

publié au Mémorial C n 

o

 529 du 10 juillet 1999.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CLARITY S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008056330/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2008, réf. LSO-CP07960. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Alia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 107.219.

La société MADAS S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B-107316, nommée administrateur en date du 6 juin 2006, a désigné Monsieur Alain RE-
NARD, né le 18 juillet 1963 à Liège (Belgique), employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat, arrivant à échéance lors de
l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Luxembourg, le 10 août 2007.

Certifié sincère et conforme
ALIA S.A.
S. BOUREKBA / A. GRAZIANO
<i>Administrateur / Administrateur, Présidente du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2008056496/795/19.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08142. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Promobilia Cursum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 129.225.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration en date du 11 avril 2008,

les décisions suivantes ont été prises:

1. Les démissions de Monsieur Paul LUTGEN de sa fonction d'Administrateur et de Monsieur Hans TORNGREN de

ses fonctions d'Administrateur et d'Administrateur-Délégué sont acceptées.

2. Sont nommés jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2007:
- Kaj SIGSTAM, demeurant à CH-1291 Commugny, 22, route de Coppet, Administrateur, Administrateur-Délégué et

Président,

58674

- Hans Tommy TROLLBORG, demeurant à CH-3975 Randogne, 17/27, route Cantonale Sierre-Montana, Adminis-

trateur et Administrateur-Délégué,

- Luc BRAUN, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008056287/504/21.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2008, réf. LSO-CP05883. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2008.

Aquatrans Shipping A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6670 Mertert, 2C, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 83.159.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTELBRUCK
Signature

Référence de publication: 2008056306/832/14.
Enregistré à Diekirch, le 15 avril 2008, réf. DSO-CP00069. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080062620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Pro Cons S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 99.552.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend und acht, den vierzehnten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Herr Uwe FROHNWIESER, Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH), geboren in Frankfurt/Main (Deutschland), am 15. Ok-

tober 1957, wohnhaft in D-63225 Langen, Zinkeysenstrasse 38 (Deutschland),

hier vertreten durch Herrn Alain THILL, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxem-

bourg,

auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
Welche Vollmacht vom Vollmachtnehmer und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der ge-

genwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welcher Komparent, durch seinen vorgenannten Vertreter, ersucht den amtierenden Notar die von ihm gefassten

Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

1.-  Dass  die  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  Pro  Cons  S.à  r.l.,  mit  Sitz  in  L-1148  Luxemburg,  12,  rue  Jean

l'Aveugle, H.G.R. Luxemburg Sektion B Nummer 99.552, gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den
instrumentierenden Notar am 11. März 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 461 vom 3. Mai 2004, und deren
Satzung  abgeändert  wurde  durch  Urkunde  des  instrumentierenden  Notars  am  8.  September  2004,  veröffentlicht  im
Mémorial C Nummer 1201 vom 24. November 2004.

2.- Dass das Gesellschaftskapital sechzehn tausend Euro (16.000,- EUR) beträgt und eingeteilt ist in ein hundert sechzig

(160) Anteile von jeweils ein hundert Euro (100,-EUR).

3.- Dass der Komparent als alleiniger Eigentümer aller Anteile der vorgenannten Gesellschaft Pro Cons S.à r.l. bes-

chliesst  diese  mit  sofortiger  Wirkung  aufzulösen  und  sämtliche  Aktiva  und  Passiva  der  aufgelösten  Gesellschaft  zu
übernehmen.

4.- Dass sich daraus ergibt sich dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Pro Cons S.à r.l. mit Wirkung vom

heutigen Tage an definitiv aufgelöst ist und dass die Liquidation, durch den alleinigen Gesellschafter ausgeführt, abges-
chlossen ist.

5.- Dass dem Geschäftsführer der aufgelösten Gesellschaft volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt

wird.

58675

6.- Dass die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren am früheren Gesellschafts-

sitz aufbewahrt werden.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

sechs hundert Euro abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: THILL; SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 avril 2008, Relation GRE/2008/1756. — Reçu douze euros 12 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Junglinster, den 23. April 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008056464/231/50.
(080063010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Accounting Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 29, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 100.588.

L'an deux mille huit, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch,

A comparu:

La société à responsabilité limitée «TRUST INVESTMENT PARTNER» ayant son siège social à L-7535 Mersch, 29, rue

de la Gare, immatriculée au Registre de Commerce sous le numéro B129.407, constituée en date du 7 juillet 2007, aux
termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
1716 du 14 août 2007.

ici représentée par Monsieur Yves DISIVISCOUR, prénommé,
agissant en sa qualité de gérant, nommé à cette fonction aux termes de la première résolution prise par l'assemblée

générale ayant immédiatement suivi la constitution, avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

Laquelle comparante, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I. Que suivant convention de cession de parts datée du 13 février 2008, Monsieur Yves SCHARLE, comptable, de-

meurant à L-7540 Rollingen/Mersch, 113, rue de Luxembourg, propriétaire de CINQUANTE (50) parts sociales d'une
valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,00) chacune de la société à responsabilité limitée «Accounting
Partners, S.à r.l», ayant son siège social à L-7540 Rollingen/Mersch, 113, rue de Luxembourg, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 100.588, constituée aux termes d'un acte reçu par
Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch, en date du 21 avril 2004, publié au Mémorial C du 3 juillet 2004,
numéro 685, a cédé et transporté avec toutes les garanties de fait et de droit, avec effet à la date de la prédite convention,
CINQUANTE (50) parts sociales à la société à responsabilité limité «TRUST INVESTMENT PARTNER», prénommée.

Que suivant convention de cession de parts datée du 13 février 2008, Monsieur Yves DISIVISCOUR, expert-comptable,

demeurant à L-7535 Mersch, 29, rue de la Gare, propriétaire de CINQUANTE (50) parts sociales d'une valeur nominale
de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,00) chacune de la société à responsabilité limitée «Accounting Partners, S.à r.l»,
ayant son siège social à L-7540 Rollingen/Mersch, 113, rue de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 100.588, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Urbain
THOLL, notaire de résidence à Mersch, en date du 21 avril 2004, publié au Mémorial C du 3 juillet 2004, numéro 685, a
cédé et transporté avec toutes les garanties de fait et de droit, avec effet à la date de la prédite convention, CINQUANTE
(50) parts sociales à la société à responsabilité limité «TRUST INVESTMENT PARTNER», prénommée.

Que suivant l'article 6 des statuts de la société «Accounting Partners S.à r.l.», les parts sociales ne peuvent être cédées

entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins trois quarts du
capital social.

Que pour autant que de besoin l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2008 a donné son accord à la cession

de parts à la société à responsabilité limité «TRUST INVESTMENT PARTNER».

58676

Que les prédites conventions de cessions de parts ainsi que copie du procès-verbal de la prédite assemblée générale

extraordinaire, après avoir été signés «Ne Varietur» par les comparants, et le notaire instrumentaire resteront annexés
aux présentes pour être formalisés avec elles.

II. Que suite aux prédites cessions de parts la société à responsabilité limitée «TRUST INVESTMENT PARTNER»,

prénommée, est le seul et unique associé de la société «Accounting Partners, S.à r.l.», préqualifiée.

Qu'elle s'est réunie en assemblée générale extraordinaire, à laquelle elle s'entend par ailleurs dûment convoquée et a

pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Suite  aux  prédites  cessions  de  parts,  l'associée  actuelle  décide  de  modifier  l'article  5  des  statuts  pour  lui  donner

désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,00), représenté par

CENT (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,00) chacune.»

<i>Intervention

Monsieur Yves DISIVISCOUR, expert-comptable, demeurant à L-7535 Mersch, 29, rue de la Gare, en sa qualité de

gérant unique de la société «Accounting Partners, S.àr.l.», déclare accepter expressément les prédites cessions de parts
au nom et pour compte de la société et dispense les cédants de les faire notifier à la société, le tout conformément à
l'article 1690 du Code Civil.

<i>Deuxième résolution

L'associée actuelle décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément unanime de tous

les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le
même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.»

<i>Troisième résolution

L'associée actuelle décide de modifier le siège social pour le porter de L-7540 Rollingen/Mersch, 113, rue de Luxem-

bourg à L-7535 Mersch, 29, rue de la Gare.

En conséquence, l'article 2 alinéa 1 

er

 sera lu comme suit:

« Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Mersch.»

DONT ACTE, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms, demeure et

qualité, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Y. DISIVISCOUR, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 21 avril 2008. MER/2008/704. - Reçu douze euros Droit fixe: (12,00 €).

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 24 avril 2008.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2008056456/243/77.
(080062718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Mecanical Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 46.165.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration en date du 11 avril 2008,

les décisions suivantes ont été prises:

1) Les démissions de Monsieur Paul LUTGEN de ses fonctions de Président du Conseil et d'administrateur et d'ARMOR

S.A. de sa fonction d'administrateur sont acceptées

2) Sont nommés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2011:
- Luc BRAUN, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur-délégué et Pré-

sident du Conseil d'administration

- Horst SCHNEIDER, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur et ad-

ministrateur-délégué

58677

- FIDESCO S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008056288/504/21.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2008, réf. LSO-CP05885. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2008.

Compagnie Luxembourgeoise d'Investissement Direct S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.278.

Constituée par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

en date du 28 mai 2004, acte publié au Mémorial C no 824 du 11 août 2004.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Compagnie Luxembourgeoise d'Investissement Direct S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008056337/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2008, réf. LSO-CP07971. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

New Star Global Property Management (Luxembourg One) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 456.125,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 114.068.

Constituée par-devant M 

e

 Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 janvier 2006, acte publié

au Mémorial C no 842 du 27 avril 2006.

Le bilan au 31 mars 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour New Star Global Property Management (Luxembourg One) S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008056418/1649/17.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2008, réf. LSO-CP08674. - Reçu 42,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Sea International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 113.728.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

58678

Luxembourg, le 25 avril 2008.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008056403/3560/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2008, réf. LSO-CP07461. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Trimontana S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 109.645.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2008.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008056404/3560/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2008, réf. LSO-CP07462. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Commerzbank International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 8.495.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2008056400/15/11.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08421. - Reçu 90,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Fund-Market S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 63.861.

L'an deux mille huit, le premier avril.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FUND-MARKET S.A.", ayant son siège

social à L-1661 Luxembourg, 103, Grand-Rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 63.861, constituée suivant acte notarié en date du 23 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 330 du 11 mai 1998 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en
date du 22 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 210 du 16 mars 2000.

L'assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Madame Malou GEHLEN, employée privée, avec adresse

professionnelle à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita MAGGIPINTO, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank STOLZ-PAGE, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

58679

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification du premier paragraphe de l'article 3 des statuts de la société relatif à l'objet social pour lui donner la

teneur suivante:

«La Société a pour objet l'activité de gérant de fortune au sens de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier,

telle que modifiée, (la "Loi sur le Secteur Financier") à savoir l'activité d'assurer la gestion des avoirs de ses clients en
vertu d'un mandat, ainsi que toutes les activités connexes comprenant entre autres, mais sans limitation, l'activité de
conseil en opérations financières, de courtier et de commissionnaire et tous services auxiliaires visés par la Loi sur le
Secteur Financier.»

2. Divers
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées "ne varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 3 des statuts de la société relatif à l'objet social pour

lui donner la teneur suivante:

«  Art. 3. (1 

er

 paragraphe). Objet.  La Société a pour objet l'activité de gérant de fortune au sens de la loi du 5 avril

1993 relative au secteur financier, telle que modifiée, (la "Loi sur le Secteur Financier") à savoir l'activité d'assurer la
gestion des avoirs de ses clients en vertu d'un mandat, ainsi que toutes les activités connexes comprenant entre autres,
mais sans limitation, l'activité de conseil en opérations financières, de courtier et de commissionnaire et tous services
auxiliaires visés par la Loi sur le Secteur Financier.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ EUR 800,00.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: Malou GEHLEN, Anita MAGGIPINTO, Frank STOLZ-PAGE et Joëlle BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 avril 2008. LAC / 2008 /14232. — Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008056507/7241/65.
(080062583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

CI CEL I S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. GenCap I S.à r.l.).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 115.526.

Constituée par-devant M 

e

 Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

en date du 5 avril 2006, acte publié au Mémorial C no 1195 du 20 juin 2006 et modifiée par-devant le même notaire,
en date du 6 novembre 2007, acte publié au Mémorial C no 171 du 22 janvier 2008.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

58680

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CI CEL I S.à r.l. (anciennement GenCap I S.à r.l.)
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008056331/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2008, réf. LSO-CP07962. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Mayriwa, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 53.257.

Le bilan au 31 décembre 2007, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008056342/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08213. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Minimercado Portugal S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 17, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 64.666.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008056378/6825/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08486. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Perseus Real Estate Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 127.199.

In the year two thousand and eight, on the twenty-sixth of March.
Before Maître Paul FRIEDERS, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

"Equilibrium Holding Establishement", with registered office in FL-9490 Vaduz, Austrasse 61, (Principality of Liechten-

stein),  inscribed  in  the  "Öffentlichkeitsregister''  of  Liechtenstein  under  the  number  FL-0002.232.967-1  (the  "Sole
Shareholder"),

represented by Mr Hassane DIABATE, attorney, professionally residing in L-2661 Luxembourg, 44, rue de Vallée, by

virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act that it is the Sole Shareholder

of the private limited liability company "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", (hereafter the "Company"), a
société à responsabilité limitée, with registered office at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register, under number B 127.199, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean
SECKLER, notary residing in Junglinster, on March 27th, 2007, published in the Mémorial C, number 1202 of the June 19,
2007,

and that it takes the following resolutions:

58681

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to split the shares in issue in the Company so that each share gives right to one hundred

thousand (100,000) shares having each the nominal value of one cent euro (EUR 0,01).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of four hundred forty-one

thousand euro (EUR 441,000.-) so as to raise it from its present amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-)
to  five  hundred  forty-one  thousand  euro  (EUR  541,000.-)  by  the  issue  of  forty-four  million  one  hundred  thousand
(44,100,000) new shares of a nominal value of one cent euro (EUR 0.01) each.

Such new shares are subscribed for and fully paid up by the Sole Shareholder against (i) a contribution in cash of an

amount of two hundred forty-one thousand euro (EUR 241,000.-) and (ii) a contribution in kind of a receivable of two
hundred thousand euro ( EUR 200,000.-) resulting from an advance on current account made by the Sole Shareholder
to the Company on 5th October 2007 (the "Receivable").

The value of the Receivable has been assessed by the Board of Managers of the Company in a report dated 21st March

2008.

The conclusion of such report reads as follows:
"In view of the above, the board of managers believes that the value of the Contribution in Kind made against issue of

twenty million (20,000,000) new shares in the Company corresponds to the subscription price of such new shares."

Said report after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary shall stay affixed to

the present deed to be filed with registration authorities.

Pursuant to the above, the Sole Shareholder resolves to value the Receivable contributed to the share capital of the

Company at two hundred thousand euro (EUR 200,000.-) and to issue, against the contribution thereof to the Company,
twenty million (20,000,000) shares to which it declares to subscribe.

Proof of the contribution of the Receivable and the amount of two hundred forty-one thousand euro (EUR 241,000.-)

in cash to the Company has been given to the undersigned notary.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to create two classes of shares i.e. the class A shares and the class B shares and to

reclassify the shares in issue after the increase of capital as follows: twenty-seven million fifty thousand (27,050,000) shares
are reclassified into the class A shares and twenty-seven million fifty thousand (27,050,000) shares are reclassified into
class B shares.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to create two classes of managers i.e. "Class A manager" and "Class B manager".

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to fully restate the articles of incorporation of the Company notably to reflect the

resolutions recorded here-above and so as they read as follows:

Art. 1. There exists a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") under the name of

"PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", (hereafter the "Company"), which will be governed by these articles of
association (the "Articles") as well as by the relevant legal dispositions.

Art. 2. The purposes of the Company are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development
of these participating interests.

It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of

any securities of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire
by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities, to grant to the
companies, in which it has participating interests either directly or indirectly or to the companies which are controlled
by the same persons as the Company, any support, loans, advances or guarantees.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security

for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible

notes), preferred equity certificates, convertible preferred equity certificates and debentures.

The Company may also undertake any commercial, industrial and financial transactions, which it might deem useful for

the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The duration of the Company is unlimited.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.

58682

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a collective decision of the

shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5.
5.1 Share capital
The corporate capital is fixed at five hundred forty-one thousand euro (EUR 541,000.-) divided into fifty-four million

one hundred thousand (54,100,000) shares with a par value of one cent euro (EUR 0.01) each consisting of

a) twenty-seven million fifty thousand (27,050,000) shares of class A (the "A Shares"); and
b) twenty-seven million fifty thousand (27,050,000) shares of class B (the "B Shares").
All A Shares and B Shares (collectively, the "Shares") have been subscribed and fully paid up.
The holder(s) of the Class A Shares are designated hereafter as the "Class A Shareholders".
The holder(s) of the Class B Shares are designated hereafter as the "Class B Shareholders".
Any available share premium shall be distributable.
5.2 Rights attached to the Shares
a) Each Share gives its holder the right to one (1 ) vote and the right to attend any shareholders' meetings.
b) Shares give their holders the right to the following dividend entitlements:
- 61.8% of the net profit is available to the holder of the A Shares; and
- 38.2% of the net profit is available to the holder of the B Shares.

Art. 6. The share capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law governing

commercial companies.

Art. 7.
7.1 General transfer provisions
Except as otherwise specifically set out in these Articles, any Transfer of Shares shall always be subject to, and will be

effective and recognised by the Company only if permitted by, and realised in compliance with, the provisions set out in
any  shareholders  agreement or like agreement  entered  into from time to time between  all  the  shareholders of the
Company (the "Shareholders Agreement").

Notwithstanding  any  provision  of  these  Articles  or  of  any  Shareholders  Agreement,  transfer  of  Shares  to  a  non-

shareholder shall always be subject to the approval of the general meeting of the Shareholders representing at least three
quarters of the share capital of the Company.

For the purpose of these Articles, "Transfer" means to transfer, sell, assign, pledge, give or create a security interest

in  or  lien  on,  place  in  trust  (voting  or  otherwise),  transfer  by  operation  of  law  (other  than  by  way  of  a  merger  or
consolidation of the Company), or in any other way encumber, dispose of or transfer the economic or other risks of
ownership to, whether or not voluntary, all or any portion of Shares.

7.2 The Sale Right
From and after a period of two (2) years from the date on which the Class B Shares of the Company will be Transferred

to Whitehall Bear S.à r.l. (the "Closing Date"), the Class A Shareholders (acting as a group) and the Class B Shareholders
(acting as a group) each may elect to cause the sale of 100% of the Shares in the Company held by all Shareholders
together with 100% of the preferred equity certificates held by the Shareholders in the Company (the "Total Company
Interest").

The right of each Shareholder to market and cause the sale of the Total Company Interests is referred hereafter as

the "Sale Right".

The group of Shareholders proposing to exercise the Sale Right (the "Selling Shareholder") shall furnish a written notice

of such proposed Transfer (a "Right of First Offer Notice") to the other Shareholders (the "Non-Triggering Shareholder")
prior to any such proposed Transfer, indicating the Selling Shareholder's intent to exercise the Sale Right. A Right of First
Offer Notice shall contain:

i) a statement as to whether the Selling Shareholder proposes to sell the Total Company Interests in the Company,
ii) a request from the Non-Triggering Shareholder for a binding, irrevocable, all cash offer by the other Shareholders

to purchase from the Selling Shareholder 100% of the Selling Shareholder's pro rata share of the Total Company Interests
(the "Specified Interests").

No Shareholders may deliver a Right of First Offer Notice in respect of the Total Company Interests during any Offer

Response Period (as defined below), Acceptance Response Period or Marketing Period (as defined below) in respect of
the Total Company Interests.

Within thirty calendar days after receipt by the Non-Triggering Shareholder of a Right of First Offer Notice (the "Offer

Response Period"), if the Non-Triggering Shareholder wishes to purchase 100% of the Specified Interests, the non-Trig-
gering Shareholder shall deliver to the Selling Shareholder written notice (an "Offer Response Notice").

58683

Each offer contained in the Offer Response Notice shall be irrevocable and binding and shall include an all-cash offer

for the Specified Interests (the "Specified Interest Purchase Price").

The Offer Response Notice shall not be subject to receipt by the Non-Triggering Shareholder of representations and

warranties and/or indemnification (other than provided for by the Shareholders Agreement) or equity or debt financing
conditions, or other conditions or contingencies (other than the Buyer Sale Right Closing Conditions as defined in the
Shareholders Agreement).

If the Non-Triggering Shareholder delivers an Offer Response Notice to the Selling Shareholder within the Offer

Response Period, and the Selling Shareholder wishes to accept the offer contained in the Offer Response Notice, the
Selling Shareholder shall deliver to the Non-Triggering Shareholder written notice (an "Acceptance Notice") (stating that
the Selling Shareholder shall sell the Specified Interests for the Specified Interest Purchase Price within ten (10) calendar
days after receipt by the Selling Shareholder of an Offer Response Notice (the "Acceptance Response Period")).

If the Non-Triggering Shareholder delivers an Offer Response Notice to the Selling Shareholder within the Offer

Response Period and the Selling Shareholder delivers an Acceptance Notice within the Acceptance Response Period, the
closing of the sale of the Specified Interests to the Non-Triggering Shareholder (the "Sale Right Buyout Closing") shall
occur on the day twenty (20) Business Days after the satisfaction of the Buyer Sale Right Closing conditions, or such
other date as the Non-Triggering Shareholder and the Selling Shareholder may mutually determine in writing.

If the Sale Right Buyout Closing does not occur within ninety (90) calendar days following the delivery of the Acceptance

Notice (the "Sale Right Buyout Cut-Off Date"), the Offer Response Notice shall be deemed to be rescinded and the
Selling Shareholder shall have the right to proceed as follows.

If the Non-Triggering Shareholder fails to deliver an Offer Response Notice that complies with the above provisions

prior to the end of the Offer Response Period or the Selling Shareholder fails to deliver an Acceptance Notice that
complies with the above provisions prior to the end of the Acceptance Response Period or the Sale Right Buyout Closing
fails to occur prior to the Sale Right Buyout Cut-Off Date, the Selling Shareholder shall have the right to market and sell
(and to cause the Non-Triggering Shareholder) the Total Company Interests for a 6-month marketing period commencing
on the day following the last day of the Offer Response Period (if the Non-Triggering Shareholder does not deliver an
Offer Response Notice that complies with the above provisions) or Acceptance Response Period (if the Selling Share-
holder does not deliver an Acceptance Notice that complies with the above provisions) or on the Sale Right Buyout Cut-
Off Date (if the Non-Triggering Shareholder delivers an Offer Response Notice that complies with the above provisions,
the Selling Shareholder delivers an Acceptance Notice that complies with the above provisions), as the case may be (the
"Marketing Period"). In such case, the "Offered Sale Price" shall be equal to (A) in the case the Non-Triggering Shareholder
has delivered an Offer Response Notice, the price at which the Total Company Interests would have to be sold in order
for the Selling Shareholder to be entitled collectively to receive cash in an amount equal of the Specified Interest Purchase
Price or (B) in the case the Non-Triggering Group has not delivered an Offer Response Notice, zero euro (EUR 0.00).

If during the Marketing Period the Selling Shareholder receives an offer (a "Third-Party Offer") from a Third Party (a

"Buyer") to purchase the Total Company Interests for a purchase price equal to at least ninety-five (95%) of the Offered
Sale Price (the "Minimum Purchase Price"), then the Selling Shareholder may elect to cause the Shareholders to accept
such Third-Party Offer and to sell the Total Company Interests to such Buyer in accordance with the terms set forth in
such Third-Party Offer.

If
(i) a binding purchase contract with a Buyer is not entered into prior to the end of the Marketing Period or
(ii) a binding purchase contract with a Buyer is entered into prior to the end of the Marketing Period but the sale of

the Total Company Interests to such Buyer has not closed prior to the sixtieth (60th) calendar day after the expiration
of the Marketing Period, or

(iii) the Selling Shareholder notifies in writing the Non-Triggering Shareholder that it has not found an acceptable Third-

Party Offer for the Total Company Interests (either because it does not meet the Minimum Purchase Price requirement
or otherwise), either Shareholder may deliver a Sale Notice to the other one in accordance with the present article and
re-commence the Sale Right procedures set forth in this article.

During the Marketing Period, the Selling Shareholder
(i) shall promptly provide the Non-Triggering Shareholder with information reasonably requested by the Non-Trig-

gering Shareholder relating to

(a) the terms of any agreement or proposed agreement with any Buyer,
(b) the identity of any Buyer and/or
(c) the status of any negotiations or sales process with any Buyer or potential Buyer;
(ii) shall promptly notify the Non-Triggering Shareholder when an agreement with a Buyer is reached as to purchase

price and a projected closing date and on the date on which a term sheet or agreement with a Buyer is executed; and

(iii) shall be permitted to complete the sale of the Total Company Interest once it has reasonably informed the Non-

Triggering Shareholder regarding the information described in items (i) and (ii) above.

Art. 8. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders.

58684

Art. 9. For no reason and in no case, the heirs or creditors of the shareholders are allowed to pursue the sealing of

property or documents of the Company.

Art. 10. The Company is managed by a board of managers (the "Board of Managers") appointed as a collegiate body

by the general meeting of the Shareholders in accordance with the provisions set out hereafter. The general meeting of
the Shareholders determines the powers and term of the mandates of the Managers. If no term is indicated the Managers
are appointed for an undetermined period. The Managers may be revoked by the general meeting of the Shareholders
with or without cause (ad nutum) at any time.

Within ten (10) calendar days from the Closing Date the Board of Managers shall consist of six (6) Managers, each of

whom does not reside in Germany and the following rules shall apply. The date on which the Board of Managers will be
re-composed as provided below is designated hereafter as the "New Board Composition date".

The Board of Managers shall always be composed of
i) three (3) Managers to be appointed by the general meeting of shareholders from a list of candidates proposed by

the Class A Shareholders, one of whom must be a resident of Luxembourg (each a "Class A Manager" and collectively
the "Class A Managers"). The list of candidates shall be sent to the Company, which shall then notify the other shareholders
of the Company.

The Class A Managers may only be removed from the Board of Managers upon proposal of Class A Shareholders.
ii) three (3) Managers to be appointed by the general meeting of shareholders from a list of candidates proposed by

the Class B Shareholders, one of whom must be a resident of Luxembourg (each a "Class B Manager" and collectively the
"Class B Managers"). The list of candidates shall be sent to the Company, which shall then notify the other shareholders
of the Company.

The Class B Managers may only be removed from the Board of Managers upon proposal of Class B Shareholders.
Any vacancy on the Board of Managers in respect of a Manager appointed as provided above shall be filled on a

provisional basis by the Board of Managers by applying the same rules as the ones described under (i) and (ii) above.

Art. 11. The Board of Managers chooses among its members a chairman.
If the chairman is unable to attend a meeting, he will be replaced by one of the Managers present at the meeting

designated to that effect by the board.

The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any two Managers.
Meetings of the Board of Managers may only validly take resolutions if at least two Managers are present being from

the New Board Composition Date one Class A Manager and one Class B Manager.

Any Manager can be represented at a meeting of the Board of Managers by another Manager.
Each Manager shall have one vote on all matters brought before the Board of Managers. The chairman will not have

any casting vote.

Resolutions of the Board of Managers may only validly be taken if the affirmative vote of a majority of the Managers

present or represented at a duly constituted meeting at which a quorum is present provided that, from the New Board
Composition Date, such majority must include the affirmative vote of at least one (1) Class A Manager and one (1) Class
B Manager.

The Board of Managers shall meet not less frequently than quarterly, upon not less than fifteen (15) calendar days prior

written notice (unless from the New Board Composition Date such prior written notice requirement is otherwise waived
in writing by at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager) duly given to all Managers (provided that
actions not specifically referred to in any agenda accompanying a notice may not be taken up at the relevant meeting). At
least one (1) meeting of the Board of Managers must be held during each quarter of each Fiscal Year at the Company's
offices in Luxembourg.

Meetings of the Board of Managers may be held at the Company's offices in Luxembourg or by conference call, video

conference, or similar means of communications equipment whereby (i) the Managers attending the meeting can be
identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting
is performed on an on-going basis and (iv) the Managers can properly deliberate. Participation in a meeting by such means
shall constitute presence in person at such meeting.

Except as otherwise specifically set forth in the Shareholders Agreement, no Manager shall be entitled to any com-

pensation or consideration for services rendered in its capacity as a Manager.

Any action or decision required or permitted to be taken at any meeting of the Board of Managers may be taken

without a meeting if (i) all of the Managers consent to such action or decision in writing, and (ii) the writing or writings
are filed with the records of the Company.

Art. 12. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposition

in the Company's interest within the limits of the Company's purpose.

All powers not expressly reserved to the general meeting of the shareholders of the Company by the law of August

10th, 1915 on commercial companies as subsequently modified (the "Law"), or by the present Articles of the Company,
fall within the competence of the board of managers.

58685

Art. 13. The Board of Managers may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons, who need not be shareholders of the Company.

The Board of Managers may further appoint such officers and/or other Company representatives as the Board of

Managers shall deem necessary or advisable. Each officer shall hold office until his earlier resignation or removal. The
Board of Managers may elect to remove any officer with or without cause at any time.

The Board of Managers shall have the power to establish one or more committees (including an executive committee)

to which the authority to make certain decisions may be delegated by the Board of Managers. No member of a committee
may be removed without the approval of the Board of Managers. The Class A Managers, on the one hand, and the Class
B Managers, on the other hand, each shall have the right to appoint (and at all times to maintain) such number of members
to any committee established by the Board of Managers as is proportional to the number of Managers for which the Class
A Shareholders and Class B Shareholders, respectively, have the right to propose candidates.

Art. 14. In the execution of their mandate, the Managers are not held personally responsible.
As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 15. The Company will be validly bound by the joint signature of any two Managers being from the New Board

Composition Date one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.

Art. 16. The Company is supervised by one independent auditor who is appointed by the general meeting of the

shareholders, which determines its remuneration. The independent auditor can be dismissed at any time by the general
meeting of the shareholders.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of the shareholders for a period

not exceeding six years.

Art. 17. Every shareholder may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number

of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 18. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.
However, decisions concerning the amendment of the Articles are taken by a majority of the shareholders representing

seventy five percent of the capital except otherwise provided in the Shareholders Agreement.

In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law or the

Articles, are assigned to the general meeting are exercised by the sole shareholder.

Art. 19. The business year begins on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

Art. 20. Every year, the annual accounts are drawn up by the Managers.

Art. 21. The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 22. Out of the net profit, five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the shareholders.
Distributions of net profit shall however only be made in compliance with the Shareholders Agreement.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board of Managers;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, increased by carried forward profits and distributable
reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the General Meeting of shareholders within two (2) months from

the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

Art. 23. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be shareholder and who are appointed by the shareholders who will specify their powers and remuneration.

Any distribution of the liquidation proceeds must be subject to the rules agreed between the shareholders in the

Shareholders Agreement.

Art. 24. For all points not regulated by these Articles of Association, reference is made to the provisions of the Law

and its modifying acts, concerning trading companies.

58686

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint, with effect on the Closing Date, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., with

registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg as auditor of the Company for a period ending on meeting of
the shareholders of the Company approving the annual accounts of the Company for the year 2008.

For the avoidance of doubt, the above appointments will be void if the Closing Date does not occur.

<i>Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately 8,750.- €.

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the

above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing party, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to the appearing party, known to the notary by first and last name, civil status and residence,

the said person signed together with the notary the present deed.

Follows the German version:

Im Jahre zwei tausend und acht, den sechsundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul FRIEDERS, mit Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Die Anstalt "Equilibrium Holding Establishement", mit Sitz in FL-9490 Vaduz, Austrasse 61, (Fürstentum Liechtenstein),

eingetragen im Öffentlichkeitsregister von Liechtenstein unter der Nummer FL-0002.232.967-1, (Einziger Gesellschafter),

hier vertreten durch Herrn Hassane DIABATE, Jurist, beruflich wohnhaft in L-2661 Luxemburg, 44, rue de la Vallée,

auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht von dem Bevollmächtigten und dem am-
tierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigelegt, um mit derselben registriert
zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden,

dass sie der einzige aktuelle Gesellschafter der Gesellschaft "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", (hiernach
die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsre-
gister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 127.199, ist, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar
Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, am 27. März 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1202 vom 19.
Juni 2007,

und dass sie, durch ihren Bevollmächtigten, folgende Beschlüsse fasst:

<i>Erster Beschluss

Die Komparentin beschließt, die betreffenden Anteile der Gesellschaft zu splitten, so dass jeder Anteil einen Anspruch

auf 100.000 Anteile zu einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01) gewährt.

<i>Zweiter Beschluss

Die Komparentin beschließt, das Grundkapital der Gesellschaft um den Betrag von vierhunderteinundvierzigtausend

Euro (EUR 441.000,-) zu erhöhen, damit es von derzeit einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) auf fünfhunderteinund-
vierzigtausend Euro (EUR 541.000,-) durch Ausgabe von vierundvierzig Millionen einhunderttausend (44.100.000) neue
Anteile  zu  einem  Nennwert  von  je  einem  Eurocent  (EUR  0,01)  aufgestockt  wird.  Diese  neuen  Anteile  werden  vom
Alleingesellschafter gezeichnet und voll eingezahlt gegen (i) eine Bareinlage in Höhe von zweihunderteinundvierzigtausend
Euro (EUR 241.000,-) und (ii) die Sacheinlage einer Forderung in Höhe von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,-)
infolge einer vom Alleingesellschafter an die Gesellschaft am 5 Oktober 2007 geleisteten Vorschusszahlung auf ein lau-
fendes Konto (die "Forderung").

Der Wert der Forderung wurde vom Vorstand der Gesellschaft in einem Bericht vom 21. März 2008 bewertet.
Dieser Bericht gelangt zu folgender Schlussfolgerung:
"Angesichts der vorstehenden Ausführungen ist der Vorstand der Auffassung, dass der Wert der Forderung, welche

gegen Ausgabe von zwanzig Millionen (20.000.000) Anteile in die Gesellschaft eingebracht wurde, zweihunderttausend
Euro (EUR 200.000,-) beträgt, was mindestens dem Zeichnungspreis der von der Gesellschaft zu begebenden Anteile
entspricht."

Besagter Bericht wird nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar

gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Aufgrund dieser Ausführungen beschließt der AlleinGesellschafter, die in das Grundkapital der Gesellschaft einge-

brachte Forderung mit zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,-) zu veranschlagen und gegen Einlage in die Gesellschaft
zwanzig Millionen (20.000.000) Anteile auszugeben, deren Zeichnung er erklärt.

Der unterzeichnete Notar hat den Nachweis für die Einlage der Forderung und den Betrag in Höhe von zweihunder-

teinundvierzigtausend Euro (EUR 241.000,-) in bar in die Gesellschaft erhalten.

58687

<i>Dritter Beschluss

Die Komparentin beschließt das Gesellschaftskapital in zwei verschiedene Kategorien von Anteilen, A und B, aufzuteilen

und die auszugebenden Anteile nach der Kapitalerhöhung wie folgt zu reklassifizieren:

- 27.050.000 Anteile gehen an Kategorie A;
- 27.050.000 Anteile gehen an Kategorie B.

<i>Vierter Beschluss

Die Komparentin beschließt zwei Kategorien von Geschäftsführern zu schaffen: eine Kategorie A-Geschäftsführer und

eine Kategorie B-Geschäftsführer.

<i>Fünfter Beschluss

Die Komparentin beschließt folgende Neufassung der Statuten vorzunehmen:

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "PERSEUS REAL ESTATE IN-

VESTMENT S.à r.l.", welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der

Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kon-
trolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen

Sicherheiten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb
durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten, deren Veräu-
ßerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst wie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vor-
schüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist oder an Unternehmen,
die von denselben Personen kontrolliert werden wie die Gesellschaft.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, und jede Art finanzieller Operationen die sich direkt oder indirekt auf

vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können vorzunehmen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg.
Er kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen, die für eine Sat-

zungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss der Geschäftsführung

verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch

im Ausland haben.

Art. 5. Gesellschaftskapital - Anteile.
5.1 Grundkapital
Das Grundkapital wird auf fünfhunderteinundvierzigtausend Euro (EUR 541.000,-) festgelegt, aufgeteilt in vierundfünfzig

Millionen einhunderttausend (54.100.000) Anteile zu einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), bestehend aus

a) siebenundzwanzig Millionen fünfzigtausend (27.050.000) Anteile der Kategorie A (die "A-Anteile"); und
b) siebenundzwanzig Millionen fünfzigtausend (27.050.000) Anteile der Kategorie B (die "B-Anteile").
Alle A-Anteile und B-Anteile (zusammen die "Anteile" genannt) wurden gezeichnet und voll eingezahlt.
Der/die Inhaber der Kategorie A-Anteile wird/werden nachstehend als "Kategorie A-Gesellschafter' bezeichnet.
Der/die Inhaber der Kategorie B-Anteile wird/werden nachstehend als "Kategorie B-Gesellschafter" bezeichnet.
Verfügbare Agios aus Anteileemission sind ausschüttungsfähig.
5.2) Anteile
a) Jede Anteile gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
b) Jeder Anteil berechtigt den Inhaber zu einem Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn wie folgt:
- 61,8% des realisierten Nettoeinkommens geht an die Inhaber der Anteile A;
- 38,2% des realisierten Nettoeinkommens geht an die Inhaber der Anteile B.

Art. 6. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden gemäss Artikel 199 des Handelsge-

sellschaftsrechts von 1915 festgelegt ist.

Art. 7.
7.1 Allgemeine Übertragungsbestimmungen

58688

Sofern in diesen Statuten nichts anderweitiges geregelt ist, unterliegt die Übertragung von Anteilen immer den Be-

stimmungen der Gesellschaftervereinbarung oder ähnlichen Vereinbarungen, die von Zeit zu Zeit zwischen allen Gesell-
schaftern der Gesellschaft geschlossen werden ("Gesellschaftervereinbarung"), und sie ist nur dann rechtswirksam und
wird von der Gesellschaft nur dann anerkannt, wenn sie aufgrund dieser Bestimmungen zulässig ist und sie im Einklang
mit diesen Bestimmungen erfolgt.

Unbeschadet der Bestimmungen dieser Statuten oder von Gesellschaftervereinbarung bedarf die Übertragung von

Anteile  an  NichtGesellschafter  in  allen  Fällen  der  Genehmigung  der  Gesellschaftervereinbarung,  die  mindestens  drei
Viertel des Grundkapitals der Gesellschaft vertritt.

Zum Zweck dieser Statuten bedeutet "Übertragung" die Übertragung, den Verkauf, die Abtretung, Verpfändung, Stel-

lung oder Bestellung von Sicherungs- oder Pfandrechten, die Begründung eines Treuhandverhältnisses (durch Abstimmung
oder anderweitig), die Übertragung kraft Gesetzes (mit Ausnahme einer Fusion oder Verschmelzung der Gesellschaft)
oder eine anderweitige Belastung, Verfügung oder Übertragung der wirtschaftlichen oder anderer Risiken in Verbindung
mit dem freiwilligen oder unfreiwilligen Eigentum an allen Anteile oder an Teilen davon.

7.2 Das Recht auf Veräußerung
Ab  und  nach  Ablauf  eines  Zeitraums  von  zwei  (2)  Jahren  nach  dem  Datum,  an  dem  die  Kategorie  B-Anteile  der

Gesellschaft an Whitehall Bear S.à.r.l. (der "Schlusstermin") übertragen werden, können die Kategorie A-Gesellschafter
(die als Gruppe handeln) und die Kategorie B-Gesellschafter (die als Gruppe handeln) jeweils beschließen, den Verkauf
von 100% der von allen Gesellschaftern gehaltenen Anteile der Gesellschaft zusammen mit 100% der von den Gesell-
schafter der Gesellschaft gehaltenen VorzugsAnteilezertifikate (die "gesamten Gesellschaftsanteile") zu veranlassen.

Das Recht eines jeden Gesellschafter, die gesamten Gesellschaftsanteile zu vermarkten oder deren Verkauf zu veran-

lassen, wird nachstehend als das "Recht auf Veräußerung" bezeichnet.

Die  Gruppe  von  Gesellschaftern,  welche  die  Ausübung  des  Rechts  auf  Veräußerung  vorschlägt  (der  "verkaufende

Gesellschafter"), legt den anderen Gesellschafter (der "nichtauslösende Gesellschafter") vor einer solchen vorgeschlage-
nen Übertragung eine schriftliche Mitteilung dieses Übertragungsvorschlags (eine "Mitteilung über das Recht auf Erstbe-
nachrichtigung") vor, in welcher die Absicht des verkaufenden Gesellschafters dargelegt wird, sein Recht auf Veräußerung
auszuüben. Eine Mitteilung über das Recht auf Erstbenachrichtigung umfasst:

i) eine Erklärung darüber, ob der verkaufende Gesellschafter vorschlägt, die gesamten Gesellschaftsanteile zu veräu-

ßern;

ii) einen Antrag des nichtauslösenden Gesellschafters auf Vorlage eines verbindlichen, unwiderruflichen Angebots durch

die anderen Gesellschafter in bar, vom verkaufenden Gesellschafter 100% der verhältnismäßigen Anteile an den gesamten
Gesellschaftsanteilen zu kaufen ("die spezifizierten Anteile").

Gesellschafter dürfen während der Frist für die Beantwortung eines Angebots (gemäß nachstehender Definition), der

Antwortannahmefrist  oder der Marketingfrist  (gemäß  nachstehender Definition) keine Mitteilung über  das  Recht  auf
Erstbenachrichtigung im Hinblick auf die gesamten Gesellschaftsanteile erteilen.

Innerhalb von dreißig Kalendertagen nach Erhalt einer Mitteilung über das Recht auf Erstbenachrichtigung durch den

nichtauslösenden Gesellschafter (die "Frist für die Beantwortung des Angebots") legt der nichtauslösende Gesellschafter
dem verkaufenden Gesellschafter eine schriftliche Mitteilung (eine "Mitteilung über die Beantwortung des Angebots") vor,
falls der nichtauslösende Gesellschafter 100% der spezifizierten Anteile kaufen möchte.

Jedes in der Mitteilung zur Beantwortung des Angebots enthaltene Angebot ist unwiderruflich und verbindlich und

umfasst ein Angebot in bar für die spezifizierten Anteile (der "spezifizierte Anteilskaufpreis").

Die Mitteilung über die Beantwortung des Angebots ist nicht an die Voraussetzung gebunden, dass der nichtauslösende

Gesellschafter Erklärungen und Zusicherungen und/oder Ersatzleistungen (mit Ausnahme derjenigen, die in der Gesell-
schaftersvereinbarung vorgesehen sind) oder Bedingungen für die Finanzierung des Anteilekapitals oder für die Schul-
denfinanzierung oder andere Bedingungen oder Eventualverbindlichkeiten (mit Ausnahme der in der Gesellschafterver-
einbarung definierten Abschlussbedingungen für das Recht des Käufers auf Veräußerung) erhält.

Für den Fall, dass der nichtauslösende Gesellschafter dem verkaufenden Gesellschafter innerhalb der Frist für die

Beantwortung des Angebots eine Mitteilung über die Beantwortung des Angebots vorlegt und der verkaufende Gesell-
schafter das in der Mitteilung über die Beantwortung des Angebots enthaltene Angebot annehmen möchte, legt der
verkaufende Gesellschafter dem nichtauslösenden Gesellschafter eine schriftliche Mitteilung vor (eine "Annahmemittei-
lung")  (in  der  ausgeführt  wird,  dass  der  verkaufende  Gesellschafter  die  spezifizierten  Anteile  zu  dem  spezifizierten
Anteilskaufpreis innerhalb von zehn (10) Kalendertagen nach Erhalt einer Mitteilung über die Beantwortung des Angebots
vom verkaufenden Gesellschafter erhält (die "Annahmeantwortfrist")).

Für den Fall, dass der nichtauslösende Gesellschafter dem verkaufenden Gesellschafter innerhalb der Frist für die

Beantwortung des Angebots eine Mitteilung über die Beantwortung des Angebots vorlegt und der verkaufende Gesell-
schafter  innerhalb  der  Annahmeantwortfrist  eine  Annahmemitteilung  vorlegt,  findet  der  Abschluss  des  Verkaufs  der
spezifizierten Anteile an den nichtauslösenden Gesellschafter (der "Abschluss des Aufkaufs aufgrund des Rechts auf Ver-
äußerung")  zwanzig  (20)  Werktage  nach  Erfüllung  der  Abschlussbedingungen  aufgrund  des  Rechts  des  Käufers  auf
Veräußerung oder an einem anderen Datum statt, das der nichtauslösende Gesellschafter und der verkaufende Gesell-
schafter gegenseitig schriftlich festlegen können.

58689

Wenn der Abschluss des Aufkaufs aufgrund des Rechts auf Veräußerung nicht innerhalb von neunzig Kalendertagen

nach Vorlage der Annahmemitteilung (der "Abschluss-Stichtag für den Aufkauf aufgrund des Rechts auf Veräußerung")
erfolgt, gilt die Mitteilung über die Beantwortung des Angebots als aufgehoben, und der verkaufende Gesellschafter ist
berechtigt, folgendermaßen vorzugehen.

Für den Fall, dass der nichtauslösende Gesellschafter vor Ablauf der Frist für die Beantwortung des Angebots keine

Mitteilung über die Beantwortung des Angebots vorlegt, die den vorstehenden Bestimmungen entspricht, oder falls der
verkaufende Gesellschafter vor Ablauf der Annahmeantwortfrist keine Annahmemitteilung vorlegt, die den vorstehend
genannten Bestimmungen entspricht, oder falls der Abschluss des Aufkaufs aufgrund des Rechts auf Veräußerung nicht
vor dem Abschluss-Stichtag für den Aufkauf aufgrund des Rechts auf Veräußerung stattfindet, ist der verkaufende Ge-
sellschafter berechtigt, die gesamten Gesellschaftsanteile innerhalb einer sechsmonatigen Marketingfrist zu vermarkten
und zu verkaufen (und den nichtauslösenden Gesellschafter dazu zu veranlassen); diese Frist beginnt an dem Tag nach
dem letzten Tag der Frist für die Beantwortung des Angebots (falls der nichtauslösende Gesellschafter keine Mitteilung
über die Beantwortung des Angebots vorlegt, die den vorstehenden Bestimmungen entspricht), bzw. nach dem letzten
Tag der Annahmeantwortfrist (falls der verkaufende Gesellschafter keine Annahmemitteilung vorlegt, die den vorste-
henden Bestimmungen entspricht), bzw. dem Abschluss-Stichtag für den Aufkauf aufgrund des Rechts auf Veräußerung
(falls der nichtauslösende Gesellschafter eine Mitteilung über die Beantwortung des Angebots vorlegt, die den vorste-
henden Bestimmungen entspricht, und der verkaufende Gesellschafter eine Annahmemitteilung vorlegt, die den vorste-
henden  Bestimmungen  entspricht),  je  nachdem  (die  "Marketingfrist").  In  diesem  Fall  entspricht  der  "angebotene
Verkaufspreis") (A) in dem Fall, in dem der nichtauslösende Gesellschafter eine Mitteilung über die Beantwortung des
Angebots vorgelegt hat, dem Preis, zu dem die gesamten Gesellschaftsanteile verkauft werden müssten, damit der ver-
kaufende Gesellschafter berechtigt wäre, als Gruppe Bargeld über einen Betrag in Höhe des spezifizierten Anteilskaufs-
preises  entgegenzunehmen,  oder  (B)  in  dem  Fall,  in  dem  die  nichtauslösende  Gruppe  keine  Mitteilung  über  die
Beantwortung des Angebots vorgelegt hat, Null Euro (EUR 0,00).

Falls der verkaufende Gesellschafter während der Marketingfrist ein Angebot (ein "Drittangebot") von Dritten (einem

"Käufer") über den Kauf der gesamten Gesellschaftsanteile zu einem Kaufpreis in Höhe von mindestens fünfundneunzig
(95%) Prozent des angebotenen Verkaufspreises (der "Mindestkaufpreis") erhält, dann kann sich der verkaufende Gesell-
schafter  dafür  entscheiden,  die  Gesellschafter  dazu  anzuhalten,  dieses  Drittangebot  anzunehmen  und  die  gesamten
Gesellschaftsanteile im Einklang mit den in einem solchen Drittangebot spezifizierten Bedingungen an diesen Käufer zu
veräußern.

Falls
(i) vor Ablauf der Marketingfrist kein verbindlicher Kaufvertrag mit einem Käufer zustande kommt oder
(ii) vor Ablauf der Marketingfrist ein verbindlicher Kaufvertrag mit einem Käufer zwar zustande kommt, der Verkauf

der gesamten Gesellschaftsanteile an diesen Käufer jedoch nicht spätestens am sechzigsten (60.) Kalendertag nach Ablauf
der Marketingfrist abgeschlossen wurde, oder

(iii) der verkaufende Gesellschafter dem nichtauslösenden Gesellschafter schriftlich mitteilt, dass er kein annehmbares

Drittangebot für die gesamten Gesellschaftsanteile erhalten hat (entweder weil dieses den Anforderungen an den Min-
destkaufpreis nicht entspricht, oder aus anderen Gründen), kann jeder Gesellschafter dem jeweils anderen eine Ver-
kaufsmitteilung in Übereinstimmung mit diesem Artikel vorlegen und die darin beschriebenen Verfahren bezüglich des
Rechts auf Veräußerung erneut einleiten.

Während der Marketingfrist legt der verkaufende Gesellschafter
(i) dem nichtauslösenden Gesellschafter unverzüglich Informationen vor, die vom nichtauslösenden Gesellschafter in

angemessenem Rahmen verlangt werden können; diese Informationen beziehen sich auf

(a) die Bedingungen von Vereinbarungen oder vorgeschlagenen Vereinbarungen mit Käufern;
(b) die Identität von Käufern, und/oder
(c) den Stand von Verhandlungen oder Verkaufsprozessen mit Käufern bzw. potenziellen Käufern; ferner
(ii) teilt er dem nichtauslösenden Gesellschafter unverzüglich mit, wenn eine Vereinbarung mit einem Käufer in Bezug

auf den Kaufpreis und auf einen geplanten Abschlusstermin sowie auf das Datum erzielt wurde, an dem ein Term Sheet
oder eine Vereinbarung mit einem Käufer ausgefertigt wird;

und
(iii) gesetzt den Fall, die in (i) und (ii) genannten Informationen sind gegeben, soll es erlaubt sein, das gesamtkapital der

Gesellschaft vollständig zu übertragen, sobald der verbleibende Gesellschafter darüber entsprechend informiert wurde.

Art. 8. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit

eines Gesellschafters.

Art. 9. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Doku-

mente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken
könnten.

58690

Verwaltung - Überwachung

Art. 10. Die Gesellschaft wird von einem Vorstand (der "Vorstand") geführt, der als Kollegialgremium von der Ge-

sellschaftershauptversammlung in Übereinstimmung mit den nachstehend beschriebenen Bedingungen bestellt wird. Die
Gesellschaftershauptversammlung legt die Befugnisse und die Mandatsdauer der Geschäftsführer fest. Wird keine Man-
datsdauer festgelegt, werden die Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer bestellt. Die Geschäftsführer können von der
Gesellschaftershauptversammlung mit oder ohne Angabe von Gründen ("ad nutum") jederzeit abberufen werden.

Zehn (10) Kalender Tage ab dem Abschlussdatum besteht der Vorstand aus sechs (6) Geschäftsführer, die alle nicht

in Deutschland ansässig sind; dabei gelten folgende Regelungen. Der Zeitpunkt, an dem die Geschäftsführung, wie unten
beschrieben neu besteht wird, wird nachfolgend als "Neubesetzung der Geschäftsführung" bezeichnet.

Der Vorstand setzt sich immer zusammen aus
i) drei (3) Geschäftsführer, die von der Gesellschaftershauptversammlung aufgrund einer Kandidatenliste bestellt wer-

den, welche von den Kategorie A-Gesellschaftern vorgeschlagen werden, wobei jeder dieser Kandidaten ein luxembur-
gischer  Staatsbürger  sein  muss  (jeder  Einzelne  ein  "Kategorie  A-Geschäftsführer"  und  zusammen  die  "Kategorie  A-
Geschäftsführer"). Die Liste der Kandidaten ist der Gesellschaft zu übermitteln, welche dann die übrigen Gesellschafter
der Gesellschaft in Kenntnis setzt.

Die Kategorie A-Geschäftsführer können nur auf Vorschlag der Kategorie A-Gesellschafter aus dem Vorstand abbe-

rufen werden.

ii) drei (3) Geschäftsführung, die von der Gesellschaftershauptversammlung aufgrund einer Kandidatenliste bestellt

werden, welche von den Kategorie B-Gesellschaftern vorgeschlagen werden, wobei jeder dieser Kandidaten ein luxem-
burgischer Staatsbürger sein muss (jeder Einzelne ein "Kategorie B-Geschäftsführung" und zusammen die "Kategorie B-
Geschäftsführung"). Die Liste der Kandidaten ist der Gesellschaft zu übermitteln, welche dann die übrigen Gesellschafter
der Gesellschaft in Kenntnis setzt.

Die Kategorie B-Geschäftsführer können nur auf Vorschlag der Kategorie B-Gesellschafter aus dem Vorstand abbe-

rufen werden.

Freie Sitze im Vorstand in Bezug auf ein Geschäftsführer, das gemäß den vorstehenden Bedingungen berufen wurde,

werden vorübergehend vom Vorstand besetzt; dabei gelten dieselben Regelungen wie unter (i) und (ii) oben beschrieben.

Art. 11. Der Vorstand wählt aus seinen eigenen Reihen einen Vorsitzenden.
Im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden wird er durch einen der Geschäftsführer ersetzt, der an der Sitzung teil-

nimmt und hierzu vom Vorstand benannt wird.

Die Sitzungen des Vorstands werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern einberufen.
Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn mindestens zwei Geschäftsführer (nach der Neubesetzung der Geschäfts-

führung) anwesend sind, d.h. ab dem Schlusstermin ein Kategorie A-Geschäftsführer und ein Kategorie B-Geschäftsführer.

Alle Geschäftsführer können sich bei Sitzungen des Vorstands durch jeden anderen Geschäftsführer vertreten lassen.
Jeder Geschäftsführer besitzt eine Stimme zu allen Angelegenheiten, mit denen der Vorstand befasst wird. Der Vor-

sitzende besitzt keine ausschlaggebende Stimme.

Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer, die bei einer ordnungsgemäß einberu-

fenen und beschlussfähigen Sitzung anwesend oder vertreten sind, mit "Ja" Stimmen, vorausgesetzt, dass diese Mehrheit
ab dem Schlusstermin die Ja-Stimme von mindestens einem (1) Kategorie A-Geschäftsführer und einem (1) Kategorie B-
Geschäftsführer umfasst.

Der  Vorstand  tritt  mindestens  einmal  vierteljährlich  nach  einer  schriftlichen  Einladung  zusammen,  die  mindestens

fünfzehn (15) Kalendertage vor der Sitzung ergehen muss (es sei denn, auf dieses Erfordernis der schriftlichen Einladung
wird verzichtet, indem mindestens ein (1) Kategorie A-Geschäftsführer und ein (1) Kategorie B-Geschäftsführer dies allen
Geschäftsführer ordnungsgemäß und in Schriftform mitteilen (vorausgesetzt, dass Maßnahmen, die in der zusammen mit
der Einladung verschickten Tagesordnung nicht gesondert aufgeführt sind, auf der entsprechenden Sitzung möglicherweise
nicht erörtert werden). In jedem Quartal eines jeden Geschäftsjahres muss am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg min-
destens eine (1) Vorstandssitzung stattfinden.

Die Vorstandssitzungen können am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder aber in Form von Konferenzschaltungen,

Videokonferenzen oder mithilfe ähnlicher Kommunikationsmittel stattfinden, wobei (i) die Identität der an der Sitzung
teilnehmenden Geschäftsführer erkennbar ist, (ii) alle an der Sitzung teilnehmenden Personen einander hören und mit-
einander sprechen können, (iii) die Sitzung ununterbrochen übertragen wird und (iv) die Geschäftsführer ordnungsgemäß
beraten können. Die Teilnahme an einer Sitzung mithilfe solcher Kommunikationsmittel gilt als persönliche Teilnahme an
der Sitzung.

Falls in der Aktionärsvereinbarung nichts anderes geregelt ist, haben Geschäftsführer keinen Anspruch auf Entschädi-

gung oder Entgelt für die in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer erbrachten Dienste.

Maßnahmen oder Entscheidungen, die auf Vorstandssitzungen erforderlich oder zulässig sind, können auch ohne eine

Sitzung getroffen werden, wenn (i) alle Geschäftsführer einer solchen Maßnahme bzw. Entscheidung schriftlich zustimmen
und (ii) diese Schreiben zu den Akten der Gesellschaft genommen werden.

58691

Art. 12. Der Vorstand hat die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft, alle Angelegenheiten zu

führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie durch die späteren Änderungen, oder

durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Vor-
standes.

Art. 13. Der Vorstand kann seine Befugnisse im Hinblick auf die tägliche Führung der Geschäfte ganz oder teilweise

an Geschäftsführer oder an Dritte übertragen, bei denen es sich nicht unbedingt um Gesellschafter handeln muss.

Der Vorstand kann ferner Führungskräfte und/oder andere Vertreter der Gesellschaft bestellen, sofern der Vorstand

dies für notwendig oder ratsam erachtet. Jede Führungskraft bekleidet dieses Amt so lange, bis sie aus dem Amt aus-
scheidet oder abberufen wird, je nachdem, welcher Fall früher Eintritt. Der Vorstand kann entscheiden, Führungskräfte
jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen abzuberufen.

Der Vorstand ist befugt, einen oder mehrere Ausschüsse (einschließlich eines geschäftsführenden Ausschusses) ein-

zusetzen und diesen die Befugnis zu erteilen, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Kein Mitglied eines solchen Aus-
schusses  darf  ohne  die  Zustimmung  des  Vorstands  abberufen  werden.  Kategorie  A-Geschäftsführer  einerseits  und
Kategorie B-Geschäftsführer andererseits sind berechtigt, die Zahl von Mitgliedern in den vom Vorstand eingesetzten
Ausschüssen zu benennen (und jederzeit beizubehalten), die in einem angemessenen Verhältnis zu der Zahl der Ge-
schäftsführer steht, für welche die Kategorie A-Gesellschafter bzw. die Kategorie B-Gesellschafter Kandidaten vorschla-
gen dürfen.

Art. 14. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 15. Die Gesellschaft ist durch die gemeinsame Unterschrift von zwei beliebigen Geschäftsführern, bei denen es

sich ab der Neubesetzung der Geschäftsführung um einen (1) Kategorie A-Geschäftsführer und um einen (1) Kategorie
B-Geschäftsführer handelt, rechtsgültig gebunden.

Art. 16. Die Gesellschaft steht unter der Aufsicht eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers, der von der Gesellschaf-

tershauptversammlung ernannt wird, die auch seine Vergütung festlegt. Der unabhängige Wirtschaftsprüfer kann von der
Gesellschaftershauptversammlung jederzeit abberufen werden.

Die Dauer des Mandats des/der statutarischen Wirtschaftsprüfer(s) wird von der Gesellschaftershauptversammlung

auf einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren festgelegt.

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten

vertreten lassen.

Art. 18. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden.
Beschlüsse  welche  eine  Satzungsänderung  betreffen  werden  durch  die  Mehrheit  der  Anteilseigner  gefasst,  welche

mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Art. 19. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 20. Jedes Jahr wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 21. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 22. Vom Reingewinn werden fünf Prozent in eine gesetzliche Rücklage eingestellt. Diese Einbehaltung ist dann

nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage auf zehn Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft angestiegen
ist.

Der Saldo steht den Aktionären zur Verfügung.
Die Ausschüttung des Reingewinns erfolgt allerdings nur im Einklang mit der Gesellschaftervereinbarung.
Zwischendividenden können jederzeit ausgeschüttet werden, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:
(i) der Vorstand erstellt Halbjahresabschlüsse;
(ii) aus diesen Halbjahresabschlüssen geht hervor, dass genügend Gewinne und andere Rücklagen (einschließlich Emis-

sionsagio) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; dabei wird davon ausgegangen, dass der auszuschüttende Betrag die
Gewinne nicht übersteigt, die seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres erzielt wurden, dessen Abschluss genehmigt
wurde, erhöht um die Gewinnvorträge und die ausschüttungsfähigen Rücklagen, jedoch gemindert um die Verlustvorträge
und die in die gesetzliche Rücklage einzu stellenden Beträge;

(iii) die Entscheidung über die Ausschüttung von Zwischendividenden wird von der Gesellschaftershauptversammlung

innerhalb von zwei (2) Monaten nach dem Datum der Halbjahresabschlüsse getroffen;

58692

(iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft sind nicht bedroht, wobei auch den Aktiva der Gesellschaft Rechnung

zu tragen ist, und

(v) sofern die ausgeschütteten Zwischendividenden die ausschüttungsfähigen Gewinne am Ende des Geschäftsjahres

überschreiten, müssen die Aktionäre die zuviel gezahlten Beträge der Gesellschaft zurückerstatten.

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein

Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung
festlegen.

Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.

August 1915 und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften, verwiesen.

<i>Sechster Beschluss

Die Komparentin beschließt PricewaterhouseCoopers S.à r.l., mit Sitz in 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg als

Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zu ernennen. Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet sofort nach der jährlichen
Generalversammlung welche über die Konten des Geschäftsjahres 2008 befindet.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 8.750,- €.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der

erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen
derselben erschienenen Partei, und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird
die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zuna-

men, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Diabate, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 avril 2008. Relation: LAC/2008/13855. — Reçu à 0,50%: deux mille deux cent cinq

euros (€ 2.205,-).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 15. April 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008056425/212/664.
(080062532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

CB Richard Ellis Investors DR Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 496.875,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 106.417.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg),

en date du 16 février 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n 

o

 650 du 5 juillet 2005.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CB RICHARD ELLIS INVESTORS DR CO-INVEST S.A R.L.
Signature

Référence de publication: 2008056477/250/16.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08511. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

58693

Brixton Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 134.738.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 51342 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008056714/211/11.
(080062545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Nostos Holdings Co S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 103.658.

Le bilan au 31/12/2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23/04/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008056421/751/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2008, réf. LSO-CP08574. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Xenios Holdings Co S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 103.657.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23/04/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008056420/751/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2008, réf. LSO-CP08577. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

I.P.F. - CA Gaz et Eau s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle, route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 27.280.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/04/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008056478/2546/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2008, réf. LSO-CM08959. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Colt Financial Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 47.052.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

58694

Luxembourg, le 15 avril 2008.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2008056482/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08328. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

RHIC Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 75.768.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2008056480/687/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08372. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080062641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Jumeva S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 76.885.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.
Signature

Référence de publication: 2008056493/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 15 avril 2008, réf. DSO-CP00059. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080062611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Mediainvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 75.627.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 avril 2008.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2008056488/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08344. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Seabird S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 57.759.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

58695

Luxembourg, le 15 avril 2008.

SG Audit SARL
Signature

Référence de publication: 2008056489/521/14.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08349. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Kilimanjaro International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 110.246.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008056490/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2008, réf. LSO-CP08842. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080062686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Waterlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.593.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2008.

<i>Pour WATERLUX S.A.
Signature

Référence de publication: 2008056453/744/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2008, réf. LSO-CP03914. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Vigamat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 101.040.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008056758/636/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP09032. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Vigamat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 101.040.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

58696

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008056760/636/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP09028. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Vigamat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 101.040.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008056761/636/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP09027. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

euroscript international S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 122.347.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008056752/1682/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP09068. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Savic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 99.075.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

Référence de publication: 2008056756/636/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP09035. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Invex Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 90.782.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

58697

Luxembourg, le 19 octobre 2007.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2008056766/535/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2008, réf. LSO-CP08606. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Tailo Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 135.109.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2008.

TAILO INVESTMENTS S.A.
Signature

Référence de publication: 2008056768/3258/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2008, réf. LSO-CP06673. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

euroscript Luxembourg Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 26.127.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008056754/1682/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP09066. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Compagnie Luxembourgeoise d'Investissement Direct S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.278.

Constituée par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

en date du 28 mai 2004, acte publié au Mémorial C no 824 du 11 août 2004.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Compagnie Luxembourgeoise d'Investissement Direct S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008056334/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2008, réf. LSO-CP07965. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

58698

M.I.E. (Matériels d'Installation Electrique) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 41, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 79.239.

Le bilan au 31 décembre 2007, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2008056340/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08192. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080062467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Empebe, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 47.436.

Le bilan au 31 décembre 2007, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008056341/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08203. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

INFOGES, Informatique et Gestion S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 37.512.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008056377/6825/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08490. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Compagnie Luxembourgeoise d'Investissement Direct S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.278.

Constituée par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

en date du 28 mai 2004, acte publié au Mémorial C no 824 du 11 août 2004.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Compagnie Luxembourgeoise d'Investissement Direct S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008056335/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2008, réf. LSO-CP07966. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

58699

Maroquinerie du Centre Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3590 Dudelange, 35, place de l'Hôtel de Ville.

R.C.S. Luxembourg B 78.035.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008056380/6825/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08483. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080062610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Toled S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 114.848.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2008.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2008056345/710/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2008, réf. LSO-CP06749. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Minimercado Portugal S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 17, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 64.666.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008056379/6825/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08484. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Compagnie Luxembourgeoise d'Investissement Direct S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.278.

Constituée par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

en date du 28 mai 2004, acte publié au Mémorial C no 824 du 11 août 2004.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Compagnie Luxembourgeoise d'Investissement Direct S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008056336/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2008, réf. LSO-CP07969. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

58700

Chauffage Mimmo &amp; Rocco S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 160, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 95.731.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008056385/6825/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08502. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080062584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Pizzeria Beim Rocco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3254 Bettembourg, 161, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 44.126.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008056384/6825/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08505. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Whitesorg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 106.921.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2008.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2008056365/710/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2008, réf. LSO-CP06745. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Huacheng Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 137.085.

In the year two thousand eight, on the fourth day of April.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

Mr Christophe BLONDEAU, employee, residing at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
acting in his capacity as a special proxy holder of the Board of Directors of "HUACHENG REAL ESTATE S.A.", a

company ("société anonyme") having its registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, registered in the Lux-
embourg Company Register under section B number 137.085, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
on  13  March  2008  its  publication  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  pending  (hereinafter  the
Company"), and whose articles of incorporation have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary on 31
March 2008, in the process of being formalised,

by virtue of the authority conferred on him by resolutions adopted by the Board of Directors of the Company, on 31

March 2008, a copy of which resolutions, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

58701

The appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to record the following

declarations and statements:

I.- The subscribed share capital of the Company is presently set II.- That pursuant to Article FIVE (5) of the Company's

Articles of Association, the authorised capital of the Company has been fixed at nineteen million two hundred thousand
euro (EUR 19.200.000.-) to be divided into shares with a par value of fifty cents (EUR 0,50). The board of directors is
especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right
to subscribe to the shares to be issued.

III.- That the Board of Directors, in its meeting of 31 March 2008 and in accordance with the authority conferred on

it pursuant to Article FIVE (5) of the Company's Articles of Association, has realised an increase of the issued share capital
by an amount of two hundred thousand euro (EUR 200.000.-) in order to raise the issued share capital to the amount of
six million six hundred thousand euro (EUR 6.600.000.-) by the creation and issue of four hundred thousand (400.000)
new shares with a par value of fifty cents (EUR 0,50) and, having the same rights and privileges as the already existing
shares.

IV.- That the Board of Directors of the Company, in its meeting of 31 March 2008, has accepted the subscription of

the total of four hundred thousand (400.000) new shares as follows:

- four thousand (4.000) new shares by "Mont-Blanc Alpen Stock SAS", having its registered office at 9/11, rue Benoît

Malon, F-92156 Suresnes Cedex;

- sixteen thousand (16.000) new shares by "Paris Lyon Gestion", having its registered office at 10, rue d'Uzes, F-75002

Paris;

- twelve thousand (12.000) new shares by "Financière D'Uzes S.A.", having its registered office at 10, rue d'Uzes,

F-75002 Paris;

- two hundred one thousand seven hundred and seventy (201.770) new shares by "Hong Kong United Huasheng

Investment Limited", having its registered office at Unit, G 21/F Seabright Plaza, 9-23 Shell Street, North Point, Hong
Kong;

- hundred sixty-six thousand two hundred and thirty (166.230) new shares by "Channel Best Enterprises Limited",

having its registered office at Simmonds Building, Wickhams Cay 1, P.O. Box 961, Road Town, Tortola, Bristish Virgin
Islands.

All these shares have been paid up in cash, together with an issue premium of twelve euro (EUR 12.-) per new issued

share, by the subscribers so that the total sum of five million euro (EUR 5.000.000.-) is at the disposal of the Company
as has been proved to the undersigned notary.

The total contribution of five million euro (EUR 5.000.000.-) represents two hundred thousand euro (EUR 200.000.-)

for the capital and four million eight hundred thousand (EUR 4.800.000.-) for the paid in share premium amount.

V.- That as a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital, paragraph one of Article FIVE

(5) of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:

"The subscribed capital of the Company is set at six million six hundred thousand euro (EUR 6.600.000.-) divided into

thirteen million two hundred thousand (13.200.000) shares with a par value of fifty cents (EUR 0,50) each, all of which
are fully paid up.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately twenty-eight thousand five hundred euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the Company, on the day named

at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing person, said appearing person signed together with Us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le quatre avril.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Christophe BLONDEAU, employé, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du Conseil d'Administration de «HUACHENG REAL ESTATE S.A.», une

société anonyme ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et
des Sociétés sous la section B numéro 137.085, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 mars
2008, la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, étant en cours (ci-après la "Société") dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 mars 2008, en voie de formalisation,

58702

en vertu de résolutions adoptées par le Conseil d'Administration de la Société en date du 31 mars 2008, une copie

desdites résolutions, après avoir été signée «ne varietur» par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle personne comparante, agissant en sa-dite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les dé-

clarations et constatations suivantes:

I.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à six millions quatre cent mille euros (EUR 6.400.000.-) divisé

en douze millions huit cent mille (12.800.000) actions d'une valeur nominale de cinquante cents (EUR 0,50) entièrement
libérées.

II.- Qu'en vertu de l'article CINQ (5) des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à dix-neuf

millions deux cent mille euros (EUR 19.200.000.-) qui sera représenté par des actions d'une valeur nominale de cinquante
cents (EUR 0,50). Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver
aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

III.- Que le Conseil d'Administration de la Société, par sa décision du 31 mars 2008, et en conformité avec les pouvoirs

lui conférés en vertu de l'article CINQ (5) des statuts de la Société, a réalisé une augmentation du capital social souscrit
à concurrence de deux cent mille euros (EUR 200.000.-) en vue de porter le capital social souscrit à six millions six cent
mille euros (EUR 6.600.000.-) par la création et l'émission de quatre cent mille (400.000) nouvelles actions, d'une valeur
nominale de cinquante cents (EUR 0,50) chacune, et jouissant des même droits et avantages que les actions existantes.

IV.- Que le Conseil d'Administration de la Société, lors de sa réunion du 31 mars 2008, a accepté la souscription de

la totalité des quatre cent mille (400.000) nouvelles actions comme suit:

- quatre mille (4.000) actions nouvelles par «Mont-Blanc Alpen Stock SAS», ayant son siège social au 9/11, rue Benoît

Malon, F-92156 Suresnes Cedex;

- seize mille (16.000) actions nouvelles par «Paris Lyon Gestion» ayant son siège social au 10, rue d'Uzes, F-75002

Paris;

- douze mille (12.000) actions nouvelles par «Financière D'Uzes S.A.», ayant son siège social au 10, rue d'Uzes, F-75002

Paris;

- deux cent un mille sept cent soixante-dix (201.770) actions nouvelles par «Hong Kong United Huascheng Investment

Limited», ayant son siège social au Unit, G 21/F Seabright Plaza, 9-23 Shell Street, North Point, Hong Kong;

- cent soixante-six mille deux cent trente (166.230) actions nouvelles par «Channel best Enterprises Limited», ayant

son siège social au Simmonds Building, Wickhams Cay 1, P.O. Box 961, Iles Vierges Britanniques.

Toutes ces actions ont été libérées en numéraire ensemble à une prime d'émission de douze euros (EUR 12.-) par

action nouvelle souscrite, de sorte que la somme totale de cinq millions d'euros (EUR 5.000.000.-) se trouve à la libre
disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

L'apport total de cinq millions d'euros (EUR 5.000.000.-) consiste en deux cent mille euros (EUR 200.000.-) de capital

et en quatre millions huit cent mille euros (EUR 4.800.000.-) de prime d'émission.

V.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l'article CINQ (5)

des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. «Le capital souscrit de la société est fixé à six millions six cent mille euros (EUR 6.600.000.-)

divisé en treize millions deux cent mille (13.200.000) actions, d'une valeur nominale de cinquante cents (EUR 0,50) cha-
cune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à environ vingt-huit mille cinq cents euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des personnes comparantes,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes compa-
rantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: C. BLONDEAU, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 8 avril 2008. Relation: EAC/2008/4690. — Reçu vingt-cinq mille Euros (5.000.000.-

à 0,5 % = 25.000.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

58703

Belvaux, le 22 avril 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008056441/239/132.
(080062505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

LBREM NW Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 119.744.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2008.

<i>Pour LBREM NW Holdings S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008056417/8222/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2008, réf. LSO-CP08534. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080062745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

VZW S.à.r.l., Voyages Zanier William S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: Alpicars.

Siège social: L-4599 Differdange, 47, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 49.660.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
AECONOMIA CONSULT
Signature

Référence de publication: 2008056479/7363/15.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP09371. - Reçu 91,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Scan-Project S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6981 Rameldange, 10, rue Joseph Schroeder.

R.C.S. Luxembourg B 33.670.

Le bilan au 31/12/2003 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25.04.08.

FBK FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008056348/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2008, réf. LSO-CP06744. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080062400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

58704


Document Outline

Accounting Partners S.à r.l.

Alia S.A.

Aquatrans Shipping A.G.

Brixton Holdings Sàrl

CB Richard Ellis Investors DR Co-Invest S.à r.l.

Century Financière S.A.

Chauffage Mimmo &amp; Rocco S.à.r.l.

CI CEL I S.à r.l.

Clarity S.A.

Colt Financial Holding S.A.

Commerzbank International S.A.

Compagnie Luxembourgeoise d'Investissement Direct S.A.

Compagnie Luxembourgeoise d'Investissement Direct S.A.

Compagnie Luxembourgeoise d'Investissement Direct S.A.

Compagnie Luxembourgeoise d'Investissement Direct S.A.

Empebe

Ersel Gestion Internationale S.A.

euroscript international S.A.

euroscript Luxembourg Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Fund-Market S.A.

GenCap I S.à r.l.

GKM Ingenieure Lux Sàrl

HGSC 2 S.A.

Huacheng Real Estate S.A.

Informatique et Gestion S.à.r.l.

Invex Properties S.A.

I.P.F. - CA Gaz et Eau s.à r.l.

IPSE Dixit Holding S.A.

Jumeva S.A.

Kilimanjaro International S.à r.l.

LBREM NW Holdings S.à r.l.

Maroquinerie du Centre Sàrl

Mayriwa

Mecanical Holding S.A.

Mediainvest S.A.

M.I.E. (Matériels d'Installation Electrique) S.A.

Minimercado Portugal S.àr.l.

Minimercado Portugal S.àr.l.

New Star Global Property Management (Luxembourg One) S.à r.l.

Nostos Holdings Co S.A.

Octagone Luxembourg 1 S.à r.l.

Octagone Luxembourg 2 S.à r.l.

Octagone Luxembourg 3 S.à.r.l.

Perseus Real Estate Investment S.à r.l.

Pizzeria Beim Rocco S.à r.l.

Pro Cons S.àr.l.

Promobilia Cursum S.A.

Raynor S.A.

RHIC Holding S.A.

Savic S.à r.l.

Scan-Project S.A.

Seabird S.A.

Sea International S.A.

Tailo Investments S.A.

Toled S.à r.l.

Trimontana S.A.

Vigamat S.A.

Vigamat S.A.

Vigamat S.A.

Voyages Zanier William S.à.r.l.

Waterlux S.A.

Whitesorg S.à r.l.

Xenios Holdings Co S.A.