This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1095
3 mai 2008
SOMMAIRE
Aberdeen Property Funds Eastern Europe
SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52533
Archangel Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .
52534
Armstripe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52525
Avelar Investments S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
52539
Beaumanoir S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52537
Beethoven CDO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52541
Bimaculatus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52534
Bluehouse Capital Advisors S.à r.l. . . . . . . .
52515
Blue Ringed S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52535
Bourns (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . .
52549
BPI Global Investment Fund Management
Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52537
Briarius S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52547
Burryi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52534
Centre de Jour Hiirzebierg . . . . . . . . . . . . . .
52540
Charles Oakes & Co S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
52542
Charles Oakes & Co S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
52546
Club Senior Nordstad . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52540
Cyanea S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52540
Deep Carribean Investments S.A. . . . . . . .
52542
Dofleini S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52542
Domolux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52543
Ersel Gestion Internationale S.A. . . . . . . . .
52539
Ersel Internationale S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
52537
EUROHYPO Europäische Hypotheken-
bank S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52514
Euro Zing I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52537
Financière Alkaline S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
52548
Gain Capital Participations SA, SICAR . . .
52543
Gestion Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
52535
Gestion Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
52536
Idécomm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52533
Intersum International S.A. . . . . . . . . . . . . .
52538
Kudelski Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
52547
LuxCo 37 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52541
Luxembourg-Décolletage . . . . . . . . . . . . . . .
52560
Macropus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52514
Meca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52526
Minafin Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52514
M.M. Warburg & Co Holding S.A. . . . . . . .
52526
M.M. Warburg & Co Holding S.A. . . . . . . .
52535
Norddeutsche Landesbank Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52536
Nord Lux Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52547
Octopussy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52526
Perma Impressions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
52539
Petrusse European Clo S.A. . . . . . . . . . . . . .
52541
Polimm S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52560
PRINCETON PROPERTY, Société à res-
ponsabilité limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52541
Red Pepper Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52546
RESOLUTION London W1 S.à r.l. . . . . . . .
52558
SigmaKalon Luxco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52527
SigmaKalon Luxco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52529
Société Civile Immobilière Bouquet . . . . .
52548
Solution for International Commerce . . . .
52546
Sopisa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52525
Southdown Luxembourg Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52546
Southdown Luxembourg Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52548
SSCP Style S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52549
Systemgastronomie K. Kiermeier
G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52527
T.C.I. Technology Communication Initiati-
ve S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52540
TD Retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52539
Telecom Italia Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52527
Tishman Speyer French Core Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52538
Vatem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52560
Welbeck Street Investments S.A. . . . . . . .
52525
52513
Minafin Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.819.700,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 107.406.
<i>Extrait des conventions de cession de parts socialesi>
ADGALE AG a cédé à hauteur de 376 parts sociales comme suit:
- Pierre ALBOUY, né le 04/10/1964 à Dunkerque (France), domicilié 30 Larchmont Avenue, USA-10538 Larchmont
New-York, détenteur de 94 parts sociales;
- Gilles SITBON, né le 27/08/1936 à Tunis (Tunisie), domicilié 60, avenue Henri Martin, F-75116 Paris, détenteur de
94 parts sociales;
- Marc BARBE, né le 08/09/1947 à Paris (France), domicilié 14, avenue Gourgaud, F-75017 Paris, détenteur de 94 parts
sociales;
- Luc LENGLET, né le 16/04/1964 à St Quentin (France), domicilié 8, rue Mathilde Girault, F-99300 Levallois Peret
ADGALE AG est donc désormais détenteur de 42 parts sociales.
DANDOIS & MEYNIAL
48, blvd G.-D. Charlotte
Signature
Référence de publication: 2008049575/2374/23.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2008, réf. LSO-CP01272. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080053930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 30.469.
Statuts coordonnés rectifiés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 19 mars 2008, référence
L080042292.04.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Joëlle BADEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008049265/7241/13.
(080048663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2008.
Macropus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 122.819.
<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 7 mars 2008i>
1) Monsieur Marcel STEPHANY a été confirmé dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le
pouvoir d'engager la société en toutes circonstances conjointement avec la signature d'un autre gérant.
2) Madame Adriana DE ALCANTARA a été confirmée dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec
le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
3) Le nombre de gérants a été augmenté de deux à quatre.
4) Monsieur Barry PORTER, né le 5 janvier 1962 à Hendon, Royaume-Uni, et demeurant à 22, Dove Park, WD3 5NY
Chorleywood, Hertfordshire, Royaume-Uni, a été nommé gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir d'engager
la société en toutes circonstances par sa seule signature.
5) Madame Marlies WEISE, née le 20 septembre 1953 à Potsdam, Allemagne, et demeurant à 9, Am Anger, D-14476
Potsdam, Allemagne, a été nommée gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir d'engager la société en toutes
circonstances conjointement avec la signature d'un autre gérant.
52514
Luxembourg, le 2 avril 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MACROPUS S.à r.l.
i>Adriana DE ALCANTARA
Référence de publication: 2008049579/8618/25.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02586. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Bluehouse Capital Advisors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 137.666.
STATUTES
In the year two thousand and eight , on the thirty-first day of March.
Before Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
IKEDJA LIMITED, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of Cyprus, with its registered
office at Pikioni 4, P.C. 3075, Limassol, Cyprus, represented by Mrs Marie LAMENSCH, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 28th March 2008.
2. CRANSTAL LIMITED, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of Cyprus, with its
registered office at Pikioni 4, P.C. 3075, Limassol, Cyprus, represented by Mrs Marie LAMENSCH, prenamed,
by virtue of a proxy given on 28th March 2008.
3. T2 BLUEHOUSE HOLDINGS LIMITED, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of
Cyprus, with its registered office at Pikioni 4, P.C. 3075, Limassol, Cyprus, represented by Mrs Marie LAMENSCH,
prenamed,
by virtue of a proxy given on 28th March 2008.
The proxies given, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary shall remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as here above stated, have requested the notary to state the following articles of
incorporation of a société à responsabilité limitée governed by the relevant laws and the present articles of incorporation.
<i>Definitionsi>
The following terms shall have the meaning as set out hereafter whenever used herein with initial capital letters:
"2002 Law" means the Luxembourg law dated 20 December 2002, relating to undertakings for collective investment,
as amended from time to time;
"2007 Law" means the Luxembourg law dated 13 February 2007, relating to specialised investment funds;
"Articles" means the present articles of incorporation;
"Business Day" means any day, other than a Saturday or Sunday, when banks in Luxembourg are open for the trans-
action of normal business;
"Euro" or "EUR" means the lawful currency of the European Union member States that have adopted the single
currency in accordance with the Treaty establishing the European Community as amended by the Treaty on European
Union and as amended by the Treaty of Amsterdam;
"Fund" means Bluehouse Accession Property III, an umbrella "fonds commun de placement - fonds d'investissement
spécialisé" governed by the 2007 Law;
"Management Company Board" means in case of plurality of Managers the board of Managers of the Management
Company;
"Management Regulations" means the management regulations of the Fund;
"Manager" means the manager or in case of plurality of managers, a manager appointed to the Management Company
Board in accordance with these Articles or as the case may be a member of the Management Company Board;
"Share(s)" means the shares issued by the Management Company and any share issued in exchange for those shares
or by way of conversion or reclassification, and any shares representing or deriving from those shares as a result of any
increases in or reorganization or variation of the capital of the Management Company; and
"Shareholder" means a holder of Shares.
52515
Title I. Name, Purpose, Duration, Registered Office
Art. 1. There is hereby formed by the present and all persons and entities who may become Shareholders in the future
a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "Bluehouse Capital Advisors S.à r.l." (he-
reinafter referred to as the "Management Company").
Art. 2. The exclusive purpose of the Management Company is the creation, administration and management of the
Fund.
The Management Company shall carry out any activities connected with the management, administration and promo-
tion of the Fund. It may, on behalf of the Fund, enter into any contract, purchase, sell, exchange and deliver any securities
or other permitted assets, proceed to any registrations and transfers in its name on behalf of the Fund and holders of
units of the Fund, all rights and privileges, especially all voting rights attached to the securities constituting the assets of
the Fund. The foregoing powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.
The Management Company may carry out any activities deemed useful for the accomplishment of its object, in ac-
cordance with chapter 14 of the 2002 Law.
Art. 3. The Management Company is formed for an unlimited duration.
Art. 4. The registered office of the Management Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Manager or in case of
plurality of Managers, by resolution of the Management Company Board, after having received Shareholders consent.
In the event that the Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, determines that
extraordinary political or military developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal
activities of the Management Company at its registered office, or with the ease of communication between such office
and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these
abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Management Company
which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office abroad, will remain a Luxembourg company.
Title II. Capital, Shares
Art. 5. The Management Company's capital is fixed at hundred twenty five thousand Euro (EUR 125,000.-) represented
by thousand (1,000) Shares of one hundred twenty five Euro (EUR 125.-) each.
The thousand (1,000) Shares have all been fully paid in cash.
The capital may be increased or reduced by a resolution of the single Shareholder or by resolution of the Shareholders
of the Management Company adopted in accordance with Article 20 hereof.
Shares will only be issued in registered form and will be inscribed in the register of Shares, which is held by the
Management Company or by one or more persons on behalf of the Management Company. Such register of Shares shall
set forth the name of each Shareholder, his residence or elected domicile, the number and class of Shares held by him.
In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the law of 10 August 1915, as amended from time to time, on commercial companies.
Title III. Shareholder meetings
Art. 6. Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Management Company shall represent the entire
body of Shareholders of the Management Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts
relating to the operations of the Management Company.
Art. 7. In case of a single Shareholder, the single Shareholder assumes all powers conferred to the Shareholders'
meeting. Any resolutions to be taken by the single Shareholder may be taken in writing.
In case of plurality of Shareholders, the provisions of Article 8 will apply to any resolution to be taken by a meeting of
Shareholders.
Each Share is entitled to one vote.
A Shareholder may be represented (at any meeting of Shareholders) by another person, which does not need to be a
Shareholder and which might be a Manager. The proxy established to this effect may be in writing or by cable, telegram,
facsimile or e-mail transmission.
Art. 8. If legally required or if not so required upon the decision of the Manager or in case of plurality of Managers,
the Management Company Board, annual general meetings of Shareholders of the Management Company shall be held,
in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Management Company, or such other
place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting. Such annual general meetings may be held abroad
if, in the judgement of the Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, exceptional
circumstances so require.
The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, may convene other meetings of
Shareholders to be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meetings.
52516
The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of Shareholders of
the Management Company, unless otherwise provided herein.
Except as otherwise required by law or provided herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly convened will
be passed by simple majority of those present and voting.
The general meeting of Shareholders shall be called by the Manager or in case of plurality of Managers, the Management
Company Board, by notices containing the agenda and which will be published as required by law.
The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, will prepare the agenda, except if
the meeting takes place due to the written request of Shareholders provided for by law; in such case the Manager or in
case of plurality of Managers, the Management Company Board, may prepare an additional agenda.
If all of the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
The matters dealt with by the meeting of Shareholders are limited to (i) the items contained in the agenda which must
contain all issues prescribed by law as well as to (ii) issues related thereto, except if all the Shareholders agree to another
agenda. In case the agenda should contain the nomination of Managers or of the auditor, the names of the eligible Managers
or of the auditors will be inserted in the agenda.
Title IV. Administration
Art. 9. The Management Company shall be managed by one or more Manager(s). If several Managers have been
appointed, they will constitute a Management Company Board.
The Manager(s) need not be Shareholders of the Management Company.
The Manager(s) shall be elected by the general meeting of Shareholders for a period as determined by such general
meeting of Shareholders and until their successors are elected and take up their functions. Upon expiry of its mandate,
a Manager may seek reappointment.
In case of plurality of managers and in the event of a vacancy in the office of a Manager because of death, retirement
or otherwise, the remaining Managers may meet and may elect, by majority vote, a Manager to fill such vacancy until the
next general meeting of Shareholders.
Art. 10. The Management Company Board shall choose from among its members a chairman.
The chairman shall preside at all meetings of the Management Company Board but in his absence or incapacity to act,
the Managers present may appoint anyone of their number to act as chairman for the purposes of the meeting.
The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board may also choose a secretary, who
need not be a Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Management Company
Board and of the Shareholders.
The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, may from time to time appoint
officers of the Management Company, including a managing director, a general manager and any assistant managers or
other officers considered necessary for the operation and management of the Management Company. Officers need not
to be Managers or Shareholders of the Management Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated herein,
shall have the powers and duties given to them by the manager or in case of plurality of managers, the Management
Company Board.
The Management Company Board shall meet upon call by the chairman, or any two Managers, at the place indicated
in the notice of meeting.
Written notice, containing an agenda which sets out any points of interest for the meeting, of any meeting of the
Management Company Board shall be given to all Managers at least 5 Business Days prior to the beginning of such meeting,
except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of
the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, facsimile or e-mail transmission of each
Manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the Management Company Board.
Any Manager may act at any meeting of the Management Company Board by appointing, in writing or by telegram,
facsimile or e-mail transmission, another Manager as his proxy.
Any Manager who is not physically present at the location of a meeting may participate in such a meeting of the
Management Company Board by remote conference facility or similar means of communication equipment, whereby all
persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.
The Management Company Board can deliberate or act validly only if at least two Managers are present or represented
at a meeting of the Management Company Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Managers
present or represented.
Resolutions signed by all Managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such
signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letters,
telegrams, facsimile or e-mail transmissions.
52517
The minutes of any meeting of the Management Company Board shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the chairman pro tempore who presided at such meeting or by any two Managers.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by
the chairman or by any two Managers or by a Manager together with the secretary or the alternate secretary.
Art. 11. The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, shall have power to
determine the course and conduct of the management and business affairs of the Management Company.
It is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the interests of the
Management Company. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of Share-
holders fall within the competence of the Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board.
Art. 12. The Management Company shall be bound by the sole signature of its single Manager, or in case of plurality
of Managers, by the joint signature of any two Managers of the Management Company, or by the individual signature of
the managing director or by the individual signature of an officer or any person(s) to whom such signatory authority has
been delegated by the Manager or in case of plurality of Managers, by the Management Company Board.
Art. 13. The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, may delegate its powers
to conduct the daily management and affairs of the Management Company, including the right to sign on behalf of the
Company, and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to officers of the Mana-
gement Company or to other persons, which at their turn may delegate their powers if they are authorised to do so by
the Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board.
Art. 14. No contract or other transaction which the Management Company and any other company or firm might
enter into shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or officers of the Management
Company is interested in such other company or firm by a relation, or is a director, officer or employee of such other
company or legal entity, provided that the Management Company obliges itself to never knowingly sell or lend assets of
UCIs it manages to any of its directors or officers or any company or firm controlled by them.
In the event that any Manager or officer of the Management Company may have any personal interest in any contract
or transaction of the Management Company other than that arising out of the fact that he is a Manager, officer or employee
or holder of securities or other interests in the counterparty, such manager or officer shall, in case of plurality of managers,
make known to the Management Company Board such personal interest and shall not consider or vote upon any such
contract or transaction. Such contract or transaction, and such Manager's or officer's personal interest therein, shall be
reported to the next succeeding meeting of Shareholders.
Art. 15. The Management Company may indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators,
against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made
a party by reason of his being or having been a Manager or officer of the Management Company or, at its request, of any
other company of which the Management Company is a unitholder or a creditor and which he is not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Management Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.
Title V. Accounting, Distributions
Art. 16. The operations of the Management Company and its financial situation as well as its books shall be supervised
by one or more auditor(s) qualifying as reviseur d'enterprises agréé(s). The auditor(s) shall be elected by the Shareholders
at the annual general meeting of Shareholders for a period which shall end on the day of the following annual general
meeting of Shareholders which decides upon the appointment of its (their) successor(s).
Art. 17. The accounting year of the Management Company shall begin on 1st January and shall terminate on 31 De-
cember of each year.
Art. 18. From the annual net profit of the Management Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve
required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the capital of the Management Company as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to
time in accordance with Article 5 hereof.
The general meeting of Shareholders shall decide each year how the remainder of the annual net profit shall be allocated
and may declare dividends from time to time or instruct the manager or in case of plurality of managers, the Management
Company Board, to do so.
The manager or in case of plurality of managers, the Management Company Board, may within the conditions set out
by law unanimously resolve to pay out interim dividends.
52518
Title VII. Winding up, Liquidation
Art. 19. In the event of a winding-up of the Management Company, the liquidation shall be carried out by one or several
liquidators. Liquidators may be physical persons or legal entities and are named by the meeting of Shareholders deciding
such winding-up and which shall determine their powers and their compensation.
Title VIII. Amendments
Art. 20. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to
the respect of the quorum and majority requirements provided by Luxembourg law.
Art. 21. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915, as amended from time to time, on commercial companies, and the 2002 Law.
<i>Transitory dispositioni>
The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Management Company and shall terminate
on 31 December 2008.
The first audited annual accounts of the Management Company will be prepared in respect of such first financial year.
<i>Subscription and Paymenti>
The capital of the Management Company is subscribed as follows:
- IKEDJA LIMITED, previously named, subscribes for two hundred and fifty (250) Shares resulting in a total payment
of thirty one thousand two hundred and fifty euros (EUR 31,250.-);
- CRANSTAL previously named, subscribes for two hundred and fifty (250) Shares resulting in a total payment of thirty
one thousand two hundred and fifty euros (EUR 31,250.-);
- T2 BLUEHOUSE HOLDINGS LIMITED, previously named subscribes for five hundred (500) Shares resulting in a
total payment of sixty-two thousand five hundred euros (EUR 62,500.-);
Evidence of the above payments, resulting in a total payment of one hundred and twenty five thousand Euros (EUR
125,000.-) was given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses which shall be borne by the Management Company as a result of its incorporation are estimated at
approximately five thousand Euro.
<i>General Meeting of Shareholdersi>
The above named persons representing the entire subscribed capital and exercising the powers devolved to the meet-
ing, passed the following resolutions:
(i) The following are elected as Managers for a term to expire at the close of the annual general meeting of Shareholders
which shall deliberate on the annual accounts as at 31 December 2008:
- Mr Victor Pisante, 32 Voukourestiou Str., 106 71 Athens, Greece;
- Mr Babis Pandis, 32 Voukourestiou Str., 106 71 Athens, Greece;
- Mr Yannis Delikanakis, 32 Voukourestiou Str., 106 71 Athens, Greece.
(ii) The following is elected as independent auditor for a term to expire at the close of the annual general meeting of
Shareholders which shall deliberate on the annual accounts as at 31 December 2008: PricewaterhouseCoopers S.à r.l.,
400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Grand Duchy of Luxembourg.
(iii) The registered office of the Management Company is set at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named
persons, this deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing persons, in
case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by names, surnames, status and resi-
dence, the person appearing signed together with the notary the present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendhundacht, am einunddreißigsten März.
Vor Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.
Erschienen die folgenden Personen:
IKEDJA LIMITED, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zypriotischen Rechts mit Sitz in Pikioni 4, P.C. 3075,
Limassol, Zypern, vertreten durch Frau Marie LAMENSCH, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund einer am
28. März 2008 1. erteilten Vollmacht.
52519
2. CRANSTAL LIMITED, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zypriotischen Rechts mit Sitz in Pikioni 4, P.C.
3075, Limassol, Zypern, vertreten durch Frau Marie LAMENSCH, vorgenannt, aufgrund einer am 28. März 2008 erteilten
Vollmacht.
3. T2 BLUEHOUSE HOLDINGS LIMITED, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zypriotischen Rechts, mit Sitz
in Pikioni 4, P.C. 3075, Limassol, Zypern, vertreten durch Frau Marie LAMENSCH, vorgenannt, aufgrund einer am 28.
März 2008 erteilten Vollmacht.
Die von den Erschienenen und dem unterzeichnenden Notar "ne varietur" gezeichneten Vollmachten bleiben dieser
Urkunde beigefügt und sind zusammen mit dieser bei den zuständigen Registerstellen einzureichen.
Die wie vorstehend beschrieben vertretenen Erschienenen haben den Notar gebeten, die nachstehende Satzung (ar-
ticles of incorporation) einer den einschlägigen Gesetzen sowie den Bestimmungen dieser Satzung unterliegenden
Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu Protokoll zu nehmen.
<i>Definitioneni>
Die folgenden Begriffe haben, wenn sie mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben sind, die ihnen jeweils zugeordnete
Bedeutung:
"Gesetz von 2002" ist das luxemburgische Gesetz vom 20. Dezember 2002 bezüglich Organismen für gemeinsame
Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung.
"Gesetz von 2007" ist das luxemburgische Gesetz vom 13. Februar 2007 bezüglich spezialisierte Investmentfonds in
seiner jeweils geltenden Fassung.
"Satzung" ist die vorliegende Satzung;
"Geschäftstag" ist jeder Tag, außer Samstag und Sonntag, an dem die Banken in Luxemburg für die üblichen Geschäfte
geöffnet sind.
"Euro" oder "EUR" ist die gesetzliche Währung derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die gemäß dem
Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft, geändert durch den Vertrag über die Europäische Union und
den Vertrag von Amsterdam, die gemeinsame Währung eingeführt haben.
"Fonds" ist der Bluehouse Accession Property III Fonds, ein umbrella "fonds commun de placement - fonds d'inves-
tissement spécialisé" gemäß dem Gesetz von 2007.
"Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft" ist, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der
Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft.
"Verwaltungsreglement" sind die Verwaltungsreglements, des Fonds .
"Geschäftsführer" ist der Geschäftsführer, oder sofern mehrere bestellt sind, einer der gemäß dieser Satzung zum
Mitglied des Rates der Geschäftsführung bestellten Geschäftsführer bzw. ein Mitglied des Rates der Geschäftsführung.
"Gesellschaftsanteil(e)" sind die von der Verwaltungsgesellschaft ausgegebenen Anteile sowie im Tausch gegen solche
Anteile oder aufgrund einer Umwandlung oder Reklassifizierung ausgegebene Anteile sowie Anteile, die aufgrund von
Kapitalerhöhungen, Umwandlungen oder Reklassifizierung für diese Anteile stehen oder aus ihnen hervorgehen.
"Gesellschafter" ist ein Inhaber von Anteilen.
Abschnitt I. Name, Zweck, Dauer, Sitz
Art. 1. Hiermit wird durch die gegenwärtigen und künftigen Gesellschafter eine Gesellschaft in der Rechtsform einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Namen "Bluehouse Capital Advisors S.à
r.l." (nachstehend "Verwaltungsgesellschaft" genannt) gegründet.
Art. 2. Der ausschließliche Zweck der Verwaltungsgesellschaft ist die Gründung, Verwaltung und die Führung des
Fonds.
Die Verwaltungsgesellschaft wird sämtliche mit der Geschäftsführung, Verwaltung und Vermarktung des Fonds ver-
bundenen Tätigkeiten durchführen. Sie kann im Namen des Fonds Verträge schließen, Wertpapiere oder andere zulässige
Vermögenswerte erwerben, veräußern, tauschen und übergeben, kann im Namen des Fonds und der Anteilinhaber des
Fonds Eintragungen und Übertragungen vornehmen lassen und deren Rechte und Vorrechte ausüben, wie insbesondere
die Ausübung von mit den Wertpapieren, die die Vermögenswerte des Fonds bilden, verbundenen Stimmrechten. Die
vorstehende Aufzählung ist nicht als abschließend, sondern als beispielhaft anzusehen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann sämtliche Tätigkeiten ausüben, die sie für die Erfüllung ihres Zwecks als nützlich
erachtet und die im Einklang mit Kapitel 14 des Gesetzes von 2002 stehen.
Art. 3. Die Verwaltungsgesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Der Sitz der Verwaltungsgesellschaft ist in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Niederlassungen oder
Büros können aufgrund eines Beschlusses des Geschäftsführers oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, auf-
grund eines Beschlusses des Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft gegründet werden, wobei solche
Beschlussfassungen unter dem Vorbehalt der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gesellschafter stehen.
Für den Fall, dass ein Geschäftsführer, oder sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung
der Verwaltungsgesellschaft befindet, dass außergewöhnliche politische oder militärische Umstände eingetreten sind oder
52520
unmittelbar bevorstehen, die die üblichen Tätigkeiten der Verwaltungsgesellschaft an ihrem Sitz stören oder die Kom-
munikation zwischen dem Sitz und im Ausland ansässigen Personen erschweren könnten, kann der Sitz vorübergehend
solange ins Ausland verlagert werden, bis die außergewöhnlichen Umstände nicht mehr vorherrschen. Solche vorüber-
gehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden
Verlagerung ihres Sitzes ins Ausland, eine Gesellschaft nach luxemburgischem Recht bleibt.
Abschnitt II. Kapital, Gesellschaftsanteile
Art. 5. Das Kapital der Verwaltungsgesellschaft ist auf einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) fest-
gelegt und in eintausend (1.000) Gesellschaftsanteile mit einem Wert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) je
Anteil aufgeteilt.
Die tausend (1.000) Gesellschaftsanteile sind vollständig eingezahlt.
Das Kapital kann aufgrund eines gemäß Artikel 20 dieser Satzung getroffenen Beschlusses des Alleingesellschafters
oder der Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft erhöht oder herabgesetzt werden.
Gesellschaftsanteile werden nur als Namensanteile ausgegeben und sind ins Anteilsregister einzutragen, das von der
Verwaltungsgesellschaft oder von einer oder mehreren Personen im Namen der Verwaltungsgesellschaft geführt wird. In
diesem Anteilsregister wird der Name des Gesellschafters, sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort, die Nummer
und die Klasse der von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile vermerkt.
Sofern die Verwaltungsgesellschaft einen Alleingesellschafter hat, sind die von dem Alleingesellschafter gehaltenen
Gesellschaftsanteile frei übertragbar.
Sofern die Verwaltungsgesellschaft mehrere Gesellschafter hat, können die von jedem Gesellschafter gehaltenen Ge-
sellschaftsanteile gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaf-
ten in seiner jeweils geltenden Fassung übertragen werden.
Abschnitt III. Gesellschafterversammlungen
Art. 6. Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft gilt als Vertre-
tung sämtlicher Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft. Sie verfügt über größtmögliche Befugnisse, mit der Geschäfts-
tätigkeit der Verwaltungsgesellschaft verbundene Handlungen anzuordnen, durchzuführen oder zu bewilligen.
Art. 7. Sofern die Verwaltungsgesellschaft einen Alleingesellschafter hat, stehen diesem sämtliche, der Gesellschafter-
versammlung übertragenen Befugnisse zu. Von dem Alleingesellschafter zu fassende Beschlüsse können schriftlich gefasst
werden.
Sofern die Verwaltungsgesellschaft mehrere Gesellschafter hat, gelten die Bestimmungen von Artikel 8 für sämtliche,
von einer Gesellschafterversammlung zu fassenden Beschlüsse.
Jeder Geschäftsanteil gewährt eine Stimme.
Ein Gesellschafter kann sich (auf Gesellschafterversammlungen) von einer anderen Person vertreten lassen, die kein
Gesellschafter sein muss und ein Geschäftsführer sein kann. Eine zu diesem Zweck gewährte Vollmacht kann schriftlich,
per Telegramm, per Fernschreiben, per Fax oder E-Mail erteilt werden.
Art. 8. Sofern kraft Gesetz erforderlich oder, andernfalls, aufgrund einer Entscheidung des Geschäftsführers oder,
sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, des Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft, werden die
jährlichen Gesellschafterversammlungen der Verwaltungsgesellschaft gemäß luxemburgischem Recht am Sitz der Ver-
waltungsgesellschaft in Luxemburg oder einem anderen, in der Einladung zur Versammlung genannten Ort abgehalten.
Solche jährlichen Gesellschafterversammlungen können im Ausland abgehalten werden, wenn der Geschäftsführer, oder,
sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft dies aufgrund
des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände für erforderlich hält.
Der Geschäftsführer, oder sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwal-
tungsgesellschaft, können weitere Gesellschafterversammlungen einberufen, die an den in den jeweiligen Einladungen
genannten Orten und zu den darin ebenfalls genannten Zeiten abgehalten werden.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in dieser Satzung gelten im Hinblick auf die Fristen für Einladungen zu
Gesellschafterversammlungen und deren Beschlussfähigkeit die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.
Vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen oder Bestimmungen dieser Satzung sind auf einer ordnungs-
gemäß einberufenen Gesellschafterversammlung zu fassende Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der anwesenden und
sich an der jeweiligen Abstimmung beteiligenden Gesellschafter zu fassen.
Die jährlichen Gesellschafterversammlungen sind von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer
bestellt sind, vom Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft durch Versendung von Einladungen einzuberufen,
die die Tagesordnung enthalten und die gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu veröffentlichen sind.
Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwal-
tungsgesellschaft wird die Tagesordnung erstellen, es sei denn, eine Versammlung findet auf schriftliches Verlangen der
Gesellschafter gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen statt; in einem solchen Fall kann der Geschäftsführer,
oder, sofern mehrere Gesellschafter bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft eine weitere
Tagesordnung erstellen.
52521
Sofern bei einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie
über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann eine Versammlung ohne vorherige Einladung oder
Veröffentlichung abgehalten werden.
Die Angelegenheiten, die von einer Gesellschafterversammlung behandelt werden, sind zu beschränken auf (i) die in
der Tagesordnung genannten Punkte, wobei alle gesetzlich vorgeschriebenen Punkte zu behandeln sind, sowie (ii) alle
damit zusammenhängenden Angelegenheiten, es sei denn, alle Gesellschafter einigen sich auf eine andere Tagesordnung.
Sofern die Bestellung von Geschäftsführern oder eines Abschlussprüfers auf der Tagesordnung steht, sind die Namen der
zur Wahl stehenden Geschäftsführer, oder Abschlussprüfer in die Tagesordnung aufzunehmen.
Abschnitt IV. Verwaltung
Art. 9. Die Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft werden von einem oder mehreren Geschäftsführern geführt. Sofern
mehrere Geschäftsführer bestellt sind, bilden sie einen Rat der Geschäftsführung.
Der bzw. die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft sein.
Der bzw. die Geschäftsführer werden von der jährlichen Gesellschafterversammlung für einen von dieser bestimmten
Zeitraum gewählt, bis ihre Nachfolger gewählt sind und ihr Amt übernehmen. Nach Ablauf seiner Amtszeit kann sich ein
Geschäftsführer wieder zur Wahl stellen.
Sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, sowie für den Fall, dass der Posten eines Geschäftsführers aufgrund des
Todes, der Eintritts in den Ruhestand eines Geschäftsführers oder aus anderen Gründen vakant wird, können sich die
verbleibenden Geschäftsführer versammeln und mit einfacher Mehrheit einen Geschäftsführer wählen, der eine solche
Vakanz bis zur nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung ausfüllt.
Art. 10. Der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ernennt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden.
Der Vorsitzende führt den Vorsitz sämtlicher Gesellschafterversammlungen der Verwaltungsgesellschaft. Sofern der
Vorsitzende bei einer Versammlung abwesend oder nicht handlungsfähig ist, können die Geschäftsführer aus ihrer Mitte
einen Vorsitzenden für die Zwecke der jeweiligen Versammlung ernennen.
Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwal-
tungsgesellschaft kann einen Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer sein muss und für die Führung des Protokolls
von Versammlungen des Rates der Geschäftsführung und von Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.
Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwal-
tungsgesellschaft kann jeweils Bevollmächtigte ("Officers") der Gesellschaft ernennen, einschließlich eines Managing
Directors, eines General Managers, eines Assistant Managers oder sonstiger Bevollmächtigte, die im Hinblick auf den
Betrieb und die Verwaltung der Verwaltungsgesellschaft für erforderlich gehalten werden. Bevollmächtigte müssen keine
Geschäftsführer, oder Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft sein. Die ernannten Bevollmächtigte haben die ihnen
von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat der Geschäftsführung der Ver-
waltungsgesellschaft zugewiesenen Befugnisse und Pflichten.
Der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern an dem in der jeweiligen Einladung genannten Ort.
Sämtlichen Geschäftsführern ist mindestens fünf Tage vor Beginn einer solchen Versammlung eine schriftliche Einladung
zusammen mit einer Tagesordnung zu übermitteln, in der sämtliche Geschäftsordnungspunkte aufgeführt sind. Von dieser
Frist kann in dringenden Ausnahmefällen abgewichen werden, in denen die näheren Umstände in der Einladung auszu-
führen sind. Auf eine Einladung kann verzichtet werden, sofern sämtliche Geschäftsführer einer solchen Verfahrensweise
schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zustimmen. Für einzelne Versammlungen, deren Zeit und Ort vorab durch
Gesellschafterbeschluss festgelegt worden sind, ist keine weitere Einladung erforderlich.
Geschäftsführer können sich bei Versammlungen des Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft vertre-
ten lassen, indem sie einen anderen Geschäftsführer schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zu ihrem Vertreter
ernennen.
Geschäftsführer, die an einem Versammlungsort nicht physisch anwesend sind, können an einer Versammlung des
Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft per Konferenzschaltung oder auf einem ähnlichen Kommunika-
tionsweg teilnehmen, wobei sich alle Teilnehmer einer solchen Versammlung gegenseitig hören können müssen, und eine
Teilnahme an einer solchen Versammlung kommt einer persönlichen Teilnahme gleich.
Eine Versammlung der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft kann nur wirksam beraten und handeln, wenn
mindestens zwei Geschäftsführer bei einer Versammlung des Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft
anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse sind mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer
zu fassen.
Von sämtlichen Geschäftsführern unterzeichnete Beschlüsse sind genauso gültig und wirksam wie bei einer ordnungs-
gemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können auf einem
einzigen Dokument oder auf mehreren Ausfertigungen eines Beschlusses gezeichnet sein und können per Brief, Tele-
gramm, Fax oder E-Mail erfolgen.
52522
Das Protokoll von Versammlungen der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft ist von dem Vorsitzenden oder,
sofern dieser abwesend ist, von dem stellvertretenden, nur für die jeweilige Versammlung ernannten Vorsitzenden oder
von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.
Kopien von oder Auszüge aus solchen Protokollen, die gegebenenfalls in Gerichtsverfahren oder bei anderen Gele-
genheiten vorgelegt werden, sind von dem Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einem Geschäftsführer
gemeinsam mit dem Sekretär oder dem stellvertretenden Sekretär zu unterzeichnen.
Art. 11. Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der
Verwaltungsgesellschaft ist befugt, die Richtung und Art der Geschäftsführung und der Geschäfte der Verwaltungsgesell-
schaft festzulegen.
Der Geschäftsführer bzw. der Rat der Geschäftsführung ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um
sämtliche im Interesse der Verwaltungsgesellschaft stehenden Verwaltungshandlungen und -verfügungen vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die nicht kraft Gesetzes oder gemäß dieser Satzung ausdrücklich der jährlichen Gesellschafterver-
sammlung zugewiesen sind, werden vom Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat
der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ausgeübt.
Art. 12. Die Verwaltungsgesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers verpflichtet
oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestet sind, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern der
Verwaltungsgesellschaft, oder durch die alleinige Unterschrift des Managing Directors oder eines Bevollmächtigten oder
einer Person oder mehrerer Personen, auf die ein solches Zeichnungsrecht durch den Geschäftsführer, oder, sofern
mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch den Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft übertragen wor-
den ist.
Art. 13. Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der
Verwaltungsgesellschaft kann seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft, ein-
schließlich des Rechts, für die Gesellschaft zu zeichnen, sowie seine Befugnisse, Handlungen zur Förderung der Unter-
nehmenspolitik und des Gesellschaftszwecks vorzunehmen, an Bevollmächtigte der Verwaltungsgesellschaft oder andere
Personen übertragen, die wiederum berechtigt sind, Untervollmachten zu erteilen, sofern sie von dem Geschäftsführer,
oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft hierzu
ermächtigt worden sind.
Art. 14. Verträge oder andere Transaktionen der Verwaltungsgesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder einem
anderen Unternehmen bleiben unberührt und werden nicht unwirksam, wenn ein oder mehrere der Geschäftsführer
oder Bevollmächtigte der Verwaltungsgesellschaft aufgrund persönlicher Beziehungen ein Interesse an dieser anderen
Gesellschaft oder diesem anderen Unternehmen hat oder haben oder dort Geschäftsführer oder Bevollmächtigter oder
Mitarbeiter ist oder sind, sofern sich die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, nicht wissentlich Vermögenswerte des
Organismus für gemeinsame Anlagen, den sie verwaltet, an ihre Geschäftsführer oder Bevollmächtigte oder von diesen
beherrschte Gesellschaften oder Unternehmen zu verkaufen oder zu verleihen.
Falls ein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Verwaltungsgesellschaft möglicherweise aus anderen Gründen als
aufgrund des Umstands, dass er Geschäftsführer, Bevollmächtigte, Mitarbeiter oder Inhaber von Wertpapieren oder
sonstigen Beteiligungen des anderen Unternehmens ist, ein persönliches Interesse an einem Vertrag oder einer Trans-
aktion der Verwaltungsgesellschaft hat, wird der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte, oder, sofern mehrere Geschäfts-
führer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft von diesem persönlichen Interesse in
Kenntnis setzen und von einer Beteiligung an Beschlussfassungen hinsichtlich eines solchen Vertrags oder einer solchen
Transaktion absehen. Die jeweils nächste Gesellschafterversammlung ist von einem solchen Vertrag oder einer solchen
Transaktion und dem persönlichen Interesse des betreffenden Geschäftsführers oder Bevollmächtigten zu unterrichten.
Art. 15. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Geschäftsführer oder, seine Erben, Testamentsvollstrecker oder
Nachlassverwalter für angemessene Kosten schadlos halten, die diesem oder diesen in Zusammenhang mit einem An-
spruch, einer Klage oder einem Verfahren entstanden sind, die möglicherweise auf der jetzigen oder früheren Tätigkeit
des Betreffenden als Geschäftsführer oder Bevollmächtigte für die Verwaltungsgesellschaft oder für eine andere Gesell-
schaft beruhen, sofern dies verlangt wird, deren Anteilinhaber oder Gläubiger die Verwaltungsgesellschaft ist, wenn der
Betreffende insoweit keinen anderen Schadloshaltungsanspruch hat; dies gilt nicht, wenn der Geschäftsführer oder Be-
vollmächtigte wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird; wird ein Vergleich geschlossen,
erfolgt die Schadloshaltung nur bezüglich solcher vom Vergleich erfassten Punkte, bezüglich derer- laut Auskunft des
Rechtsberaters gegenüber der Verwaltungsgesellschaft - keine Pflichtverletzung der schadlos zu haltenden Person vorliegt.
Das vorstehende Recht auf Schadloshaltung schließt andere, dem Geschäftsführer oder Bevollmächtigte möglicherweise
zustehende Rechte nicht aus.
Abschnitt V. Buchhaltung, Ausschüttung von Dividenden
Art. 16. Die Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft, ihre finanzielle Situation sowie ihre Bücher werden von einem
(oder mehreren) Abschlussprüfer(n) überwacht, bei denen es sich um reviseur d'enterprises agréé(s) handelt. Der Ab-
schlussprüfer (oder die Abschlussprüfer) wird von den Gesellschaftern bei der jährlichen Gesellschafterversammlung für
52523
einen Zeitraum bestimmt, der am Tage der nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung endet, an dem über die Be-
stellung des Nachfolgers oder der Nachfolger entschieden wird.
Art. 17. Das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden
Jahres.
Art. 18. Von dem Jahresüberschuss der Verwaltungsgesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die gesetzlich vorge-
schriebenen Reserven eingestellt. Diese Zuführung von Geldern endet, sobald und solange die Reserven bei zehn Prozent
(10 %) des Kapitals der Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 5 dieser Satzung oder dem gegebenenfalls gemäß Artikel
5 dieser Satzung herauf- oder herabgesetzten Betrag liegen.
Die Gesellschafterversammlung beschließt jährlich über die Verwendung des Jahresüberschusses; sie kann ggf. Divid-
enden festsetzen oder den Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, den Rat der Geschäfts-
führung der Verwaltungsgesellschaft anweisen, dies zu tun.
Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwal-
tungsgesellschaft kann im gesetzlich vorgesehenen Rahmen einstimmig die Ausschüttung von Interimdividenden beschlie-
ßen.
Abschnitt VII. Auflösung, Liquidation
Art. 19. Im Falle einer Auflösung der Verwaltungsgesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liqui-
datoren. Bei den Liquidatoren kann es sich um natürliche oder juristische Personen handeln, die von der Gesellschafter-
versammlung bestellt werden, die über die Auflösung entscheidet und die Befugnisse und die Vergütung der Liquidatoren
bestimmt.
Abschnitt VIII. Änderungen
Art. 20. Diese Satzung kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung geändert werden, wenn diese beschlussfähig
ist und die nach luxemburgischem Recht erforderlichen Mehrheiten erreicht werden.
Art. 21. Alle Fragen, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, sind gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung und dem Gesetz von 2002 zu behandeln.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Verwaltungsgesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.
Der erste geprüfte Jahresbericht der Verwaltungsgesellschaft wird im Hinblick auf dieses erste Geschäftsjahr erstellt.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Das Kapital der Verwaltungsgesellschaft wird folgendermaßen gezeichnet:
- IKEDJA LIMITED, zeichnet zweihundertfünfzig (250) Geschäftsanteile, woraus sich eine Zahlung von einunddreißig-
tausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 31.250,-) ergibt.
- CRANSTAL LIMITED, zeichnet zweihundertundfünfzig (250) Geschäftsanteile, woraus sich eine Zahlung von ein-
unddreißigtausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 31.250,-) ergibt.
- T2 BLUEHOUSE HOLDINGS LIMITED, zeichnet fünfhundert (500) Geschäftsanteile, woraus sich eine Zahlung von
zweiundsechzigtausendfünfhundert Euro (EUR 62.500,-) ergibt.
Der Nachweis über die Zahlungen, die in ihrer Summe einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) er-
geben, wurde gegenüber dem unterzeichnenden Notar erbracht.
<i>Kosteni>
Die von der Verwaltungsgesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf
schätzungsweise fünftausend Euro (EUR 5.000,-).
<i>Gesellschafterversammlungi>
Als Inhaber des gesamten gezeichneten Kapitals der Gesellschaft fassen die oben genannten Personen in Ausübung der
der Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse die folgenden Beschlüsse:
(i) Die folgenden Personen werden für die Dauer eines Zeitraums bis zum Ende der jährlichen Gesellschafterver-
sammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 berät, als Geschäftsführer bestellt:
- Herr Viktor Pisante, 32 Voukourestiou Str., 10671 Athen, Griechenland;
- Herr Babis Pandis, 32 Voukourestiou Str., 10671 Athen, Griechenland;
- Herr Yannis Delikanakis, 32 Voukourestiou Str., 10671 Athen, Griechenland; ,
(ii) Als unabhängiger Abschlussprüfer wird für die Dauer eines Zeitraums bis zum Ende der jährlichen Gesellschafter-
versammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 berät, PricewaterhouseCoopers S.à r.l, 400, route
d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
(iii) Der Sitz der Verwaltungsgesellschaft befindet sich in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg.
52524
Der unterzeichnende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der vorstehend
genannten Personen die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung;
auf Wunsch der vorstehend genannten Personen ist bei Widersprüchen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung die englische Fassung maßgebend.
Daraufhin wurde der vorstehende Akt in Luxemburg zu dem oben genannten Datum notariell beurkundet.
Nachdem der Text der Erschienenen vorgelesen wurde, deren Vor- und Nachname, Status und Wohnsitz dem Notar
bekannt sind, wurde die vorliegende Urkunde im Original von der Erschienenen gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: M. LAMENSCH, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 2. April 2008. Relation: EAC/2008/4500. - Erhalten sechshundertfünfundzwanzig
Euro (125.000.- zu 0,5 % = 625,- EUR).
<i>Der Einnehmer (i>
gezeichnet): SANTIONI.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Ge-
sellschaften und Vereinigungen.
Beles, den 07. APRIL 2008.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2008050057/239/558.
(080054622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2008.
Welbeck Street Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 113.246.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02/04/08.
TMF Secretarial Services S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008049716/805/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2008, réf. LSO-CP02994. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Sopisa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 107.286.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
11.04.2008.
Äert Sekretariat S.à.r.l.
10a, rue de l'Alzette - L-3396 Roeser
Signature
Référence de publication: 2008049741/1972/15.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08562. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Armstripe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 122.826.
<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 7 mars 2008i>
1) Monsieur Marcel STEPHANY a été confirmé dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le
pouvoir d'engager la société en toutes circonstances conjointement avec la signature d'un autre gérant.
2) Madame Adriana DE ALCANTARA a été confirmée dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec
le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
52525
3) Monsieur Barry PORTER a été confirmé dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir
d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
4) Madame Marlies WEISE a été confirmée dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir
d'engager la société en toutes circonstances conjointement avec la signature d'un autre gérant.
Luxembourg, le 2 avril 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ARMSTRIPE S.à r.l.
i>Adriana DE ALCANTARA
Référence de publication: 2008049582/8615/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02582. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080054046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Octopussy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 107.900.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 2008.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008049724/3560/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2008, réf. LSO-CP02053. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Meca S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, 2, Zone Industrielle Scheleck.
R.C.S. Luxembourg B 117.505.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 2008.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008049725/3560/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2008, réf. LSO-CP02051. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
M.M. Warburg & Co Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 17.881.
In der ordentlichen Generalversammlung vom 28. September 2007 wurden die Mandate nachfolgender Verwaltungs-
ratsmitglieder um weitere 6 Jahre verlängert:
Herr Bernhard Kuhn, 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg
Herr Peter Johannsen, 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg
Herr Dr. David Lohmann, 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg
52526
Die Mandate enden mit der im Jahre 2013 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung, die über den Jahresabs-
chluss per 30.06.2013 befindet.
Ebenfalls wurde in der ordentlichen Generalversammlung vom 28. September 2007 beschlossen, dass das Mandat des
Rechnungskommissars
Frau Inge Ehrles-Meirer, Moselstrasse, 8, D-54341 Fell-Fastrau
um weitere 6 Jahre verlängert wird. Das Mandat endet mit der im Jahre 2013 stattfindenden ordentlichen General-
versammlung, die über den Jahresabschluss per 30.06.2013 befindet.
Luxembourg, den 8. Januar 2008.
M.M. Warburg & Co Holding S.A., Société Anonyme
Unterschriften
Référence de publication: 2008049231/1/24.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05044. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080045219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.
Systemgastronomie K. Kiermeier G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 90.970.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008049721/534/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01773. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Telecom Italia Capital, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 77.970.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée des actionnaires qui a été tenue le 5 mars 2008i>
Il résulte du verbale de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a été tenue au siège social à Luxembourg
le 5 mars 2008 que:
L'Assemblée prend acte de la démission de M. Brimeyer en tant que Commissaire aux Comptes et nomme Ernst &
Young S.A. en tant que Reviseur d'Entreprises de la Société pour les exercices 2008/2009.
<i>Telecom Italia Capital, Société Anonyme
i>Adriano TRAPLETTI
<i>Managing Directori>
Référence de publication: 2008049811/1812/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2008, réf. LSO-CP02171. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
SigmaKalon Luxco, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 90.056.
RECTIFICATIF
L'an deux mille huit, le douze mars,
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Mademoiselle Armony Allamanno, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
52527
Laquelle comparante, ayant agi comme représentant du gérant unique de SigmaKalon Luxco S.C.A. (la "Société") une
société en commandite par actions ayant son siège social au 9A, Parc d'Activité Syrdall, Unit 8, L-5365 Münsbach, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 90.056, suivant une résolution du
gérant unique de la Société en date du 10 janvier 2008, a requis le notaire instrumentant d'acter qu'une erreur matérielle
s'est glissée dans l'acte du 11 janvier 2008 et qu'aux points 2 et 4 de l'acte relatifs à la constatation d'augmentation de
capital suite à une résolution du gérant unique de la Société en date du 10 janvier 2008, il y a lieu de lire que le gérant
unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de mille huit cent quatre-vingt-dix euros (EUR
1.890,-) afin de le porter de sa valeur actuelle de soixante-huit mille quatre-vingt-trois euros soixante-quinze cents (EUR
68.083,75) à soixante-neuf mille neuf cent soixante-treize euros soixante-quinze cents (EUR 69.973,75) par la conversion
de mille cinq cent douze (1.512) CPECs de Série 1 en mille cinq cent douze (1.512) Actions Ordinaires de Classe A.
Par conséquent, l'article 6.1 des statuts est à modifier comme suit:
Dans sa version anglaise:
" 6.1. Subscribed Capital. The Company has a subscribed capital of EUR 69,973.75 (sixty-nine thousand nine hundred
seventy-three euro seventy-five cents) represented by 23,873 (twenty-three thousand eight hundred seventy-three) Class
A Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, by 9,579 (nine thousand five
hundred seventy-nine) Class B Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, by
9,611 (nine thousand six hundred eleven) Class C Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents
(EUR 1.25) each, by 9,627 (nine thousand six hundred twenty-seven) Class D Ordinary Shares with a par value of one
euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, by 1,095 (one thousand ninety-five) Class F Ordinary Shares with a par value
of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, by 1,095 (one thousand ninety-five) Class G Ordinary Shares with a
par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, by 1,080 (one thousand eighty) Class H Ordinary Shares
with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, and by 19 (nineteen) Management Shares with a par
value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required for amendment of these articles of incorporation (the "Articles").
The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.
All shares shall vote together and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders of any
separate class of shares shall not be entitled to vote separately on any matter. No shares of any class shall be entitled to
any pre-emptive rights with respect to any shares of the Company, except as may be required by law."
Dans sa version française:
" 6.1. Capital souscrit. La Société a un capital souscrit de EUR 69.973,75 (soixante-neuf mille neuf cent soixante-treize
euros soixante-quinze cents) représenté par 23.873 (vingt-trois mille huit cent soixante-treize) Actions Ordinaires de
Classe A avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, par 9.579 (neuf mille cinq cent soixante
dix-neuf) Actions Ordinaires de Classe B ayant une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, par
9.611 (neuf mille six cent onze) Actions Ordinaires de Classe C avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR
1,25) chacune, par 9.627 (neuf mille six cent vingt-sept) Actions Ordinaires de Classe D avec une valeur nominale d'un
euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, par 1.095 (mille quatre-vingt-quinze) Actions Ordinaires de Classe F avec une
valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, par 1.095 (mille quatre-vingt-quinze) Actions Ordinaires
de Classe G avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, par 1.080 (mille quatre-vingt)
Actions Ordinaires de Classe H avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (ci-après les
"Actions Ordinaires"), et par 19 (dix-neuf) Actions de Gérance avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR
1,25) chacune.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts (les "Statuts").
La société pourra, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Toutes les Actions votent ensemble et, sauf si la loi ou les présents Statuts en disposent autrement, les porteurs
d'actions de classes différentes ne seront pas en droit de voter séparément dans quelque question que ce soit. Aucune
action appartenant à une quelconque classe ne comporte un droit de préemption sur une quelconque action de la Société,
sauf si la loi en dispose autrement."
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. ALLAMANNO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mars 2008. Relation: LAC/2008/12145. — Reçu douze euros (12,- €).
<i>Pr. Le Receveuri> (signé): F. SCHNEIDER.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
52528
Luxembourg, le 7 avril 2008.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2008048699/242/68.
(080053532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2008.
SigmaKalon Luxco, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 90.056.
In the year two thousand and eight, on the on the eleventh day of January.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Ms Armony Allamanno, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as the representative of the sole manager of
SigmaKalon Luxco S.C.A. (the "Company"), a société en commandite par actions having its registered office at 9A, Parc
d'Activité Syrdall, Unit 8, L-5365 Münsbach, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section
B number 90.056, pursuant to a resolution of the sole manager of the Company dated 10 January 2008.
A copy of the said resolution, initialled "ne varietur" by the appearing person and the notary, will remain attached to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state her declarations as follows:
1) The Company has been incorporated in the form of a société en commandite par actions under the name of
SigmaKalon Luxco S.C.A. pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven , on 14 November
2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 31 December 2003, number 1823. The articles
of incorporation of the Company have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 28
November 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
2) The issued share capital of the Company is currently set at sixty-seven thousand nine hundred twenty-one euro
and twenty-five cents (EUR 67,921.25) represented by twenty-two thousand three hundred and sixty-one (22,361) Class
A Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, by nine thousand five hundred
thirty-nine (9,539) Class B Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, by nine
thousand five hundred sixty-seven (9,567) Class C Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents
(EUR 1.25) each, by nine thousand five hundred eighty-one (9,581) Class D Ordinary Shares with a par value of one euro
and twenty-five cents (EUR 1.25) each, by one thousand ninety-five (1,095) Class F Ordinary Shares with a par value of
one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, by one thousand ninety-five (1,095) Class G Ordinary Shares with a par
value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, by one thousand eighty (1,080) Class H Ordinary Shares with
a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, and by nineteen (19) Management Shares with a par value
of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each;
3) Pursuant to article 6.13 ("Authorised Capital") of the articles of incorporation of the Company, the authorised share
capital of the Company is currently set at one million seven hundred six thousand four hundred forty-seven euro and
fifty cents (EUR 1,706,447.50) represented by:
(a) one million three hundred thirteen thousand five hundred and twenty-two (1,313,522) "Class A Ordinary Shares"
with a nominal value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share;
(b) one thousand eight hundred seventy (1,870) "Class B Ordinary Shares" with a nominal value of one euro and
twenty-five cents (EUR 1.25) per share;
(c) one thousand eight hundred seventy (1,870) "Class C Ordinary Shares" with a nominal value of one euro and
twenty-five cents (EUR 1.25) per share;
(d) one thousand eight hundred seventy (1,870) "Class D Ordinary Shares" with a nominal value of one euro and
twenty-five cents (EUR 1.25) per share;
(e) forty-three thousand two hundred ninety-six (43,296) "Class E Ordinary Shares" with a nominal value of one euro
and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance upon the conversion of any Class B, Class
C, Class D, Class F, Class G, Class H Ordinary Shares in accordance with their terms;
(e) nine hundred five (905) "Class F Ordinary Shares" with a nominal value of one euro and twenty-five cents (EUR
1.25) per share;
(f) nine hundred five (905) "Class G Ordinary Shares" with a nominal value of one euro and twenty-five cents (EUR
1.25) per share;
(h) nine hundred twenty (920) "Class H Ordinary Shares" with a nominal value of one euro and twenty-five cents (EUR
1.25) per share.
The sole manager of the Company is authorised to issue shares without reserving for the existing shareholders a
preferential right to subscribe to the shares issued.
4) By a resolution adopted on 10 January 2008, the sole manager of the Company has decided to increase the issued
share capital of the Company by an amount of one thousand eight hundred ninety euro (EUR 1,890.-) in order to increase
52529
it from its current amount of sixty-seven thousand nine hundred twenty-one euro and twenty-five cents (EUR 67,921.
25) up to sixty-nine thousand eight hundred eleven euro twenty-five cents (EUR 69,811.25) through the conversion of
one thousand five hundred and twelve (1,512) Series 1 CPECs issued by the Company into one thousand five hundred
and twelve (1,512) Class A Ordinary Shares;
As a consequence of such increase of share capital, articles 6.1 and 6.13 of the articles of incorporation of the Company
are amended and now read as follows:
" 6.1. Subscribed Capital. The Company has a subscribed capital of EUR 69,811.25 (sixty-nine thousand eight hundred
eleven euro twenty-five cents) represented by 23,873 (twenty-three thousand eight hundred seventy-three) Class A
Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, by 9,539 (nine thousand five hundred
thirty-nine) Class B Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, by 9,567 (nine
thousand five hundred sixty-seven) Class C Ordinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR
1.25) each, by 9,581 (nine thousand five hundred eighty-one) Class D Ordinary Shares with a par value of one euro and
twenty-five cents (EUR 1.25) each, by 1,095 (one thousand ninety-five) Class F Ordinary Shares with a par value of one
euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, by 1,095 (one thousand ninety-five) Class G Ordinary Shares with a par value
of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, by 1,080 (one thousand eighty) Class H Ordinary Shares with a par
value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, and by 19 (nineteen) Management Shares with a par value of
one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required for amendment of these articles of incorporation (the "Articles").
The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.
All shares shall vote together and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders of any
separate class of shares shall not be entitled to vote separately on any matter. No shares of any class shall be entitled to
any pre-emptive rights with respect to any shares of the Company, except as may be required by law."
" 6.13. Authorised Capital. In addition to the subscribed capital, the Manager is authorised to increase the subscribed
capital by up to EUR 1,704,557.50 (one million seven hundred and four thousand five hundred fifty-seven euro fifty cents)
represented by:
(a) 1,312,010 (one million three hundred and twelve and ten) "Class A Ordinary Shares" with a nominal value of one
euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share;
(e) 1,870 (one thousand eight hundred seventy) "Class B Ordinary Shares" with a nominal value of one euro and twenty-
five cents (EUR 1.25) per share;
(f) 1,870 (one thousand eight hundred seventy) "Class C Ordinary Shares" with a nominal value of one euro and twenty-
five cents (EUR 1.25) per share;
(g) 1,870 (one thousand eight hundred seventy) "Class D Ordinary Shares" with a nominal value of one euro and
twenty-five cents (EUR 1.25) per share;
(e) 43,296 (forty-three thousand two hundred ninety-six)"Class E Ordinary Shares" with a nominal value of one euro
and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, which are reserved for issuance upon the conversion of any Class B, Class
C, Class D, Class F, Class G, Class H Ordinary Shares in accordance with their terms;
(e) 905 (nine hundred five) "Class F Ordinary Shares" with a nominal value of one euro and twenty-five cents (EUR
1.25) per share;
(f) 905 (nine hundred five) "Class G Ordinary Shares" with a nominal value of one euro and twenty-five cents (EUR
1.25) per share;
(h) 920 (nine hundred twenty) "Class H Ordinary Shares" with a nominal value of one euro and twenty-five cents (EUR
1.25) per share.
During a period beginning on 29 July 2005 and finishing five years after this date, the Manager is authorised to increase
in one or several times the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within the limits of the
authorised capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Manager
may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the new shares to be subscribed and
issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to determine if the
new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the
newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash. Unless the shareholders shall have
otherwise agreed, when realising the authorised capital in full or in part, the Manager is expressly authorised to limit or
to waive the preferential subscription right reserved to existing shareholders. The Manager may delegate to any duly
authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscrip-
tions and receiving payment for the new shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each
increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the Manager, the present article is, as a
consequence to be adjusted."
52530
<i>Expensesi>
The expenses, encumbant on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approxi-
mately EUR 2,000.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person
the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this deed.
After reading and interpretation to the appearing person, known to the notary by her first and surname, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le onze janvier.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Mademoiselle Armony Allamanno, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de représentant
du gérant unique de SigmaKalon Luxco S.C.A. (la "Société"), une société en commandite par actions ayant son siège social
au 9A, Parc d'Activité Syrdall, Unit 8, L-5365 Münsbach, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous la section B numéro 90.056, suivant une résolution du gérant unique de la Société en date du 10 janvier 2008.
Une copie de ladite résolution paraphée "ne varietur" par la partie comparante et par le notaire soussigné restera
annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La personne comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter
les déclarations suivantes:
1) La Société a été constituée sous la forme d'une société en commandite par actions sous le nom de SigmaKalon
Luxco S.C.A. suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 14 novembre
2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 31 décembre 2002 sous le numéro 1823. Les statuts
de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 novembre
2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
2) La Société a un capital émis de soixante-sept mille neuf cent vingt et un euro et vingt cinq centimes (EUR 67.921,25)
représenté par vingt-deux mille trois cent soixante et une (22.361) Actions Ordinaires de Classe A avec une valeur
nominale d'un euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, par neuf mille cinq cent trente-neuf (9.539) Actions Ordi-
naires de Classe B ayant une valeur nominale d'un euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, par neuf mille cinq cent
soixante-sept (9.567) Actions Ordinaires de Classe C avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25)
chacune, par neuf mille cinq cent quatre-vingt-une (9.581) Actions Ordinaires de Classe D avec une valeur nominale d'un
euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, par mille quatre-vingt-quinze (1.095) Actions Ordinaires de Classe F avec
une valeur nominale d'un euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, par mille quatre-vingt-quinze (1.095) Actions
Ordinaires de Classe G avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, par mille quatre-
vingt (1.080) Actions Ordinaires de Classe H avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune
et par dix-neuf (19) Actions de Gérance avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune.
3) Suivant l'article 6.13 ("Capital Autorisé") des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société est fixé à un million
sept cent six mille quatre cent quarante-sept euros cinquante centimes (EUR 1.706.447,50) représenté par:
(a) un million trois cent treize mille cinq cent vingt-deux (1.313.522) "Actions Ordinaires de Classe A" avec une valeur
nominale d'un euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune;
(b) mille huit cent soixante-dix (1.870) "Actions Ordinaires de Classe B" avec une valeur nominale d'un euro vingt-
cinq centimes (EUR 1,25) chacune;
(c) mille huit cent soixante-dix (1.870) "Actions Ordinaires de Classe C" avec une valeur nominale d'un euro vingt-
cinq centimes (EUR 1,25) chacune;
(d) mille huit cent soixante dix (1,870) "Actions Ordinaires de Classe D" avec une valeur nominale d'un euro vingt-
cinq centimes (EUR 1,25) chacune;
(e) quarante-trois mille deux cent quatre-vingt-seize (43.296) "Actions Ordinaires de Classe E" avec une valeur no-
minale d'un euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, qui sont réservées pour être émises lors de la conversion de
chaque Action Ordinaire de Classe B, Classe C, Classe D, Classe F, Classe G, Classe H conformément à leurs conditions;
(f) neuf cent cinq (905) "Actions Ordinaires de Classe F" avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq centimes (EUR
1,25) chacune;
(g ) neuf cent cinq (905) "Actions Ordinaires de Classe G" avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq centimes
(EUR 1,25) chacune;
(h) neuf cent vingt (920) "Actions Ordinaires de Classe H" avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq centimes
(EUR 1,25) chacune.
52531
Le gérant unique de la Société est autorisé à émettre des actions sans réserver aux actionnaires existants un droit
préférentiel de souscription.
4) Par une résolution adoptée en date du 10 janvier 2008, le gérant unique de la Société a décidé d'augmenter le capital
social d'un montant de mille huit cent quatre-vingt-dix euros (EUR 1.890,-) afin de le porter de sa valeur actuelle de
soixante-sept mille neuf cent vingt et un euros vingt-cinq centimes (EUR 67.921,25) à soixante-neuf mille huit cent onze
euros vingt-cinq centimes (EUR 69.811,25) par la conversion de mille cinq cent douze (1.512) CPECs de Série 1 en mille
cinq cent douze (1.512) Actions Ordinaires de Classe A.
En conséquence de cette augmentation de capital, les articles 6.1 et 6 .13 des statuts de la Société sont modifiés et
auront désormais la teneur suivante:
« 6.1. Capital souscrit. La Société a un capital souscrit de EUR 69.811,25 (soixante-neuf mille huit cent onze euro vingt-
cinq centimes) représenté par 23,873 (vingt-trois mille huit cent soixante-treize) Actions Ordinaires de Classe A avec
une valeur nominale d'un euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, par 9.539 (neuf mille cinq cent trente-neuf) Actions
Ordinaires de Classe B ayant une valeur nominale d'un euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, par 9.567 (neuf
mille cinq cent soixante-sept) Actions Ordinaires de Classe C avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq centimes
(EUR 1,25) chacune, par 9.581 (neuf mille cinq cent quatre-vingt et une) Actions Ordinaires de Classe D avec une valeur
nominale d'un euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, par 1.095 (mille quatre-vingt-quinze) Actions Ordinaires de
Classe F avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, par 1.095 (mille quatre-vingt-quinze)
Actions Ordinaires de Classe G avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, par 1.080
(mille quatre-vingt) Actions Ordinaires de Classe H avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25)
chacune (ci-après les «Actions Ordinaires»), et par 19 (dix-neuf) Actions de Gérance avec une valeur nominale d'un euro
vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts (les Statuts).
La société pourra, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Toutes les Actions votent ensemble et, sauf si la Loi ou les présents Statuts en disposent autrement, les porteurs
d'actions de classes différentes ne seront pas en droit de voter séparément dans quelque question que ce soit. Aucune
action appartenant à une quelconque classe ne comporte un droit de préemption sur une quelconque action de la Société,
sauf si la Loi en dispose autrement.»
" 6.13. Capital autorisé. En plus du capital souscrit, le Gérant est autorisé à augmenter le capital souscrit dans la limite
de EUR 1.704.557,50 (un million sept cent quatre mille cinq cent cinquante-sept euros cinquante centimes) représenté
par:
(a) 1.312.010 (un million trois cent douze mille dix) "Actions Ordinaires de Classe A" avec une valeur nominale d'un
euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune;
(e) 1.870 (mille huit cent soixante-dix) ""Actions Ordinaires de Classe B" avec une valeur nominale d'un euro vingt-
cinq centimes (EUR 1,25) chacune;
(f) 1.870 (mille huit cent soixante-dix) "Actions Ordinaires de Classe C" avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq
centimes (EUR 1,25) chacune;
(g) 1,870 (mille huit cent soixante-dix) "Actions Ordinaires de Classe D" avec une valeur nominale d'un euro vingt-
cinq centimes (EUR 1,25) chacune;
(e) 43.296 (quarante-trois mille deux cent quatre-vingt-seize) "Actions Ordinaires de Classe E" avec une valeur no-
minale d'un euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, qui sont réservées pour être émises lors de la conversion de
chaque Action Ordinaire de Classe B, Classe C, Classe D, Classe F, Classe G, Classe H conformément à leurs conditions;
(e) 905 (neuf cent cinq) "Actions Ordinaires de Classe F" avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq centimes (EUR
1,25) chacune;
(f ) 905 (neuf cent cinq) "Actions Ordinaires de Classe G" avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq centimes
(EUR 1,25) chacune;
(h) 920 (neuf cent vingt) "Actions Ordinaires de Classe H" avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq centimes
(EUR 1,25) chacune.
Pendant une période de cinq ans à compter du 29 juillet 2005, le Gérant sera autorisé à augmenter en une ou plusieurs
fois le capital souscrit en faisant émettre des actions nouvelles dans les limites du capital autorisé par la Société. Ces
actions nouvelles seront souscrites et émises suivant les conditions que le Gérant pourra déterminer, surtout en ce qui
concerne la souscription et le paiement des actions nouvelles, tel que déterminer la date et le nombre des actions nouvelles
à souscrire et à émettre, déterminer si les actions nouvelles doivent être émises avec ou sans prime d'émission, déterminer
dans quelle mesure le paiement des actions nouvelles sera accepté par numéraire ou par des actifs autres que numéraires.
A moins que les actionnaires en aient décidé autrement, lorsque le Gérant réalise le capital autorisé entièrement ou
partiellement, il est expressément autorisé à restreindre ou à supprimer le droit de souscription préférentiel réservé aux
actionnaires existants. Le Gérant pourra déléguer à tout administrateur ou cadre de la Société dûment autorisé ou à
toute autre personne dûment autorisée, la tâche d'accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour les actions
52532
nouvelles correspondant entièrement ou partiellement au montant de l'augmentation de capital. Après chaque augmen-
tation du capital souscrit réalisée dans la forme légale requise par le Gérant, la présente disposition sera modifiée en
conséquence."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 2.000,-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu à la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état civil et demeure, la
partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. ALLAMANNO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 janvier 2008. Relation: LAC/2008/2892. — Reçu douze euros (12,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2008.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2008048700/242/244.
(080053532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2008.
Idécomm, Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 25, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 122.130.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008049684/1681/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04458. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Aberdeen Property Funds Eastern Europe SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV -
Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 132.956.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") tenue en date du 28 janvier 2008i>
L'Assemblée a décidé d'augmenter le nombre des administrateurs de 3 à 4.
De plus, l'Assemblée a décidé de nommer M. Selim Saykan, résidant professionnellement au 46a, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme administrateur de la Société pour une période se terminant
à la date de l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2012.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial , Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2008.
<i>Pour ABERDEEN PROPERTY FUNDS EASTERN EUROPE SICAV-FIS
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2008049573/1092/20.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO09076. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080053904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
52533
Archangel Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 132.646.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2008.
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008048734/5770/12.
(080053442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2008.
Bimaculatus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 122.825.
<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 7 mars 2008i>
1) Monsieur Marcel STEPHANY a été confirmé dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le
pouvoir d'engager la société en toutes circonstances conjointement avec la signature d'un autre gérant.
2) Madame Adriana DE ALCANTARA a été confirmée dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec
le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
3) Monsieur Barry PORTER a été confirmé dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir
d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
4) Madame Marlies WEISE a été confirmée dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir
d'engager la société en toutes circonstances conjointement avec la signature d'un autre gérant.
Luxembourg, le 2 avril 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BIMACULATUS S.à r.l.
i>Adriana DE ALCANTARA
Référence de publication: 2008049609/8620/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02572C. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Burryi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 122.814.
<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 7 mars 2008i>
1) Monsieur Marcel STEPHANY a été confirmé dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le
pouvoir d'engager la société en toutes circonstances conjointement avec la signature d'un autre gérant.
2) Madame Adriana DE ALCANTARA a été confirmée dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec
le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
3) Monsieur Barry PORTER a été confirmé dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir
d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
4) Madame Marlies WEISE a été confirmée dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir
d'engager la société en toutes circonstances conjointement avec la signature d'un autre gérant,
Luxembourg, le 2 avril 2008
Pour extrait sincère et conforme
<i>BURRYI S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2008049587/8621/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02580. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
52534
Blue Ringed S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 122.813.
<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 7 mars 2008i>
1) Monsieur Marcel STEPHANY a été confirmé dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le
pouvoir d'engager la société en toutes circonstances conjointement avec la signature d'un autre gérant.
2) Madame Adriana DE ALCANTARA a été confirmée dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec
le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
3) Monsieur Barry PORTER a été confirmé dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir
d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
4) Madame Marlies WEISE a été confirmée dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir
d'engager la société en toutes circonstances conjointement avec la signature d'un autre gérant.
Luxembourg, le 2 avril 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BLUE RINGED S.à r.l.
i>Adriana DE ALCANTARA
Référence de publication: 2008049601/8616/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02573. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Gestion Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1112 Luxembourg, 58, rue de l'Aciérie.
R.C.S. Luxembourg B 59.447.
Le bilan au 31/12/2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08/04/2008.
Signature.
Référence de publication: 2008049728/1969/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2008, réf. LSO-CP03174. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
M.M. Warburg & Co Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 17.881.
<i>Rücktritt des Verwaltungsratsmitgliedsi>
Herrn Günther Hinz, 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg
<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 31. August 2007i>
"Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Rücktritt des Herrn Günther Hinz als Mitglied des Verwaltungsrates
zum 31.08.2007."
Wahl zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates von
Herrn Dr. David Lohmann, 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg
<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 31. August 2007i>
"Es wird beschlossen Herrn Dr. David Lohmann zum neuen Verwaltungsratsmitglied zu ernennen. Sein Mandat endet
wie das der übrigen Mitglieder mit Datum der im Jahre 2007 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung, die über
den Jahresabschluss per 30.06.2007 befindet."
52535
Luxembourg, den 8. Januar 2008.
M.M. Warburg & Co Holding S.A., Société Anonyme
Unterschriften
Référence de publication: 2008049232/1/23.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05043. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080045212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.
Gestion Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1112 Luxembourg, 58, rue de l'Aciérie.
R.C.S. Luxembourg B 59.447.
Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08/04/2008.
Signature.
Référence de publication: 2008049729/1969/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2008, réf. LSO-CP03177. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080054328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 10.405.
I. Mit Wirkung vom 1. Februar 2008 hat Herr Dirk Vormberge seine Mandate als Mitglied des Verwaltungsrates und
als Mitglied der Geschäftsleitung der Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. niedergelegt.
II. Der Verwaltungsrat setzt sich mit Wirkung vom 1. Februar 2008 wie folgt zusammen:
Dr. Hannes Rehm,
Vorsitzender des Vorstandes Norddeutsche Landesbank Girozentrale, geschäftsansässig Friedrichswall 10, D-30159
Hannover,
Dr. Gunter Dunkel,
Mitglied des Vorstandes Norddeutsche Landesbank Girozentrale, geschäftsansässig Friedrichswall 10, D-30159 Han-
nover,
Hans Hartmann,
Administrateur-Délégué Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., geschäftsansässig 26, route d'Arlon, L-1140 Lu-
xembourg,
Dr. Stephan-Andreas Kaulvers,
Vorsitzender des Vorstandes Bremer Landesbank, geschäftsansässig Domshof 26, D-28195 Bremen,
Walter Kleine,
Vorsitzender des Vorstandes Sparkasse Hannover, geschäftsansässig Aegidientorplatz 1, D-30159 Hannover,
Jürgen Kösters,
Mitglied des Vorstandes Norddeutsche Landesbank Girozentrale, geschäftsansässig Friedrichswall 10, D-30159 Han-
nover,
Christoph Schulz,
Mitglied des Vorstandes Norddeutsche Landesbank Girozentrale, geschäftsansässig Friedrichswall 10, D-30159 Han-
nover.
III. Die Geschäftsleitung setzt sich mit Wirkung vom 1. Februar 2008 wie folgt zusammen:
Hans Hartmann,
Administrateur-Délégué Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., geschäftsansässig 26, route d'Arlon, L-1140 Lu-
xembourg,
Uwe Rossmannek,
Directeur Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., geschäftsansässig 26, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg,
Christian Veit,
Directeur Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., geschäftsansässig 26, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.
52536
IV. Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Norddeutsche Landesbank
Luxembourg S.A., Luxemburg, vom 17. März 2008.
Die Generalversammlung bestellt Ernst & Young S.A., L-5365 Münsbach, zum Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr
2008.
Luxemburg, den 18. März 2008.
Dr. Ursula Hohenadel.
Référence de publication: 2008048994/1984/44.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07490. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080053578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2008.
BPI Global Investment Fund Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 46.684.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 Mars 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008049688/1229/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2008, réf. LSO-CP00112. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Ersel Internationale S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 122.074.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2008.
Signatures.
Référence de publication: 2008049695/1024/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2008, réf. LSO-CP03007. - Reçu 36,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Beaumanoir S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 50.164.
Le bilan au 31/12/2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008049715/1429/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06188. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Euro Zing I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 85.549.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
52537
Luxembourg, le 01/04/2008.
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2008049737/805/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02828. - Reçu 44,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Intersum International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 79.748.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2008.
Helle Dueholm.
Référence de publication: 2008049717/5029/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2008, réf. LSO-CO05747. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Tishman Speyer French Core Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 960.525,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 134.950.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'associé unique en date du 5 mars 2008 que la personne suivante a démissionné avec effet
immédiat de ses fonctions de Gérant de Catégorie A de la Société:
- Monsieur James Arthur Rosenthal, né le 12 mai 1953 à New-York (USA), résidant au 1148, 5è Avenue, NY 10128
New-York, USA.
Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée Gérant de Catégorie B, avec effet
immédiat, pour une durée indéterminée:
- Madame Joséphine Andonissamy, née le 27 février 1973 à Pondichery (Inde), ayant son adresse professionnelle au
34-38 Avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg.
Le Conseil de Gérance est donc composé comme suit à partir du 5 mars 2008:
- Monsieur Paul Anthony Galiano, Gérant de Catégorie A
- Madame Geraldine Copeland-Wright, Gérant de Catégorie A
- Monsieur Jerry I Speyer, Gérant de Catégorie A
- Madame Katherine Farley, Gérant de Catégorie A
- Monsieur Robert J Speyer, Gérant de Catégorie A
- Monsieur Michael Philip Maurice Spies, Gérant de Catégorie A
- Monsieur Marcel Stephany, Gérant de Catégorie B
- Madame Joséphine Andonissamy, Gérant de Catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2008.
Pour extrait conforme
ATOZ
Référence de publication: 2008049804/4170/32.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2008, réf. LSO-CP03467. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
52538
Perma Impressions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 109.850.
Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008049686/1429/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07685. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080054215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Avelar Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 115.803.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2007.
Helle Dueholm.
Référence de publication: 2008049718/5029/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2008, réf. LSO-CO05748. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
TD Retail, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 101.620.
Le bilan au 31. Dezember 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire Weber et Bontemps
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprise
i>Signatures
Référence de publication: 2008049733/592/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02566. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Ersel Gestion Internationale S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 30.350.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008049736/1024/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02904. - Reçu 52,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
52539
T.C.I. Technology Communication Initiative S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 101.103.
Le bilan au 31/12/2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1/04/2008.
Signature.
Référence de publication: 2008049730/751/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2008, réf. LSO-CP02348. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080054317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Club Senior Nordstad, Association sans but lucratif,
(anc. Centre de Jour Hiirzebierg).
Siège social: L-9016 Ettelbruck, 5, rue de l'Ecole Agricole.
R.C.S. Luxembourg F 6.800.
Statuts de l'ASBL «Centre de Jour Hiirzebierg» adoptés par l'assemblée générale constituante du 19 avril 1990, enre-
gistrés à Diekirch le 4.5.1990, Vol.: 246, fol.: 7, case 10, publiés au Mémorial C numéro 384 du 17.10.1990, page 1839.
Matricule: 19906160447.
<i>Modifications adoptées à l'unanimité par l'assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2008i>
Art. 1. L'association est dénommée CLUB SENIOR NORDSTAD.
Ettelbruck, le 8 avril 2008.
<i>Club Senior Nordstad
Pour le conseil d'administration
i>Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétairei>
Référence de publication: 2008049748/800831/20.
Enregistré à Diekirch, le 11 avril 2008, réf. DSO-CP00048. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080054147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Cyanea S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 122.818.
<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 7 mars 2008i>
1) Monsieur Marcel STEPHANY a été confirmé dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le
pouvoir d'engager la société en toutes circonstances conjointement avec la signature d'un autre gérant.
2) Madame Adriana DE ALCANTARA a été confirmée dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec
le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
3) Monsieur Barry PORTER a été confirmé dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir
d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
4) Madame Marlies WEISE a été confirmée dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir
d'engager la société en toutes circonstances conjointement avec la signature d'un autre gérant.
Luxembourg, le 2 avril 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour CYANEA S.à r.l.
i>Adriana DE ALCANTARA
Référence de publication: 2008049613/8614/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02571. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
52540
LuxCo 37 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 130.025.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 Avril 2008.
Polyxeni Kotoula / Robert Schol.
Référence de publication: 2008049738/805/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02824. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080054287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Beethoven CDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 84.100.
Le bilan au 31 Décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 01/04/2008.
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2008049739/805/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02839C. - Reçu 36,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Petrusse European Clo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 100.018.
Le bilan au 31 Décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 01/04/2008.
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2008049740/805/15.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02833. - Reçu 40,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
PRINCETON PROPERTY, Société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 133.847.
<i>Extrait du Conseil de gérance du 19 mars 2008i>
Il résulte du Conseil de Gérance de la Société Princeton Property
qui s'est tenu en date du 19 mars 2008, à son siège social: 11, avenue de la Liberté L1931 Luxembourg.
L'unanimité des associés présents a donné son accord pour:
- la cession de 12 parts numérotées 143 à 154 détenues par David CHOQUET à Jean Pierre MARIE.
A l'issue de ces opérations le capital social de Princeton Property Sàrl s'établira comme suit:
- SUNVALLEY INTERNATIONAL TRADING: 112 parts sociales numérotées 1 à 112
- Jean-Philippe RICHON: 8 parts sociales numérotées 113 à 120
52541
- Jean Pierre MARIE: 20 parts sociales numérotées 121 à 128/143-154
- Sylvie HABIB: 3 parts sociales numérotées 129 à 131
- Jean Claude LEPAGE VIGER: 8 parts sociales numérotées 132 à 139
- Fabien LEPAGE VIGER: 3 parts sociales numérotées 140 à 142
- David CHOQUET: 106 parts sociales numérotées 155 à 260
Soient au total: 260 parts numérotées de 1 à 260
Philippe SCHMIT
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2008049477/6259/25.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2008, réf. LSO-CP04567. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080054378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Charles Oakes & Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 107.287.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 11.04.2008.
Äert Sekretariat S.à r.l.
10a, rue de l'Alzette - L-3396 Roeser
Signature
Référence de publication: 2008049742/1972/15.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08557. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Deep Carribean Investments S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 37.103.
Le bilan de la société au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008049749/655/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08680. - Reçu 22,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Dofleini S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 122.821.
<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 7 mars 2008i>
1) Monsieur Marcel STEPHANY a été confirmé dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le
pouvoir d'engager la société en toutes circonstances conjointement avec la signature d'un autre gérant.
2) Madame Adriana DE ALCANTARA a été confirmée dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec
le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
3) Monsieur Barry PORTER a été confirmé dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir
d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
4) Madame Marlies WEISE a été confirmée dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir
d'engager la société en toutes circonstances conjointement avec la signature d'un autre gérant.
52542
Luxembourg, le 2 avril 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour DOFLEINI S.à r.l.
i>Adriana DE ALCANTARA
Référence de publication: 2008049615/8619/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02569. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Domolux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8460 Eischen, 7, rue Clairefontaine.
R.C.S. Luxembourg B 96.729.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008049677/1681/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08537. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080054041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Gain Capital Participations SA, SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement
en Capital à Risque.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 128.091.
In the year two thousand and eight, on the seventh day of March.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "GAIN CAPITAL PARTICIPATIONS SA, SICAR", a
public limited venture capital company (société anonyme, société d'investissement en capital à risque), incorporated and
existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 128 091, incorporated by a deed received
by Maître Henri HELLINCKX, notary residing at Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), on April 18, 2007, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1166 of June 15, 2007.
The meeting is declared open by Mr. Paul MARX, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, acting as chairman, and appointing Mrs. Laetitia CARIAUX, employée privée,
residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as secretary of the meeting.
The meeting appoints as scrutineer Mr. David SANA, maître en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Waiver of convening notices.
2. Decision to change article 6.3 (a) (ii) of the articles of incorporation as followed: "gives its holder the right to receive
a Management Fee and Set-Up Fee, as set out in the Prospectus, and a Carried Interest in accordance with the provisions
of the Prospectus".
3. Decision to change article 11.3 (d) of the articles of incorporation as followed: "any transferable security and any
money market instrument negotiated or listed on a stock exchange or any other organised market will be valued on the
basis of the last known price, unless this price is not representative, in which case the value of such asset will be determined
on the basis of its foreseeable realisation value estimated by the Board with good faith".
4. Decision to change (a) and (c) of article 26.3 of the articles of incorporation as followed: "Return of Capital Con-
tributions: first, 100% to all the holders of Shares in proportion to their respective Capital Contributions until the
cumulative distributions to the Shareholders equal the Capital Contributions of each Shareholder;" and "85/15 Split:
thereafter, 85% to the holders of Ordinary Shares in proportion to their respective Capital Contributions and 15% to
the holders of the Shares issued within the other Classes as Carried Interest.".
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, checked and signed "ne varietur" by the shareholders,
52543
the proxy holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will be kept
at the latter's office.
The proxies of the represented shareholders signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed in order to be recorded with it.
After the foregoing has been approved by the meeting, the latter unanimously has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entire share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices,
the shareholders of the Company represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring
having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
To replace article 6.3 (a) (ii) of the articles of incorporation as followed: "gives its holder the right to receive a
Management Fee and Set-Up Fee, as set out in the Prospectus, and a Carried Interest in accordance with the provisions
of the Prospectus".
<i>Third resolutioni>
To replace article 11.3 (d) of the articles of incorporation as followed: "any transferable security and any money market
instrument negotiated or listed on a stock exchange or any other organised market will be valued on the basis of the last
known price, unless this price is not representative, in which case the value of such asset will be determined on the basis
of its foreseeable realisation value estimated by the Board with good faith".
<i>Fourth resolutioni>
To replace (a) and (c) of article 26.3 of the articles of incorporation as followed: "Return of Capital Contributions:
first, 100% to all the holders of Shares in proportion to their respective Capital Contributions until the cumulative
distributions to the Shareholders equal the Capital Contributions of each Shareholder;" and "85/15 Split: thereafter, 85%
to the holders of Ordinary Shares in proportion to their respective Capital Contributions and 15% to the holders of the
Shares issued within the other Classes as Carried Interest.".
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges to be borne by the present deed are estimated at nine hundred and twenty-five
Euro.
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the proxy
holder, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same proxy holder and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surname. Christian name,
civil status and residence, the latter signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le sept mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "GAIN CAPITAL PARTICIPATIONS
SA, SICAR", une société anonyme d'investissement en capital à risque de droit luxembourgeois ayant son siège social au
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 128091, consti-
tuée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
le 18 avril 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1166 du 15 juin 2007.
L'assemblée est ouverte par Monsieur Paul MARX, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Lu-
xembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, agissant en tant que président et désigne Madame Laetitia
CARIAUX, employée privée, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David SANA, maître en droit, demeurant professionnellement à
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Décision de modifier l'article 6.3 (a) (ii) des statuts comme suit: "donne à son détenteur le droit de percevoir une
Commission de Gestion, une Commission de Montage et un "carried interest" conformément au Prospectus".
52544
3. Décision de modifier l'article 11.3 (d) des statuts comme suit: "toute valeur mobilière et tous instruments du marché
monétaire négociés ou cotés sur une bourse de valeurs ou tout autre marché organisé sont évalués sur base du dernier
prix disponible, sauf si ce prix n'est pas représentatif, auquel cas l'évaluation d'un tel avoir sera basée sur sa valeur de
réalisation prévisible que le Conseil d'Administration estimera de bonne foi".
4. Décision de modifier (a) et (c) de l'article 26.3 des statuts comme suit: "Retour sur investissement: en premier,
100% à tous les détenteurs d'Actions en proportion de leur Engagement de Souscription jusqu'à ce que le cumul des
Distributions des Actionnaires soient équivalentes aux Engagements de Souscription de chaque Actionnaire;" et "85/15
Split: enfin, 85% aux détenteurs d'Actions Ordinaires en proportion de leur Engagement de Souscription et 15% aux
détenteurs des Actions émises dans les autres Classes comme carried interest".
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et
signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à l'étude de celui-ci.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux for-
malités de convocation, les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués
et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.
<i>Deuxième résolutioni>
Décide de remplacer l'article 6.3 (a) (ii) des statuts comme suit: "donne à son détenteur le droit de percevoir une
Commission de Gestion, une Commission de Montage et un "carried interest" conformément au Prospectus".
<i>Troisième résolutioni>
Décide de modifier l'article 11.3 (d) des statuts comme suit: "toute valeur mobilière et tous instruments du marché
monétaire négociés ou cotés sur une bourse de valeurs ou tout autre marché organisé sont évalués sur base du dernier
prix disponible, sauf si ce prix n'est pas représentatif, auquel cas l'évaluation d'un tel avoir sera basée sur sa valeur de
réalisation prévisible que le Conseil d'Administration estimera de bonne foi".
<i>Quatrième résolutioni>
Décide de modifier (a) et (c) de l'article 26.3 des statuts comme suit: "Retour sur investissement: en premier, 100% à
tous les détenteurs d'Actions en proportion de leur Engagement de Souscription jusqu'à ce que le cumul des Distributions
des Actionnaires soient équivalentes aux Engagements de Souscription de chaque Actionnaire;" et "85/15 Split: enfin, 85%
aux détenteurs d'Actions Ordinaires en proportion de leur Engagement de Souscription et 15% aux détenteurs des
Actions émises dans les autres Classes comme carried interest.".
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de neuf cent vingt-
cinq euros.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français constate par les présentes qu'à la requête du man-
dataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête du même mandataire et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: MARX - CARIAUX - SANA - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 mars 2008, Relation GRE/2008/1225. — Reçu Douze euros 12,- €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Junglinster, le 9 avril 2008.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2008050098/231/141.
(080054904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2008.
52545
Red Pepper Lux, Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 25, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 97.185.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008049679/1681/12.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07828. - Reçu 36,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080054044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Charles Oakes & Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 107.287.
Le bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 11.04.2008.
Äert Sekretariat S.à r.l.
10a, rue de l'Alzette - L-3396 Roeser
Signature
Référence de publication: 2008049743/1972/15.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08555. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Solution for International Commerce, Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 96.923.
Le bilan rectificatif au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02/04/2008.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008049746/751/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2008, réf. LSO-CP02332. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Southdown Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 52.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 113.424.
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévu par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés pour la période du 14 septembre
2005 (date de constitution) au 31 décembre 2006 de sa société mère, World Power Holdings, L/P ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
52546
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2008.
.
Référence de publication: 2008049770/581/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2008, réf. LSO-CP01938. - Reçu 46,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Briarius S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 122.815.
<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 7 mars 2008i>
1) Monsieur Marcel STEPHANY a été confirmé dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le
pouvoir d'engager la société en toutes circonstances conjointement avec la signature d'un autre gérant.
2) Madame Adriana DE ALCANTARA a été confirmée dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec
le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
3) Monsieur Barry PORTER a été confirmé dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir
d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
4) Madame Marlies WEISE a été confirmée dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir
d'engager la société en toutes circonstances conjointement avec la signature d'un autre gérant.
Luxembourg, le 2 avril 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BRIARIUS S.à r.l.
i>Adriana DE ALCANTARA
Référence de publication: 2008049617/8622/22.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02568. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Nord Lux Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 108.803.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008049682/1681/12.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07829. - Reçu 38,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Kudelski Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 85.284.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008049772/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO09025. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
52547
Financière Alkaline S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 82.515.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2008.
MERCURIA SERVICES S.A.
8-10, rue Mathias Hardt , B.P. 3023, L-1030 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008049783/1005/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2008, réf. LSO-CP02978. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080054099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Southdown Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 52.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 113.424.
Les comptes annuels pour la période du 15 décembre 2005 (date de constitution) au 31 décembre 2006 ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008049771/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2008, réf. LSO-CP01930. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Société Civile Immobilière Bouquet, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-7240 Bereldange, 13, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg E 1.096.
<i>Constatation de cession de parts socialesi>
Suite à deux cessions de parts sociales sous-seing privé, signées entre les parties et acceptées par les gérants au nom
de la société en date du 2 juin 2003, il résulte que le capital social de la société civile immobilière BOUQUET se répartit
désormais comme suit:
Parts
sociales
- Monsieur Joseph Bouquet, garagiste, demeurant à L-8042 Strassen, 5, rue Mathias Saur . . . . . . . . . . . . . . .
301
- Madame Astrid Bouquet-Metzdorf, employée privée, demeurant à L-8042 Strassen, 5, rue Mathias Saur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
301
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
602
Bereldange, le 2 juin 2003.
Pour extrait conforme
Signatures
Référence de publication: 2008049870/503/22.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05082. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080053862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
52548
Bourns (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.265.000,00.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 75.572.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Bourns (Luxembourg) S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2008049781/565/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2008, réf. LSO-CP01345. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080054107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
SSCP Style S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 137.667.
STATUTES
In the year two thousand eight, on the twenty-sixth of March.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.
There appeared:
Stirling Square Capital Partners Second Fund Limited Partnership, having its registered office at 32 Commercial Street,
PO Box 730, St Helier, Jersey JE4 0QH, with registration number LP 12516, represented by its General Partner, Stirling
Square Capital Partners Jersey GP Limited, having its registered of at 32 Commercial Street, PO Box 730, St Helier, Jersey
JE4 0QH, with registration number LP 12516, here represented by François Lerusse himself represented by Corinne
Petit, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal on March 26th,
2008.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company:
Chapter I.- Form, name, registered office, object, duration
Art. 1. Form - Corporate Name. Hereby is formed under the name of SSCP Style S. à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the
"Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the
"Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").
Art. 2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The Manager or the Board of
Managers (as defined below) is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the statutory
registered office.
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board
of Managers.
2.4 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
52549
Art. 3. Corporate Objectives.
3.1 The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial
or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution,
underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licenses, to
manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances
or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.
3.2 The Company may in particular take participations in the partnership limited by shares ("société en commandite
par actions") SSCP Style Holding S.C.A. and it may act as its general partner ("gérant commandité").
3.3 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,
all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose.
Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II.- Capital, shares
Art. 5. Corporate capital. The issued share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (Euro
12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares (the "Shares" and each a "Share"), each with a par
value of one Euro (Euro 1.-).
Art. 6. Capital Amendment. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder (where
there is only one shareholder) or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with articles 0 to 0 of the
Articles.
Art. 7. Shares. Each Share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company
in direct proportion to the number of Shares in existence.
Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 8. Transfer of Shares.
8.1 The Shares are freely transferable between shareholders. A shareholder may sell, assign, pledge, hypothecate, grant
a security interest in any of its Shares or otherwise transfer its Shares in whole or in part to any person or entity who is
shareholder.
8.2 Any transfer of Shares to any third party by way of sale, assignment, pledge, security interest or any other form,
must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three quarters of the capital of
the Company.
Art. 9. Redemption of Shares. The Company shall have the power to acquire Shares in its own capital in accordance
with the provisions of the Law.
Chapter III.- Management
Art. 10. Management.
10.1 The Company is managed by one or more managers; if there are more than one managers, they will constitute
a board of managers (the "Board of Managers"). The members of the Board of Managers need not be shareholders.
10.2 They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of
votes.
10.3 The Board of Managers will be composed of at least two members.
10.4 The meetings of the Board of Managers are convened by any member of the Board of Managers. In case that all
the members of the Board of Managers are present or represented, they may waive all convening requirements and
formalities.
10.5 Any member of the Board of Managers may act at any meeting of such Board by appointing in writing or by
telegram or telefax or email another member of the Board of Managers as his proxy; in that case, such member will be
considered as present for the purposes of article 10.6.
10.6 The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of votes of the managers present or
represented, provided that at least the majority of the members of the Boards of Managers are present or represented.
10.7 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating
member of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not
using this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall
be authorised to vote by video or by telephone.
10.8 Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the
members of the Board of Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-
mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Managers'
meetings, physically held.
52550
10.9 Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is
confirmed in writing.
10.10 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all members present or represented at
the meeting. Extracts shall be certified by any manager.
Art. 11. Powers of the Manager or the Board of Managers. In dealing with third parties, the Board of Managers will
have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the Board of Managers.
The Board of Managers may, in particular, enter into investment adviser agreements and administration agreements.
Art. 12. Representation of the Company. In case of one manager or if the Board of Managers is composed of two
members, the Company shall be bound by the sole signature of any manager; in the event the Board of Managers is
composed of more than two members, then the Company shall be bound by the joint signature of any two members of
the Board of Managers.
Art. 13. Delegation and Agent of the Board of Managers. Any manager, in case that there is one manager or the Board
of Managers is composed of two members, and any two managers, in case that the Board of Managers is composed of
more than two members, may delegate powers of the Board of Managers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
Any manager, in case that there is one manager or the Board of Managers is composed of two members, and any two
managers, in case that the Board of Managers is composed of more than two members, will determine any such agent's
responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of his agency.
Art. 14. Remuneration of the member of the Board of Managers. For its activities as manager the members of the
Board of Managers shall not receive any remuneration.
Art. 15. Incapacity of the Board of Managers and Dissolution. In case of dissolution or legal incapacity of any member
of the Board of Managers or where for any other reason it is impossible for a member to act, the Company will not be
dissolved.
In that event the shareholders in general meeting shall promptly appoint the new member(s) of the Board of Managers.
Chapter IV.- General meeting of shareholders
Art. 16. Powers of the general meeting of shareholder(s).
16.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
16.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions. Each shareholder
has voting rights commensurate with his shareholding.
Art. 17. Annual general meeting. In case the Company has more than 25 shareholders, the annual general meeting of
shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg
on the third Friday of May, at 03.00. P.M. and for the first time in 2009.
Art. 18. Other general meetings. Other general meetings of the shareholders may be convened in compliance with
Article 0 of the Articles. Such meetings must be convened if shareholders representing more than fifty per cent of the
Company's capital so require.
Art. 19. Notice.
19.1 The shareholders shall meet upon notice by any manager, in case there is one manager or that the Board of
Managers is composed of two members, and by any two managers, in case that the Board of Managers is composed of
more than two members, pursuant to the notice of meeting setting forth the agenda and sent at least 8 days prior to the
meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register.
19.2 The agenda for a general meeting of the shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes
to the Articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.
19.3 The shareholders shall receive all relevant information in relation to the matters stated in the agenda.
19.4 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of the shareholders and if they state that
they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 20. Attendance - Representation.
20.1 All shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings of the shareholders.
20.2 Any shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing or by telefax, cable,
telegram, telex, email as his proxy another person who need not be a shareholder himself.
20.3 Any company or other legal entity being a shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly
authorized officer, or may authorize by letter, by telegram or by telefaxed letter or by email such person as it thinks fit
52551
to act as its representative at any general meeting of the shareholders, subject to the production of such evidence of
authority as the Board of Managers may require.
20.4 The Board of Managers may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the
place indicated by him or it at least five days prior to the date set for the meeting.
Art. 21. Adjournment.
21.1 The shareholders meeting may be adjourned in compliance with article 22.4 of the Articles. It must be adjourned
if so required by shareholders representing at least one fifth of the Company's capital.
21.2 Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
21.3 The adjourned general meeting of the shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies
regularly deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.
Art. 22. Vote.
22.1 Each Share entitles the holder thereof to one vote.
22.2 Resolutions of shareholders shall be adopted at general meetings. However, the holding of general meetings shall
not be obligatory where the number of shareholders does not exceed twenty-five. In such case, each shareholder shall
receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.
22.3 Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of the shareholders resolves
by a simple majority vote to adopt another voting procedure.
22.4 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than
half of the share capital of the Company. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the
shareholders shall be convened or consulted a second time, by register letter, and decisions shall be adopted by a majority
of votes cast, regardless of the proportion of the capital represented.
22.5 However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at
least three-quarter of the Company's share capital, subject to any provisions of the Law.
Chapter V.- Business year - balance sheet
Art. 23. Business year.
23.1 The Company's financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year.
23.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the Manager or the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
23.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 24. Distribution right of shares.
24.1 From the net profits, determined in respect of each financial year in accordance with the applicable legal provisions
and accounting principles, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease
to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.
24.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by law and by these Articles, the Board of Managers may propose that cash available for remittance be distributed.
24.3 The decision to distribute funds and the determination of the conditions and amount of such a distribution will
be taken by the shareholders representing more than a half of the share capital.
24.4 Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim
dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed,
where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distrib-
utable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according
to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned
shall be reimbursed by the shareholder(s).
Chapter VI.- Dissolution - liquidation
Art. 25. Causes of dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 26. Liquidation.
26.1 The liquidation of the Company will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed
by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
26.2 Subject to the provisions of the Law, a majority of shareholders owning at least three-quarter of the company's
share capital can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation.
Chapter VII.- Applicable law
Art. 27. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
52552
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31
December 2008.
<i>Subscription - paymenti>
All the twelve thousand five hundred (12,500) Shares representing the entire capital have been entirely subscribed by
Stirling Square Capital Partners Second Fund Limited Partnership, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the
amount of twelve thousand five hundred Euro (Euro 12,500.-), is as now at the disposal of the Company, proof of which
has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro (Euro
1,500.-).
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions through its proxy
holder:
1. Are appointed as members of the Board of Managers for an undetermined period:
(a) Gregorio Napoleone, investment manager, born on 18 August 1954, in Genova, Italy, with professional address at
127-131 Sloane Street, London SW1 XAS, United Kingdom;
(b) Edward Henry Whittingham Moore, company manager, born on 17 may 1968 in Guildford, United Kingdom, with
professional address at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
(c) Alexander James Bermingham, company manager, born on 19 December 1972 in Sheffield, United Kingdom, with
professional address at 46A, avenue John J. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
In accordance with Article 0, the Company shall be bound by the joint signature of any two members of the Board of
Managers, as the Board of Managers is composed of more than two members.
2. The Company shall have its registered office at 46A Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, he signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Stirling Square Capital Partners Second Fund Limited Partnership, ayant son siège social au 32 Commercial Street, PO
Box 730, St Helier, Jersey JE4 0QH, avec numéro d'immatriculation LP 12516, representée par son gérant commandité,
Stirling Square Capital Partners Jersey GP Limited, ayant son siège social au 32 Commercial Street, PO Box 730, St Helier,
Jersey JE4 0QH, avec numéro d'immatriculation LP 12516, ici représentée par François Lerusse, lui-même représenté par
Corinne Petit, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé délivrée en date du 26 mars 2008.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Forme, nom, siège social, objet, durée
Art. 1
er
. Forme - Dénomination. Par la présente, il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination
de "SSCP Style S. à r.l." qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "la Société"), et en particulier la loi
du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "la Loi"), ainsi que par les présents statuts
de la Société (ci-après "les Statuts").
52553
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le gérant ou le Conseil de Gérance (tel que
défini ci-dessous) est autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur de la ville du siège statutaire.
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-
promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le gérant ou le Conseil de
Gérance.
2.4 La Société peut disposer de sièges et de succursales à Luxembourg et à l'étranger.
Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés com-
merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de toutes sûretés et de droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur; l'octroi aux entreprises dans
lesquelles elle a un intérêt, de tous concours, prêts, avances ou garanties; enfin, la Société peut accomplir toute opération
se rattachant directement ou indirectement à son objet.
3.2 La Société peut notamment prendre des participations dans la société en commandite par actions SSCP Style
Holding S.C.A. et agir, le cas échéant, comme gérant commandité de cette société.
3.3 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes
opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ainsi que toutes les opérations en relation directe
ou indirecte facilitant l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II.- Capital, parts
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500 Euro)
représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales (ci-après les "Parts Sociales") d'une valeur nominale de un
Euro (1 euro).
Art. 6. Modification du capital. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique (quand
il y a un seul associé) ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec les articles 16 à 22
des présents Statuts.
Art. 7. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la
Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 8. Transfert des parts.
8.1 Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés. Un associé pourra vendre, céder, mettre en gage, hy-
pothéquer, conférer une garantie sur ou transférer par tout autre moyen ses parts, en tout ou en partie, à une personne
ou une entité qui est associé.
8.2 Tout transfert de Parts Sociales à un tiers par voie de vente, transfert, gage ou sûreté, garantie ou toute autre
forme, devra être approuvé par l'assemblée des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit de
la Société.
Art. 9. Rachat des Parts. La Société aura le pouvoir d'acquérir des Parts Sociales de son propre capital conformément
aux dispositions de la Loi.
Titre III.- Gérance
Art. 10. Gérance.
10.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants; en cas de pluralité de gérant, ils constitueront un conseil de
gérance (le " Conseil de Gérance "). Les membres du Conseil de Gérance ne sont pas obligatoirement associés.
10.2 Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de
la majorité des votes.
10.3 Le Conseil de Gérance sera composé d'au moins deux membres.
10.4 Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d'un membre du Conseil de Gérance. Lorsque tous les membres
du Conseil de Gérance sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.
52554
10.5 Tout membre du Conseil de Gérance est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance
par un autre membre, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax
ou d'un courrier électronique; dans ce cas, ledit membre sera considéré comme présent en vue de l'application de l'article
10.6.
10.6 Toute décision du Conseil de Gérance est prise à la majorité des votes des membres présents ou représentés,
pour autant que la majorité au moins des membres du Conseil de Gérance soient présents ou représentés.
10.7 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée et chaque participant en mesure
d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de
technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
10.8 Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées
et approuvées par écrit par tous les membres du Conseil de Gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de
plusieurs documents séparés transmis par fax, courrier électronique, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même
effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil de Gérance physiquement tenue.
10.9 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen tels que télécopie, courrier électronique, télé-
gramme, fax ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.
10.10 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les membres présents ou repré-
sentés aux séances. Des extraits seront certifiés par un membre du Conseil de Gérance.
Art. 11. Pouvoirs du Conseil de Gérance.
11.1 Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
11.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront
de la compétence du Conseil de Gérance.
11.3 Le Conseil de Gérance pourra, notamment, conclure des contrats de conseil d'investissement et des contrats
d'administration.
Art. 12. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par la seule signature d'un gérant, en présence
d'un gérant unique ou si le Conseil de Gérance est composé de deux membres, et par la signature conjointe de deux des
membres du Conseil de Gérance, si le Conseil de Gérance est composé de plus de deux membres.
Art. 13. Délégation et agent du Conseil de Gérance.
13.1 Un seul gérant, si il n'y a qu'un seul gérant ou, si le Conseil de Gérance est composé de deux membres, et deux
des gérants, si le Conseil de Gérance est composé de plus de deux membres, peut/peuvent déléguer une partie des
pouvoirs du Conseil de Gérance pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
13.2 Un seul gérant, si il n'y a qu'un seul gérant si le Conseil de Gérance est composé de deux membres, et deux des
gérants, si le Conseil de Gérance est composé de plus de deux membres, déterminera/détermineront les responsabilités
et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Art. 14. Rémunération des membres du Conseil de Gérance. Pour leurs activités en qualité de gérant, les membres
du Conseil de Gérance ne recevront aucune rémunération.
Art. 15. Incapacité du Conseil de Gérance et dissolution.
15.1 En cas de dissolution ou d'incapacité légale de tout membre du Conseil de Gérance ou si le Conseil de Gérance
est dans l'impossibilité d'agir pour quelque raison que ce soit, la Société ne sera pas dissoute.
15.2 Dans ce cas, l'assemblée générale des associés nommera rapidement le (les) nouveau(x) membres du Conseil de
Gérance.
Titre IV.- Assemblée générale des associés
Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés.
16.1 L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés à l'assemblée générale des associés.
16.2 En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives. Chaque associé possède
des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.
Art. 17. Assemblée générale annuelle. Dans le cas ou la Société a plus de 25 associés, l'assemblée générale annuelle
des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le troisième
vendredi du mois de mai à 15h00, et pour la première fois en 2009.
Art. 18. Autres assemblées générales. D'autres assemblées générales pourront être convoquées conformément à
l'article 19 des Statuts. De telles assemblées doivent être convoquées si des associés représentant plus de cinquante pour
cent du capital de la Société le demandent.
52555
Art. 19. Convocation.
19.1 Les associés seront réunis sur convocation d'un seul gérant, si le Conseil de Gérance est composé de deux
membres ou en cas de gérant unique, et de deux des gérants, si le Conseil de Gérance est composé de plus de deux
membres selon un avis reprenant l'ordre du jour et envoyé à chaque associé à l'adresse indiquée dans le registre des
parts au moins 8 jours avant la réunion.
19.2 L'ordre du jour d'une assemblée générale des associés, devra également, le cas échéant, décrire les changements
statutaires proposés et, en outre, reprendre le texte des changements affectant l'objet ou la forme de la Société.
19.3 Les associés devront recevoir toutes les informations nécessaires en relation avec les points repris à l'ordre du
jour.
19.4 Si tous les associés son présent ou représentés lors de l'assemblée générale des associés, et s'il est constaté qu'ils
ont été informés de l'ordre du jour de la réunion, l'assemblée pourrait être tenue sans convocation préalable.
Art. 20. Assistance - Représentation.
20.1 Tous les associés ont le droit d'assister et de prendre la parole lors des assemblées générales des associés.
20.2 Un associé est autorisé à se faire représenter à toute assemblée des associés par un mandataire qui ne doit pas
nécessairement être associé lui-même, pour autant que ce dernier ait été nommé à cet égard par une procuration écrite
ou par téléfax, téléphone, télégramme, télex, courrier électronique.
20.3 Une société ou toute autre entité légale, associée, pourra exécuter un modèle de procuration sous seing privé
afin de donner pouvoir à un agent ou pourra autoriser par lettre, par lettre transmise par télégramme ou par fax ou par
courrier électronique, une personne qu'elle considère comme pouvant agir comme son représentant lors d'une assemblée
générale des associés, sous réserve de la production de la preuve d'un tel pouvoir, comme pourrait le demander le Conseil
de Gérance.
20.4 Le Conseil de Gérance pourra déterminer le modèle de procuration et pourra demander que les procurations
soient déposées à un endroit indiqué par celui-ci au moins cinq jours avant la date de l'assemblée.
Art. 21. Ajournement.
21.1 Le Président de l'assemblée générale des actionnaires pourra immédiatement remettre toute assemblée générale
des associés conformément à l'article 22.4 des Statuts. Il devra la remettre si la demande en est faite par des associés
représentant au moins un cinquième du capital de la Société.
21.2 Un tel ajournement annule automatiquement toute résolution déjà adoptée avant l'ajournement.
21.3 L'assemblée générale des associés ajournée a le même ordre du jour que la première. Parts sociales et procurations
régulièrement déposées en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la seconde.
Art. 22. Vote.
22.1 Chaque Part Sociale donne droit à un vote.
22.2 Les décisions des associés sont prises en assemblées générales. Toutefois la tenue d'assemblées générales n'est
pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le
texte de résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.
22.3 Le vote a lieu par mains levées ou par appel nominatif, à moins que l'assemblée générale des associés décide à la
majorité simple d'adopter une autre procédure de vote.
22.4 Les décisions collectives sont valablement prises seulement si elles sont adoptées par les associés représentant
au moins la moitié du capital de la Société. Si ce chiffre n'est pas atteint lors de la première assemblée ou consultation
écrite, les associés seront conviés ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les décisions seront prises
à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion de capital représentée.
22.5 Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'as-
sociés détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi.
Titre V.- Exercice social - comptes annuels
Art. 23. Exercice social.
23.1 L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
23.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant unique ou le Conseil
de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
23.3 Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.
Art. 24. Droit de distribution des parts.
24.1 Sur le bénéfice net déterminé chaque année conformément aux dispositions légales applicables et aux principes
comptables, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être
obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
24.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des
Statuts, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.
52556
24.3 La décision de distribuer des fonds et la détermination des conditions et du montant d'une telle distribution sera
prise par les associés représentants plus de la moitié du capital.
24.4 Malgré les dispositions précédentes, le gérant unique ou le Conseil de Gérance peut décider de verser des
acomptes sur dividendes au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant
que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas
excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et
des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi
ou ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés
seront remboursées par l'associé(s).
Titre VI.- Dissolution - liquidation
Art. 25. Causes de dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils,
d'insolvabilité, de faillite de son associé unique ou de l'un des associés.
Art. 26. Liquidation.
26.1 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui déter-
mineront leurs pouvoirs et rémunérations.
26.2 Sous réserve des dispositions légales, la majorité des actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital
social peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation.
Titre VII.- Loi applicable
Art. 27. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence
à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.
<i>Souscription - libérationi>
Les douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites
par Stirling Square Capital Partners Second Fund Limited Partnership, prénommée, et intégralement libérées par des
versements en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500 EUR) se trouve dès maintenant
à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros (1.500 EUR).
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes, par la voie de son représentant:
1. Sont nommés membres du Conseil de Gérance pour une période indéterminée:
a) Gregorio Napoleone, investment manager, né le 18 août 1954 à Gênes, Italie, avec adresse professionnelle au,
127-131 Sloane Street, London SW1 XAS, United Kingdom;
b) Edward Henry Whittingham Moore, gérant de société, né le 17 mai 1968 à Guildford, Royaume-Uni, avec adresse
professionnelle au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg;
c) Alexander James Bermingham, gérant de société, né le 19 décembre 1972 à Sheffield, Royaume-Uni, avec adresse
professionnelle au 46A, avenue John J. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Conformément à l'article 12 des statuts, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux des
membres du Conseil de Gérance comme celui-ci est composé de plus de deux membres.
2. Le siège social de la Société est établi au 46A, avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duché de
Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
52557
Enregistré à Luxembourg AC, le 1
er
avril 2008. LAC/2008/13405. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents, Eur
0,5% = 62,50.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008050056/5770/477.
(080054651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2008.
RESOLUTION London W1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 136.566.
In the year two thousand and eight, on the third of March.
Before Us, Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Resolution III Holdings S.à r.l., having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 130.916 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mr Raymond THILL, maître en droit, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on March 3, 2008,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities,
The appearer has requested the undersigned notary to record the following:
I. That it is the Sole Shareholder of RESOLUTION LONDON W1 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 136 566, incorporated pursuant to a deed
of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on February 14, 2008, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the subscribed capital by an amount of EUR 62,500.00 (sixty-two thousand and five hundred euros),
increasing the present subscribed capital from EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) up to EUR 75,000.00
(seventy-five thousand euros);
2. Issuance of 500 (five hundred) additional shares, having the same rights and obligations as the existing shares,
increasing the number of issued shares up to 600 (six hundred);
Subscription in the name and for the account of the Shareholders for 500 (five hundred) shares, each with a par value
of 125 Euro (one hundred and twenty-five Euro) and to pay them in full;
3. Subsequent amendment of article 6 of the Articles of Association;
4. Miscellaneous.
III. that the Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 62,500.00 (sixty-two thousand
and five hundred euros), increasing the present subscribed capital from EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros)
up to EUR 75,000.00 (seventy-five thousand euros) by way of the issue of 500 (five hundred) new shares of the Company,
having a par value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to accept the subscription to all the new shares by Resolution III Holdings S.à r.l., prenamed.
The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend article 6 of the Articles so that it shall
henceforth read as follows:
" Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at EUR 75,000 (seventy-five thousand euro), represented by 600
(six hundred) shares with a par value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euros) each, all subscribed and fully paid
up."
52558
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le trois mars.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Resolution III Holdings S.à r.l., avec siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130 916,
ici représentée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 3 mars 2008.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
par le notaire instrumentant, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci,
La comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Qu'elle est l'Associée Unique de RESOLUTION LONDON W1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136 566, constituée suivant un acte du notaire Henri
HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 février 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 62.500.00 (soixante-deux mille cinq cents euros), augmentant
le capital souscrit actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 75.000.00 (soixante-quinze mille euros);
2. Emission de 500 (cinq cents) actions supplémentaires, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes,
augmentant le nombre des actions émises à 600 (six cents);
Souscription au nom et pour le compte des actionnaires à 500 (cinq cents) actions, chacune avec une valeur nominale
de 125 Euro (cent vingt-cinq euros) et libération intégrale;
3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts;
4. Divers.
III. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 62.500.00 (soixante-deux mille
cinq cents euros), augmentant le capital souscrit actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 75.000.00
(soixante-quinze mille euros) par l'émission de 500 (cinq cents) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur
nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accepter la souscription intégrale par Resolution III Holdings S.à r.l., préqualifiée.
Le montant de l'augmentation de capital est désormais à la libre disposition de la Société, preuve en a été donnée au
notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 6 des Statuts de sorte qu'il
aura la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros) représenté par 600 (six
cents) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées."
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte est établi
en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même comparante, et en cas de divergences entre la version
anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé le présent
acte avec nous, Notaire.
Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
52559
Enregistré à Luxembourg AC, le 10 mars 2008. LAC/2008/10199. — Reçu trois cent douze euros cinquante cents Eur
0,5% = 312,50.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008050046/5770/107.
(080054955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2008.
Vatem S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 18.487.
RECTIFICATIF
Le bilan rectifié au 31 décembre 2006 (déposé le 12 juillet 2007 sous la référence L070089766.04) a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2008049872/506/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08109. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
LUDEC, Luxembourg-Décolletage, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8279 Holzem, 24, route de Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 13.745.
Le bilan et l'annexe au 31.12.2006 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008049873/3242/13.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02678. - Reçu 24,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080053943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Polimm S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 80.029.
Le bilan au 30 septembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
POLIMM S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur catégorie A / Administrateur catégorie Bi>
Référence de publication: 2008049879/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2008, réf. LSO-CP03013. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080054223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
52560
Aberdeen Property Funds Eastern Europe SICAV-FIS
Archangel Investments S.à r.l.
Armstripe S.à r.l.
Avelar Investments S. à r.l.
Beaumanoir S.A.
Beethoven CDO S.A.
Bimaculatus S.à r.l.
Bluehouse Capital Advisors S.à r.l.
Blue Ringed S.à r.l.
Bourns (Luxembourg) S.à r.l.
BPI Global Investment Fund Management Company S.A.
Briarius S.à r.l.
Burryi S.à r.l.
Centre de Jour Hiirzebierg
Charles Oakes & Co S.à r.l.
Charles Oakes & Co S.à r.l.
Club Senior Nordstad
Cyanea S.à r.l.
Deep Carribean Investments S.A.
Dofleini S.à r.l.
Domolux SA
Ersel Gestion Internationale S.A.
Ersel Internationale S.A.
EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A.
Euro Zing I S.A.
Financière Alkaline S.A.
Gain Capital Participations SA, SICAR
Gestion Luxembourg S.A.
Gestion Luxembourg S.A.
Idécomm
Intersum International S.A.
Kudelski Luxembourg S.à r.l.
LuxCo 37 S.à r.l.
Luxembourg-Décolletage
Macropus S.à r.l.
Meca S.A.
Minafin Sàrl
M.M. Warburg & Co Holding S.A.
M.M. Warburg & Co Holding S.A.
Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.
Nord Lux Immo S.A.
Octopussy S.A.
Perma Impressions S.à r.l.
Petrusse European Clo S.A.
Polimm S.A.
PRINCETON PROPERTY, Société à responsabilité limitée
Red Pepper Lux
RESOLUTION London W1 S.à r.l.
SigmaKalon Luxco
SigmaKalon Luxco
Société Civile Immobilière Bouquet
Solution for International Commerce
Sopisa S.à r.l.
Southdown Luxembourg Holdings S.à r.l.
Southdown Luxembourg Holdings S.à r.l.
SSCP Style S.à r.l.
Systemgastronomie K. Kiermeier G.m.b.H.
T.C.I. Technology Communication Initiative S.A.
TD Retail
Telecom Italia Capital
Tishman Speyer French Core Holdings S.à r.l.
Vatem S.A.
Welbeck Street Investments S.A.