This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1037
26 avril 2008
SOMMAIRE
Anine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49775
Barby Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49760
Barfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49776
Baumert,s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49768
Berkeley Investment Holdings S.A. . . . . . .
49759
Bero S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49774
Bric S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49766
CalEast French Investments 1 . . . . . . . . . . .
49754
CalEast Holdings 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
49754
CalEast Holdings 5 Properties 1 S.à r.l. . . .
49754
Catella Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
49765
CB Luxembourg V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49764
Compagnie de Révision . . . . . . . . . . . . . . . . .
49765
Corelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49772
Ernst & Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49763
Ernst & Young Tax Advisory Services . . . .
49764
Estrada Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49766
European Car Distribution and Services
Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49773
European Investments Associates (E.I.A.)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49755
European Management Fiduciary S.A. . . .
49758
Famy Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49760
Financial Mathematics S.A. . . . . . . . . . . . . .
49776
Him-Racing-Kart S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
49768
Imperial Holding S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
49761
Index 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49767
INDUCTRON Inductive Electronic Com-
ponents S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49772
Isidro International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
49767
iStructure S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49774
Javi International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49767
Kaytwo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49758
K'FE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49773
Kilbroney Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49757
K Invest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49762
LaSalle Japan Logistics (JPY) S.à r.l. . . . . . .
49730
Les Bierts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49773
LFS Advisory Services S.A. . . . . . . . . . . . . . .
49768
LFS Multi-Family Office S.A. . . . . . . . . . . . .
49768
Mallard Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49755
Meson Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49757
Neried Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49762
Open Mind S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49763
Reis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49761
Richie Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49760
Saes Getters International Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49775
Saxi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49756
Sitka S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49758
Société de Participations Antares S.A. . . .
49764
Sopalim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49759
Tivoli International Holding S.A. . . . . . . . .
49767
Tong International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49768
Torre Ingles S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49756
UPRN 1 SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49730
Wiesen-Piront Constructions S.A. . . . . . . .
49772
49729
LaSalle Japan Logistics (JPY) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: JPY 1.700.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 102.729.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution de l'associé unique prise en date du 22 février 2008 qu'a été nommé aux fonctions de gérant
de la société en remplacement de Mr Laurent Bélik, démissionnaire, avec effet au 23 février 2008:
- Mme Virginie Vely, demeurant professionnellement au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008046167/2570/18.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08254. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080050560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
UPRN 1 SE, Société Européenne.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 81.377.
In the year two thousand and eight, on the twenty-third day of the month of April,
the undersigned, Paul de Haan and Dennis Bosje, directors of the Company, duly authorised by the board of directors
of the Company on 12th February 2008 and in accordance with article 101-2 of the Luxembourg law of 10th August 1915
on commercial companies, as amended (the "Law") and with article 8 (2) of the Council Regulation (EC) N
o
2157/2001
of 8th October 2001 on the Statute for a European company (the "Regulation") drafted the present proposal of transfer
of the registered office of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to the Netherlands as follows:
<i>1. The Companyi>
The Company is a société européenne having its registered office at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg incorporated as société à responsabilité limitée by deed of Me Joseph Elvinger, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 4th March, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the "Memorial"), N
o
936 of 13th October 2001 and transformed into a société anonyme by
deed of Me Joseph Elvinger, prenamed, on 6th February 2008 published in the Mémorial N
o
687 of 20th March 2008.
The articles of incorporation of the Company were amended for the last time and the Company has been transformed
into a société européenne by deed of Me Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Lu-
xembourg, on 21st April 2008 to be published in the Mémorial on 25th April 2008.
<i>2. Proposed transfer of registered officei>
It is proposed to transfer the registered office of the Company from 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg to Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, the Netherlands.
<i>3. Proposed articles of association of the Companyi>
The transfer of the registered office implies that the articles of association of the Company shall comply with Dutch
law so that it is herewith proposed to amend and restate the articles of association of the Company (English version
immediately followed by Dutch version of the proposed articles of association of the Company) as follows:
"Articles of Association of UPRN 1 SE
Articles of Association
Art. 1. Definitions.
1.1. In these articles of association:
- "Body" (orgaan) is a term that applies to the Management Board or the General Meeting;
- "Company" means this Societas Europaea;
- "General Meeting" (algemene vergadering) is the Body consisting of the Shareholders;
- "General Meeting of Shareholders" (algemene vergadering van aandeelhouders) means the gathering of the Share-
holders in a meeting;
49730
- "Managing Director" (bestuurder) is a managing director as referred to in Dutch law, being a natural person or a legal
entity;
- "Management Board" (bestuur) is the Body made up of the Managing Directors;
- "Shareholder" (aandeelhouder) means a holder of one or more shares in the capital of the Company, being a natural
person or a legal entity.
Art. 2. Name and seat.
2.1. The name of the Company is: UPRN 1 SE.
2.2. The Company shall have its seat in Amsterdam (The Netherlands).
2.3 As long as the Company has its seat in the Netherlands, it must also have its head office in the Netherlands.
Art. 3. Objects.
3.1. The objects of the Company are:
- to incorporate, to participate in and to finance companies or businesses;
- to collaborate with, to manage the affairs of and to provide advice and other services to companies and other
businesses;
- to lend and to borrow funds;
- to provide collateral for the debts and other obligations of the Company, of other companies and businesses that
are affiliated with the Company in a group and of third parties;
- to acquire, to operate and to dispose of property, including registered property; and
- to acquire, to operate and to dispose of industrial and intellectual property rights,
as well as to carry out all that which is incidental or conducive to the above, in the broadest sense.
Art. 4. Capital and shares.
4.1. The authorised capital is seven hundred thirty-three thousand one hundred and twenty-five Euro (€ 733,125.--)
and shall be divided into twenty-nine thousand three hundred and twenty-five (29,325) shares, each having a nominal
value of twenty-five Euro (€ 25.--).
4.2. The shares shall be registered and shall be numbered consecutively, starting at one.
4.3. Share certificates shall not be issued by the Company.
4.4. If shares or the right to shares are jointly held, the joint Shareholders may only be represented by a single person
holding a written proxy signed by them all.
Art. 5. Issue.
5.1. Shares shall be issued pursuant to a resolution adopted by the General Meeting. Furthermore, the resolution shall
set out the price and other terms and conditions of issue. The issue price shall not be below par.
5.2. The general meeting may delegate its powers in this respect to another constituent body for a fixed period not
exceeding five years.
On such designation the number of shares which may be issued must be specified.
The designation may be extended from time to time for periods not exceeding five years.
Unless such designation provides otherwise, it may not be withdrawn.
5.3. Within eight days after a resolution of the general meeting to issue or to make a designation, the Company shall
deposit the full text thereof at the office of the commercial register.
5.4. Within eight days after each issue of shares, the Company shall report the same to the office of the commercial
register, stating the number.
5.5. Without prejudice to any provision of Dutch law, every Shareholder shall have a pre-emptive right on any issue
of shares "pro rata" to the aggregate amount of his shares. A pre-emptive right is non-transferable.
5.6. A notice of any issue in respect of which there is a pre-emptive right and the period during which such right can
be exercised, shall be given in writing to all the Shareholders at the addresses as indicated by them to the Company.
5.7. The pre-emptive right may be exercised during a period of four weeks after the days of sending such notice to
the Shareholders.
5.8. The pre-emptive right may be limited or excluded by virtue of a resolution adopted by the general meeting.
The pre-emptive right may also be restricted or excluded by the constituent body designated pursuant to subsection
2 of this article, if, by a resolution of the general meeting, it was designated and authorized for a fixed period not exceeding
five years, to restrict or exclude such pre-emptive right.
The designation may be extended, from time to time, for a period not exceeding five years.
The designation is only valid as long as the designation as referred to in paragraph 2 is valid.
Unless the designation provides otherwise, it may be withdrawn.
49731
5.9. If less than fifty percent of the issued capital is represented at the meeting, a majority of at least two-thirds of the
votes cast shall be required for a resolution of the general meeting to restrict or exclude the pre-emptive right or to
make such designation.
Within eight days after the resolution the Company shall deposit the full text thereof at the office of the commercial
register.
5.10. On the grant of rights to subscribe for shares, the Shareholders have a pre-emptive right.
The provisions of the above subsections are applicable "mutatis mutandis" to the granting of a right to subscribe for
shares.
Shareholders shall have no pre-emptive right in respect of shares issued to a person who exercises a previously acquired
right to subscribe for shares.
5.11 On subscription for a share, payment must be made of its nominal amount. It may be provided that a part, not
exceeding three-quarters of the nominal amount, need only be paid after the Company has called it up.
Art. 6. Own shares.
6.1. On an issue of shares the Company is not able to subscribe to its own shares.
6.2. The acquisition by the Company of its own shares when those shares have not been fully paid up shall be null and
void, unless acquired under universal title.
6.3. The Company may only acquire its own fully paid-up shares either gratuitously or as specified in Dutch law.
6.4. The provisions set out in these articles for the restriction on the transfer of shares are applicable to the Company's
disposal of its own shares.
6.5. In this article "shares" includes depositary receipts for shares.
Art. 7. Financial assistance.
7.1. The Company shall not grant loans, provide collateral, provide a price guarantee or otherwise guarantee, or bind
itself with or on behalf of third parties for the purpose of subscription to or acquisition of shares in its own capital, or of
depository receipts issued in respect thereof.
7.2. The prohibition of the previous subsection shall not apply if shares or depositary receipts are acquired by or on
behalf of employees of the Company or a group company as meant in Dutch law.
Art. 8. Reduction of capital.
8.1. The General Meeting may resolve to reduce the issued capital by cancelling shares or by amending the Articles of
Association to reduce the nominal amount of the shares.
8.2. Dutch law applies to such a resolution and its implementation.
Art. 9. The issue of depositary receipts for, the pledging of and the establishment of a right of usufruct over shares.
9.1. The Company shall not lend assistance in the issuance of depositary receipts for shares in the Company.
9.2. A right of usufruct or a right of pledge may be granted over shares. Voting rights shall not be vested in a holder
of a right of usufruct nor in a holder of a right of pledge of shares, unless voting rights are vested in a holder of a right of
usufruct pursuant to article 2:88, paragraph 3, final sentence, of the Dutch Civil Code.
Art. 10. Register of Shareholders.
10.1. The Management Board shall keep a register recording the names and addresses of all Shareholders, the date on
which they acquired the shares, the date of acknowledgement by or service upon the Company and the amount paid up
on each share. The names and addresses of those who have a right of usufruct or a right of pledge in respect of shares
shall also be recorded, stating the date on which they acquired the right and the date of acknowledgement by or service
upon the Company.
10.2. Every Shareholder, holder of a right of usufruct or holder of a right of pledge is obliged to ensure that the
Company is notified of the address of the Shareholder or holder of a right of usufruct or pledge.
10.3. The register shall be regularly updated in accordance with Dutch law.
10.4. All entries in, copies of, or extracts from the register of Shareholders shall be authenticated by a Managing
Director.
Art. 11. Transfer of shares.
11.1. The issue and transfer of a registered share, or the transfer or waiver of a limited right to a registered share,
require a deed which has been executed before a notary practicing in the Netherlands and to which all persons involved
are a party.
11.2. The transfer of a registered share, or the transfer or waiver of a limited right to a registered share, in accordance
with the provisions of the previous section shall also, by operation of Dutch law, be legally binding on the Company.
Except in the event that the Company itself is a party to the legal transaction, the rights accruing to the share may not
be exercised until the Company has either acknowledged this legal transaction or been served with the deed of transfer
in accordance with Dutch law.
49732
Art. 12. Management Board.
12.1. The Company shall have a Management Board consisting of at least three Managing Directors. The number of
Managing Directors shall be laid down by the General Meeting taking into account the aforementioned minimum. If the
number of appointed Managing Directors at any time falls below one, than one or more new Managing Directors will be
appointed by the General Meeting as soon as possible. The Management Board shall appoint one of the Managing Directors
as chairman of the Management Board.
The Managing Director-legal entity shall designate a natural person to exercise its functions and authorities.
12.2. Managing Directors shall be appointed by the General Meeting for a maximum period of six years. Managing
Directors may be reappointed once or more than once, each time for a maximum period of six years.
12.3. Managing Directors may be suspended or dismissed by the General Meeting at any time.
12.4. The total period of a suspension, including any extensions, may last no longer than three months.
12.5. The remuneration and other terms and conditions for the appointment of each individual Managing Director
shall be determined by the General Meeting.
Art. 13. Adoption of resolutions by the Management Board.
13.1. The Management Board shall adopt resolutions by an absolute majority of the total number of votes cast by all
the Managing Directors in a meeting in which at least one half of the Managing Directors is present or represented.
13.2. In meetings of the Management Board each Managing Director shall be entitled to cast one vote. In case of a tie
in the votes, the vote of the chairman of the Management Board shall be decisive.
13.3. Managing Directors may only be represented in meetings of the Management Board by another Managing Director
pursuant to a written power of attorney.
13.4. The Management Board may also adopt resolutions without convening a meeting, provided that all Managing
Directors have been consulted and none of them have raised an objection to adopt resolutions in this manner.
13.5. The approval of the General Meeting shall be required for decisions by the Management Board leading to an
important change in the company's or its business enterprise's entity or character, including in any case:
a. the transfer the business of the company or almost the entire business of the company to a third party;
b. the entering into or termination of any long-term co-operation of the company with another legal entity or company
or as a fully liable partner in a limited or general partnership, if such co-operation or termination is of far-reaching
significance to the company;
c. the acquisition or disposal by the company or by a subsidiary of the company of a participation in the capital of
another company with a value of at least one third of the amount of the assets according to the balance sheet with
explanatory notes, or in case the company prepares a consolidated balance sheet, according to the consolidated balance
sheet with explanatory notes, forming part of the most recently adopted annual accounts of the company.
13.6. The absence of the approval as defined in paragraph 5 of this article shall not affect the powers of the Managing
Board or of the Managing Directors to represent the Company.
Art. 14. Unavailability or inability to act of a Managing Director. If a Managing Director is unavailable or unable to act,
then the management of the Company shall be vested in the remaining Managing Director or Managing Directors. If no
Managing Director is available or able to act, the management of the Company shall be temporarily vested in one or more
persons appointed for that purpose by the General Meeting.
Art. 15. Representation of the Company.
15.1. The authority to represent shall vest exclusively in:
- the Management Board;
- any one of the Managing Directors.
15.2. In the event that a conflict of interest arises between the Company and a Managing Director, the Management
Board will represent the Company. The General Meeting is authorised to appoint one or more persons to represent the
Company at any time. If it does so, the representative authority contemplated in the previous sentence of this paragraph
will no longer apply. Without prejudice to the representative authority, in any case involving a conflict of interest, the
Management Board may act on behalf of the Company only after obtaining express prior permission from the General
Meeting.
Art. 16. Confidentiality. The Managing Directors shall be under a duty, even after they have ceased to hold office, not
to divulge any information which they have concerning the company the disclosure of which might be prejudicial to the
company's interest, except where such disclosure is required under the law or is in the public interest.
Art. 17. Financial year, annual accounts and annual report.
17.1. The Company's financial year shall be concurrent with the calendar year.
17.2. The Management Board shall prepare the annual accounts, which shall consist of the balance sheet and the profit
and loss statement with explanatory notes. The annual accounts shall be prepared within five months of the end of each
financial year, unless the General Meeting grants an extension to a maximum of six months in special circumstances. The
49733
annual accounts require the signatures of all the Managing Directors. The absence of a signature, and the reason therefore,
shall be expressly stated. Unless the provisions of article 2:403 of the Dutch Civil Code are applicable to the Company,
the Management Board shall also prepare an annual report within the above-mentioned period.
17.3. If, and to the extent that, any relevant provision of Dutch law is applicable to the Company, the General Meeting
shall retain a registered accountant or a firm of registered accountants, as defined in article 2:393, section 1, of the Dutch
Civil Code, to examine the annual accounts and, if prepared, the annual report prepared by the Management Board, in
order to write a report and to provide an opinion.
17.4. The annual accounts shall be adopted by the General Meeting.
17.5. If, and to the extent that, it is required under Dutch law, the Company is obliged to make the annual accounts
publicly available at the Trade Register.
Art. 18. Appropriation of the profits.
18.1. The Company may make distributions to the Shareholders and other persons entitled to the distributable profits,
to the extent the equity of the Company exceeds the paid-up and called-up part of the Company's equity, plus the reserves
which must be maintained under Dutch law.
18.2. The profits evidenced by the profit and loss statement adopted by the General Meeting shall be at the disposal
of the General Meeting.
18.3. The Company may make interim (profit-)distributions after the General Meeting has granted its approval, to the
extent that the provisions as set out in subsection 1 above have been complied with as evidenced by an interim statement
in conformity with Dutch.
The Company shall deposit the interim statement at the office of the commercial register within eight days after the
day on which the resolution to distribute is published.
18.4. There shall be no distribution of profits on shares or depositary receipts for shares held by the Company in its
own capital.
18.5. The shares and depositary receipts for shares for which no distribution will be made as described in section 4
above shall be disregarded when calculating the distribution of profits.
18.6. The right to receive a distribution shall expire five years from the day on which such a distribution became
payable.
Art. 19. Shareholder meetings.
19.1. The annual meeting of Shareholders shall be held every year within six months of the end of the financial year.
In this meeting the following, amongst other matters, shall be brought up for consideration, unless the six-month time
period mentioned above in Article 17.2, has been extended in accordance with the provisions set out in the said article:
- the annual report;
- the adoption of the annual accounts;
- the granting of discharge to the Managing Directors from liability for actions in respect of their management during
the preceding financial year;
- if required by Dutch law, the instruction of an expert as referred to in article 2:393, of the Dutch Civil Code; and
- the language in which the items of the next annual accounts shall be stated and the currency.
19.2. The General Meeting of Shareholders shall be held in the municipality where the Company has its registered
seat.
19.3. One or more shareholders who together hold at least ten percent (10%) of the subscribed capital may request
to convene a General Meeting of Shareholders and to draw up an agenda therefore. If, following the request a General
Meeting of Shareholders is not held in due time and, in any event, within two months, the judge (voorzieningenrechter)
of the court may order that a General Meeting of Shareholders shall be convened within a given period or authorize the
shareholders who have requested it to convene a General Meeting of Shareholders.
19.4. Unless the last sentence of the preceding paragraph is applicable, notice of the convening of the General Meeting
of Shareholders shall be issued by the Management Board, or one of the Managing Directors by means of written notices
dispatched no later than the fifteenth day before the date of the meeting.
19.5. The written notices convening the meeting shall set out the place, date and time of the meeting and the matters
to be considered. One or more shareholders who together hold at least one percent (1%) of the subscribed capital may
request that one or more additional items be put on the agenda of any General Meeting of Shareholders, provided that
the company has received the request no later than on the sixtieth day before the day of the meeting.
19.6. The written notices shall be dispatched to the addresses recorded in the Shareholder register. The failure of one
or more of the written notices dispatched in accordance with the stipulations set out above to reach the destination shall
not affect the validity of the General Meeting of Shareholders or the resolutions adopted thereby.
19.7. The General Meeting of Shareholders appoints a chairman from its midst.
19.8. Minutes shall be taken of the matters dealt with in a General Meeting of Shareholders unless a notarial record
of the proceedings is drawn up. The minutes shall be entered into a register maintained for that purpose and require the
49734
adoption and signature of the chairman of the meeting and the secretary of the meeting, who shall be appointed by the
chairman at the commencement of the meeting. The minutes or the notarial record of the proceedings shall serve as
evidence of the resolutions adopted in the General Meeting of Shareholders.
Art. 20. Adoption of resolutions in a General Meeting of Shareholders.
20.1. All Shareholders shall be entitled to attend a General Meeting of Shareholders and to address that meeting. The
shareholder-legal entity shall designate a natural person to exercise its functions and authorities. This person shall be able
to resolve and act on behalf of the shareholder-legal entity without limitation or consultation. The Managing Director or
Managing Directors, shall have, in these capacities, an advisory vote in the General Meeting of Shareholders.
20.2. In order to be able to participate in the voting the Shareholders - in case of shareholders-legal entities the persons
designated pursuant to article 20.1 - must sign the attendance book, recording the number of shares represented by
them.
20.3. Every share entitles the holder thereof to cast one vote.
20.4. In a General Meeting of Shareholders, no votes may be cast for shares held by the Company or by any subsidiary
thereof, nor may votes be cast for a share for which either of them holds a depositary receipt for a share.
20.5. The sum of the shares for which no voting rights may be exercised according to Dutch law shall be disregarded
in determining the extent to which the Shareholders are entitled to vote, are present or represented, or to which extent
the share capital is provided or represented.
20.6. Resolutions passed in a General Meeting of Shareholders shall be adopted by an absolute majority of the votes
validly cast in a meeting in which at least half of the Shareholders is present or represented. The votes cast shall not
include votes attaching to shares in respect of which the Shareholder has not taken part in the vote or has abstained or
has returned a blank or spoilt ballot paper.
20.7. The votes shall be cast orally, unless the chairman of the meeting decides otherwise.
20.8. In case of a tie in the vote, the proposal shall be deemed to have been rejected.
20.9. In a General Meeting of Shareholders in which the entire issued capital is represented valid resolutions can be
adopted provided they are adopted unanimously, even if the requirements in respect of the convening and holding of
meetings have not been complied with.
20.10. The Management Board shall keep a record of the adopted resolutions. This record shall be made available at
the Company's office for inspection by the Shareholders. Each Shareholder shall, upon request, be provided with a copy
of or extract from this record at no more than the actual costs.
Art. 21. Adoption of resolutions outside a General Meeting of Shareholders.
21.1. Shareholders may also adopt resolutions without convening a meeting of Shareholders, provided that all Share-
holders have declared in writing (including all generally accepted means of communication) to be in favour of the resolution
and provided that the Managing Director or Managing Directors, have had the opportunity to cast an advisory vote.
Art. 22. Merger, division, amendment to the articles of association, dissolution.
22.1. The General Meeting may resolve to merge the Company, to divide the Company, to amend the Articles of
Association or to dissolve the Company.
22.2. Those who convene a General Meeting of Shareholders in which a proposal is made to adopt a resolution to
amend the Articles of Association or to dissolve the Company must deposit a copy of the proposal, stating the verbatim
text of the proposed amendment, at the offices of the Company for inspection by the Shareholders. The proposal must
be deposited at the same time as the notice of the meeting and kept there until after the close of the meeting. The
Shareholders must be given the opportunity to obtain a copy of the proposal described in the previous sentence from
the day on which the convening notice for that meeting is dispatched until the day of the General Meeting of Shareholders.
Such copies shall be provided free of charge.
22.3. In the event that a resolution to dissolve the Company is adopted, the liquidation shall be arranged by the
Management Board, unless the court should appoint another liquidator or other liquidators. If a resolution to liquidate
the Company is passed, a resolution regarding the remuneration to be paid to the liquidator, or the joint liquidators,
must be passed at the same time.
22.4. The Articles of Association shall, as far as possible, remain effective during the process of liquidation.
22.5. The liquidation surplus shall be distributed to Shareholders and other parties entitled thereto in proportion to
their respective rights.
22.6. After the liquidation has been completed, the books and records of the dissolved Company shall remain in custody
of a person to be appointed for that purpose by the General Meeting for a period of seven years.
Statuten van UPRN 1 SE
Statuten
Art. 1. Definities.
1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:
49735
- orgaan: het bestuur of de algemene vergadering;
- vennootschap: deze Societas Europaea;
- algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders;
- algemene vergadering van aandeelhouders: bijeenkomst van aandeelhouders;
- bestuurder(s): de bestuurder(s) in de zin van de wet, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen;
- bestuur: het orgaan gevormd door de bestuurder(s);
- aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen in het kapitaal van de vennootschap, zijnde een natuurlijk
persoon of een rechtspersoon.
Art. 2. Naam en zetel.
2.1 De vennootschap draagt de naam: UPRN 1 SE.
2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.
2.3 Zolang de vennootschap haar statutaire zetel in Nederland heeft, dient het hoofdbestuur van de vennootschap
gelegen te zijn in Nederland.
Art. 3. Doel.
3.1 De vennootschap heeft ten doel:
- het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van vennootschappen of ondernemingen;
- het samenwerken met-, het voeren van bestuur over- en het verlenen van adviezen en andere diensten aan ven-
nootschappen of ondernemingen;
- het opnemen en verstrekken van geldleningen;
- het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennoot-
schappen of ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of van derden;
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen; en
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten,
alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin van het woord.
Art. 4. Kapitaal en aandelen.
4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd drieëndertig duizend éénhonderd vijfentwintig euro (€
733.125,--) en is verdeeld in negenentwintig duizend driehonderd vijfentwintig (29.325) aandelen van nominaal vijfent-
wintig euro (€ 25,--) elk.
4.2 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
4.3 Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
4.4 Indien aandelen of rechten op aandelen tot een gemeenschap behoren kunnen de deelgenoten zich slechts tege-
nover de vennootschap doen vertegenwoordigen door een persoon, daartoe schriftelijk door hen allen gemachtigd.
Art. 5. Uitgifte.
5.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering dat tevens de koers en de
verdere voorwaarden van uitgifte bevat.
5.2 De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
De algemene vergadering kan een ander orgaan aanwijzen om de bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld uit te
oefenen en wel voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren.
Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
5.3 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing
een volledige tekst daarvan neer bij het handelsregister.
5.4 De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave bij het handelsregister, met
vermelding van het aantal.
5.5 Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk
bedrag van zijn aandelen behoudens het bepaalde in de wet.
Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.
5.6 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in
een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres.
5.7 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende vier weken na verzending van de aankondiging aan de
aandeelhouders.
5.8 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
49736
Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge lid 2 van dit artikel aangewezen orgaan,
indien dit bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als
bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.
Zodanige aanwijzing kan slechts geschieden indien het betreffende orgaan tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen
als het tot uitgifte bevoegde orgaan als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
De aanwijzing geldt slechts zolang een aanwijzing als bedoeld in lid 2 van kracht is.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.
5.9 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing
is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het
geplaatste kapitaal in de vennootschap is vertegenwoordigd.
De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer bij het handelsregister.
5.10 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht.
Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds
verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
5.11 Bij het nemen van een aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden
dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap
het zal hebben opgevraagd.
Art. 6. Eigen aandelen.
6.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
6.2 Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte eigen aandelen is nietig, tenzij wordt verkregen onder
algemene titel.
6.3 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen slechts verkrijgen om niet of met inachtneming van het bepaalde
in de wet.
6.4 Met betrekking tot vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen is het bepaalde in de blok-
keringsregeling in deze statuten van toepassing.
6.5 Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.
Art. 7. Verboden steunverlening.
7.1 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten
daarvan, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich
hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
7.2 Het in het vorige lid vervatte verbod geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of
verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij als bedoeld in de wet.
Art. 8. Kapitaalvermindering.
8.1 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen
of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
8.2 Op een dergelijk besluit en de uitvoering daarvan is het bepaalde in de wet van toepassing.
Art. 9. Certificering, verpanding en vestiging van vruchtgebruik op aandelen.
9.1 De vennootschap verleent geen medewerking aan uitgifte van certificaten van aandelen van de vennootschap.
9.2 Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd.
Aan de vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen kan het stemrecht niet worden toegekend, tenzij het stemrecht
toekomt aan een vruchtgebruiker op grond van artikel 2:88 lid 3 laatste volzin van het Burgerlijk Wetboek.
Art. 10. Aandeelhoudersregister.
10.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met
vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede
van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op
aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen alsmede de datum van erkenning
of betekening.
10.2 Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de ven-
nootschap bekend is.
10.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van de wet.
10.4 Alle aantekeningen in en afschriften of uittreksels uit het aandeelhoudersregister zullen worden ondertekend door
een bestuurder.
49737
Art. 11. Levering van aandelen.
11.1 Voor de uitgifte en levering van een aandeel op naam of de levering of afstanddoening van een beperkt recht
daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de
betrokkenen partij zijn.
11.2 De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het in lid 1 bepaalde
werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap.
Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden
rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeen-
komstig het daaromtrent bepaalde in de wet.
Art. 12. Bestuur.
12.1 De vennootschap heeft een bestuur bestaande uit ten minste drie bestuurders. Het aantal bestuurders wordt
met inachtneming van dit minimum door de algemene vergadering vastgesteld. Is het aantal bestuurders minder dan één,
dan benoemt de algemene vergadering zo spoedig mogelijk een of meer nieuwe bestuurders. Het bestuur benoemt uit
zijn midden een voorzitter.
Een bestuurder rechtpersoon wijst voor de uitoefening van zijn bevoegdheden een natuurlijk persoon als vertegen-
woordiger aan.
12.2 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van ten hoogste zes jaar. Zij
kunnen een of meerdere malen worden herbenoemd, steeds voor een periode van ten hoogste zes jaar.
12.3 Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
12.4 Een schorsing kan, ook na een of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.
12.5 De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere bestuurder afzonderlijk, bepaald door de
algemene vergadering.
Art. 13. Besluitvorming bestuur.
13.1 Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van het in totaal door alle bestuurders uit te brengen aantal
stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
13.2 In de vergaderingen van het bestuur brengt iedere bestuurder één stem uit. In geval van staking van stemmen is
de stem van de voorzitter van het bestuur doorslaggevend.
13.3 Iedere bestuurder kan zich in de bestuursvergaderingen uitsluitend door een mede-bestuurder doen vertegen-
woordigen. Die vertegenwoordiging dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht.
13.4 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en geen van hen zich
tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
13.5 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een
belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of haar onderneming, waaronder in ieder
geval:
a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een
andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap
of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde
van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans
opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennoot-
schap, door haar of een dochtermaatschappij.
13.6 Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in lid 5 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur
of de bestuurders niet aan.
Art. 14. Belet of ontstentenis.
14.1 In geval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders berust het bestuur van de vennootschap bij de
overblijvende bestuurders dan wel de enig overgebleven bestuurder.
In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur van de vennoot-
schap tijdelijk bij een of meer door de algemene vergadering daartoe aangewezen personen.
Art. 15. Vertegenwoordiging.
15.1 De vennootschap wordt slechts vertegenwoordigd door:
- hetzij het bestuur;
- hetzij iedere bestuurder.
15.2 In alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een bestuurder, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd door het bestuur. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe
aan te wijzen, waardoor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging zoals beschreven in de vorige volzin, komt te vervallen.
49738
Onverminderd de bevoegdheid tot vertegenwoordiging, is het handelen door het bestuur namens de vennootschap in
alle gevallen van tegenstrijdig belang onderworpen aan uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de algemene verga-
dering.
Art. 16. Geheimhouding. De directeuren mogen, ook nadat zij hun functie hebben beëindigd, geen ruchtbaarheid geven
aan de te hunner beschikking staande inlichtingen over de vennootschap waarvan de openbaarmaking de belangen van de
vennootschap zou kunnen schade, behalve in gevallen waarin deze openbaarmaking krachtens de wet of om reden van
algemeen belang verplicht of toegestaan zijn.
Art. 17. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag.
17.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
17.2 Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ver-
gadering met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening
(bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
Tenzij artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, maakt het bestuur binnen voornoemde
termijn een jaarverslag op.
17.3 Indien en voorzover het dienaangaande in de wet bepaalde op de vennootschap van toepassing is, zal door de
algemene vergadering opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel
2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de door het bestuur ontworpen jaarrekening alsmede - indien opgemaakt
- het jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.
17.4 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
17.5 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking bij het handelsregister indien en voorzover de wet dit vereist.
Art. 18. Winstbestemming.
18.1 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts
uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het
kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
18.2 De winst blijkende uit de door de algemene vergadering vastgestelde winst- en verliesrekening staat ter be-
schikking van de algemene vergadering.
18.3 De vennootschap mag tussentijds slechts (winst-)uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 1 is voldaan
blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig de wet en na voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering.
De vennootschap legt de vermogensopstelling bij het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het
besluit tot uitkering wordt bekendgemaakt.
18.4 Op door de vennootschap gehouden aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan vindt geen uitkering ten
behoeve van de vennootschap plaats.
18.5 Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen of certificaten van aandelen, waarop ingevolge het in
lid 4 bepaalde geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaatsvindt, niet mee.
18.6 De vordering tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaars-
telling.
Art. 19. Vergaderingen van aandeelhouders.
19.1 Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
gehouden. In deze jaarvergadering worden onder meer - tenzij de termijn als bedoeld in artikel 17.2 van deze statuten
overeenkomstig het aldaar bepaalde is verlengd -, aan de orde wordt gesteld:
- de behandeling van het jaarverslag;
- de vaststelling van de jaarrekening;
- het verlenen van decharge aan het bestuur voor het door haar in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;
- het verlenen van een opdracht aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, voorzover
wettelijk vereist;
- de taal waarin de posten van de eerstvolgende jaarrekening worden gesteld en de geldeenheid.
19.2 De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel
heeft.
19.3 Het verzoek tot bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders en tot vaststelling van de agenda
kan worden gedaan door een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigen. Indien na de indiening van het verzoek de algemene vergadering van aandeelhouders niet
tijdig, in elk geval binnen een termijn van twee maanden, wordt gehouden, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
49739
de bijeenroeping binnen een bepaalde termijn gelasten of de aandeelhouders die het verzoek hebben gedaan machtigen
tot bijeenroeping.
19.4 Tenzij de laatste zin van het vorige artikel van toepassing is, geschiedt de bijeenroeping van aandeelhouders door
het bestuur of door een bestuurder door middel van oproepingsbrieven welke moeten worden verzonden niet later dan
op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.
19.5 De oproepingsbrieven vermelden plaats, dag en uur van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen.
Een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen,
kan of kunnen verzoeken om een of meer nieuwe punten op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders
te plaatsen indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft
ontvangen.
19.6 De oproepingsbrieven worden verzonden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister.
Wanneer een of meer oproepingsbrieven, overeenkomstig het hiervoor bepaalde verzonden, hun bestemming niet
bereiken, dan zal dit geen invloed uitoefenen op de geldigheid van de algemene vergadering van aandeelhouders en de
daarin te nemen besluiten.
19.7 De algemene vergadering van aandeelhouders voorziet zelf haar voorzitterschap.
Indien hij niet aanwezig is voorziet de algemene vergadering van aandeelhouders zelf in haar leiding.
19.8 Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden tenzij een
notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
De notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en vastgesteld en getekend door de voorzitter van
de vergadering en de door deze bij de aanvang van de vergadering aangewezen secretaris van de vergadering.
De notulen of het notarieel proces-verbaal strekken tot bewijs van het in de vergadering beslotene.
Art. 20. Besluitvorming in vergadering.
20.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord
te voeren. Een aandeelhouder-rechtspersoon wijst voor de uitoefening van zijn bevoegdheden een natuurlijke persoon
als vertegenwoordiger aan. Deze persoon dient zonder last of ruggespraak namens de aandeelhouder-rechtspersoon te
kunnen besluiten en handelen.
De bestuurder(s) heeft (hebben) als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.
20.2 Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders - in geval van aandeelhouders-rechts-
personen de personen aangewezen op grond van artikel 20.1 - de presentielijst tekenen, onder vermelding van het aantal
door ieder vertegenwoordigde aandelen.
20.3 Elk aandeel geeft recht op één stem.
20.4 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene
vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de
certificaten houdt.
20.5 Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre
het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de
wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
20.6 De besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen met volstrekte meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de aandeelhouders aanwezig of verte-
genwoordigd is.
De uitgebrachte stemmen omvatten niet de stemmen die verbonden zijn aan aandelen ten aanzien waarvan de aan-
deelhouder niet aan de stemming heeft deelgenomen of zich heeft onthouden, dan wel blanco of ongeldig heeft gestemd.
20.7 Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt.
20.8 Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
20.9 In een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is,
kunnen, mits met algemene stemmen, rechtsgeldige besluiten worden genomen ook al zijn de voorschriften met be-
trekking tot het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
20.10 Het bestuur van de vennootschap houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten
kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of
uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
Art. 21. Besluitvorming buiten vergadering. Besluitvorming door aandeelhouders kan op andere wijze dan in een ver-
gadering van aandeelhouders plaatsvinden doordat alle aandeelhouders zich schriftelijk (waaronder begrepen elk gangbaar
communicatiemiddel) vóór het voorstel hebben verklaard, en mits de bestuurder(s) de gelegenheid heeft (hebben) gehad
raadgevende stem uit te brengen.
Art. 22. Fusie, splitsing, statutenwijziging, ontbinding.
22.1 De algemene vergadering kan besluiten tot fusie, splitsing, wijziging van de statuten en tot ontbinding van de
vennootschap.
49740
22.2 Degenen, die een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders hebben gedaan, waarin een
voorstel tot het nemen van een besluit tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moeten tegelijkertijd met
de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van
de vennootschap neerleggen ter inzage van aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.
De aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging tot die van de algemene
vergadering van aandeelhouders een afschrift van het voorstel, zoals in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen.
Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.
22.3 Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door het bestuur tenzij de rechter
een andere vereffenaar of andere vereffenaars benoemt.
Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald door de vereffenaar, of de vereffenaars gezamenlijk,
te genieten.
22.4 Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
22.5 Het overschot na vereffening wordt aan aandeelhouders en andere rechthebbenden in verhouding tot ieders
recht uitgekeerd.
22.6 Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende zeven
jaren blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering te benoemen."
<i>4. Implication of the proposed transfer of registered office on the involvement of employeesi>
The Company has no employees.
Its business and the realisation of the Company's object are implemented without exception by the members of the
board of directors, who are not engaged in any employment agreement with the Company. Thus Council Directive N
o
2001/86/EC of 8th October 2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement
of employees and the provisions of the law of 25th August 2006 implementing it are not applicable.
<i>5. Proposed transfer timetablei>
It is proposed that the relevant steps and actions in view of the transfer of the registered office of the Company from
the Grand Duchy of Luxembourg to the Netherlands occur and that the transfer be effective as follows:
Action / Step to be taken - Timing for implementation
Publication of the present transfer proposal - 28th April 2008
Two month period for the creditors of the Company to apply for security to the Tribunal d'Arrondissement de et à
Luxembourg sitting in commercial matters - 28th June 2008
One month period during which the shareholders and the creditors of the Company are entitle to consult the present
transfer proposal and the report of the board of directors relating thereto - 28th May 2008
Holding of an extraordinary general meeting of the shareholders of UPRN 1 SE to deliberate on the transfer proposal
provided for herein - 28th June 2008
Filing, registration and publication of the deed of transfer, delivery of notary's certificate - 7th July 2008
Execution of Dutch notarial deed confirming Articles of Association - 8th July 2008
Registration with the Trade Registry of the Dutch Chamber of Commerce for Amsterdam - 10th July 2008
Notification of registration from the Trade Registry of the Dutch Chamber of Commerce for Amsterdam to the
Register of Commerce and Companies in Luxembourg - Before 10th August 2008
Deregistration of the Company from the Register of Commerce and Companies in Luxembourg - Before 15th August
2008
It is proposed that the transfer of the registered of the Company be effective on or about 5th August 2008 at the
latest.
It shall however be noted that such timeline is only indicative as certain steps involve actions to be taken by public
authorities over which the Company has no influence.
<i>6. Protection of the shareholders and the creditors of the Companyi>
The transfer of the registered office of the Company from Luxembourg to the Netherlands will not result in the winding
up or the dissolution of the Company or in the creation of a new legal entity. Any rights and obligations of the Company
vis-à-vis its shareholders and vis-à-vis its creditors shall continue to exist.
The creditors of the Company may apply for security to the Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg sitting
in commercial matters within a two-month period starting on the date of publication of the present transfer proposal.
Within a one month period prior to the date set for the extraordinary general meeting of the shareholders of the
Company deliberating on the transfer proposal, any creditor or any shareholder of the Company is entitled to consult
and to receive a free copy of the present transfer proposal and of the report of the board of directors on the legal and
economic justification of the transfer of the registered office of the Company and explaining the consequences of such
transfer for the shareholder and the creditors of the Company.
49741
<i>7. Approval by the shareholdersi>
The present transfer proposal shall be submitted to the extraordinary general meeting of shareholders of the Company
at the earliest two months after the date of its publication in the Memorial in accordance with article 101-3 and 101-6 of
the Law and article 8 (6) of the Regulation.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le vingt-troisième jour du mois d'avril,
les soussignés, M. Paul de Haan et M. Dennis Bosje, administrateurs de la Société dûment autorisés par le Conseil
d'Administration de la Société le 12 février 2008 et conformément aux articles 101-2 de la loi luxembourgeoise du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et l'article 8 (2) du Règlement (CE) n
o
2157/2001
du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne (le «Règlement»), ont préparé le présent projet
de transfert du siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers les Pays-Bas comme suit:
<i>1. La Sociétéi>
La Société est une société européenne ayant son siège social au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg constituée sous forme d'une société à responsabilité limitée par acte de Me Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg, le 4 mars 2001 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
«Mémorial») n
o
936 du 13 octobre 2001 et transformée en une société anonyme par acte de Me Joseph Elvinger,
prénommé, le 6 février 2008 publié au Mémorial n
o
687 du 20 mars 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés pour
la dernière fois et la Société transformée en société européenne par acte de Me Blanche Moutrier, notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 21 avril 2008 lequel sera publié au Mémorial le 25 avril 2008.
<i>2. Transfert proposé du siège sociali>
Il est proposé de transférer le siège social de la Société du 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg à Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, Pays-Bas.
<i>3. Statuts proposés de la Sociétéi>
Le transfert du siège social implique la conformité des statuts de la Société au droit néerlandais de sorte qu'il est par
le présent projet proposé de procéder à une refonte des statuts de la Société comme suit:
"Articles of Association of UPRN 1 SE
Articles of Association
Art. 1. Definitions.
1.1. In these articles of association:
- "Body" (orgaan) is a term that applies to the Management Board or the General Meeting;
- "Company" means this Societas Europaea;
- "General Meeting" (algemene vergadering) is the Body consisting of the Shareholders;
- "General Meeting of Shareholders" (algemene vergadering van aandeelhouders) means the gathering of the Share-
holders in a meeting;
- "Managing Director" (bestuurder) is a managing director as referred to in Dutch law, being a natural person or a legal
entity;
- "Management Board" (bestuur) is the Body made up of the Managing Directors;
- "Shareholder" (aandeelhouder) means a holder of one or more shares in the capital of the Company, being a natural
person or a legal entity.
Art. 2. Name and seat.
2.1. The name of the Company is: UPRN 1 SE.
2.2. The Company shall have its seat in Amsterdam (The Netherlands).
2.3 As long as the Company has its seat in the Netherlands, it must also have its head office in the Netherlands.
Art. 3. Objects.
3.1. The objects of the Company are:
- to incorporate, to participate in and to finance companies or businesses;
- to collaborate with, to manage the affairs of and to provide advice and other services to companies and other
businesses;
- to lend and to borrow funds;
- to provide collateral for the debts and other obligations of the Company, of other companies and businesses that
are affiliated with the Company in a group and of third parties;
- to acquire, to operate and to dispose of property, including registered property; and
- to acquire, to operate and to dispose of industrial and intellectual property rights,
49742
as well as to carry out all that which is incidental or conducive to the above, in the broadest sense.
Art. 4. Capital and shares.
4.1. The authorised capital is seven hundred thirty-three thousand one hundred and twenty-five Euro (€ 733,125.--)
and shall be divided into twenty-nine thousand three hundred and twenty-five (29,325) shares, each having a nominal
value of twenty-five Euro (€ 25.--).
4.2. The shares shall be registered and shall be numbered consecutively, starting at one.
4.3. Share certificates shall not be issued by the Company.
4.4. If shares or the right to shares are jointly held, the joint Shareholders may only be represented by a single person
holding a written proxy signed by them all.
Art. 5. Issue.
5.1. Shares shall be issued pursuant to a resolution adopted by the General Meeting. Furthermore, the resolution shall
set out the price and other terms and conditions of issue. The issue price shall not be below par.
5.2. The general meeting may delegate its powers in this respect to another constituent body for a fixed period not
exceeding five years.
On such designation the number of shares which may be issued must be specified.
The designation may be extended from time to time for periods not exceeding five years.
Unless such designation provides otherwise, it may not be withdrawn.
5.3. Within eight days after a resolution of the general meeting to issue or to make a designation, the Company shall
deposit the full text thereof at the office of the commercial register.
5.4. Within eight days after each issue of shares, the Company shall report the same to the office of the commercial
register, stating the number.
5.5. Without prejudice to any provision of Dutch law, every Shareholder shall have a pre-emptive right on any issue
of shares "pro rata" to the aggregate amount of his shares. A pre-emptive right is non-transferable.
5.6. A notice of any issue in respect of which there is a pre-emptive right and the period during which such right can
be exercised, shall be given in writing to all the Shareholders at the addresses as indicated by them to the Company.
5.7. The pre-emptive right may be exercised during a period of four weeks after the days of sending such notice to
the Shareholders.
5.8. The pre-emptive right may be limited or excluded by virtue of a resolution adopted by the general meeting.
The pre-emptive right may also be restricted or excluded by the constituent body designated pursuant to subsection
2 of this article, if, by a resolution of the general meeting, it was designated and authorized for a fixed period not exceeding
five years, to restrict or exclude such pre-emptive right.
The designation may be extended, from time to time, for a period not exceeding five years.
The designation is only valid as long as the designation as referred to in paragraph 2 is valid.
Unless the designation provides otherwise, it may be withdrawn.
5.9. If less than fifty percent of the issued capital is represented at the meeting, a majority of at least two-thirds of the
votes cast shall be required for a resolution of the general meeting to restrict or exclude the pre-emptive right or to
make such designation.
Within eight days after the resolution the Company shall deposit the full text thereof at the office of the commercial
register.
5.10. On the grant of rights to subscribe for shares, the Shareholders have a pre-emptive right.
The provisions of the above subsections are applicable "mutatis mutandis" to the granting of a right to subscribe for
shares.
Shareholders shall have no pre-emptive right in respect of shares issued to a person who exercises a previously acquired
right to subscribe for shares.
5.11 On subscription for a share, payment must be made of its nominal amount. It may be provided that a part, not
exceeding three-quarters of the nominal amount, need only be paid after the Company has called it up.
Art. 6. Own shares.
6.1. On an issue of shares the Company is not able to subscribe to its own shares.
6.2. The acquisition by the Company of its own shares when those shares have not been fully paid up shall be null and
void, unless acquired under universal title.
6.3. The Company may only acquire its own fully paid-up shares either gratuitously or as specified in Dutch law.
6.4. The provisions set out in these articles for the restriction on the transfer of shares are applicable to the Company's
disposal of its own shares.
6.5. In this article "shares" includes depositary receipts for shares.
49743
Art. 7. Financial assistance.
7.1. The Company shall not grant loans, provide collateral, provide a price guarantee or otherwise guarantee, or bind
itself with or on behalf of third parties for the purpose of subscription to or acquisition of shares in its own capital, or of
depository receipts issued in respect thereof.
7.2. The prohibition of the previous subsection shall not apply if shares or depositary receipts are acquired by or on
behalf of employees of the Company or a group company as meant in Dutch law.
Art. 8. Reduction of capital.
8.1. The General Meeting may resolve to reduce the issued capital by cancelling shares or by amending the Articles of
Association to reduce the nominal amount of the shares.
8.2. Dutch law applies to such a resolution and its implementation.
Art. 9. The issue of depositary receipts for, the pledging of and the establishment of a right of usufruct over shares.
9.1. The Company shall not lend assistance in the issuance of depositary receipts for shares in the Company.
9.2. A right of usufruct or a right of pledge may be granted over shares. Voting rights shall not be vested in a holder
of a right of usufruct nor in a holder of a right of pledge of shares, unless voting rights are vested in a holder of a right of
usufruct pursuant to article 2:88, paragraph 3, final sentence, of the Dutch Civil Code.
Art. 10. Register of Shareholders.
10.1. The Management Board shall keep a register recording the names and addresses of all Shareholders, the date on
which they acquired the shares, the date of acknowledgement by or service upon the Company and the amount paid up
on each share. The names and addresses of those who have a right of usufruct or a right of pledge in respect of shares
shall also be recorded, stating the date on which they acquired the right and the date of acknowledgement by or service
upon the Company.
10.2. Every Shareholder, holder of a right of usufruct or holder of a right of pledge is obliged to ensure that the
Company is notified of the address of the Shareholder or holder of a right of usufruct or pledge.
10.3. The register shall be regularly updated in accordance with Dutch law.
10.4. All entries in, copies of, or extracts from the register of Shareholders shall be authenticated by a Managing
Director.
Art. 11. Transfer of shares.
11.1. The issue and transfer of a registered share, or the transfer or waiver of a limited right to a registered share,
require a deed which has been executed before a notary practicing in the Netherlands and to which all persons involved
are a party.
11.2. The transfer of a registered share, or the transfer or waiver of a limited right to a registered share, in accordance
with the provisions of the previous section shall also, by operation of Dutch law, be legally binding on the Company.
Except in the event that the Company itself is a party to the legal transaction, the rights accruing to the share may not
be exercised until the Company has either acknowledged this legal transaction or been served with the deed of transfer
in accordance with Dutch law.
Art. 12. Management Board.
12.1. The Company shall have a Management Board consisting of at least three Managing Directors. The number of
Managing Directors shall be laid down by the General Meeting taking into account the aforementioned minimum. If the
number of appointed Managing Directors at any time falls below one, than one or more new Managing Directors will be
appointed by the General Meeting as soon as possible. The Management Board shall appoint one of the Managing Directors
as chairman of the Management Board.
The Managing Director-legal entity shall designate a natural person to exercise its functions and authorities.
12.2. Managing Directors shall be appointed by the General Meeting for a maximum period of six years. Managing
Directors may be reappointed once or more than once, each time for a maximum period of six years.
12.3. Managing Directors may be suspended or dismissed by the General Meeting at any time.
12.4. The total period of a suspension, including any extensions, may last no longer than three months.
12.5. The remuneration and other terms and conditions for the appointment of each individual Managing Director
shall be determined by the General Meeting.
Art. 13. Adoption of resolutions by the Management Board.
13.1. The Management Board shall adopt resolutions by an absolute majority of the total number of votes cast by all
the Managing Directors in a meeting in which at least one half of the Managing Directors is present or represented.
13.2. In meetings of the Management Board each Managing Director shall be entitled to cast one vote. In case of a tie
in the votes, the vote of the chairman of the Management Board shall be decisive.
13.3. Managing Directors may only be represented in meetings of the Management Board by another Managing Director
pursuant to a written power of attorney.
49744
13.4. The Management Board may also adopt resolutions without convening a meeting, provided that all Managing
Directors have been consulted and none of them have raised an objection to adopt resolutions in this manner.
13.5. The approval of the General Meeting shall be required for decisions by the Management Board leading to an
important change in the company's or its business enterprise's entity or character, including in any case:
a. the transfer the business of the company or almost the entire business of the company to a third party;
b. the entering into or termination of any long-term co-operation of the company with another legal entity or company
or as a fully liable partner in a limited or general partnership, if such co-operation or termination is of far-reaching
significance to the company;
c. the acquisition or disposal by the company or by a subsidiary of the company of a participation in the capital of
another company with a value of at least one third of the amount of the assets according to the balance sheet with
explanatory notes, or in case the company prepares a consolidated balance sheet, according to the consolidated balance
sheet with explanatory notes, forming part of the most recently adopted annual accounts of the company.
13.6. The absence of the approval as defined in paragraph 5 of this article shall not affect the powers of the Managing
Board or of the Managing Directors to represent the Company.
Art. 14. Unavailability or inability to act of a Managing Director. If a Managing Director is unavailable or unable to act,
then the management of the Company shall be vested in the remaining Managing Director or Managing Directors. If no
Managing Director is available or able to act, the management of the Company shall be temporarily vested in one or more
persons appointed for that purpose by the General Meeting.
Art. 15. Representation of the Company.
15.1. The authority to represent shall vest exclusively in:
- the Management Board;
- any one of the Managing Directors.
15.2. In the event that a conflict of interest arises between the Company and a Managing Director, the Management
Board will represent the Company. The General Meeting is authorised to appoint one or more persons to represent the
Company at any time. If it does so, the representative authority contemplated in the previous sentence of this paragraph
will no longer apply. Without prejudice to the representative authority, in any case involving a conflict of interest, the
Management Board may act on behalf of the Company only after obtaining express prior permission from the General
Meeting.
Art. 16. Confidentiality. The Managing Directors shall be under a duty, even after they have ceased to hold office, not
to divulge any information which they have concerning the company the disclosure of which might be prejudicial to the
company's interest, except where such disclosure is required under the law or is in the public interest.
Art. 17. Financial year, annual accounts and annual report.
17.1. The Company's financial year shall be concurrent with the calendar year.
17.2. The Management Board shall prepare the annual accounts, which shall consist of the balance sheet and the profit
and loss statement with explanatory notes. The annual accounts shall be prepared within five months of the end of each
financial year, unless the General Meeting grants an extension to a maximum of six months in special circumstances. The
annual accounts require the signatures of all the Managing Directors. The absence of a signature, and the reason therefore,
shall be expressly stated. Unless the provisions of article 2:403 of the Dutch Civil Code are applicable to the Company,
the Management Board shall also prepare an annual report within the above-mentioned period.
17.3. If, and to the extent that, any relevant provision of Dutch law is applicable to the Company, the General Meeting
shall retain a registered accountant or a firm of registered accountants, as defined in article 2:393, section 1, of the Dutch
Civil Code, to examine the annual accounts and, if prepared, the annual report prepared by the Management Board, in
order to write a report and to provide an opinion.
17.4. The annual accounts shall be adopted by the General Meeting.
17.5. If, and to the extent that, it is required under Dutch law, the Company is obliged to make the annual accounts
publicly available at the Trade Register.
Art. 18. Appropriation of the profits.
18.1. The Company may make distributions to the Shareholders and other persons entitled to the distributable profits,
to the extent the equity of the Company exceeds the paid-up and called-up part of the Company's equity, plus the reserves
which must be maintained under Dutch law.
18.2. The profits evidenced by the profit and loss statement adopted by the General Meeting shall be at the disposal
of the General Meeting.
18.3. The Company may make interim (profit-)distributions after the General Meeting has granted its approval, to the
extent that the provisions as set out in subsection 1 above have been complied with as evidenced by an interim statement
in conformity with Dutch.
49745
The Company shall deposit the interim statement at the office of the commercial register within eight days after the
day on which the resolution to distribute is published.
18.4. There shall be no distribution of profits on shares or depositary receipts for shares held by the Company in its
own capital.
18.5. The shares and depositary receipts for shares for which no distribution will be made as described in section 4
above shall be disregarded when calculating the distribution of profits.
18.6. The right to receive a distribution shall expire five years from the day on which such a distribution became
payable.
Art. 19. Shareholder meetings.
19.1. The annual meeting of Shareholders shall be held every year within six months of the end of the financial year.
In this meeting the following, amongst other matters, shall be brought up for consideration, unless the six-month time
period mentioned above in Article 17.2, has been extended in accordance with the provisions set out in the said article:
- the annual report;
- the adoption of the annual accounts;
- the granting of discharge to the Managing Directors from liability for actions in respect of their management during
the preceding financial year;
- if required by Dutch law, the instruction of an expert as referred to in article 2:393, of the Dutch Civil Code; and
- the language in which the items of the next annual accounts shall be stated and the currency.
19.2. The General Meeting of Shareholders shall be held in the municipality where the Company has its registered
seat.
19.3. One or more shareholders who together hold at least ten percent (10%) of the subscribed capital may request
to convene a General Meeting of Shareholders and to draw up an agenda therefore. If, following the request a General
Meeting of Shareholders is not held in due time and, in any event, within two months, the judge (voorzieningenrechter)
of the court may order that a General Meeting of Shareholders shall be convened within a given period or authorize the
shareholders who have requested it to convene a General Meeting of Shareholders.
19.4. Unless the last sentence of the preceding paragraph is applicable, notice of the convening of the General Meeting
of Shareholders shall be issued by the Management Board, or one of the Managing Directors by means of written notices
dispatched no later than the fifteenth day before the date of the meeting.
19.5. The written notices convening the meeting shall set out the place, date and time of the meeting and the matters
to be considered. One or more shareholders who together hold at least one percent (1%) of the subscribed capital may
request that one or more additional items be put on the agenda of any General Meeting of Shareholders, provided that
the company has received the request no later than on the sixtieth day before the day of the meeting.
19.6. The written notices shall be dispatched to the addresses recorded in the Shareholder register. The failure of one
or more of the written notices dispatched in accordance with the stipulations set out above to reach the destination shall
not affect the validity of the General Meeting of Shareholders or the resolutions adopted thereby.
19.7. The General Meeting of Shareholders appoints a chairman from its midst.
19.8. Minutes shall be taken of the matters dealt with in a General Meeting of Shareholders unless a notarial record
of the proceedings is drawn up. The minutes shall be entered into a register maintained for that purpose and require the
adoption and signature of the chairman of the meeting and the secretary of the meeting, who shall be appointed by the
chairman at the commencement of the meeting. The minutes or the notarial record of the proceedings shall serve as
evidence of the resolutions adopted in the General Meeting of Shareholders.
Art. 20. Adoption of resolutions in a General Meeting of Shareholders.
20.1. All Shareholders shall be entitled to attend a General Meeting of Shareholders and to address that meeting. The
shareholder-legal entity shall designate a natural person to exercise its functions and authorities. This person shall be able
to resolve and act on behalf of the shareholder-legal entity without limitation or consultation. The Managing Director or
Managing Directors, shall have, in these capacities, an advisory vote in the General Meeting of Shareholders.
20.2. In order to be able to participate in the voting the Shareholders - in case of shareholders-legal entities the persons
designated pursuant to article 20.1 - must sign the attendance book, recording the number of shares represented by
them.
20.3. Every share entitles the holder thereof to cast one vote.
20.4. In a General Meeting of Shareholders, no votes may be cast for shares held by the Company or by any subsidiary
thereof, nor may votes be cast for a share for which either of them holds a depositary receipt for a share.
20.5. The sum of the shares for which no voting rights may be exercised according to Dutch law shall be disregarded
in determining the extent to which the Shareholders are entitled to vote, are present or represented, or to which extent
the share capital is provided or represented.
20.6. Resolutions passed in a General Meeting of Shareholders shall be adopted by an absolute majority of the votes
validly cast in a meeting in which at least half of the Shareholders is present or represented. The votes cast shall not
49746
include votes attaching to shares in respect of which the Shareholder has not taken part in the vote or has abstained or
has returned a blank or spoilt ballot paper.
20.7. The votes shall be cast orally, unless the chairman of the meeting decides otherwise.
20.8. In case of a tie in the vote, the proposal shall be deemed to have been rejected.
20.9. In a General Meeting of Shareholders in which the entire issued capital is represented valid resolutions can be
adopted provided they are adopted unanimously, even if the requirements in respect of the convening and holding of
meetings have not been complied with.
20.10. The Management Board shall keep a record of the adopted resolutions. This record shall be made available at
the Company's office for inspection by the Shareholders. Each Shareholder shall, upon request, be provided with a copy
of or extract from this record at no more than the actual costs.
Art. 21. Adoption of resolutions outside a General Meeting of Shareholders.
21.1. Shareholders may also adopt resolutions without convening a meeting of Shareholders, provided that all Share-
holders have declared in writing (including all generally accepted means of communication) to be in favour of the resolution
and provided that the Managing Director or Managing Directors, have had the opportunity to cast an advisory vote.
Art. 22. Merger, division, amendment to the articles of association, dissolution.
22.1. The General Meeting may resolve to merge the Company, to divide the Company, to amend the Articles of
Association or to dissolve the Company.
22.2. Those who convene a General Meeting of Shareholders in which a proposal is made to adopt a resolution to
amend the Articles of Association or to dissolve the Company must deposit a copy of the proposal, stating the verbatim
text of the proposed amendment, at the offices of the Company for inspection by the Shareholders. The proposal must
be deposited at the same time as the notice of the meeting and kept there until after the close of the meeting. The
Shareholders must be given the opportunity to obtain a copy of the proposal described in the previous sentence from
the day on which the convening notice for that meeting is dispatched until the day of the General Meeting of Shareholders.
Such copies shall be provided free of charge.
22.3. In the event that a resolution to dissolve the Company is adopted, the liquidation shall be arranged by the
Management Board, unless the court should appoint another liquidator or other liquidators. If a resolution to liquidate
the Company is passed, a resolution regarding the remuneration to be paid to the liquidator, or the joint liquidators,
must be passed at the same time.
22.4. The Articles of Association shall, as far as possible, remain effective during the process of liquidation.
22.5. The liquidation surplus shall be distributed to Shareholders and other parties entitled thereto in proportion to
their respective rights.
22.6. After the liquidation has been completed, the books and records of the dissolved Company shall remain in custody
of a person to be appointed for that purpose by the General Meeting for a period of seven years.
Statuten van UPRN 1 SE
Statuten
Art. 1. Definities.
1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:
- orgaan: het bestuur of de algemene vergadering;
- vennootschap: deze Societas Europaea;
- algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders;
- algemene vergadering van aandeelhouders: bijeenkomst van aandeelhouders;
- bestuurder(s): de bestuurder(s) in de zin van de wet, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen;
- bestuur: het orgaan gevormd door de bestuurder(s);
- aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen in het kapitaal van de vennootschap, zijnde een natuurlijk
persoon of een rechtspersoon.
Art. 2. Naam en zetel.
2.1 De vennootschap draagt de naam: UPRN 1 SE.
2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.
2.3 Zolang de vennootschap haar statutaire zetel in Nederland heeft, dient het hoofdbestuur van de vennootschap
gelegen te zijn in Nederland.
Art. 3. Doel.
3.1 De vennootschap heeft ten doel:
- het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van vennootschappen of ondernemingen;
49747
- het samenwerken met-, het voeren van bestuur over- en het verlenen van adviezen en andere diensten aan ven-
nootschappen of ondernemingen;
- het opnemen en verstrekken van geldleningen;
- het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennoot-
schappen of ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of van derden;
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen; en
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten,
alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin van het woord.
Art. 4. Kapitaal en aandelen.
4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd drieëndertig duizend éénhonderd vijfentwintig euro (€
733.125,--) en is verdeeld in negenentwintig duizend driehonderd vijfentwintig (29.325) aandelen van nominaal vijfent-
wintig euro (€ 25,--) elk.
4.2 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
4.3 Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
4.4 Indien aandelen of rechten op aandelen tot een gemeenschap behoren kunnen de deelgenoten zich slechts tege-
nover de vennootschap doen vertegenwoordigen door een persoon, daartoe schriftelijk door hen allen gemachtigd.
Art. 5. Uitgifte.
5.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering dat tevens de koers en de
verdere voorwaarden van uitgifte bevat.
5.2 De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
De algemene vergadering kan een ander orgaan aanwijzen om de bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld uit te
oefenen en wel voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren.
Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
5.3 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing
een volledige tekst daarvan neer bij het handelsregister.
5.4 De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave bij het handelsregister, met
vermelding van het aantal.
5.5 Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk
bedrag van zijn aandelen behoudens het bepaalde in de wet.
Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.
5.6 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in
een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres.
5.7 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende vier weken na verzending van de aankondiging aan de
aandeelhouders.
5.8 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge lid 2 van dit artikel aangewezen orgaan,
indien dit bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als
bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.
Zodanige aanwijzing kan slechts geschieden indien het betreffende orgaan tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen
als het tot uitgifte bevoegde orgaan als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
De aanwijzing geldt slechts zolang een aanwijzing als bedoeld in lid 2 van kracht is.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.
5.9 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing
is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het
geplaatste kapitaal in de vennootschap is vertegenwoordigd.
De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer bij het handelsregister.
5.10 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht.
Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds
verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
49748
5.11 Bij het nemen van een aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden
dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap
het zal hebben opgevraagd.
Art. 6. Eigen aandelen.
6.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
6.2 Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte eigen aandelen is nietig, tenzij wordt verkregen onder
algemene titel.
6.3 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen slechts verkrijgen om niet of met inachtneming van het bepaalde
in de wet.
6.4 Met betrekking tot vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen is het bepaalde in de blok-
keringsregeling in deze statuten van toepassing.
6.5 Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.
Art. 7. Verboden steunverlening.
7.1 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten
daarvan, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich
hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
7.2 Het in het vorige lid vervatte verbod geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of
verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij als bedoeld in de wet.
Art. 8. Kapitaalvermindering.
8.1 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen
of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
8.2 Op een dergelijk besluit en de uitvoering daarvan is het bepaalde in de wet van toepassing.
Art. 9. Certificering, verpanding en vestiging van vruchtgebruik op aandelen.
9.1 De vennootschap verleent geen medewerking aan uitgifte van certificaten van aandelen van de vennootschap.
9.2 Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd.
Aan de vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen kan het stemrecht niet worden toegekend, tenzij het stemrecht
toekomt aan een vruchtgebruiker op grond van artikel 2:88 lid 3 laatste volzin van het Burgerlijk Wetboek.
Art. 10. Aandeelhoudersregister.
10.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met
vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede
van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op
aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen alsmede de datum van erkenning
of betekening.
10.2 Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de ven-
nootschap bekend is.
10.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van de wet.
10.4 Alle aantekeningen in en afschriften of uittreksels uit het aandeelhoudersregister zullen worden ondertekend door
een bestuurder.
Art. 11. Levering van aandelen.
11.1 Voor de uitgifte en levering van een aandeel op naam of de levering of afstanddoening van een beperkt recht
daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de
betrokkenen partij zijn.
11.2 De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het in lid 1 bepaalde
werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap.
Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden
rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeen-
komstig het daaromtrent bepaalde in de wet.
Art. 12. Bestuur.
12.1 De vennootschap heeft een bestuur bestaande uit ten minste drie bestuurders. Het aantal bestuurders wordt
met inachtneming van dit minimum door de algemene vergadering vastgesteld. Is het aantal bestuurders minder dan één,
dan benoemt de algemene vergadering zo spoedig mogelijk een of meer nieuwe bestuurders. Het bestuur benoemt uit
zijn midden een voorzitter.
Een bestuurder rechtpersoon wijst voor de uitoefening van zijn bevoegdheden een natuurlijk persoon als vertegen-
woordiger aan.
49749
12.2 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van ten hoogste zes jaar. Zij
kunnen een of meerdere malen worden herbenoemd, steeds voor een periode van ten hoogste zes jaar.
12.3 Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
12.4 Een schorsing kan, ook na een of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.
12.5 De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere bestuurder afzonderlijk, bepaald door de
algemene vergadering.
Art. 13. Besluitvorming bestuur.
13.1 Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van het in totaal door alle bestuurders uit te brengen aantal
stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
13.2 In de vergaderingen van het bestuur brengt iedere bestuurder één stem uit. In geval van staking van stemmen is
de stem van de voorzitter van het bestuur doorslaggevend.
13.3 Iedere bestuurder kan zich in de bestuursvergaderingen uitsluitend door een mede-bestuurder doen vertegen-
woordigen. Die vertegenwoordiging dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht.
13.4 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en geen van hen zich
tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
13.5 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een
belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of haar onderneming, waaronder in ieder
geval:
a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een
andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap
of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde
van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans
opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennoot-
schap, door haar of een dochtermaatschappij.
13.6 Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in lid 5 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur
of de bestuurders niet aan.
Art. 14. Belet of ontstentenis.
14.1 In geval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders berust het bestuur van de vennootschap bij de
overblijvende bestuurders dan wel de enig overgebleven bestuurder.
In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur van de vennoot-
schap tijdelijk bij een of meer door de algemene vergadering daartoe aangewezen personen.
Art. 15. Vertegenwoordiging.
15.1 De vennootschap wordt slechts vertegenwoordigd door:
- hetzij het bestuur;
- hetzij iedere bestuurder.
15.2 In alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een bestuurder, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd door het bestuur. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe
aan te wijzen, waardoor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging zoals beschreven in de vorige volzin, komt te vervallen.
Onverminderd de bevoegdheid tot vertegenwoordiging, is het handelen door het bestuur namens de vennootschap in
alle gevallen van tegenstrijdig belang onderworpen aan uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de algemene verga-
dering.
Art. 16. Geheimhouding. De directeuren mogen, ook nadat zij hun functie hebben beëindigd, geen ruchtbaarheid geven
aan de te hunner beschikking staande inlichtingen over de vennootschap waarvan de openbaarmaking de belangen van de
vennootschap zou kunnen schade, behalve in gevallen waarin deze openbaarmaking krachtens de wet of om reden van
algemeen belang verplicht of toegestaan zijn.
Art. 17. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag.
17.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
17.2 Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ver-
gadering met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening
(bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
49750
Tenzij artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, maakt het bestuur binnen voornoemde
termijn een jaarverslag op.
17.3 Indien en voorzover het dienaangaande in de wet bepaalde op de vennootschap van toepassing is, zal door de
algemene vergadering opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel
2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de door het bestuur ontworpen jaarrekening alsmede - indien opgemaakt
- het jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.
17.4 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
17.5 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking bij het handelsregister indien en voorzover de wet dit vereist.
Art. 18. Winstbestemming.
18.1 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts
uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het
kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
18.2 De winst blijkende uit de door de algemene vergadering vastgestelde winst- en verliesrekening staat ter be-
schikking van de algemene vergadering.
18.3 De vennootschap mag tussentijds slechts (winst-)uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 1 is voldaan
blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig de wet en na voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering.
De vennootschap legt de vermogensopstelling bij het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het
besluit tot uitkering wordt bekendgemaakt.
18.4 Op door de vennootschap gehouden aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan vindt geen uitkering ten
behoeve van de vennootschap plaats.
18.5 Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen of certificaten van aandelen, waarop ingevolge het in
lid 4 bepaalde geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaatsvindt, niet mee.
18.6 De vordering tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaars-
telling.
Art. 19. Vergaderingen van aandeelhouders.
19.1 Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
gehouden. In deze jaarvergadering worden onder meer - tenzij de termijn als bedoeld in artikel 17.2 van deze statuten
overeenkomstig het aldaar bepaalde is verlengd -, aan de orde wordt gesteld:
- de behandeling van het jaarverslag;
- de vaststelling van de jaarrekening;
- het verlenen van decharge aan het bestuur voor het door haar in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;
- het verlenen van een opdracht aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, voorzover
wettelijk vereist;
- de taal waarin de posten van de eerstvolgende jaarrekening worden gesteld en de geldeenheid.
19.2 De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel
heeft.
19.3 Het verzoek tot bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders en tot vaststelling van de agenda
kan worden gedaan door een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigen. Indien na de indiening van het verzoek de algemene vergadering van aandeelhouders niet
tijdig, in elk geval binnen een termijn van twee maanden, wordt gehouden, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
de bijeenroeping binnen een bepaalde termijn gelasten of de aandeelhouders die het verzoek hebben gedaan machtigen
tot bijeenroeping.
19.4 Tenzij de laatste zin van het vorige artikel van toepassing is, geschiedt de bijeenroeping van aandeelhouders door
het bestuur of door een bestuurder door middel van oproepingsbrieven welke moeten worden verzonden niet later dan
op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.
19.5 De oproepingsbrieven vermelden plaats, dag en uur van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen.
Een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen,
kan of kunnen verzoeken om een of meer nieuwe punten op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders
te plaatsen indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft
ontvangen.
19.6 De oproepingsbrieven worden verzonden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister.
Wanneer een of meer oproepingsbrieven, overeenkomstig het hiervoor bepaalde verzonden, hun bestemming niet
bereiken, dan zal dit geen invloed uitoefenen op de geldigheid van de algemene vergadering van aandeelhouders en de
daarin te nemen besluiten.
19.7 De algemene vergadering van aandeelhouders voorziet zelf haar voorzitterschap.
Indien hij niet aanwezig is voorziet de algemene vergadering van aandeelhouders zelf in haar leiding.
49751
19.8 Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden tenzij een
notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
De notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en vastgesteld en getekend door de voorzitter van
de vergadering en de door deze bij de aanvang van de vergadering aangewezen secretaris van de vergadering.
De notulen of het notarieel proces-verbaal strekken tot bewijs van het in de vergadering beslotene.
Art. 20. Besluitvorming in vergadering.
20.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord
te voeren. Een aandeelhouder-rechtspersoon wijst voor de uitoefening van zijn bevoegdheden een natuurlijke persoon
als vertegenwoordiger aan. Deze persoon dient zonder last of ruggespraak namens de aandeelhouder-rechtspersoon te
kunnen besluiten en handelen.
De bestuurder(s) heeft (hebben) als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.
20.2 Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders - in geval van aandeelhouders-rechts-
personen de personen aangewezen op grond van artikel 20.1 - de presentielijst tekenen, onder vermelding van het aantal
door ieder vertegenwoordigde aandelen.
20.3 Elk aandeel geeft recht op één stem.
20.4 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene
vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de
certificaten houdt.
20.5 Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre
het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de
wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
20.6 De besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen met volstrekte meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de aandeelhouders aanwezig of verte-
genwoordigd is.
De uitgebrachte stemmen omvatten niet de stemmen die verbonden zijn aan aandelen ten aanzien waarvan de aan-
deelhouder niet aan de stemming heeft deelgenomen of zich heeft onthouden, dan wel blanco of ongeldig heeft gestemd.
20.7 Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt.
20.8 Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
20.9 In een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is,
kunnen, mits met algemene stemmen, rechtsgeldige besluiten worden genomen ook al zijn de voorschriften met be-
trekking tot het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
20.10 Het bestuur van de vennootschap houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten
kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of
uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
Art. 21. Besluitvorming buiten vergadering. Besluitvorming door aandeelhouders kan op andere wijze dan in een ver-
gadering van aandeelhouders plaatsvinden doordat alle aandeelhouders zich schriftelijk (waaronder begrepen elk gangbaar
communicatiemiddel) vóór het voorstel hebben verklaard, en mits de bestuurder(s) de gelegenheid heeft (hebben) gehad
raadgevende stem uit te brengen.
Art. 22. Fusie, splitsing, statutenwijziging, ontbinding.
22.1 De algemene vergadering kan besluiten tot fusie, splitsing, wijziging van de statuten en tot ontbinding van de
vennootschap.
22.2 Degenen, die een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders hebben gedaan, waarin een
voorstel tot het nemen van een besluit tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moeten tegelijkertijd met
de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van
de vennootschap neerleggen ter inzage van aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.
De aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging tot die van de algemene
vergadering van aandeelhouders een afschrift van het voorstel, zoals in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen.
Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.
22.3 Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door het bestuur tenzij de rechter
een andere vereffenaar of andere vereffenaars benoemt.
Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald door de vereffenaar, of de vereffenaars gezamenlijk,
te genieten.
22.4 Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
22.5 Het overschot na vereffening wordt aan aandeelhouders en andere rechthebbenden in verhouding tot ieders
recht uitgekeerd.
49752
22.6 Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende zeven
jaren blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering te benoemen."
<i>4. Conséquences du transfert du siège social proposé sur l'implication des travailleursi>
La Société n'a pas d'employés.
Ses affaires et la réalisation de l'objet social de la Société sont mises en œuvre sans exception par les membres du
conseil d'administration, lesquels n'ont contracté aucun contrat de travail avec la Société. Par conséquent la Directive
2008/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'impli-
cation des travailleurs et les dispositions de la loi du 25 août 2006 la transposant ne sont pas applicables.
<i>5. Calendrier pour le transfert proposéi>
Il est proposé que les démarches et actions nécessaires en vue du transfert du siège social de la Société du Grand-
Duché de Luxembourg vers les Pays-Bas aient lieu et que le transfert prenne effet comme suit:
Action et démarches à entreprendre - Calendrier pour la mise en œuvre
Publication du présent projet de transfert - 28 avril 2008
Une période de deux mois durant laquelle les créanciers de la Société peuvent demander la constitution de sûretés
au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale - 28 juin 2008
Une période d'un mois durant laquelle les actionnaires et les créanciers de la Société ont le droit de consulter le
présent projet de transfert et le rapport du conseil d'administration y relatif - 28 mai 2008
Tenue d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société délibérant sur le projet de transfert
prévu par le présent projet - 28 juin 2008
Enregistrement, dépôt et publication de l'acte notarié de transfert, délivrance d'un certificat par un notaire - 7 juillet
2008
Signature d'un acte notarié par un notaire néerlandais confirmant les statuts de la Société - 8 juillet 2008
Immatriculation au Registre de Commerce de la Chambre de Commerce Néerlandaise pour Amsterdam - 10 juillet
2008
Notification de l'immatriculation du Registre de Commerce de la Chambre de Commerce Néerlandaise pour Ams-
terdam au Registre de Commerce et des Sociétés à Lxuembourg - Avant le 10 août 2008
Radiation de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg - Avant le 15 août 2008
Il est proposé que le transfert du siège social de la Société prenne effet le ou vers le 5 août 2008 au plus tard.
Néanmoins il convient de noter que le calendrier ci-dessus est seulement indicatif dans la mesure où certaines dé-
marches impliquent l'intervention d'autorités publiques sur lesquelles la Société n'a aucun influence.
<i>6. Protection des actionnaires et des créanciers de la Sociétéi>
Le transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg aux Pays-Bas n'aura comme conséquence
ni la liquidation ni la dissolution de la Société ni la création d'une nouvelle entité juridique. Tous les droits et obligations
de la Société vis-à-vis de ses actionnaires et vis-à-vis de ses créanciers continueront à exister.
Les créanciers de la Société peuvent demander la constitution de sûretés au Tribunal d'Arrondissement de et à Lu-
xembourg siégeant en matière commerciale endéans un délai de deux mois à partir de la date de publication du présent
projet de transfert.
Durant une période d'un mois avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la Société délibérant sur le projet de transfert, tout créancier ou actionnaire de la Société a le droit de consulter et
recevoir sans frais une copie du présent projet de transfert et du rapport du conseil d'administration sur les justifications
économiques et juridiques du transfert du siège social de la Société et expliquant les conséquences d'un tel transfert pour
les actionnaires et les créanciers de la Société.
<i>7. Approbation par les actionnairesi>
Le présent projet de transfert sera soumis à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société au plus
tôt deux mois après la date de sa publication au Mémorial conformément aux articles 101-3 et 101-6 de la Loi et de
l'article 8 (6) du Règlement.
<i>On behalf of the board of directors of the Company:
i>Paul de Haan / Dennis Bosje
<i>Directori> / <i>Directori>
Référence de publication: 2008053140/260/1300.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2008, réf. LSO-CP07761. - Reçu 84,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080061272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2008.
49753
CalEast French Investments 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 127.635.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution de l'associé unique prise en date du 22 février 2008 qu'a été nommé aux fonctions de gérant
de la société en remplacement de Mr Laurent Bélik, démissionnaire, avec effet au 23 février 2008:
- Mr Ernest Fiorante, demeurant professionnellement au 200, East Randolph Street, IL-60601, Chicago, Etats-Unis
d'Amérique.
Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008046179/2570/19.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08250. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
CalEast Holdings 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 132.743.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution de l'associé unique prise en date du 22 février 2008 qu'a été nommé aux fonctions de gérant
de la société en remplacement de Mr Laurent Bélik, démissionnaire, avec effet au 23 février 2008:
- Mr Ernest Fiorante, demeurant professionnellement au 200, East Randolph Street, IL-60601, Chicago, Etats-Unis
d'Amérique.
Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008046183/2570/19.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08248. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
CalEast Holdings 5 Properties 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 9.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 135.508.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution de l'associé unique prise en date du 22 février 2008 qu'a été nommé aux fonctions de gérant
de la société en remplacement de Mr Laurent Bélik, démissionnaire, avec effet au 23 février 2008:
- Mr Ernest Fiorante, demeurant professionnellement au 200, East Randolph Street, IL-60601, Chicago, Etats-Unis
d'Amérique.
Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
49754
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008046177/2570/19.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08251. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
European Investments Associates (E.I.A.) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 62.165.
<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 20 marsi>
<i>2008i>
1. Monsieur Cornelius Martin BECHTEL a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statutaire de 2009.
2. Madame Monique JUNCKER a été reconduite dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée gé-
nérale statutaire de 2009.
3. Monsieur Gérard BIRCHEN a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
statutaire de 2009.
4. Monsieur Sinan SAR a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale sta-
tutaire de 2009.
5. Monsieur Pol François LAMBERT a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statutaire de 2009.
6. Monsieur Pol François LAMBERT a été nommé comme président du conseil d'administration.
7. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire aux
comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.
Luxembourg, le 21 mars 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour EUROPEAN INVESTMENTS ASSOCIATES (E.I.A.) S.A.
i>Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008046276/29/29.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08305. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Mallard Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 72.320.
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 21 Décembre 2007 a élu comme administrateurs:
- Össur Kristinsson, né le 5 Novembre 1943 à Reykjavik en Islande, et résidant au Saebolsbraut 42, IS-200 Kopavogur,
en Islande;
- Björg Rafnar, né le 1
er
Septembre 1945 à Eyjafjardarsveit en Islande, et résidant au Saebolsbraut 42, IS-200 Kopavogur,
en Islande;
- Björn Jonsson, né le 25 Septembre 1963 à Reykjavik en Islande, et résidant au Op der Tonn 36, L-6188 Gonderange,
au Luxembourg;
et comme commissaire aux comptes Rothley Company Limited, P.O.Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town,
Tortola British Virgin Islands.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
49755
Luxembourg, le 27 décembre 2007.
<i>Pour Mallard Holding S.A.
i>Kaupthing Bank Luxembourg S.A.
Signature
Référence de publication: 2008046270/1021/23.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2008, réf. LSO-CN00028. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Torre Ingles S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 53.325.
Constituée suivant acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, notaire de résidence à L-LUXEMBOURG, en date du 19
décembre 1995, publié au Mémorial C n
o
101 du 27 février 1996;
Modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois par devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à
L-LUXEMBOURG, en date du 09 octobre 2003, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
o
1189 du 12 novembre
2003.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société TORRE INGLES S.A., tenue
au siège social le 21 décembre 2007 que:
- ont démissionné de leur fonction d'administrateur avec effet immédiat:
* Monsieur Giovanni BRUSCHETTI et de Madame Rossella BRUSCHETTI, tous les deux demeurant à 10, Via Genzana,
CH-6900 MASSAGNO.
- ont été nommé en tant que nouveaux administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009:
* Mademoiselle Jeanne PIEK, employée privée, demeurant professionnellement au 15, boulevard Roosevelt, L-2450
Luxembourg;
- Monsieur Lionel CAPIAUX, employé privé, demeurant professionnellement au 15, boulevard Roosevelt, L-2450
Luxembourg.
Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
Conformément à l'article 12 des statuts de la société les nouveaux administrateurs sont autorisés d'engager la société
par la signature conjointe.
Luxembourg, le 11 mars 2008.
<i>Pour la société TORRE INGLES S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2008046285/687/31.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05397. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Saxi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 74.082.
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 21 Décembre 2007 a élu comme administrateurs:
- Waverton Group Limited, P.O.Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town, Tortola British Virgin Islands,
- Birefield Holdings Limited, P.O.Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town, Tortola British Virgin Islands,
- Starbrook International Limited, P.O.Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town, Tortola British Virgin Islands
et comme commissaire aux comptes Rothley Company Limited, P.O.Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town,
Tortola British Virgin Islands.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
49756
Luxembourg, le 31 décembre 2007.
<i>Pour Saxi Holding S.A.
i>Kaupthing Bank Luxembourg S.A.
Signature
Référence de publication: 2008046274/1021/20.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2008, réf. LSO-CN00030. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Kilbroney Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 92.624.
<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires en date du 26 mars 2008i>
1. Monsieur Jean FELL a été reconduit dans ses mandat d'administrateur, d'administrateur-délégué et de président du
conseil d'administration, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
2. Monsieur Cornelius Martin BECHTEL a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statutaire de 2013.
3. Monsieur Laurence Joseph GOODMAN a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'as-
semblée générale statutaire de 2013.
4. Monsieur John Mc LAUGHLIN a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statutaire de 2013.
5. Monsieur David MURPHY a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
statutaire de 2013.
6. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire aux
comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
Luxembourg, le 27 mars 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour KILBRONEY FINANCE S.A.
i>Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008046280/29/27.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00867. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Meson Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 79.171.
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 21 Décembre 2007 a élu comme administrateurs:
- Vilhjálmur Thorsteinsson, né le 30 décembre 1965 à Copenhague et résidant à Baugatangi 6, IS 101 Reykjavik, Iceland
- Birefield Holdings Limited, P.O.Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town, Tortola British Virgin Islands,
- Starbrook International Limited, P.O.Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town, Tortola British Virgin Islands
et comme commissaire aux comptes Rothley Company Limited, P.O.Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town,
Tortola British Virgin Islands.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2007.
<i>Pour Meson Holding S.A.
i>Kaupthing Bank Luxembourg S.A.
Signature
Référence de publication: 2008046271/1021/20.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2008, réf. LSO-CN00029. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
49757
Kaytwo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.000.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 17 décembre 2007i>
1. L'associé unique prend acte de la nomination de:
- Madame Anne RASSEL, née le 13 janvier 1971, à Messancy (Belgique), employée de banque, demeurant 28, rue de
Thiaumont, B-6700 Heinsch Arlon,
- Monsieur Jean-Louis FREY, né le 12 septembre 1969, à Metz (France), employé de banque, demeurant 22, rue de la
République, F-57330 Kanfen,
de leurs fonctions de gérants de la Société, avec effet au 17 décembre 2007.
2. L'associé unique décide de fixer à trois le nombre de gérants.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008046269/1021/20.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2008, réf. LSO-CN00027. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080050474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
European Management Fiduciary S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 69.966.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 5i>
<i>mars 2007i>
Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:
- d'accepter de renouveler le mandat d'administrateur délégué de Monsieur René Christian JANNES. Son mandat
viendra à échéance le 31 mai 2011.
- de transformer le mandat à durée indéterminée d'administrateur délégué de Monsieur Bernard RIVOIRE en mandat
à durée déterminée. Son mandat viendra à échéance le 31 mai 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2007.
Certifié sincère et conforme
Signature
Référence de publication: 2008046256/1383/21.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07305C. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Sitka S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 74.942.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 18 mars 2008 a renouvellé les mandats des administrateurs et
du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Marc KOEUNE
- Madame Nicole THOMMES
- Madame Andrea DANY
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg
49758
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2014.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2008046257/693/23.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2008, réf. LSO-CP00232. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Berkeley Investment Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 107.701.
En date du 31 mars 2008 l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires a décidé:
- d'accepter la démission avec effet au 12 février 2008 de Mr Livius Gorecka avec adresse privée au 104, rue du
Gruenewald, L-1912 Luxembourg de son mandat d' Administrateur de la Société
- d'accepter la nomination avec effet au 12 février 2008 de Mr John Kleynhans avec adresse professionnelle au 6, rue
Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg en tant que nouvel Administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale qui
se tiendra en 2010.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008046258/1012/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2008, réf. LSO-CP01153. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Sopalim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 100.341.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 18 mars 2008 a renouvellé les mandats des administrateurs et
du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Marc KOEUNE
- Madame Nicole THOMMES
- Madame Andrea DANY
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg
(anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg)
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2012.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2008046262/693/24.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2008, réf. LSO-CP00220. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
49759
Famy Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 96.072.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 8 mars 2007 a renouvellé les mandats des administrateurs et
du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Marc KOEUNE
- Madame Nicole THOMMES
- Madame Andrea DANY
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg
Le commissaire aux comptes est La société Studio Commercialista Francesco Ippolito, ayant son siège social au 11,
via Cantonale, CH-6900 Lugano.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2013.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2008046264/693/24.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2008, réf. LSO-CP00159. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Richie Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 134.820.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg en date du 12 mars 2008 a pris à l'unanimité les résolutions
suivantes:
1. L'assemblée générale prend acte de la démission de la société CeDerLux-Services S.à r.l. ayant son siège social au
18, rue de L'Eau, L-1449 Luxembourg, de son mandat de commissaire aux comptes. L'assemblée décide de nommer en
son remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes la société Studio Commerciale e Fiduciario Michele Ro-
merio, ayant son siège social à Carabella, 6582 Pianezzo, Suisse.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2012.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2008046252/693/20.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2008, réf. LSO-CP00243. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Barby Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 134.094.
Suite à une erreur matérielle dans la notification déposée le 18 février 2008 la présente notification rectificative annule
et remplace la notification Référence: LO80025937.05. Veuillez prendre note que lors de l'inscription du transfert des
parts sociales de la Société qui a eut lieu en date du 11 décembre 2007, le nouvel actionnaire a été enregistré auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés avec des erreurs dans son nom et dans son numéro de registre du commerce:
49760
Ainsi Perlagonia 1 Holding GmbH, ayant son adresse à Bankgasse 2 1010 Wienn, Autriche, enregistrée au Gerchit
Handelsgericht Wien Autriche sous le numéro FN 29462Z est devenue le seul actionnaire de la société Barby Holding
S.à r.l suite au dit transfert et détient depuis cette date la totalité des parts sociales de la Société (1,250.000 parts sociales).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Barby Holding S.à.r.l
i>Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Référence de publication: 2008046254/683/22.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07662. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080050642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Reis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 35.010.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 19 mars 2008 a renouvellé les mandats des administrateurs et
du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Marc KOEUNE
- Madame Nicole THOMMES
- Madame Andrea DANY
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l, avec siège social à 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2014.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2008046265/693/23.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2008, réf. LSO-CP00137. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Imperial Holding S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 38.107.370,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 117.750.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 25 juillet 2007i>
Il résulte des décisions de l'assemblée générale de la Société du 25 juillet 2007:
- que l'assemblée a accepté la démission de:
* Mme. Véronique Cochais Widmer, née le 11 décembre 1962, à Courbevoie, France, avec adresse professionnelle
112, avenue Kléber, F-75116 Paris, France, de sa fonction de commissaire aux comptes de la Société avec effet au 25
juillet 2007.
- que l'assemblée a nommé:
* M. David Pearson, de nationalité américaine, né le 13 décembre 1968 à Washington D.C., Etats Unis d'Amérique,
avec adresse professionnelle 1001 Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington, DC 20004-2505, Etats Unis
d'Amérique,
comme nouveau commissaire aux comptes de la Société avec effet au 25 juillet 2007 et pour une période indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
49761
Luxembourg, le 31 mars 2008.
<i>Imperial Holding S.C.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008046281/2508/26.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2008, réf. LSO-CP01181C. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
K Invest Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 92.457.
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 15 Aout 2007 a élu comme administrateurs:
- Bjorn Jonsson, né le 25 Septembre 1963 à Reykjavik en Islande, et résidant au 36, Op der Tonn, L-6188, Gonderange,
au Luxembourg;
- Thordur Emil Olafsson, né le 4 Janvier 1974 à Reykjavik en Islande, et résidant au 51C, rue de la Montagne, Junglister,
L-6136 au Luxembourg;
- Eggert J. Hilmarsson, né le 10 Septembre 1968 à Reykjavik en Islande, et résidant au 57, Op der Tonn, L-6188,
Gonderange, au Luxembourg,
et comme commissaire aux comptes KPMG Endurskodun hf., Vegmuli 3, IS-108 Reykjavik, Iceland .
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2007.
<i>Pour K. Invest Holding S.A.
i>Kaupthing Bank Luxembourg S.A.
Signature
Référence de publication: 2008046267/1021/22.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2007, réf. LSO-CK07074. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Neried Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 29.328.
Constituée en date du 18 novembre 1988 suivant acte reçu par Maître Réginald NEUMAN, notaire alors de résidence à
L - LUXEMBOURG, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
o
41 du 15 février 1989;
Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 30 janvier 2003 suivant acte reçu par Maître
Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence à L - LUXEMBOURG, publié au Mémorial Recueil Spécial C n
o
263 du 12
mars 2003.
Il résulte d'une lettre adressée à la société NERIED FINANCE S.A. en date du 07 février 2008 que Monsieur Roland
LEGUIZAMON, demeurant à CH - 1276 GINGINS, Chemin du Mont d'Eau du Milieu, 13 a démissionné avec effet im-
médiat de sa fonction d'administrateur.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 25 février
2008 que Monsieur Juan Manuel CID, employé privé, né le 14 mai 1965 à E - XUNQUEIRA DE AMBIA (ORENSE) et
demeurant professionnellement à CH - 1205 GENEVE, 8, rue St. Léger, a été nommée comme administrateur en rem-
placement de Monsieur Roland LEGUIZAMON, démissionnaire. Le mandat de Monsieur Juan CID se terminera lors de
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.
Conformément à l'article 12 des statuts coordonnés de la société le nouvel administrateur. Monsieur Juan Manuel
CID, est autorisé d'engager la société par la signature conjointe à deux.
49762
Luxembourg, le 06 mars 2008.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2008046290/687/28.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05401. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Ernst & Young, Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 47.771.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire du 18 octobre 2007 que les mandats des administra-
teurs et du réviseur d'entreprise ont été renouvelés comme suit, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2008:
<i>CONSEIL D'ADMINISTRATION:i>
- Jean-Marie Gischer, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 26 février 1956 à Arlon (Belgique), demeurant
au 7, rue des Frênes, B-6700 Arlon;
- Jean-Michel Pacaud, Réviseur d'Entreprises, né le 8 novembre 1962 au Mans (France), demeurant au 27, rue Léandre
Lacroix, I-1913 Luxembourg;
- Raymond Schadeck, Réviseur d'Entreprises et Eypert Comptable, né le 11 août 1955 à Luxembourg (Grand Duché
de Luxembourg), demeurant au 44, rue des Prunelles, L-5639 Mondorf-les-Bains;
Werner Weynand, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St. Vith (Belgique), demeurant
6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.
<i>REVISEUR D'ENTREPRISES:i>
- BDO Compagnie Fiduciaire, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, RCS Lu-
xembourg B 71.178.
Münsbach, le 5 mars 2008.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2008046293/556/28.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00568. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Open Mind S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4772 Pétange, 41B, rue de la Piscine.
R.C.S. Luxembourg B 78.159.
Le bilan au 31.12.2003 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008046307/317/13.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2008, réf. LSO-CP00426. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
49763
CB Luxembourg V, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 37.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 119.732.
Il résulte d'un contrat de transfert de part sociales signé en date du 19 octobre 2007, que
- Fourth Cinven Fund (no 1) Limited Partnership a transféré 721 parts sociales
- Fourth Cinven Fund (no 2) Limited Partnership a transféré 752 parts sociales
- Fourth Cinven Fund (no 3-VCOC) Limited Partnership a transféré 746 parts sociales
- Fourth Cinven Fund (no 4) Limited Partnership a transféré 712 parts sociales
- Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership a transféré 401 parts sociales
à
Fourth Cinven Fund FCPR, un fonds commun de placement à risques français, géré par Cinven SA, une société anonyme
ayant son siège social au 4, Square Edouard VII, 75009 Paris, France, enregistré dans le Registre de Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro B 424 123 487 et autorisé par les Autorité des marchés financiers sous le numéro
GP07000004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2008.
<i>CB Luxembourg V
i>Signature
Référence de publication: 2008046309/7978/25.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2008, réf. LSO-CN00729. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Ernst & Young Tax Advisory Services, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 88.073.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'associé unique du 18 octobre 2007 que les mandats du gérant et du réviseur
d'entreprise ont été renouvelés comme suit, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes au 30 juin 2008:
<i>GERANT:i>
- Ernst & Young Luxembourg, société anonyme, ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,
enregistrée sous le numéro RCS Luxembourg B 88.019.
<i>REVISEUR D'ENTREPRISES:i>
- BDO Compagnie Fiduciaire, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, RCS Lu-
xembourg B 71.178.
Münsbach, le 5 mars 2008.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2008046296/556/22.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00569. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Société de Participations Antares S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 29.288.
Constituée suivant acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, notaire alors de résidence à L - LUXEMBOURG, en date
du 18 novembre 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial C no 38 du 11 février 1989;
49764
Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 30 janvier 2003 suivant acte reçu par Maître
Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence à L - LUXEMBOURG, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
o
262 du
12 mars 2003.
Il résulte d'une lettre adressée à la société SOCIETE DE PARTICIPATIONS ANTARES S.A. en date du 07 février 2008
que Monsieur Roland LEGUIZAMON, demeurant à CH- 1276 GINGINS, Chemin du Mont d'Eau du Milieu, 13 a démis-
sionné avec effet immédiat de sa fonction d'administrateur.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 25 février
2008 que Monsieur Juan Manuel CID, employé privé, né le 14 mai 1965 à E - XUNQUEIRA DE AMBIA (ORENSE) et
demeurant professionnellement à CH - 1205 GENEVE, 8, rue St. Léger, a été nommée comme administrateur en rem-
placement de Monsieur Roland LEGUIZAMON, démissionnaire. Le mandat de Monsieur Juan CID se terminera lors de
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.
Conformément à l'article 12 des statuts coordonnés de la société le nouvel administrateur, Monsieur Juan Manuel
CID, est autorisé d'engager la société par la signature conjointe à deux.
Luxembourg, le 06 mars 2008.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2008046289/687/28.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05400. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Compagnie de Révision, Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 32.665.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire du 18 octobre 2007 que les mandats des administra-
teurs et du réviseur d'entreprise ont été renouvelés comme suit, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2008:
<i>CONSEIL D'ADMINISTRATION:i>
- Raymond Schadeck, Réviseur d'Entreprises et Eypert Comptable, né le 11 août 1955 à Luxembourg (Grand Duché
de Luxembourg), demeurant au 44, rue des Prunelles, L-5639 Mondorf-les-Bains;
- Werner Weynand, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St. Vith (Belgique), demeurant
6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.
- Jean-Marie Gischer, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 26 février 1956 à Arlon (Belgique), demeurant
au 7, rue des Frênes, B-6700 Arlon
- Jean-Michel Pacaud, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 8 novembre 1961 Au Mans (France), demeu-
rant au 27, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg
<i>REVISEUR D'ENTREPRISES:i>
- BDO Compagnie Fiduciaire, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, RCS Lu-
xembourg B 71.178.
Münsbach, le 5 mars 2008.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2008046297/556/28.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00573. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Catella Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 61.518.
Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence à L - LUXEMBOURG, en date du 03
novembre 1997, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
o
83 du 09 février 1998;
49765
Statuts modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence
à L - SANEM, en date du 26 janvier 2004, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
o
331 du 24 mars 2004.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social en date du 21 décembre 2007
que les décisions suivantes ont été prises:
- REVILUX S.A., avec siège social à L - 1371 LUXEMBOURG, 223, Val Ste Croix et inscrite au R.C.S. LUXEMBOURG
sous le n
o
B-25.549 a démissionné avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux comptes;
- EWA REVISION S.A., avec siège social à L - 9053 ETTELBRUCK, 45, avenue J.F. Kennedy et inscrite au R.C.S.
LUXEMBOURG sous le n° B-38.937 a été élu comme nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commis-
saire aux comptes démissionnaire. Le mandat du nouveau commissaire aux comptes EWA REVISION S.A. se terminera
lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.
Luxembourg, le 06 février 2008.
<i>Pour la société
i>REVILUX S.A.
Signature
Référence de publication: 2008046286/687/25.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05398. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080050365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Estrada Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 79.661.
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 15 Octobre 2007 a élu comme administrateurs:
- Waverton Group Limited, P.O. Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town, Tortola British Virgin Islands,
- Birefield Holdings Limited, P.O. Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town, Tortola British Virgin Islands,
- Starbrook International Limited, P.O. Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town, Tortola British Virgin Islands
et comme commissaire aux comptes Rothley Company Limited, P.O. Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town,
Tortola British Virgin Islands.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2007.
<i>Pour Estrada Holding S.A.
i>Kaupthing Bank Luxembourg S.A.
Signature
Référence de publication: 2008046299/1021/20.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2008, réf. LSO-CN00026. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Bric S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 18.475.
Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BRIC S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008046314/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2008, réf. LSO-CP00406. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
49766
Javi International S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 28.061.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>JAVI INTERNATIONAL S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008046315/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2008, réf. LSO-CP00409. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080050486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Isidro International S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 11.906.
Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ISIDRO INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008046316/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2008, réf. LSO-CP00411. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Tivoli International Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 25.298.
Le bilan au 30 septembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour TIVOLI INTERNATIONAL HOLDING S.A.
i>Services Généraux de Gestion
Signatures
Référence de publication: 2008046312/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00952. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Index 3D, Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 92.347.
Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rodange, le 04/04/08.
Signature.
Référence de publication: 2008046453/8837/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01767. - Reçu 99,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
49767
Tong International S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.
R.C.S. Luxembourg B 29.630.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TONG INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Administrateur-Déléguei>
Référence de publication: 2008046317/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2008, réf. LSO-CP00436. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080050494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Him-Racing-Kart S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3394 Roeser, 33A, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 57.089.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE REISERBANN, société civile
L-3206 ROESER - B.P. 11
Signature
Référence de publication: 2008046456/2503/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM00892. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
Baumert,s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1243 Luxembourg, 5, rue Felix de Blochausen.
R.C.S. Luxembourg B 62.583.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE REISERBANN, société civile
L-3206 ROESER - B.P. 11
Signature
Référence de publication: 2008046457/2503/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM00893. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.
LFS Multi-Family Office S.A., Société Anonyme,
(anc. LFS Advisory Services S.A.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 115.083.
L'an deux mille huit, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LFS Advisory Services S.A.",
(ci-après la "Société"), ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 115.083, constituée originairement sous la déno-
mination de "ZELENA S.A.", suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 mars 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1152 du 14 juin 2006,
49768
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 février 2007, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1006 du 30 mai 2007, contenant notamment le changement
de la dénomination sociale en "LFS Advisory Services S.A.".
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Kalle NORBERG, consultant financier, demeurant à Hesperange.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Laurent MULLER, économiste, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric MULLER, économiste, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-
rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination de la Société en "LFS Multi-Family Office S.A." et modification afférente de l'article
1
er
des statuts.
2.- Modification de l'objet social afin de donner à l'article 4 des statuts la teneur suivante:
" Art. 4. La société a pour but d'entreprendre au Grand-Duché de Luxembourg toutes opérations se rapportant aux
activités de domiciliataire de sociétés relevant de l'article 29 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle
que modifiée, notamment le conseil en structuration de patrimoine et la représentation économique et commerciale,
l'étude et à la mise en œuvre de projets de restructuration, d'expansion, de coopération, de fusion et d'acquisition
d'entreprises ainsi que toutes opérations qui y sont directement ou indirectement liées.
La société a également pour objet la prestation de services de constitution et de gestion de sociétés, telles que définies
par l'article 29-5 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée, sous toute forme que ce soit
ainsi que toutes opérations qui y sont directement ou indirectement liées.
La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et
faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet. Elle pourra d'une
façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la
réalisation."
3.- Libération intégrale du capital.
4.- Remplacement des 15.500 actions existantes d'une valeur nominale de 2,- EUR chacune par 310 actions d'une valeur
nominale de 100,- EUR chacune.
5.- Augmentation de capital à concurrence de 370.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR
à 401.000,- EUR, par la création et l'émission de 3.700 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100,- EUR, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
6.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
7.- Modification des articles 5 et 6 des statuts.
8.- Modification du pouvoir de signature.
9.- Modification de l'article 9 des statuts.
10.- Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur.
11.- Démission du commissaire aux comptes.
12.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de changer la dénomination de la Société en "LFS Multi-Family Office S.A." et de modifier en
conséquence l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
49769
" Art. 1
er
. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de "LFS Multi-Family Office S.A."
qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que par les présents statuts."
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour l'article 4 des statuts la teneur comme
ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le point 2).
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée constate que le capital social de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR),
représenté par quinze mille cinq cents (15.500) actions de deux euros (2,- EUR) chacune, qui lors de la constitution de
la société a été libéré à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), soit pour un montant de sept mille sept cent cinquante
euros (7.750,- EUR).
L'assemblée constate que les actionnaires ont entretemps versé en numéraire les soixante-quinze pour cent (75%)
non-libérés du capital lors de la constitution, de sorte que la somme de vingt-trois mille deux cent cinquante euros
(23.250,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation
bancaire, qui le constate expressément.
Suite à cette libération supplémentaire le capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est entièrement
libéré.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de remplacer les quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (2,-
EUR) chacune par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent soixante-dix mille euros (370.000,- EUR),
pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quatre cent et un mille euros (401.000,-
EUR), par la création et l'émission de trois mille sept cents (3.700) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros
(100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée constate que les 3.700 actions nouvellement émises ont été souscrites par les anciens actionnaires au
prorata de leur participation actuelle dans la Société et libérées intégralement par les souscripteurs prédits moyennant
un versement en numéraire, de sorte que la somme de trois cent soixante-dix mille euros (370.000,- EUR) se trouve dès-
à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le
constate expressément.
<i>Septième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les articles
5 et 6 des statuts pour leur donner les teneurs suivantes:
" Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quatre cent et un mille euros (401.000,- EUR), représenté par quatre mille et dix
(4.010) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital social de la société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des
actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.
La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions."
" Art. 6. Toutes les actions de la société seront uniquement émises sous forme nominative.
Toutes les actions émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la société ou par une ou
plusieurs personnes désignées à cet effet par la société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions,
son domicile, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient.
Le droit de propriété de l'actionnaire sur les actions s'établit par l'inscription de son nom dans le registre des action-
naires. Un certificat constatant cette inscription sera délivré sur demande à l'actionnaire. Ce certificat devra être signé
par deux membres du conseil d'administration. Les signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit sous
forme télécopiée.
Tout transfert d'actions requiert l'agrément unanime de tous les actionnaires et sera inscrit au registre des actionnaires
au moyen de la remise à la société d'un instrument de transfert convenant à la société, ou par une déclaration de transfert
écrite, portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valable-
ment constitué à cet effet, et, à chaque fois, avec la remise à la société du certificat d'actions qui s'y rapporte, s'il en a été
émis. Une pareille inscription devra être signée par deux membres du conseil d'administration, ou par une ou plusieurs
autres personnes dûment autorisées à cet effet par le conseil d'administration.
Tout actionnaire devra fournir à la société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront
être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.
49770
Au cas où un actionnaire ne fournit pas d'adresse à la société, la société sera autorisée à en faire mention au registre
des actionnaires, et l'adresse de l'actionnaire sera censée être au siège social de la société ou à telle autre adresse inscrite
au registre des actionnaires jusqu'à ce qu'une autre adresse soit communiquée à la société par l'actionnaire. Un actionnaire
pourra, à tout moment, faire changer l'adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite, envoyée
au siège social de la société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues
ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, les personnes invoquant un droit sur la/
les action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la société. L'omission
d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux action(s).
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier le pouvoir de signature, de supprimer en conséquence les alinéas 8 à 10 de l'article 8
des statuts et d'insérer 2 nouveaux alinéas ayant les teneurs suivantes:
" Art. 8. (alinéas 8 et 9). Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation de la société à deux ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs chargés de la gestion journalière de
la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, conformément aux critères
retenus par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)."
<i>Neuvième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier le 3
ème
alinéa de l'article 8 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 8. (troisième alinéa). Le conseil d'administration élit en son sein un président; en cas d'absence du président, la
présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent."
<i>Dixième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts afin de lui donner en conséquence la teneur suivante:
" Art. 9. Les opérations de la société sont surveillées par un réviseur externe à désigner par le conseil d'administration
et choisit parmi les membres figurant sur la liste des réviseurs d'entreprises agrées du Grand-Duché de Luxembourg.
Le réviseur d'entreprises sera désigné pour une période n'excédant pas six ans et il sera rééligible."
<i>Onzième résolutioni>
L'assemblée accepte la démission de Madame Janika KOLK de ses fonctions d'administrateur et, par vote spécial, lui
donne décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.
Est nommé en son remplacement, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2013:
Monsieur Guillaume DE VILLENAUT, employé privé, né le 12 juillet 1974 à Nevers (France), avec adresse profes-
sionnelle au 3 A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
<i>Douzième résolutioni>
L'assemblée accepte la démission de la société "KLOPP & BOUR CONSEILS S.A." de ses fonctions de commissaire
aux comptes et, par vote spécial, lui donne décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève
approximativement à trois mille sept cents euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: NORBERG - MULLER - MULLER - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 mars 2008. Relation GRE/2008/1066. — Reçu Mille huit cent cinquante euros 0,5%:
1.850,-€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Junglinster, le 27 mars 2008.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2008046731/231/174.
(080051529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.
49771
INDUCTRON Inductive Electronic Components S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 13, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 104.936.
Il résulte de différentes cessions de parts sociales que la répartition des parts sociales de la société à responsabilité
limitée INDUCTRON INDUCTIVE ELECTRONIC COMPONENTS S. à r.l. est dorénavant la suivante:
Parts
- SARASINO SOPARFI S.A., avec siège social à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg: . . . . . . . . . . . . . . .
100
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21.03.2008.
Fiduciaire Hellers, Kos & Associés, sàrl, Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008046704/7262/18.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO09036. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080050988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.
Wiesen-Piront Constructions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 85.748.
Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire du 03.03.2008 que:
- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
- Monsieur Helmut Anton WIESEN est révoqué de son poste d'administrateur avec effet au 03.03.2008.
Il résulte d'une réunion du conseil d'administration en date du 06.03.2008 que:
- Monsieur Maurice ELZ est nommé au poste d'administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société
et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
qui se tiendra en l'année 2012.
L'adresse professionnelle de Maurice Elz: 88C, rue de Luxembourg, L-8140 Bridel
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13.03.2008.
Fiduciaire Hellers, Kos & Associés sàrl, Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008046703/7262/21.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06543. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.
Corelis, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2334 Luxembourg, 11, place Saints Pierre et Paul.
R.C.S. Luxembourg B 99.150.
La nouvelle adresse de Monsieur Bernard KUHNER, gérant de la société est: 29, rue de Luxembourg, L-3392 Roedgen.
Luxembourg, le 20 mars 2008.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour CORELIS
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Référence de publication: 2008046705/1261/15.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08920. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080050915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.
49772
K'FE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5252 Sandweiler, 12, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 110.526.
Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 19.03.2008 que:
- L'assemblée a décidé que la société K'FE s.à r.l. est engagée valablement, en toute circonstance, et vis-à-vis des tiers,
et pour une durée indéterminée, par la signature conjointe d'un gérant technique nommé Jean-Claude ROULET, né le
02.03.1957 à Varennes sur Loire (France), demeurant à L-8508 Redange sur Attert, 12, rue Seitert et d'un gérant admi-
nistratif nommé Nathalie HOJAN, née le 06.03.1974 à Bitche (France), demeurant à L-5252 Sandweiler, 12, rue Michel
Rodange.
Pour réquisition et publication aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26.03.2008.
Fiduciaire Hellers, Kos & Associés, S.à r.l., Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008046702/7262/19.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2008, réf. LSO-CP00255. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080051048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.
European Car Distribution and Services Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 18, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 83.710.
Il résulte d'une assemblée générale ordinaire en date du 20.06.2007 que:
Les mandats de l'administrateur et administrateur-délégué Christian Mariolle de Tizac, demeurant à L-9227 Diekirch,
18, Esplanade et celui de l'administrateur Romain Hilbert, demeurant à L-9395 Tandel, 6, Veiannerstroos sont prorogés
pour une durée 6 ans et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2013.
Madame Béatrice Kling, née le 20.08.1958 à Mulhouse (France), demeurant à F-83920 La Motte en Provence, Domaine
de Saint Endréol, Aureto 16 est nommée administrateur en remplacement de Monsieur Georges Wagner, démissionnaire.
Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2013.
La société Fiduciaire Hellers, Kos & Associés, sàrl, inscrite au RCSL sous le numéro B 121.917, avec siège social à
L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg est nommée commissaire aux comptes en remplacement de Becker + Cahen
& Associés, sàrl, démissionnaire. Le mandat du nouveau commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
de l'année 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28.03.2008.
Fiduciaire Hellers, Kos & Associés, sàrl, Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008046701/7262/24.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP01081. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080051171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.
Les Bierts, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 51.336.
EXTRAIT
L'Assemblée générale du 27 mars 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Monsieur Henri GRISIUS, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, Place Winston Churchill,
L-1340 Luxembourg, Luxembourg;
- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,
Luxembourg;
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,
Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.
49773
L'assemblée générale du 27 mars 2008 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- Monsieur Aloyse SCHERER, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.
Luxembourg, le 27 mars 2008.
<i>Pour LES BIERTS, Société anonyme holding
i>Signature
Référence de publication: 2008046697/833/24.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2008, réf. LSO-CP00443. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080051326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.
Bero S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 60.413.
EXTRAIT
L'Assemblée générale du 27 mars 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,
Luxembourg;
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,
Luxembourg;
- Monsieur Henri GRISIUS, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston
Churchill, L-1340 Luxembourg, Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.
L'assemblée générale du 27 mars 2008 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- Monsieur Aloyse SCHERER, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.
Luxembourg, le 27 mars 2008.
<i>Pour BERO S.A., Société anonyme holding
i>Signature
Référence de publication: 2008046696/833/24.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2008, réf. LSO-CP00435. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080051327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.
iStructure S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 111.063.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors du Conseil d'Administration du 28 novembre 2007i>
- Est nommé réviseur d'entreprises, Pricewaterhousecoopers S.à r.l, dont le siège social est 400, route d'Esch, L-1014
Luxembourg.
- Le mandat du réviseur d'entreprises, Pricewaterhousecoopers S.à r.l, prendra fin lors de l'assemblée générale qui se
tiendra en 2012 sur les comptes annuels de 2011.
Luxembourg, le 10 mars 2008.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008046700/1463/17.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06732. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080051213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.
49774
Anine, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 59.196.
EXTRAIT
L'Assemblée générale du 28 mars 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Monsieur Henri GRISIUS, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, Place Winston Churchill,
L-1340 Luxembourg, Luxembourg;
- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,
Luxembourg;
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,
Luxembourg,
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.
L'assemblée générale du 28 mars 2008 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- Monsieur Aloyse SCHERER, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.
Luxembourg, le 28 mars 2008.
<i>Pour ANINE, Société anonyme holding
i>Signature
Référence de publication: 2008046695/833/24.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2008, réf. LSO-CP00430. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080051329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.
Saes Getters International Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 55.526.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue à Luxembourg, le 17 mars 2008, que
l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Salvatore DESIDERIO, en qualité d'Administrateur de la
société, en remplacement de Monsieur Jean-Philippe FIORUCCI, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en
date du 17 septembre 2007.
L'Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Vincent THILL, en qualité d'Administrateur de la société,
en remplacement de Monsieur Mirko LA ROCCA, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 30
octobre 2007.
L'Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Olivier CONRARD, en qualité d'Administrateur de la
société, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du
1
er
février 2008.
L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Salvatore DESIDERIO, Monsieur Vincent THILL et Monsieur Olivier
CONRARD en qualité d'Administrateurs de la société.
Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expirera à l'Assemblée Générale de
l'an 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18/03/2008.
<i>SAES GETTERS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.
i>Salvatore DESIDERIO / Vincent THILL
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008046692/43/30.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07702. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080051381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.
49775
Financial Mathematics S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 114.827.
EXTRAIT
L'Assemblée générale du 17 mars 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Monsieur Henri GRISIUS, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill
L-1340 Luxembourg, Luxembourg;
Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston
Churchill, L-1340 Luxembourg, Luxembourg;
- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,
Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.
L'assemblée générale du 17 mars 2008 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.
Luxembourg, le 17 mars 2008.
<i>Pour FINANCIAL MATHEMATICS, Société anonyme
i>Signature
Référence de publication: 2008046693/833/24.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07158. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080051351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.
Barfi, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 44.051.
EXTRAIT
L'Assemblée générale du 28 mars 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs,
- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,
Luxembourg;
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,
Luxembourg;
Monsieur Henri GRISIUS, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston
Churchill, L-1340 Luxembourg, Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.
L'assemblée générale du 28 mars 2008 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes. Monsieur Aloyse SCHE-
RER, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.
Luxembourg, le 28 mars 2008.
<i>Pour BARFI, Société anonyme holding
i>Signature
Référence de publication: 2008046694/833/24.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2008, réf. LSO-CP00427. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080051332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
49776
Anine
Barby Holding S.à r.l.
Barfi
Baumert,s.à r.l.
Berkeley Investment Holdings S.A.
Bero S.A.
Bric S.A.
CalEast French Investments 1
CalEast Holdings 3 S.à r.l.
CalEast Holdings 5 Properties 1 S.à r.l.
Catella Investments S.A.
CB Luxembourg V
Compagnie de Révision
Corelis
Ernst & Young
Ernst & Young Tax Advisory Services
Estrada Holding S.A.
European Car Distribution and Services Holding S.A.
European Investments Associates (E.I.A.) S.A.
European Management Fiduciary S.A.
Famy Investment S.A.
Financial Mathematics S.A.
Him-Racing-Kart S.à r.l.
Imperial Holding S.C.A.
Index 3D
INDUCTRON Inductive Electronic Components S.à r.l.
Isidro International S.A.
iStructure S.A.
Javi International S.A.
Kaytwo S.à r.l.
K'FE S.à r.l.
Kilbroney Finance S.A.
K Invest Holding S.A.
LaSalle Japan Logistics (JPY) S.à r.l.
Les Bierts
LFS Advisory Services S.A.
LFS Multi-Family Office S.A.
Mallard Holding S.A.
Meson Holding S.A.
Neried Finance S.A.
Open Mind S.A.
Reis S.A.
Richie Investments S.A.
Saes Getters International Luxembourg S.A.
Saxi Holding S.A.
Sitka S.A.
Société de Participations Antares S.A.
Sopalim S.A.
Tivoli International Holding S.A.
Tong International S.A.
Torre Ingles S.A.
UPRN 1 SE
Wiesen-Piront Constructions S.A.