This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 957
17 avril 2008
SOMMAIRE
249 Saint Denis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45904
3P Automation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45928
3P Solutions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45929
Adho Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45936
Akeler Property Investments Sàrl . . . . . . .
45924
Alimede Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .
45905
Aria Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45900
Arnage Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45903
BCF Photonics II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
45904
BCF Photonics I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45904
Clay Tiles Participations S.à.r.l. . . . . . . . . . .
45906
Cognetas II German Holdings S.à r.l. . . . .
45893
Delamain S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45936
Dexia Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45928
DIT Luxembourg 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
45929
Dumanet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45929
EP Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45905
EP Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45906
Euro - Celtique S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45901
F.I.B.M. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45906
Fortis LDI Solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45903
Golf Management Company S.A. . . . . . . . .
45893
ILP III S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45907
ILP III S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45917
Immopam S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45890
Kensington S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45910
LaSalle German Retail Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45925
Luxembourgeoise de Construction Immo-
bilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45906
Miscanthus-Nawaro-Innovations S.A. . . . .
45902
MK Helicopter Participation S.à r.l. . . . . . .
45890
Patrimoine Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45927
Perseus Immobilien Gesellschaft 1 . . . . . . .
45930
Perseus Immobilien Gesellschaft 11 . . . . .
45918
Pert V S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45911
Phone Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . .
45936
Pilkington Luxembourg No. 1 S.à r.l. . . . . .
45893
Promotions Rante S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
45901
Richnou S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45928
Saveurs Lao Thaï S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
45905
Silver Star S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45902
Société Générale des Assaisonnements
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45903
Sportime Capital Management S.à r.l. . . .
45918
Tower 2008 (Luxco 1) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
45911
United in Sports Management S.à r.l. . . . .
45918
Urna S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45902
U.S. Fixed Income Fund Management
Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45907
45889
Immopam S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8369 Hivange, 3A, route de Kahler.
R.C.S. Luxembourg B 129.201.
<i>Assemblée générale extraordinaire du janvier 2008i>
Présents:
1. Monsieur Batista Antunes José Carlos, gérant de société, demeurant au n
o
38, rue Emile Mayrisch, L-3522 Dudelange
2. Madame Pinheiro Pereira Maria Alice, employée privée, demeurant au n
o
3A, rue de Kahler, L-8369 Hivange
3. Monsieur Ferreira Martins Belmiro, employé privé, demeurant au n
o
15, rue Guido Oppenheim, L-2263 Luxembourg
<i>Ordre du jour:i>
1. Cession de parts par Monsieur Batista Antunes José Carlos.
<i>Résolutions prisesi>
<i>Première résolutioni>
Entre les soussignés:
1) Monsieur Batista Antunes José Carlos, gérant de société, demeurant au n
o
38, rue Emile Mayrisch, L-3522 Dudelange
ci-après dénommé "le cédant" et
2) Madame Pinheiro Pereira Maria Alice, femme au foyer, demeurant au n
o
3A, rue de Kahler, L-8369 Hivange
ci-après dénommée "la cessionnaire"
Le cédant, Monsieur Batista Antunes José Carlos est propriétaire de 25 parts de la société à responsabilité limitée
Immopam S.à r.l. établie et ayant son siège social à Hivange;
Le cédant, Monsieur Batista Antunes José Carlos cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit à la
cessionnaire Madame Pinheiro Pereira Maria Alice, qui accepte, 25 parts de la société dont il s'agit.
Après la cession mentionnée ci-dessus, le capital social de la société s'élevant à 12.600,00 €, représenté par cent (100)
parts sociales, est réparti comme suit:
Parts
sociales
Monsieur Ferreira Martins Belmiro, (gérant technique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Monsieur Pires Pinheiro Patricio, (employé privé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Madame Pinheiro Pereira Maria Alice (employée privée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
La présente cession est consentie et acceptée par donation, que Monsieur Batista Antunes José Carlos reconnaît avoir
donné.
Les frais, droits et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront supportés par la
cessionnaire.
Tous les pouvoirs sont conférés au porteur d'un exemplaire des présentes en vue de leur signification à la société et
pour effectuer les dépôts et publications légales.
Signé: Monsieur Batista Antunes José Carlos, Madame Pinheiro Pereira Maria Alice, Monsieur Ferreira Martins Belmiro.
Fait à Hivange, le 24 janvier 2008, en 3 exemplaires.
Signatures.
Référence de publication: 2008042348/8797/43.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07773. - Reçu 91,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
MK Helicopter Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 137.255.
Im Jahre zwei tausend acht, den siebenundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.
SIND ERSCHIENEN:
1.- Herr Dr. Christoph GOTTWALD, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in D-28717 Bremen, Auf dem Pasch 36.
2.- Herr Daniel WRUCK, Kaufmann, wohnhaft in D-61348 Bad Homburg, Mariannenweg 40,
45890
hier vertreten durch Herrn Dr. Christoph GOTTWALD, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift
vom 25. Februar 2008
welche Vollmacht, von dem Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, und dem amtierenden Notar ne varietur
unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparenten, anwesend oder vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden
Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den sie miteinander abgeschlossen haben:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile
werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zu-
treffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "MK Helicopter Participation S.à r.l.".
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-
ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,
Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-
werben und verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt massgeblich
beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-
Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der
Gesellschaft förderlich sind.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500,-), aufgeteilt in EIN
HUNDERT (100) Anteile, mit einem Nominalwert von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125,-), welche
wie folgt übernommen werden:
1.- Herr Daniel WRUCK, Kaufmann, wohnhaft in D-61348 Bad Homburg, Mariannenweg 40, fünfzig Anteile
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Herr Dr. Christoph GOTTWALD, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in D-28717 Bremen, Auf dem Pasch 36, fünfzig
Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Total: EIN HUNDERT ANTEILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€
12.500,-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachge-
wiesen wurde.
Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an
Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschafts-
kapitals vertreten.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690
des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die
Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
45891
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt welches auch immer die Anzahl seiner Anteile ist. Jeder Anteil gibt Anrecht
auf eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-
schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtun-
gen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres
Mandats verantwortlich.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt.
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der General-
versammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Vers-
torbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.
Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2008.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr ein tausend Euro (€ 1.000.-).
<i>Erklärungi>
Die Komparenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst
nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen Ge-
neralversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende
Beschlüsse gefasst:
a) Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden für eine unbestimmte Dauer ernannt:
- Herr Daniel WRUCK, Kaufmann, wohnhaft in D-61348 Bad Homburg, Mariannenweg 40.
- Herr Dr. Christoph GOTTWALD, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in D-28717 Bremen, Auf dem Pasch 36.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die gemeinsamen Unterschriften der beiden Geschäftsführer rechtsgültig
vertreten und verpflichtet.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1621 Luxemburg, 24, rue des Genêts.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.
Gezeichnet: GOTTWALD, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 28 février 2008. Relation: ECJH/2008/266. — Reçu soixante-deux Euros cinquante Cents.
12.500,- à 0,5% = 62.50 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
45892
Echternach, den 10. März 2008.
Henri BECK.
Référence de publication: 2008042889/201/119.
(080045949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Golf Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 91.820.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 20 février 2008i>
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de renouveler les mandats de Monsieur Jonathan BEGGIATO,
Monsieur Jean-Marc ASSA et de la société EXCELIANCE SA, représentée par son administrateur-délégué Monsieur
Jonathan BEGGIATO en tant qu'administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de renouveler le mandat de la société LE COMITIUM INTER-
NATIONAL SA, représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jonathan BEGGIATO en tant que commissaire
aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.
Pour mention et publication
Signature
<i>Le Présidenti>
Référence de publication: 2008042712/1091/21.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07066. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080045768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Cognetas II German Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 95.175,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 112.854.
<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés de la Société le 04 mars 2008i>
Il résulte du procès-verbal des résolutions des associés du 04 mars 2008 que les associés:
- accepte la démission de Ms. Kristel Segers de ses fonctions de gérant B de la Société avec effet le 04 mars 2008
- nomme Mireille Annick Fervail, comptable, née à Jemappes (Belgique) le 21 août 1953, résidant au 22, rue Sim-
merschmelz, L-8392 Nospelt comme gérant B de la Société avec effet au 07 mars 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mireille FERVAIL
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2008042704/5760/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08134. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Pilkington Luxembourg No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 182.738.225,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 103.413.
In the year two thousand and eight, on the fifth day of March, at four p.m.
Before Maître Martine DECKER, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Pilkington Luxembourg No. 1 S.à r.l." (the "Compa-
ny"), a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B 103.413, incorporated by a notarial deed enacted on 27 September 2004, published in the
45893
Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1260, page 60460 of 9 December 2004, lastly amended on 8
December 2006 pursuant to a deed enacted by the undersigned notary, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 313, page 15009 of 6 March 2007.
The meeting is presided by Mr. Laurent Fessmann, with professional address at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr. Torsten Schmitt, with professional address at 398, route d'Esch, L-1471
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman elects as scrutineer Mr. Christoph Dahlgrün, with professional address at 398, route d'Esch, L-1471
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.
That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain attached hereto to be registered with
these minutes.
II.- As appears from the attendance list, all the 7,228,890 (seven million two hundred twenty-eight thousand eight
hundred ninety) shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each, representing the whole capital of the Company, are repre-
sented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholders expressly state
that they have been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the rectification, with retroactive effect as from 8 December 2006, of the list of assets contributed to
the Company in the framework of an all assets and liabilities contribution to simultaneously the Company and Pilkington
Australia Finance Pty Ltd S.à r.l. as approved in an extraordinary meeting of the sole shareholder of the Company on 8
December 2006, and in particular its impact on (i) the value of the contribution made to the Company, (ii) the amount
of the increase of the share capital, (iii) the number of new shares issued, (iv) the amount of share premium and (v) the
amount allotted to the legal reserve;
2. Amendment of article eight of the articles of association of the Company relating to the share capital in order to
reflect the new share capital of the Company amounting to EUR 182,738,225 (one hundred eighty-two million seven
hundred thirty-eight thousand two hundred twenty-five Euro) pursuant to the above resolution; and
3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
It was noted that the extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Company held on 8 December
2006 before the undersigned notary (the "EGM") has decided to increase the share capital of the Company by an amount
of EUR 42,586,825 (forty-two million five hundred eighty-six thousand eight hundred twenty-five Euro) by the issue of
1,703,473 (one million seven hundred three thousand four hundred seventy-three) new shares with a nominal value of
EUR 25 (twenty-five Euro) each (the "New Shares") (the "Increase of Capital").
It was further noted that 21,455 (twenty-one thousand four hundred fifty-five) of the New Shares were issued to
Pilkington Luxembourg No. 2 S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office
at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "First Contribu-
tor"), subject to the payment of a share premium of EUR 2,145,004 (two million one hundred forty-five thousand four
Euro) (the "First Share Premium"), of which an amount of EUR 53,638 (fifty-three thousand six hundred thirty-eight Euro)
was allocated to the legal reserve (the "First Legal Reserve Amount").
In addition, it was noted that 1,682,018 (one million six hundred eighty-two thousand eighteen) of the New Shares
were issued to Pilkington Luxembourg No. 3 S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the
"Second Contributor", the First Contributor and the Second Contributor together referred to as the "Contributors"),
subject to the payment of a share premium of EUR 168,165,922 (one hundred sixty-eight million one hundred sixty-five
thousand nine hundred twenty-two Euro) (the "Second Share Premium"), of which an amount of EUR 4,205,045 (four
million two hundred five thousand forty-five Euro) was allocated to the legal reserve (the "Second Legal Reserve Amount").
It was then noted that the Increase of Capital was fully paid through two contributions in kind made by (i) the First
Contributor of part of all its assets and liabilities, in the framework of an all assets and liabilities contribution simultaneously
to the Company and Pilkington Australia Finance Pty Ltd S.à r.l., a company incorporated under the laws of Australia
having its registered office at 95 Greens Road, Dandenong, Victoria, Australia 3175, which had, at the time of these
contributions, its effective place of management and control at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg ("PAFL"), at a total value of EUR 2,681,379 (two million six hundred eighty-one
thousand three hundred seventy-nine Euro) (the "First Contribution") and (ii) by the Second Contributor, of part of all
its assets and liabilities, in the framework of an all assets and liabilities contribution simultaneously to the Company and
PAFL, at a total value of EUR 210,216,372 (two hundred ten million two hundred sixteen thousand three hundred seventy-
45894
two Euro) (the "Second Contribution", the First Contribution and the Second Contribution together referred to as the
"Contributions").
It was then reminded that the First Contribution was described in the minutes of the EGM as follows:
<i>"Assetsi>
- a loan receivable in an amount of EUR 2,122,429 (two million one hundred twenty-two thousand four hundred
twenty-nine Euro) against Pilkington Australia Investments LP, a limited partnership existing under the laws of Australia
("PAIL"), resulting of a loan facility granted by the First Contributor on 24 March 2006 together with accrued interest;
- debtors in a total amount of EUR 1 (one Euro);
- cash at bank in an amount of EUR 674,921 (six hundred seventy-four thousand nine hundred twenty-one Euro);
<i>Liabilitiesi>
- provisions for liabilities and charges in a total amount of EUR 76,218 (seventy-six thousand two hundred eighteen
Euro); and
- other creditors in a total amount of EUR 39,754 (thirty-nine thousand seven hundred fifty-four Euro); and any and
all assets and liabilities held by the First Contributor that would exist at the date hereof, not mentioned because unknown,
which are contributed to the Company only with all rights, titles, commitments and obligations, which can or could be
attached thereto in any manner whatsoever."
It was also reminded that the Second Contribution was described in the minutes of the EGM as follows:
<i>"Assetsi>
- a loan receivable of EUR 210,120,497 (two hundred ten million one hundred twenty thousand four hundred ninety-
seven Euro) against Pilkington Australia Investments LP, a limited partnership existing under the laws of Australia ("PAIL"),
resulting of a loan facility granted by the Second Contributor on 24 March 2006 together with accrued interest;
- debtors in a total amount of EUR 59 (fifty-nine Euro);
- cash at bank in an amount of EUR 127,754 (one hundred twenty-seven thousand seven hundred fifty-four Euro);
<i>Liabilitiesi>
- provisions for liabilities and charges in a total amount of EUR 18,946 (eighteen thousand nine hundred forty-six Euro);
and
- other creditors in a total amount of EUR 12,992 (twelve thousand nine hundred ninety-two Euro); and any and all
assets and liabilities held by the Second Contributor that would exist at the date hereof, not mentioned because unknown,
which are contributed to the Company only with all rights, titles, commitments and obligations, which can or could be
attached thereto in any manner whatsoever."
It was then reported that later verifications revealed that errors were contained in the above descriptions of the
Contributions, as the interests accrued on (i) the loan receivable of EUR 2,122,429 (two million one hundred twenty-
two thousand four hundred twenty-nine Euro) against Pilkington Australia Investments LP contributed by the First
Contributor to the Company (the "First Loan") and (ii) the loan receivable of EUR 210,120,497 (two hundred ten million
one hundred twenty thousand four hundred ninety-seven Euro) against Pilkington Australia Investments LP contributed
by the Second Contributor to the Company (the "Second Loan"), the First Loan and the Second Loan together referred
to as the "Loans"), although mentioned, were not numeralised.
In this respect, in the above description of the First Contribution, the amount of the accrued interest on the First Loan
as at 8 December 2006, which should have been mentioned in an amount of EUR 100,783 (one hundred thousand seven
hundred eighty-three Euro) (the "First Accrued Interest") was omitted.
Moreover, in the above description of the Second Contribution, the amount of the accrued interest on the Second
Loan as at 8 December 2006, which should have been mentioned in an amount of EUR 9,977,486 (nine million nine
hundred seventy-seven thousand four hundred eighty-six Euro) (the "Second Accrued Interest", the First Accrued Interest
and the Second Accrued Interest together referred to as the "Accrued Interests") was omitted.
Consequently the above mentioned errors have had an impact on the total value of the Contributions. Thus, (i) the
aggregate value of the First Contribution was referred to in the minutes of the EGM as amounting to EUR 2,681,379 (two
million six hundred eighty-one thousand three hundred seventy-nine Euro) instead of the proper amount of EUR 2,782,162
(two million seven hundred eighty-two thousand one hundred sixty-two Euro) (the "Proper First Contribution Amount")
and (ii) the aggregate value of the Second Contribution was referred to in the minutes of the EGM as amounting to EUR
210,216,372 (two hundred ten million two hundred sixteen thousand three hundred seventy-two Euro) instead of the
proper amount of EUR 220,193,858 (two hundred twenty million one hundred ninety-three thousand eight hundred fifty-
eight Euro) (the "Proper Second Contribution Amount", the Proper First Contribution Amount and the Proper Second
Contribution Amount together referred to as the "Proper Contribution Amounts").
In this respect, the following documents were produced at the meeting:
- an amendment agreement to the Contribution of all Assets and Liabilities Agreement entered into by and between
the First Contributor and the Company dated 5 March 2008, with retroactive effect as from 8 December 2006, which
shall remain attached to this deed;
45895
- an amendment agreement to the Contribution of all Assets and Liabilities Agreement entered into by and between
the Second Contributor and the Company dated 5 March 2008, with retroactive effect as from 8 December 2006, which
shall remain attached to this deed; and
- a rectified statement of contribution value dated 5 March 2008, with retroactive effect as from 8 December 2006,
which shall remain attached to this deed to be submitted with it to the formality of registration.
It was then noted that it was necessary to rectify the minutes of the EGM in order to take into consideration the
Accrued Interests and the Proper Contribution Amounts.
It was hence unanimously resolved to amend the minutes of the EGM, with retroactive effect as from 8 December
2006, as follows:
(i) The description of the first item in the list of assets and liabilities contributed by the First Contributor mentioned
in the second resolution of the EGM shall be read as follows (the remaining items shall remain unchanged):
<i>"Assetsi>
- a loan receivable in an amount of EUR 2,122,429 (two million one hundred twenty-two thousand four hundred
twenty-nine Euro) against Pilkington Australia Investments LP, a limited partnership existing under the laws of Australia
("PAIL"), resulting of a loan facility granted by the First Contributor on 24 March 2006 together with accrued interest as
at 8 December 2006 in an amount of EUR 100,783 (one hundred thousand seven hundred eighty-three Euro);"
(ii) The description of the first item in the list of the assets and liabilities contributed by the Second Contributor
mentioned in the second resolution of the EGM shall be read as follows (the remaining items shall remain unchanged):
<i>"Assetsi>
- a loan receivable of EUR 210,120,497 (two hundred ten million one hundred twenty thousand four hundred ninety-
seven Euro) against Pilkington Australia Investments LP, a limited partnership existing under the laws of Australia ("PAIL"),
resulting of a loan facility granted by the Second Contributor on 24 March 2006 together with accrued interest as at 8
December 2006 in an amount of EUR 9,977,486 (nine million nine hundred seventy-seven thousand four hundred eighty-
six Euro);"
(iii) The amount of the total value of the First Contribution mentioned in the minutes of the EGM shall be read in each
place as EUR 2,782,162 (two million seven hundred eighty-two thousand one hundred sixty-two Euro) instead of EUR
2,681,379 (two million six hundred eighty-one thousand three hundred seventy-nine Euro) and the amount of the total
value of the Second Contribution shall be read in each place as EUR 220,193,858 (two hundred twenty million one hundred
ninety-three thousand eight hundred fifty-eight Euro) instead of EUR 210,216,372 (two hundred ten million two hundred
sixteen thousand three hundred seventy-two Euro).
(iv) The amount of the increase of capital mentioned in the minutes of the EGM shall be read in each place as EUR
44,602,800 (forty-four million six hundred two thousand eight hundred Euro) instead of EUR 42,586,825 (forty-two million
five hundred eighty-six thousand eight hundred twenty-five Euro).
(v) The number of the New Shares issued by the Company mentioned in the minutes of the EGM shall be read in each
place as 1,784,112 (one million seven hundred eighty-four thousand one hundred twelve) instead of 1,703,473 (one million
seven hundred three thousand four hundred seventy-three).
(vi) The number of the New Shares issued by the Company to the First Contributor mentioned in the minutes of the
EGM shall be read in each place as 22,261 (twenty-two thousand two hundred sixty-one) instead of 21,455 (twenty-one
thousand four hundred fifty-five) and the number of the New Shares issued by the Company to the Second Contributor
mentioned in the minutes of the EGM shall be read in each place as 1,761,851 (one million seven hundred sixty-one
thousand eight hundred fifty-one) instead of 1,682,018 (one million six hundred eighty-two thousand eighteen).
(vii) The amount of the First Share Premium mentioned in the minutes of the EGM shall be read in each place as EUR
2,225,637 (two million two hundred twenty-five thousand six hundred thirty-seven Euro) instead of EUR 2,145,004 (two
million one hundred forty-five thousand four Euro) and the amount of the Second Share Premium shall be read in each
place as EUR 176,147,583 (one hundred seventy-six million one hundred forty-seven thousand five hundred eighty-three
Euro) instead of EUR 168,165,922 (one hundred sixty-eight million one hundred sixty-five thousand nine hundred twenty-
two Euro).
(viii) The First Legal Reserve Amount mentioned in the minutes of the EGM shall be read in each place as EUR 55,653
(fifty-five thousand six hundred fifty-three Euro) instead of EUR 53,638 (fifty-three thousand six hundred thirty-eight Euro)
and the Second Legal Reserve Amount mentioned in the minutes of the EGM shall be read in each place as EUR 4,404,628
(four million four hundred four thousand six hundred twenty-eight Euro) instead of EUR 4,205,045 (four million two
hundred five thousand forty-five Euro).
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolution and the total amount of the Contributions having been
rectified, it is unanimously resolved to amend the first paragraph of article eight of the articles of association of the
Company to be read as follows (the second paragraph remaining unchanged):
45896
"The Company's capital is set at EUR 182,738,225 (one hundred eighty-two million seven hundred thirty-eight thousand
two hundred twenty-five Euro), represented by 7,309,529 (seven million three hundred nine thousand five hundred
twenty-nine) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-fiveEuro) each"
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 2,800.
There being no further business, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that, on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le cinq mars, à 16.00 heures,
Par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché du Luxembourg, soussigné,
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de «Pilkington Luxembourg No. 1 S.à r.l.» (la Société»),
une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 103.413, constituée par acte notarié du 27 septembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1260, page 60460, du 9 décembre 2004, modifié en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 8 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 313,
page 15009, du 6 mars 2007.
L'assemblée est présidée par Monsieur Laurent Fessmann, ayant son adresse professionnelle au 398, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Torsten Schmitt, ayant son adresse professionnelle au 398, route
d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Le président désigne comme scrutateur, Monsieur Christoph Dahlgrün, ayant son adresse professionnelle au 398,
route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 7.228.890 (sept millions deux cent vingt huit mille huit cent quatre-vingt-
dix) parts sociales d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social
de la Société sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à
l'ordre du jour, dont les associés reconnaissent expressément avoir été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation de la rectification, avec effet rétroactif à compter du 8 décembre 2006, de la liste des actifs apportés
à la Société dans le cadre de l'apport de tous les éléments d'actifs et de passifs, simultanément à la Société et Pilkington
Australia Finance Pty Ltd S.à r.l., tel qu'approuvé à l'assemblée extraordinaire de l'associé unique de la Société le 8
décembre 2006, et en particulier son incidence sur (i) la valeur de l'apport fait à la Société, (ii) le montant de l'augmentation
du capital social, (iii) le nombre des nouvelles parts émises, (iv) le montant de la prime d'émissions et (v) le montant alloué
à la réserve légale;
2. Modification de l'article huit des statuts de la Société concernant le capital social pour refléter le nouveau capital
social de la Société d'un montant de 182.738.225 EUR (cent quatre-vingt-deux millions sept cent trente-huit mille deux
cent vingt-cinq euros) suite aux résolutions précédentes; et
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par les associés, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il a été rappelé que l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la Société réunie le 8 décembre 2006
devant le notaire soussigné («l'AGE») avait décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 42.586.825
EUR (quarante-deux millions cinq cent quatre-vingt-six mille huit cent vingt-cinq euros) par l'émission de 1.703.473 (un
million sept cent trois mille quatre cent soixante-treize) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-
cinq euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales"») (l'«Augmentation du Capital»).
45897
Il a été également rappelé que 21.455 (vingt et un mille quatre cent cinquante-cinq) des Nouvelles Parts Sociales ont
été émises en faveur de Pilkington Luxembourg No. 2 S.à r.l., une société constituée sous les lois de Luxembourg, ayant
son siège social au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg (le
«Premier Apporteur») sujettes au paiement d'une prime d'émission de 2.145.004 EUR (deux millions cent quarante-cinq
mille quatre euros) (la «Première Prime d'Emission»), pour lesquelles un montant de 53.638 EUR (cinquante-trois mille
six cent trente-huit euros) était alloué à la réserve légale (le «Premier Montant de Réserve Légale»).
Par ailleurs, il a été rappelé que 1.682.018 (un million six cent quatre-vingt-deux mille dix-huit) des Nouvelles Parts
Sociales ont été émises en faveur de Pilkington Luxembourg No. 3 S.à r.l., une société constituée sous les lois de Lu-
xembourg, ayant son siège social au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg (le «Second Apporteur», le Premier Apporteur et le Second Apporteur ensemble, les «Apporteurs») sujettes
au paiement d'une prime d'émission de 168.165.922 EUR (cent soixante-huit millions cent soixante-cinq mille neuf cent
vingt-deux euros) (la «Seconde Prime d'Emission»), pour lesquelles un montant de 4.205.045 EUR (quatre millions deux
cent cinq mille quarante-cinq euros) était alloué à la réserve légale (le «Second Montant de Réserve Légale»).
Il a été également rappelé que l'Augmentation du Capital a été entièrement payée au moyen de deux apports en nature
effectués par (i) le Premier Apporteur, d'une partie de tous ses éléments d'actifs et de passifs dans le cadre de l'apport
de tous les éléments d'actifs et de passifs, simultanément à la Société et Pilkington Australia Finance Pty Ltd S.à r.l., une
société constituée sous la loi australienne, ayant son siège social au 95 Greens Road, Dandenong, Victoria, Australie 3175,
qui avait au moment de ces apports, son siège effectif de direction et de contrôle au 67, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg («PAFL»), pour une valeur totale de 2.681.379 EUR (deux
millions six cent quatre-vingt-un mille trois cent soixante-dix neuf euros) (le «Premier Apport») et (ii) par le Second
Apporteur, d'une partie de tous ses éléments d'actifs et passifs, dans le cadre de l'apport de tous les éléments d'actifs et
passifs simultanément à la Société et PAFL, pour une valeur totale de 210.216.372 EUR (deux cent dix millions deux cent
seize mille trois cent soixante-douze euros) (le «Second Apport», le Premier Apport et le Second Apport ensemble, les
«Apports»).
Il a été ensuite rapporté que le Premier Apport a été décrit dans le procès-verbal de l'AGE comme suit:
<i>«Actifsi>
- une créance d'un montant de 2.122.429 EUR (deux millions cent vingt-deux mille quatre cent vingt-neuf euros) contre
Pilkington Australia Invetsments LP, a limited partnership gouverné par la loi australienne («PAIL») résultant d'un prêt
octroyé par le Premier Apporteur le 24 mars 2006 ensemble avec intérêts échus;
- débiteurs pour un montant total de 1 EUR (un euro);
- liquidités en banque pour un montant de 674.921 EUR (six cent soixante-quatorze mille neuf cent vingt et un euros);
<i>Passifsi>
-provisions "for liabilities and charges" d'un montant total de 76.218 EUR (soixante-seize mille deux cent dix-huit
euros); et
- autres créanciers pour un montant total de 39.754 EUR (trente-neuf mille sept cent cinquante-quatre euros);
ainsi que tous les actifs et passifs détenus par le Premier Apporteur qui pourraient exister à ce jour, non mentionnés
car non connus, et qui seront apportés à la Société uniquement avec tous les droits, titres, engagements et obligations
qui peuvent ou pourraient s'y rattacher de quelque manière que ce soit.»
Il a été ensuite rapporté que le Second Apport a été décrit dans le procès-verbal de l'AGE comme suit:
<i>«Actifsi>
- une créance pour un montant de 210.120.497 EUR (deux cent dix millions cent vingt mille quatre cent quatre-vingt-
dix-sept euros) contre Pilkington Australia Invetsments LP, a limited partnership gouverné par la loi australienne («PAIL»)
résultant d'un prêt alloué par le Second Apporteur le 24 mars 2006 ensemble avec intérêts échus;
- débiteurs pour un montant total de 59 EUR (cinquante-neuf euros);
- liquidités en banque pour un montant de 127.754 EUR (cent vingt-sept-mille sept cent cinquante-quatre euros);
<i>Passifsi>
-provisions "for liabilities and charges" d'un montant total de 18.946 EUR (dix-huit mille neuf cent quarante-six euros);
et
- autres créanciers pour un montant total de 12.992 EUR (douze mille neuf cent quatre-vingt-douze euros);
ainsi que tous les actifs et passifs détenus par le Second Apporteur qui pourraient exister à ce jour, non mentionnés
car non connus, et qui seront apportés à la Société uniquement avec tous les droits, titres, engagements et obligations
qui peuvent ou pourraient s'y rattacher de quelque manière que ce soit.»
Il a été rapporté que des vérifications ultérieures ont révélé que des erreurs figuraient dans les précédentes descriptions
des Apports, à savoir les intérêts échus sur (i) la créance de 2.122.429 EUR (deux millions cent vingt-deux mille quatre
cent vingt-neuf euros) contre Pilkington Australia Invetsments LP apportée par le Premier Apporteur en faveur de la
Société (la «Première Créance») et (ii) la créance de 210.120.497 EUR (deux cent dix millions cent vingt mille quatre
cent quatre-vingt-dix-sept euros) contre Pilkington Australia Invetsments LP apportée par le Second Apporteur en faveur
45898
de la Société (la «Seconde Créance», la Première Créance et la Seconde Créance ensemble, les «Créances»), bien que
mentionnés, n'avaient pas été chiffrés.
A cet égard, dans la description faite ci-dessus du Premier Apport, le montant des intérêts échus sur la Première
Créance à la date du 8 décembre 2006, qui auraient du être mentionnés pour un montant de 100.783 EUR (cent mille
sept cent quatre-vingt-trois euros) (le «Premier Intérêt Echu»), a été omis.
De surcroît, dans la description faite ci-dessus du Second Apport, le montant des intérêts échus sur la Seconde Créance
à la date du 8 décembre 2006, qui auraient du être mentionnés pour un montant de 9.977.486 EUR (neuf millions neuf
cent soixante-dix sept mille quatre cent quatre-vingt-six euros) (le «Second Intérêt Echu», le Premier Intérêt Couru et
le Second Intérêt Couru constituant ensemble les «Intérêts Echus»), a été omis.
Par conséquent, les erreurs mentionnées précédemment ont eu une incidence sur la valeur totale des Apports. Ainsi,
(i) la valeur globale du Premier Apport était indiqué dans le procès verbal de l'AGE à hauteur de 2.681.379 EUR (deux
millions six cent quatre-vingt-un mille trois cent soixante-dix-neuf euros) au lieu du montant correct de 2.782.162 EUR
(deux millions sept cent quatre-vingt-deux mille cent soixante-deux euros) (le «Montant Correct du Premier Apport»)
et la valeur globale du Second Apport faisant référence au procès verbal de l'AGE, indiquait un montant de 210.216.372
EUR (deux cent dix millions deux cent seize mille trois cent soixante-douze euros) au lieu du montant correct de
220.193.858 EUR (deux cent vingt millions cent quatre-vingt-treize mille huit cent cinquante-huit euros) (le «Montant
Correct du Second Apport», le Montant Correct du Premier Apport et le Montant Correct du Second Apport ensemble,
les «Montants Corrects d'Apports»).
A cet égard, les documents suivants ont été produits à l'assemblée:
- un avenant au contrat d'apport de tous les éléments d'Actifs et de Passifs conclu entre le Premier Apporteur et la
Société daté du 5 mars 2008, avec effet rétroactif au 8 décembre 2006, lequel devra rester annexé à cet acte;
- un avenant au contrat d'apport de tous les éléments d'Actifs et de Passifs conclu entre le Second Apporteur et la
Société daté du 5 mars 2008, avec effet rétroactif au 8 décembre 2006, lequel devra rester annexé à cet acte; et
- une déclaration de valeur de l'apport rectifiée datée du 5 mars 2008, avec effet rétroactif au 8 décembre 2006, laquelle
devra restée annexée à cet acte pour les besoins des formalités d'enregistrement.
Il a été rappelé qu'il était indispensable de modifier le procès verbal de l'AGE afin de prendre en considération les
Intérêts Échus et les Montants Corrects d'Apports.
Il a été donc unanimement décidé de modifier le procès-verbal de l'AGE, avec effet rétroactif à compter du 8 décembre
2006, comme suit:
(i) La description du premier point dans la liste des actifs et passifs apportés par le Premier Apporteur mentionné dans
la deuxième résolution de l'AGE devra être lu comme suit (les autres points restant inchangés):
<i>«Actifsi>
- une créance d'un montant de 2.122.429 EUR (deux millions cent vingt-deux mille quatre cent vingt-neuf euros) contre
Pilkington Australia Invetsments LP, a limited partnership gouverné par la loi australienne («PAIL») résultant d'un prêt
octroyé par le Premier Apporteur le 24 mars 2006 ensemble avec intérêts échus en date du 8 décembre 2006 pour un
montant de 100.783 EUR (cent mille sept cent quatre-vingt-trois euros);»
(ii) La description du premier point dans la liste des actifs et passifs apportés par le Second Apporteur mentionné dans
la deuxième résolution de l'AGE devra être lue comme suit (les autres points restant inchangés):
<i>«Actifsi>
- une créance d'un montant de 210.120.497 EUR (deux cent dix millions cent vingt mille quatre cent quatre-vingt dix-
sept euros) contre Pilkington Australia Invetsments LP, a limited partnership gouverné par la loi australienne («PAIL»)
résultant d'un prêt alloué par le Second Apporteur le 24 mars 2006 ensemble avec intérêts échus en date du 8 décembre
2006 pour un montant de 9.977.486 EUR (neuf millions neuf cent soixante-dix sept mille quatre cent quatre-vingts-six
euros);»
(iii) Le montant de la valeur totale du Premier Apport tel que mentionné dans le procès verbal de l'AGE devra être
indiqué à chaque endroit comme étant de 2.782.162 EUR (deux millions sept cent quatre-vingt- deux mille cent soixante-
deux euros) au lieu de 2.681.379 EUR (deux millions six cent quatre-vingt-un mille trois cent soixante-dix-neuf euros) et
le montant de la valeur totale du Second Apport devra être de 220.193.858 EUR (deux cent vingt millions cent quatre-
vingts-treize mille huit cent cinquante-huit euros) au lieu de 210.216.372 EUR (deux cent dix millions deux cent seize
mille trois cent soixante-douze euros).
(iv) Le montant de l'Augmentation de Capital mentionné dans le procès verbal de l'AGE devra être indiqué à chaque
endroit comme étant de 44.602.800 EUR (quarante-quatre millions six cent deux mille huit cents euros) au lieu de
42.586.825 EUR (quarante-deux millions cinq cent quatre-vingts-six mille huit cent vingt-cinq euros);
(v) Le nombre des Nouvelles Parts Sociales émises par la Société mentionné dans le procès-verbal de l'AGE devra être
indiqué à chaque endroit comme étant de 1.784.112 (un million sept cent quatre-vingt-quatre mille cent douze) au lieu
de 1.703.473 (un million sept cent trois mille quatre cent soixante-treize).
(vi) Le nombre des Nouvelles Parts Sociales émises par la Société en faveur du Premier Apporteur mentionné dans le
procès-verbal de PAGE devra être indiqué à chaque endroit comme étant de 22.261 (vingt-deux mille deux cent soixante
45899
et un) au lieu de 21.455 (vingt et un mille quatre cent cinquante-cinq) et le nombre des Nouvelles Parts Sociales émises
par la Société en faveur du Second Apporteur mentionné dans le procès-verbal de l'AGE devra être indiqué à chaque
endroit comme étant de 1.761.851 (un million sept cent soixante et un mille huit cent cinquante et un) au lieu de 1.682.018
(un million six cent quatre vingt-deux mille dix-huit).
(vii) Le montant de la Première Prime d'Emissions mentionné dans le procès verbal de l'AGE devra être indiqué à
chaque endroit comme étant de 2.225.637 EUR (deux millions deux cent vingt-cinq mille six cent trente-sept euros) au
lieu de 2.145.004 EUR (deux millions cent quarante-cinq mille quatre euros) et le montant de la Seconde Prime d'Emissions
mentionné dans le procès-verbal de l'AGE devra être indiqué à chaque endroit comme étant de 176.147.583 EUR (cent
soixante-seize millions cent quarante-sept mille cinq cent quatre-vingts-trois euros) au lieu de 168.165.922 EUR (cent
soixante-huit millions cent soixante-cinq mille neuf cent vingt-deux euros).
(viii) Le Premier Montant de Réserve Légale mentionné dans le procès verbal de l'AGE devra être indiqué à chaque
endroit comme étant de 55.653 EUR (cinquante-cinq mille six cent cinquante-trois euros) au lieu de 53.638 EUR (cin-
quante-trois mille six cent trente-huit euros) et le Second Montant de Réserve Légale mentionné dans le procès-verbal
de l'AGE devra être indiqué à chaque endroit comme étant de 4.404.628 EUR (quatre millions quatre cent quatre mille
six cent vingt-huit euros) au lieu de 4.205.045 EUR (quatre millions deux cent cinq mille quarante-cinq euros).
<i>Seconde résolutioni>
En conséquence des déclarations et de la résolution qui précèdent, le montant total des Apports ayant été rectifié, il
est unanimement décidé de modifier l'article huit premier paragraphe des Statuts de la Société et de lui donner la teneur
suivante (le second paragraphe restant inchangé):
«Le capital de la Société est fixé à 182.738.225 EUR (cent quatre-vingt-deux millions sept cent-trente huit mille deux
cent vingt-cinq euros), représenté par 7.309.529 (sept millions trois cent neuf mille cinq cent vingt-neuf) parts sociales
d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune».
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital social, s'élève à environ EUR 2.800 Plus rien n'étant
à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît et parle anglais constate que, sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: Fessmann, Dahlgrün, Schmitt, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 mars 2008, Relation: LAC/2008/10053. — Reçu douze euros (€12.-).
<i>Le Receveuri> (signé): Sandt.
POUR COPIE CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Hesperange, le vendredi 21 mars 2008.
MARTINE DECKER.
Référence de publication: 2008042512/241/393.
(080046028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Aria Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 83.875.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 février 2008i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 25 février 2008, que les membres du Conseil
d'administration, délibérant valablement, ont décidé de:
1. transférer le siège social de la Société de L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare à 34A, bd Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxembourg.
2. nommer Monsieur François Georges, expert-comptable, né le 20 mars 1967 à Luxembourg, demeurant profes-
sionnellement au 34A, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, à la fonction d'administrateur-délégué,
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013, et ont décidé d'élire ce dernier en tant que Président du Conseil
d'administration.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
45900
Luxembourg, le 25 février 2008.
ARIA EUROPE S.A.
François Georges
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2008042788/5710/24.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04902. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Euro - Celtique S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 30.986,69.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 17.846.
Conformément à la décision des administrateurs de la Société, en date du 19 septembre 2007, le siège de la société
est transféré du 122, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
avec effet au 1
er
janvier 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Euro-Celtique S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2008042786/260/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06893. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Promotions Rante S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4888 Lamadelaine, 2, Op den Gehren.
R.C.S. Luxembourg B 39.563.
DISSOLUTION
L'an deux mille huit, le vingt-neuf février.
Par-devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
La société à responsabilité limitée «V.R.D. TONI RANTE S.àr.l.», avec siège à L-4888 Lamadelaine, 2, Op den Gehren,
(RC No B 90.243), constituée suivant acte notarié du 11 décembre 2002, publié au Mémorial C page 2.876/2003.ici
représentée par son gérant, Monsieur Toni RANTE, entrepreneur de construction, demeurant à L-4888 Lamadelaine, 2,
Op den Gehren,
agissant comme unique associé (suite à des cessions de parts) de la société à responsabilité limitée "PROMOTIONS
RANTE S.àr.l.", avec siège social à L-4888 Lamadelaine, 2, Op den Gehrén, (RC B No 39.563), constituée suivant acte
notarié du 21 janvier 1992, publié au Mémorial C No 328 du 31 juillet 1992,
laquelle comparante en sa qualité d'associée unique réunissant toute les parts sociales en une main, conclut formelle-
ment à la dissolution de ladite société, avec effet rétroactif au 31 décembre 2007.
- elle déclare encore que la liquidation de la société a d'ores et déjà été opérée et clôturée et qu'elle assume person-
nellement tous éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute.
Les documents resteront pendant le délai de 5 ans au domicile de Monsieur Toni RANTE.
Nous Notaire avons donné acte de la liquidation et de la dissolution de la société "PROMOTIONS RANTE S.àr.l.",
avec effet rétroactif au 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Les frais du présent acte sont estimés à la somme de neuf cent dix euro (€ 910.-)
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: RANTE, D'HUART.
Enregistré à Esch/AIzette A.C., le 03 mars 2008, Relation: EAC/2008/2986. — Reçu douze euros EUR 12.-.
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
45901
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 11 mars 2008.
Georges d'HUART.
Référence de publication: 2008042521/207/34.
(080046170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Miscanthus-Nawaro-Innovations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.677.
<i>Transfert du siège sociali>
L'actionnaire unique de la société anonyme MISCANTHUS-NAWARO-INNOVATIONS S.A, en abrégé M.N.I S.A, a
décidé, en date du 13 novembre 2007, de transférer le siège de la société de 8, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
à l'adresse suivante:
203, route d'Esch à L-1471 Luxembourg.
Ce transfert de siège prend effet ce jour.
Le 13.11.2007.
Pour extrait conforme
Signatures
Référence de publication: 2008042785/503/18.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04233. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Urna S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 70.117.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement du 6 mars 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, Vl
e
chambre siégeant en matière
commerciale, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société URNA S.A., ayant eu
son siège social à L-1611 LUXEMBOURG, 61, avenue de la Gare.
Les frais ont été mis à charge du Trésor.
Pour extrait conforme
Maître Pierre FELTGEN
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2008042761/1421/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04807. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080045969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Silver Star S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1230 Luxembourg, 5, rue Jean Bertels.
R.C.S. Luxembourg B 71.740.
Selon le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 5 mars 2008 au siège social de la société
SILVER STAR SA, il résulte que la résolution suivante a été prise à l'unanimité par tous les actionnaires de la société:
<i>Résolution Unique - Modification du siège sociali>
L'assemblée générale décide de modifier, à partir de ce jour, le siège social comme suit:
5, rue Jean Bertels, L-1230 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
45902
Luxembourg, le 5 mars 2008.
Signature / Signature / Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur / Actionnaire 1 / Actionnaire 2i>
Référence de publication: 2008042777/2741/18.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07098. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080045858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Arnage Holding S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 84.073.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement du 21 février 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, Vl
e
chambre siégeant en matière
commerciale, a ordonné la liquidation de la société ARNAGE HOLDING S.A., ayant eu son siège social à L-7268 BE-
RELDANGE, 23, Cité Aline Mayrisch.
Le même jugement a nommé Juge-Commissaire Monsieur Gilles MATHAY, Juge au Tribunal d'Arrondissement de et
à Luxembourg et liquidateur Maître Pierre FELTGEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Les déclarations de créances sont à déposer au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg avant le 21
mars 2008.
Pour extrait conforme
Maître Pierre FELTGEN
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2008042759/1421/19.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04168. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080045954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Fortis LDI Solution, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 108.079.
Le bilan au 30/06/2007, ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2008.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS LDI SOLUTION
i>Fortis Investment Management Luxembourg S.A.
Nathalie Moroni
Référence de publication: 2008043429/755/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07263C. - Reçu 42,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.
SO.GE.AS., Société Générale des Assaisonnements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 38.798.
Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1
er
février 2008, que
le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa
fonction de Président du Conseil d'Administration et d'Administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide
de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Vincent THILL, demeurant 12, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le man-
dat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.
45903
En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomi-
nation définitive.
Luxembourg, le 5 février 2008.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Vincent THILL / Salvatore DESIDERIO
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008042852/43/23.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2008, réf. LSO-CO02285. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080045997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
249 Saint Denis, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 111.937.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>249 SAINT DENIS
i>LOUV S.à.r.l. / FINDI S.à.r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>l. SCHUL / N. THIRION
<i>Représentant permanent / Représentant permanenti>
Référence de publication: 2008042809/795/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06671. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
BCF Photonics II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.936.950,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 79.960.
Le bilan au 31 janvier 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BCF PHOTONICS II SARL
i>Services Généraux de Gestion S.A. - SGG
Signatures
Référence de publication: 2008042810/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06677. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
BCF Photonics I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.622.700,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 79.959.
Le bilan au 31 janvier 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
45904
<i>Pour BCF PHOTONICS I SARL
i>Services Généraux de Gestion S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008042814/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06834. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Alimede Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 128.645.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008042816/805/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2008, réf. LSO-CO05608. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
EP Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 99.218.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008042819/587/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05022. - Reçu 34,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Saveurs Lao Thaï S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 136.038.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de la réunion de l'assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 18
mars 2008 que:
1) L'associée unique a nommé Madame PHONG Jacqueline, née le 3 avril 1963 à Vientiane (LAOS), employée privée,
demeurant à F-93000 NOISY LE GRAND, 9, allée de la Futaie, en qualité de gérante de la société pour une durée
indéterminée.
Laquelle aura le pouvoir d'engager en toute circonstance la société par sa seule signature, sauf pour les opérations
nécessitant la co-signature obligatoire du porteur de l'autorisation d'établissement.
2) Suite à la décision ci-avant, les gérants de la société pour une durée indéterminée sont:
- Monsieur PHONG Amu, commerçant, né le 2 décembre 1961 à Vientiane (LAOS), demeurant à F-93160 NOISY LE
GRAND, 2 Mail Victor Jara,
- Madame PHONG Jacqueline, née le 3 avril 1963 à Vientiane (LAOS), employée privée, demeurant à F-93000 NOISY
LE GRAND, 9, allée de la Futaie.
Chacun aura le pouvoir d'engager en toute circonstance la société par sa seule signature, sauf pour les opérations
nécessitant la co-signature obligatoire du porteur de l'autorisation d'établissement.
45905
<i>Pour la société
i>Signature
<i>L'associée uniquei>
Référence de publication: 2008042843/1123/27.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07669. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080045852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
EP Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 99.218.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008042820/587/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05020. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080046352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Clay Tiles Participations S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 89.336.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2008.
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2008042821/805/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN07781. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
F.I.B.M. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 40.615.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2008043415/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07455. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.
Luxembourgeoise de Construction Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 29.744.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
45906
LUXEMBOURGEOISES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008042813/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06952. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
U.S. Fixed Income Fund Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 67.053.
Le bilan au 30 novembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2008.
<i>Pour U.S. FIXED INCOME FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2008042801/1126/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03250. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
ILP III S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement
en Capital à Risque.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 127.503.
In the year two thousand eight, on the third of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Mr Jean-Pierre VERLAINE having professional residence in Luxembourg,
acting in his capacity as director ("gérant") of the Manager of the «société en commandite par actions», "ILP III S.C.A.,
SICAR", which was incorporated by a deed of the undersigned notary of 13 April 2007, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, number 1269 of June 26, 2007, and whose articles of incorporation have been modified for
the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on October 30, 2007, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, number 78 of January 11, 2008, registered in the Luxembourg Company Register under section
B number 127503 and having its registered office at 30, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, (the «Company»),
by virtue of the authority conferred on him by resolutions of the Company's Manager on 29 February 2008, a certified
copy of these resolutions, signed ne varietur by the appearing person and the notary, shall remain annexed to the present
deed which they shall be formalised.
The appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to record the following
declarations and statements:
I.- The subscribed share capital of the Company is presently set at five hundred and eleven thousand six hundred and
sixty-six euro and sixty-six cents (EUR 511,666.66) divided into:
- one (1) Management Share,
- forty-four thousand one hundred (44.100) Class A Shares
- three thousand nine hundred and sixty-six point six thousand six hundred and sixty-six (3,966.6666) Class B Shares
and
- three thousand ninety nine (3,099) Class C Shares.
II.- Pursuant to Article 8 of the Company's Articles of Incorporation, the Company's authorised capital is set at one
hundred fifty million euro (EUR 150,000,000.-).
III.- Pursuant to the Company's Articles of Incorporation, the Company's Manager has been authorised to increase
the Company's subscribed share capital within the limits of the authorised capital and to amend Article 8 of the Articles
of Incorporation so as to reflect the increase of capital.
45907
IV.- The Company's Manager, in its resolutions adopted on 29 February 2008, and in accordance with the authorities
conferred on it pursuant to the Articles of Incorporation, resolved to increase the subscribed corporate capital by the
amount of six million four hundred eighty-eight thousand nine hundred seventy-one euro forty-three cents (EUR
6.488.971.43.-) in order to raise it from its present amount of five hundred and eleven thousand six hundred and sixty-
six euro and sixty-six cents (EUR 511,666.66) to an amount of seven million six hundred thirty-eight euro nine cents
(EUR 7.000.638,09) by the creation and the issuing of five hundred ninety-five thousand three hundred forty-seven point
three seven eight eight (595.347,3788) new Class A Shares and fifty-three thousand five hundred forty-nine point seven
six four two (53.549,7642) new Class B Shares with a par value of ten euro (EUR 10.-) per share, having the same rights
attached as the existing Shares.
V.- The Company's Manager further resolved to waive to the extent necessary the preferential subscriptions rights
reserved to the existing Shareholders and to accept the subscriptions on 29 February 2008 of five hundred ninety-five
thousand three hundred forty-seven point three seven eight eight (595.347,3788) new Class A Shares and fifty-three
thousand five hundred forty-nine point seven six four two (53.549,7642) new Class B Shares.
VI.- All these new Shares have been entirely subscribed and entirely paid in cash as follows:
A Limited Shareholders
Nb of New
Share
Share
Payments
Shares
Capital
Premium
EUR
Subscribed
Efibanca S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 749,3759 1 417 493,76
900 000,00 2 317 493,76
Società Cattolica di Assicurazione S.c.a.r.l. . . . . . . . . . . . . 62 999,7226
629 997,23
400 000,00 1 029 997,23
Halfmoon Assets S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 349,8752
283 498,75
180 000,00
463 498,75
Pamphili Consultadoria e Serviços Lda . . . . . . . . . . . . . . .
9 449,9584
94 499,58
60 000,00
154 499,58
FINOGEST FINANCE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 999,7226
629 997,23
400 000,00 1 029 997,23
ORLYAN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 999,4452 1 259 994,45
800 000,00 2 059 994,45
Union Bancaire Privée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 449,9584
94 499,58
60 000,00
154 499,58
FIN PO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 449,9584
94 499,58
60 000,00
154 499,58
Compagnie Monegasque de Banque . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 899,9168
188 999,17
120 000,00
308 999,17
Banca Popolare di Vicenza S.C.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 249,7920
472 497,92
300 000,00
772 497,92
Futura Invest S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 499,8613
314 998,61
200 000,00
514 998,61
Yleen Investments LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 749,9307
157 499,31
100 000,00
257 499,31
Private Equity International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 499,8613
314 998,61
200 000,00
514 998,61
Total A Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 347,3788 5 953 473,78 3 780 000,00 9 733 473,78
B Limited Shareholders
DANIO INVEST S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 549,7642
535 497,65
0,00
535 497,65
Total B Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 549,7642
535 497,65
0,00
535 497,65
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 897,1430 6 488 971,43 3 780 000,00 10 268 971,43
All these shares have been paid up in cash by the subscribers so that the total sum of ten million two hundred sixty-
eight thousand nine hundred seventy-one euro forty-three (EUR 10.268.971,43) is at the disposal of the Company as has
been proved to the undersigned notary.
The total contribution of ten million two hundred sixty-eight thousand nine hundred seventy-one euro forty-three
(EUR 10.268.971,43) represents six million four hundred eighty-eight thousand nine hundred seventy-one euro forty-
three cents (EUR 6.488.971.43.-) for the capital and three millions seven hundred eighty thousand euro (EUR 3.780.000.-)
for the share premium.
VII.- As a consequence of the above mentioned increase of the subscribed share capital, Article 8 b of the Articles of
Incorporation is therefore amended and shall forthwith read as follows:
'' Art. 8(b). The issued share capital of the Company is set at seven million six hundred thirty-eight euro nine cents
(EUR 7.000.638,09) divided into:
- one (1) Management Share,
- six hundred thirty-nine thousand four hundred forty-seven point three seven eight eight (639.447,3788) Class A
Shares
- fifty-seven thousand five hundred sixteen point four three zero eight (57.516,4308) Class B Shares and
- three thousand ninety nine (3,099) Class C Shares."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document are estimated at approximately five thousand euro.
45908
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the Company, on the day named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing person, said appearing person signed together with Us, the notary,
the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le trois mars.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Jean-Pierre VERLAINE, résidant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de gérant de l'Associé Gérant Commandité de la société en commandite par actions «ILP III
S.C.A., SICAR», constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 avril 2007, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1269 du 26 juin 2007, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 octobre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 78 du 11 janvier 2008, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 127.503
et ayant son siège social au 30, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg (la «Société»),
en vertu des pouvoirs lui conférés par les résolutions de l'Associé Gérant Commandité, prises en date du 29 février
2008 dont la copie certifiée de ces résolutions, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Laquelle personne comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les décla-
rations et constatations suivantes:
I.- Le capital souscrit de la Société s'élève actuellement à cinq cent onze mille six cent soixante-six euros soixante-six
cents (EUR 511.666,66) représenté par:
- une (1) Action de Commandité,
- quarante-quatre mille cent (44.100) actions de Classe A,
- trois mille neuf cent soixante-six virgule six mille six cent soixante-six (3.966,6666) actions de Classe B et
- trois mille quatre-vingt-dix-neuf (3.099) Actions de Classe C.
II.- En vertu de l'Article 8 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société, est fixé à cent cinquante millions
d'euros (EUR 150.000.000.-).
III.- En vertu des statuts de la Société, l'Associé Gérant Commandité de la Société a été autorisé à augmenter le capital
souscrit dans les limites du capital autorisé et à modifier l'Article 8 des Statuts de manière à refléter l'augmentation de
capital.
IV.- L'Associé Gérant Commandité de la Société, dans ses résolutions du 29 février 2008, et en conformité des pouvoirs
lui conférés en vertu des Statuts, a décidé une augmentation du capital souscrit à concurrence de six millions quatre cent
quatre-vingt-huit mille neuf cent soixante et onze euros quarante-trois cents (EUR 6.488.971,43) afin de le porter de son
montant actuel de cinq cent onze mille six cent soixante-six euros soixante-six cents (EUR 511.666,66) à sept millions
six cent trente-huit euros neuf cents (EUR 7.000.638,09) par la création et l'émission de cinq cent quatre-vingt-quinze
mille trois cent quarante-sept virgule trois sept huit huit (595.347,3788) nouvelles actions de Classe A et cinquante-trois
mille cinq cent quarante-neuf virgule sept six quatre deux (53.549.7642) nouvelles actions des Classe B, ayant une valeur
de dix euros (EUR 10.-) par action et ayant les mêmes droits que les Actions existantes.
V.- L'Associé Gérant Commandité de la Société a également décidé de supprimer le droit de souscription préférentiel
de l'Actionnaire existant dans la mesure du nécessaire et a admis les souscriptions le 29 février 2008 de cinq cent quatre-
vingt-quinze mille trois cent quarante-sept virgule trois sept huit huit (595.347,3788) nouvelles actions de Classe A et
cinquante-trois mille cinq cent quarante-neuf virgule sept six quatre deux (53.549.7642) nouvelles actions des Classe B.
VI.- Toutes ces nouvelles Actions Ordinaires ont été entièrement souscrites et entièrement payées en numéraire
comme suit:
Associés Commanditaires A
Nombres
Capital
Prime
Paiements
d'actions
d'émission
EUR
souscrites
Efibanca S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 749,3759 1 417 493,76
900 000,00 2 317 493,76
Società Cattolica di Assicurazione S.c.a.r.l. . . . . . . . . . . . . 62 999,7226
629 997,23
400 000,00 1 029 997,23
Halfmoon Assets S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 349,8752
283 498,75
180 000,00
463 498,75
Pamphili Consultadoria e Serviços Lda . . . . . . . . . . . . . . .
9 449,9584
94 499,58
60 000,00
154 499,58
FINOGEST FINANCE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 999,7226
629 997,23
400 000,00 1 029 997,23
45909
ORLYAN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 999,4452 1 259 994,45
800 000,00 2 059 994,45
Union Bancaire Privée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 449,9584
94 499,58
60 000,00
154 499,58
FIN PO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 449,9584
94 499,58
60 000,00
154 499,58
Compagnie Monegasque de Banque . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 899,9168
188 999,17
120 000,00
308 999,17
Banca Popolare di Vicenza S.C.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 249,7920
472 497,92
300 000,00
772 497,92
Futura Invest S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 499,8613
314 998,61
200 000,00
514 998,61
Yleen Investments LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 749,9307
157 499,31
100 000,00
257 499,31
Private Equity International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 499,8613
314 998,61
200 000,00
514 998,61
Total actions A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 347,3788 5 953 473,78 3 780 000,00 9 733 473,78
Associés Commanditaires A
DANIO INVEST S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 549,7642
535 497,65
0,00
535 497,65
Total actions B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 549,7642
535 497,65
0,00
535 497,65
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 897,1430 6 488 971,43 3 780 000,00 10 268 971,43
Toutes ces actions ont été libérées en numéraire, de sorte que la somme totale de dix millions deux cent soixante-
huit mille neuf cent soixante et onze euros quarante-trois cents (EUR 10.268.971,43) se trouve à la libre disposition de
la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.
L'apport total de dix millions deux cent soixante-huit mille neuf cent soixante et onze euros quarante-trois cents (EUR
10.268.971,43) consiste en six millions quatre cent quatre-vingt-huit mille neuf cent soixante et onze euros quarante-trois
cents (EUR 6.488.971,43) de capital et en trois millions sept cent quatre-vingt mille euros (EUR 3.780.000.-) de prime
d'émission.
VIII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital souscrit, l'Article 8 (b) des Statuts de la Société est
modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
« Art. 8. (b). Le capital social souscrit de la Société est fixé à sept millions six cent trente-huit euros neuf cents (EUR
7.000.638,09) représenté par:
- une (1) Action de Commandité,
- six cent trente-neuf mille quatre cent quarante-sept virgule trois sept huit huit (639.447,3788) actions de Classe A,
- cinquante-sept mille cinq cent seize virgule quatre trois zéro huit (57.516,4308) actions de Classe B et
- trois mille quatre-vingt-dix-neuf (3.099) Actions de Classe C.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à environ cinq mille euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des personnes comparantes,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes compa-
rantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire
instrumentant le présent acte.
Signé: J. P. VERLAINE, J. J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 mars 2008, Relation: EAC/2008/3153. — Reçu douze Euros (12,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Belvaux, le 21 mars 2008.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2008042606/239/188.
(080045925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Kensington S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 21.859.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
45910
FIDUPAR
10, boulevard Rpyal ,L-2449 LUXEMBOURG
Signatures
Référence de publication: 2008043414/1172/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07453. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.
Pert V S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 69.560.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PERT V S.A.
i>Claude SCHMITZ / Thierry FLEMING
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008043419/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO06016. - Reçu 32,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.
Tower 2008 (Luxco 1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 137.300.
STATUTES
In the year two thousand eight, on the sixth of March.
Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
"Tower 2008 Charitable Trust", a "Trust" governed by the laws of Guernsey, having its registered office in 7, New
Street, St Peter Port, Guernsey GY1 4BZ, British Virgin Islands, here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, with
professional address in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given in Guernsey, on March
6th, 2008.
The prenamed proxy given, signed "ne varietur" by the appearing persons and the undersigned notary shall remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of
incorporation of an unipersonal limited liability company.
Art. 1. Form. There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the "Company") governed
by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as
amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.
The Company is initially composed of a single shareholder, owner of all the shares. The Company may however at
any time be composed of several shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Name. The Company will exist under the name of "Tower 2008 (Luxco 1)S. à r.l.".
Art. 3. Object. The sole object of the Company is the holding of participations in Luxembourg and/or in foreign
companies, as well as the administration, development and management of its portfolio.
However, the Company shall neither directly or indirectly interfere in the management of these companies, except
that the Company shall exercise its rights as a shareholder in such companies.
The Company may provide any financial assistance to companies forming part of the group of the Company such as,
among others, the provision of loans, the granting of guarantees or securities in any kind or form.
In a general fashion, the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.
45911
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of the
general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-
agement.
The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand-Duchy of
Luxembourg or abroad.
Art. 6. Capital. The capital is set at twenty-five thousand euro (25.000.- EUR) represented by one two hundred and
fifty (250) parts of a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.
Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the single shareholder or
pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets
of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders.
If the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises all powers which are granted by law and the
articles of incorporation to all the shareholders.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions
of the single shareholder or the general meeting of shareholders.
The creditors or successors of the single shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever
reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered
by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single
shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
Art. 10. Transfer of shares.
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single shareholder:
The single shareholder may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several shareholders:
The shares may be transferred freely amongst shareholders.
The shares can be transferred by living persons to non-shareholders only with the authorization of the general meeting
of shareholders representing at least three-quarters of the capital.
Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or
accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
Art. 12. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the
law.
Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Art. 14. Management. The Company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders
or not.
Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single shareholder or by the general meeting of
the shareholders.
While appointing the manager(s), the single shareholder or the general meeting of the shareholders sets their number,
the duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.
The single shareholder or, as the case may be, the general meeting of the shareholders may decide to remove a manager,
with or without cause. Each manager may as well resign. The single shareholder or the shareholders decide upon the
compensation of each manager.
The board of managers meetings shall in any case be held in Luxembourg.
Art. 15. Powers. Each manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal
concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the
Company. He has the social signature and is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.
45912
Art. 16. Events affecting the manager. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting
a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.
Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the
Company.
Art. 17. Liability of the manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in
relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.
Art. 18. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the individual signature
of any manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been
delegated by the managers, but only within the limits of such power.
Art. 19. General meeting of shareholders.
19.1. If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the
general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that
situation.
19.2. If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general
meeting of shareholders or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the
management to the shareholders by registered mail.
In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of
the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
The general meetings of shareholders shall in any case be held in Luxembourg.
Art. 20. Decisions. The decisions of the single shareholder or of the general meeting of shareholders are documented
in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the
shareholders and the power of-attorneys are attached to the minutes.
Art. 21. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December.
Art. 22. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws
up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company
within a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of shareholders.
Art. 23. Allocation of profits.
23.1. The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net
profit of the financial year.
23.2. Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer
be mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.
23.3. The remaining profit is allocated by decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of the general
meeting of shareholders, as the case may be. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or
transfer it to the reserve or carry it forward.
23.4. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager(s);
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by the carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to
be allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividend sis taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
23.5 The final dividend with respect to a financial year must be declared by a resolution of the signed shareholder or
a resolution of the general meeting of shareholders of the Company, taking into consideration any advance payment on
dividends declared by the manager(s) with respect to the same financial year.
23.6. Each shareholder who is entitled to receive a final dividend or, as the case may be, an advance payment on
dividends may decide that said dividend shall accrue and be paid on a later date.
Art. 24. Dissolution, liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation
will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the single shareholder or by the
general meeting of shareholders of the shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of
the liquidator(s).
45913
Art. 25. Matters not provided. All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with
applicable laws.
<i>Subscription and paymenti>
The appearing party "Tower 2008 Charitable Trust" declares to subscribe the whole capital.
All the two hundred and fifty (250) shares have been fully paid up to the amount of one hundred euro (100.- EUR) per
share by a contribution in cash of twenty-five thousand euro (25.000.- EUR). As a result, the amount of twenty-five
thousand euro (25.000.- EUR) is as of now at the disposal of the company as has been certified to the notary executing
this deed.
<i>Expensesi>
The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company
as a result of its formation are estimated at approximately one thousand three hundred euro (1.300.-EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named participant, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has
immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
The sole shareholder, acting in place of the general meeting of the shareholders, has taken immediately the following
resolutions:
1. Resolved to set at two (2) the number of managers of the Company, and to appoint:
1) Orangefield Trust (Luxembourg) S.A., with registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453- Luxembourg, reg-
istered at the Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, under the number B 28.967;and
2) Mr Nicolas SCHREURS, employee, born in Knokke-Heist (Belgium) on December 3rd, 1970 with professional
address in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert;
as managers of the Company for an unlimited duration and to entrust them with the powers set forth in article 16 of
the articles of incorporation of the Company.
2. Resolved to set the registered office at L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the Notary, the present original
deed.
Suit la version française:
L'an deux mille huit, le six mars
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
«Tower 2008 Charitable Trust», un «Trust» régi par la loi de Guernsey, avec siège social à 7, New Street, St Peter
Port, Guernsey GY1 4BZ, Iles Vierges Britanniques, ici représenté par Madame Corinne PETIT, employée privée, avec
adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration délivrée à Guernsey
le 6 mars 2008.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par les mandataires du comparant et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à
responsabilité limitée unipersonnelle et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l'article 1832 du code civil, tel que modifié,
ainsi que par les présents statuts.
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute
époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles.
Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de «Tower 2008 (Luxco 1) S. à r.l.».
Art. 3. Objet. La Société a pour seul objet la prise de participations dans toutes sociétés luxembourgeoises et/ou
étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de son portefeuille.
Toutefois, la Société ne s'immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion de ces sociétés, à l'exception des
droits que la Société peut exercer en sa qualité d'actionnaire dans ces sociétés.
45914
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que
la Société, comme par exemple des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.
D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au dévelop-
pement de son objet social.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée
générale des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000.- EUR) représenté par deux cent cinquante
(250) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de
l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à
la collectivité des associés.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique
ou de la collectivité des associés.
Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire
des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.
Art. 10. Cession de parts.
10.1. Cession en cas d'un associé unique:
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont
libres.
10.2. Cession en cas de pluralité d'associés:
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément de l'assemblée
générale des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou
acceptées par elle conformément à l'article 1690 du code civil.
Art. 12. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions
légales.
Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement
similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 14. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l'associé unique ou par l'assemblée générale des
associés.
Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.
L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés pourra décider la révocation d'un
gérant, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Les assemblées des gérants doivent dans tous les cas être tenus à Luxembourg.
Art. 15. Pouvoirs. Chaque gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion
et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles
45915
rentrent dans l'objet de la Société. Il a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en
demandant soit en défendant.
Art. 16. Événements atteignant la gérance. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire
affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.
Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 17. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exé-
cution de son mandat.
Art. 18. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de tout
gérant ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été
délégué par la gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 19. Décisions de l'associé ou des associés.
19.1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée
générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
19.2. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale ou par vote écrit
sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de
quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Les assemblées générales des associés doivent dans tous les cas être tenus à Luxembourg.
Art. 20. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit
et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que
les procurations leur seront annexées.
Art. 21. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 22. Bilan. Chaque année le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas de l'assemblée
générale des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes
annuels, au cours d'une période de quinze jours précédant la date de l'assemblée générale.
Art. 23. Répartition des bénéfices.
23.1. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions,
constitue le bénéfice net de l'exercice.
23.2. Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légal; ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
23.3. Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés.
Il (elle) peut, en particulier, allouer ce bénéfice au paiement de dividende ou le transférer à une réserve ou le reporter.
23.4. Des dividendes intérimaires peuvent être versés, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) un état comptable, un inventaire ou un rapport est établi par le ou les gérants;
(ii) l'état comptable, l'inventaire ou le rapport indique que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont
les comptes annuels ont été approuvés, augmentée des bénéfices reportés et prélèvements effectués sur réserves dis-
ponibles mais diminué des pertes reportées et sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation statutaire;
(iii) la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés;
(iv) assurance est prise qu'il n'est pas porté atteinte aux droits des créanciers de la Société.
23.5. Le dividende final d'un exercice social doit être déclaré par une résolution de l'associé unique ou par une réso-
lution de l'assemblée générale des associés de la Société, en tenant compte du tout versement d'acomptes sur dividendes
déclarés par le ou les gérant(s) pour la même Année sociale.
23.6. Chaque associé qui est autorisé à recevoir un dividende final ou, le cas échéant, le paiement d'un acompte sur
les dividendes peut décider que ledit dividende peut être accumulé et payé à une date ultérieure.
Art. 24. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce
soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
45916
Art. 25. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou les associés,
selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
<i>Souscription et paiementi>
La société comparante "Tower 2008 Charitable Trust", prénommée déclare vouloir souscrire la totalité du capital
social.
Les deux cent cinquante (250) parts ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de cent euros (100.- EUR)
par part par un apport en liquide de vingt-cinq mille euros (25.000.-EUR).
Le montant de vingt-cinq mille euros (25.000.- EUR) est par conséquent à la disposition à partir de ce moment tel qu'il
a été certifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société,
ou qui est mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille trois cents euros (1.300.- EUR.)
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Après que les statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-
dinaire:
Et à l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale des associés, a pris les résolutions
suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à deux (2). Sont nommés gérants de la Société pour une durée illimitée:
1) Orangefield Trust (Luxembourg) S.A., une société anonyme avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène
Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 28.967; et
2) Monsieur Nicolas SCHREURS, employé privé, né à Knokke-Heist (Belgique), le 3 décembre 1970, demeurant pro-
fessionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
Ils ont les pouvoirs prévus à l'article 16 des statuts de la Société.
2. Le siège social de la société est établi à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
Le notaire soussigné, qui comprend l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de constitution
est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite au mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 11 mars 2008. LAC/2008/10356. — Reçu cent vingt-cinq euros
Eur 0,5%= 125.-.
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2008.
Martine SCHAEFFER.
Référence de publication: 2008043177/5770/337.
(080046723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.
ILP III S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement
en Capital à Risque.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 127.503.
RECTIFICATIF
L'an deux mille huit, le trois mars.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Jean-Pierre VERLAINE, employé, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial des
associés de la société "ILP III S.C.A., SICAR" (ci après la "Société"), ayant son siège social au 30, rue Marie-Adélaïde, L-2128
Luxembourg,
en vertu de procurations sous seing privé, lesquelles procurations, après signature, sont restées annexées à l'acte de
constitution reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 avril 2007, numéro 17391 de son répertoire.
45917
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses
déclarations et constatations:
- Que la société "ILP III S.C.A., SICAR" (ci après la "Société") est une société en commandite par actions (S.C.A.) à
capital fixe qualifiée de SICAR, ayant son siège social au 30, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 127503, constituée suivant acte reçu par
le notaire soussigné en date du 13 avril 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1269
du 26 juin 2007;
- Que par suite d'une erreur matérielle, il a été oublié de relater dans la version française seulement de l'acte de
constitution l'existence d'actions de Classe C tandis que la version anglaise en fait état;
- Que par conséquent il s'agit de modifier le deuxième alinéa de l'article 8 dans la version française comme suit:
"(i) "Action de Commandité": une action unique souscrite au moment de la constitution de la Société par l'Associé
Gérant Commandité en tant que associé gérant commandité de la Société.
(ii) "Actions de Classe A": une Classe d'Actions souscrites par des associés commanditaires;
(iii) "Actions de Classe B": une Classe d'Actions souscrites par des associés commanditaires;
(iv) "Actions de Classe C": une Classe d'Actions souscrites par des associés commanditaires;".
- En outre dans le chapitre "Souscription et libération", il est indiqué erronément que "ILP III Investments & Consulting
LLP" a souscrit trois mille quatre-vingt-dix-neuf (3.099) actions de Classe B alors qu'il s'agit d'actions de Classe C;
- Que toutes les autres dispositions figurant audit acte du 13 avril 2007 demeureront inchangées.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante pré-mentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J.P. VERLAINE, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 mars 2008. Relation: EAC/2008/3152. — Reçu douze Euros (12,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Belvaux, le 21 mars 2008.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2008042607/239/43.
(080045925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
United in Sports Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Sportime Capital Management S.à r.l.).
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 113.597.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 47294 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Joseph ELVINGER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008042896/211/12.
(080045881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Perseus Immobilien Gesellschaft 11, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 132.800.
In the year two thousand and eight, on the twentieth of March.
Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
The private limited liability company "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", with registered office at L-2311
Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B
127.199,
duly represented by Hassane DIABATE, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under
private seal, given on March 20, 2007.
Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary shall stay affixed to
the present deed to be filed with the registration authorities.
45918
The appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act that it is the sole actual
shareholder of the public limited company "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 11", (hereafter the "Company"),
with registered office at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under number B 132.800, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in
Junglinster, on October 11, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2677 of
November 22, 2007,
and that it takes, through its representative, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the legal form of the Company, in order to transform it from a public limited
company ("Aktiengesellschaft" - "AG") into a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung" -
"G.m.b.H.").
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to fully restate the articles of association of the Company so as they read as follows:
Art. 1. There exists a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") under the name of
"PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 11", (hereafter the "Company"), which will be governed by these articles of
association (the "Articles") as well as by the relevant legal dispositions.
Art. 2. The purpose of the Company is the purchase and sale of immoveable properties as well as real estate man-
agement.
It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of
any securities of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire
by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever securities, to
realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities, to grant to the companies,
in which it has participating interests either directly or indirectly or to the companies which are controlled by the same
persons as the Company, any support, loans, advances or guarantees.
Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security
for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible
notes), preferred equity certificates, convertible preferred equity certificates and debentures.
The Company may also undertake any commercial, industrial and financial transactions, which it might deem useful for
the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The duration of the Company is unlimited.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a collective decision of the
shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR), divided into one hundred (100) shares
with a par value of three hundred and ten euro (310.- EUR) each.
All the shares have been subscribed and fully paid up.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. The share capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law governing
commercial companies.
Art. 7. Each share entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.
Art. 8. Shares shall be freely transferable between shareholders.
They can only be transferred inter vivos or upon death to non-shareholders with the unanimous approval of all the
shareholders.
Art. 9. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders.
Art. 10. For no reason and in no case, the heirs or creditors of the shareholders are allowed to pursue the sealing of
property or documents of the Company.
Art. 11. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected
by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.
If the post of a Manager elected by the general meeting becomes vacant, the remaining Managers thus elected, may
provisionally fill the vacancy.
45919
In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 12. The Board of Managers chooses among its members a chairman.
If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the Managers present at the meeting designated
to that effect by the board.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any two Managers.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented; proxies
between Managers being permitted, with the restriction that a Manager can only represent one of his colleagues.
The Company will be validly bound by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person(s)
whom such signatory power will be delegated by the Board of Managers.
The Managers may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, fax or e-mail, confirmed by letter.
Written resolutions, approved and signed by all Managers, shall have the same effect as resolutions voted at the
Managers' meetings.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.
If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg
if the call is initiated from Luxembourg.
Art. 13. Decisions of the Board of Managers are taken by an absolute majority of the votes cast.
In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.
Art. 14. The minutes of the meetings of the Board of Managers shall be signed by all the Managers having assisted at
the debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one Manager or by a proxy.
Art. 15. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposition
in the Company's interest within the limits of the Company's purpose.
All powers not expressly reserved to the general meeting of the shareholders of the Company by the law of August
10th, 1915 on commercial companies as subsequently modified (the "Law"), or by the present Articles of the Company,
fall within the competence of the Board of Managers.
Art. 16. The Board of Managers may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons, who need not be shareholders of the Company.
Art. 17. In the execution of their mandate, the Managers are not held personally responsible.
As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 18. The Company is supervised by one independent auditor who is appointed by the general meeting of the
shareholders, which determines its remuneration. The independent auditor can be dismissed at any time by the general
meeting of the shareholders.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of the shareholders for a period
not exceeding six years.
Art. 19. Every shareholder may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number
of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.
Art. 20. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.
However, decisions concerning the amendment of the Articles are taken by a majority of the shareholders representing
seventy five percent of the capital.
In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law or the
Articles, are assigned to the general meeting are exercised by the sole shareholder.
Art. 21. The business year begins on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.
Art. 22. Every year, the annual accounts are drawn up by the Managers.
Art. 23. The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 24. Out of the net profit, five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be
compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.
The balance is at the disposal of the shareholders.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions: (i) interim accounts are drawn up
by the Board of Managers; (ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share
45920
premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits
made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, increased by carried
forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal
reserve; (iii) the decision to pay interim dividends is taken by the General Meeting of shareholders within two (2) months
from the date of the interim accounts; (iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into
account the assets of the Company; and (v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end
of the financial year, the share-holders must refund the excess to the Company.
Art. 25. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need
not to be shareholder and who are appointed by the shareholders who will specify their powers and remuneration.
Art. 26. For all points not regulated by these Articles, reference is made to the provisions of the Law and its modifying
acts, concerning trading companies.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that the current directors of the Company as listed below be requalified as managers
of the Company and shall continue their management duties for an undetermined duration:
a) Mr Nico HANSEN, manager, born in Differdange, (Grand Duchy of Luxembourg), on 31st of March 1969, profes-
sionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;
b) Mrs Sophie BATARDY, private employee, born in Lille, (France), on 22nd of January 1963, professionally residing
in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;
c) Mr Peter MATHIS, manager, born in Wolfenschiessen, (Switzerland), on 17th of January 1953, residing in CH-8400
Winterthur, Sonnenbergstraße, 39.
<i>Expensesi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately 1,820.- €.
The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the
above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing party, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to person appearing, known to the notary by name, given name, civil status and residence,
the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the German version:
Im Jahre zwei tausend und acht, den zwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul FRIEDERS, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", mit Sitz in L-2311 Lu-
xemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der
Nummer 127.199,
vertreten durch Hassane DIABATE, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter
Privatschrift vom 20. März 2008.
Besagte Vollmacht bleibt, nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten
Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden,
dass sie einziger aktueller Aktionär der Aktiengesellschaft "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 11", (hiernach die
"Gesellschaft"), mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 132.800, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean
Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, am 11. Oktober 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 2677 vom 22. November 2007, ist,
und dass sie, durch ihren Vertreter, folgende Beschlüsse fasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Komparentin beschließt, die Rechtsform der Gesellschaft abzuändern, um sie von einer Aktiengesellschaft ("AG")
in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (G.m.b.H.) umzuwandeln.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Komparentin beschließt, die Statuten vollständig neu zu fassen, um sie der neuen Rechtsform der Gesellschaft
anzupassen:
Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "PERSEUS IMMOBILIEN GE-
SELLSCHAFT 11", welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.
45921
Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien.
Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen
Sicherheiten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unter-nehmen, zum Er-
werb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten, deren
Veräußerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst wie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen,
Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist oder an Unter-
nehmen, die von denselben Personen kontrolliert werden wie die Gesellschaft.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen und kann Schuldinstrumente sowie nicht verzinslichen PEC,
CPEC, Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Wertpapieren ausgeben.
Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, und jede Art finanzieller Operationen die sich direkt oder indirekt auf
vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
Er kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen, die für eine Sat-
zungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrats
verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch
im Ausland haben.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt ein und dreißig tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in ein hundert (100)
Anteile mit einem Nominalwert von je drei hundert zehn Euro (310,- EUR).
Alle Anteile wurden vollständig eingezahlt.
Jeder verfügbare Betrag des Anteilagios soll ausgeschüttet werden.
Art. 6. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-
schaftsrechts festgelegt ist.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen
sowie am Gewinn.
Art. 8. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter,
bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.
Art. 9. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit
eines Gesellschafters.
Art. 10. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Do-
kumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschrän-
ken könnten.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch mindestens drei Geschäftsführer geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen,
und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.
Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten
verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.
In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.
Art. 12. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.
Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; Voll-
machten unter Verwaltungsratsmitgliedern sind erlaubt, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen
vertreten kann.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die alleinige Unterschrift
jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Verwaltungsrat übertragen wor-
den ist.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme per Brief, Fern-schreiben, Telefax oder E-Mail abgeben, welche
schriftlich bestätigt werden müssen.
45922
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-
nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Außerdem soll jedes Verwaltungsratsmitglied - welches an einer Vorstandssitzung im Wege einer Kommunikationshilfe
(einschließlich Telefon) teilnimmt, welche es den anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern erlaubt, die anderen Verwal-
tungsratsmitglieder jederzeit während der Sitzung zu hören und selbst gehört zu werden - als für diese Vorstandssitzung
anwesend gelten und soll bei der Aufstellung des Quorums und mit seiner Stimme bei Abstimmungen während einer
solchen Sitzung berücksichtigt werden.
Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst
gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.
Art. 13. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 14. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 15. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft, alle Angelegenheiten
zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie durch die späteren Änderungen, oder
durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Ver-
waltungsrates.
Art. 16. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, die
Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.
Art. 17. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.
Art. 18. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen Kommissar, welcher nicht Gesellschafter sein muss, überwacht,
welcher von der Generalversammlung, die seine Vergütung festlegt, ernannt wird. Er kann beliebig durch die General-
versammlung der Gesellschafter abberufen werden.
Die Amtszeit des Kommissars wird von der Generalversammlung fest-gelegt, welche die Dauer von sechs Jahren nicht
überschreiten kann.
Art. 19. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten
vertreten lassen.
Art. 20. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden.
Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche
mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.
Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder
Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.
Art. 21. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 22. Jedes Jahr wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.
Art. 23. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.
Art. 24. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage
zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.
Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Zwischendividenden können jederzeit unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden: (i) eine Zwischenbilanz
wird vom Geschäftsführungsrat aufgesetzt; (ii) die Zwischenbilanz zeigt, dass genügend Profit und andere Reserven (in-
klusive Aktienprämie) zur Ausführung der Ausschüttung vorhanden sind; allerdings sollte der Betrag der auszuzahlen ist
den Profit seit dem Ende des letzten Finanzjahres, für das die Bilanz angenommen wurde, vermehrt durch den vorgetra-
genen Profit und ausschüttbare Reserven aber reduziert durch vorgetragene Verluste und Summen, die in die gesetzliche
Rücklage einzustellen sind, nicht überschreiten, (iii) die Entscheidung, Zwischendividenden auszuzahlen, wird von der
Hauptversammlung der Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Datum der Einrichtung der Zwischen-
konten getroffen; (iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft sind nicht beeinträchtigt, wenn die Vermögenswerte der
Gesellschaft in Betracht gezogen werden; und (v) im Falle, dass die gezahlten Zwischendividenden die ausschüttbaren
Gewinne am Ende des Bilanzjahres übertreffen, müssen die Gesellschafter den Überschuss an die Gesellschaft zurücker-
statten.
45923
Art. 25. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt,
welche keine Gesellschafter sein müssen und die von den Gesellschaftern ernannt werden, welche ihre Befugnisse und
ihre Entschädigung festlegen.
Art. 26. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften, verwiesen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Komparentin beschließt, dass die derzeit bestellten Verwaltungsräte (wie unten aufgelistet) der Gesellschaft für
eine unbestimmte Dauer ihre Managementtätigkeiten weiterführen sollen:
a) Herr Nico HANSEN, Gesellschaftsverwalter, geboren in Differdingen, (Großherzogtum Luxemburg), am 31. März
1969, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;
b) Frau Sophie BATARDY, Privatangestellte, geboren in Lille, (Frank-reich), am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft in
L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;
c) Herr Peter MATHIS, Gesellschaftsverwalter, geboren in Wolfenschiessen, (Schweiz), am 17. Januar 1953, wohnhaft
in CH-8400 Winterthur, Sonnenbergstraße, 39.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 1.820.-€.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der er-
schienenen Partei die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen
derselben erschienenen Partei und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird die
englische Fassung maßgeblich sein.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zuna-
men, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H. Diabate, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mars 2008. Relation: LAC / 2008 / 12070. - Reçu 12 €.- (douze euros).
<i>Le Receveur ffi>
. (signé): Franck Schneider.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 25. März 2008.
Paul FRIEDERS.
Référence de publication: 2008042506/212/315.
(080046095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Akeler Property Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: GBP 10.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 64.048.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés le 13 novembre 2006:i>
L'associé LLGP Holdings LLC a cédé 5 parts à la société Arlington Business Parks Partnership en vertu d'un acte de
cession de parts avec effet au 14 novembre 2006.
A la suite de cette vente, il résulte que les associés détiennent respectivement le nombre de parts suivant:
- Akeler Holdings S.A., 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, détient 495 parts sociales.
- Arlington Business Parks Partnership, Arlington House, Arlington Business Park, Theale, Reading RG7 4SA, Royaume-
Uni, agissant par le biais de son partenaire Arlington Business Parks GP Limited, détient 5 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait le 17 mars 2008.
<i>Pour Akeler Property Investments S. à r. l.
i>Akeler Portugal
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2008042894/1649/22.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07511. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
45924
LaSalle German Retail Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 109.085.
In the year two thousand and seven, on the twenty-eight of December.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
- "LaSalle German Retail Venture L.P.", a limited partnership organised under the laws of England and Wales, having
its registered office at 33 Cavendish Square, London W1A 2NF (United Kingdom), represented by its general partner
LaSalle German Retail Venture GP, L.L.C., a limited liability company organized under the laws of Delaware, having its
registered office at Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808 (United States of America)
hereby represented by Ms Cathy BLONDEL, legal assistant, residing professionally at 41, avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 19th December 2007,
- "LaSalle Investment Scottish Limited Partnership", a limited partnership organised under the laws of Scotland having
its registered office at 66 Hanover Street, Edinburgh EH2 1HH, Scotland,
hereby represented by Ms Cathy BLONDEL, prenamed,
by virtue of a proxy given on 20th December 2007,
- "bcIMC International Real Estate (2005) Investment Corporation", a company organised under the laws of Canada,
having its registered office at c/o British Columbia Investment Management Corporation, P.O. Box 9910, Stn. Prov. Govt.,
Sawmill Point, 3rd Floor, 2940 Jetland Road, Victoria, B.C. V8T 5K6 (Canada),
hereby represented by Ms Cathy BLONDEL, prenamed,
by virtue of a proxy given on 20th December 2007,
- "bcIMC (WCBAF) International Real Estate Investment Corporation", a company organised under the laws of Canada,
having its registered office at c/o British Columbia Investment Management Corporation, P.O. Box 9910, Stn. Prov. Govt.,
Sawmill Point, 3rd Floor, 2940 Jetland Road, Victoria, B.C. V8T 5K6 (Canada),
hereby represented by Ms Cathy BLONDEL, prenamed,
by virtue of a proxy given on 20th December 2007.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are the sole partners of "LaSalle German Retail Investments S.à r.l.", a société à responsabilité
limitée, having its registered office at Centre Place de Paris, 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 109085, incorporated following a notarial deed on 29
June 2005, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1150 of 4 November 2005. The
Company's articles of incorporation have last been amended by a notarial deed on November 15, 2007, not yet published
in Mémorial C.
The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to increase the Company's corporate capital by an amount of eighty-two thousand two
hundred fifty euro (EUR 82.250.-) so as to raise it from its present amount of three hundred seventy-two thousand four
hundred euro (EUR 372,400.-) up to four hundred fifty-four thousand six hundred fifty euro (EUR 454,650.-) through the
issue of three thousand two hundred ninety (3.290) Class A shares, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-)
each.
All the newly issued shares have been subscribed by "LaSalle German Retail Venture L.P.", prequalified, paid up by a
contribution in kind consisting of one claim held by "LaSalle German Retail Venture L.P." against the Company for a total
amount of ninety thousand four hundred seventy-five euro (EUR 90.475.-).
The total contribution of ninety thousand four hundred seventy-five euro (EUR 90.475.-) will be allocated as follows:
(i) eighty-two thousand two hundred fifty euro (EUR 82.250.-) will be allocated to the share capital of the Company and
(ii) eight thousand two hundred twenty-five euro (EUR 8.225.-) will be allocated to the share premium account.
The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the Company's articles of incorporation so as
to reflect the above resolutions. The first paragraph of article 5 shall forthwith read as follows:
" Art. 5. paragraph 1. The issued capital of the Company is set at four hundred fifty-four thousand six hundred fifty
euro (EUR 454,650.-) divided into eighteen thousand one hundred eighty-three (18.183) class A shares (the "Class A
Shares") and three (3) class B shares (the "Class B Shares"), with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all
45925
of which are fully paid up. Save as otherwise permitted by the Articles of Incorporation, the Class A Shares may only be
issued to and held by the Partnership and the Class B Shares may only be issued to and held by limited partners of the
Partnership (other than its special limited partner)."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase
are estimated at four thousand euro.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version at the request of the appearing parties and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.
The document having been read to the person, who is known to the notary, by his surname, first name, civil status
and residence, has signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
- "LaSalle German Retail Venture L.P.", une société en commandite régie par le droit d'Angleterre et du Pays de Galles,
ayant son siège social à 33 Cavendish Square, Londres W1A 2NF (Royaume-Uni), représenté par son associé comman-
ditaire LaSalle German Retail Venture GP, L.L.C., une société régie par les lois du Delaware, ayant son siège social à
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808 (Etats-Unis d'Amérique),
représentée aux fins des présentes par Madame Cathy BLONDEL, juriste, demeurant professionnellement au 41,
avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 19 décembre 2007,
- "LaSalle Investment Scottish Limited Partnership", une société régie par les lois d'Ecosse, ayant son siège social au 66
Hanover Street, Edimbourg EH2 1HH, Ecosse,
représentée aux fins des présentes par Madame Cathy BLONDEL, prénommée,
en vertu d'une procuration donnée le 20 décembre 2007,
- "bcIMC International Real Estate (2005) Investment Corporation", une société régie par les lois du Canada, ayant
son siège social au c/o British Columbia Investment Management Corporation, P.O. Box 9910, Stn. Prov. Govt., Sawmill
Point, 3rd Floor, 2490 Jetland Roda, Victoria, B.C. V8T 5K6 (Canada),
représentée aux fins des présentes par Madame Cathy BLONDEL, prénommée,
en vertu d'une procuration donnée le 20 décembre 2007,
- "bcIMC (WCBAF) International Real Estate Investment Corporation", une société régie par les lois du Canada, ayant
son siège social au c/o British Columbia Investment Management Corporation, P.O. Box 9910, Stn. Prov. Govt., Sawmill
Point, 3rd Floor, 2490 Jetland Road, Victoria, B.C. V8T 5K6 (Canada),
représentée aux fins des présentes par Madame Cathy BLONDEL, prénommée,
en vertu d'une procuration donnée le 20 décembre 2007,
Lesdites procurations paraphées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné
resteront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes sont les seuls associés de "LaSalle German Retail Investments S.à r.l.", une société à respon-
sabilité limitée ayant son siège social au Centre Place de Paris, 41, avenue de la Liberté, L- 1931 Luxembourg, inscrite
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-109.085, constituée par un acte
notarié le 29 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1150 du 4 novembre 2005.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15
novembre 2007, non encore publié au Mémorial C.
Lesquels comparants, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés ont décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-deux mille deux cent
cinquante euros (EUR 82.250,-) afin de le porter de son montant actuel de trois cent soixante-douze mille quatre cents
euros (EUR 372.400.-) à quatre cent cinquante-quatre mille six cent cinquante euros (EUR 454.650.-) par l'émission de
trois mille deux cent quatre-vingt-dix (3.290) parts sociales de Catégorie A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25.-) chacune.
Toutes les parts sociales ainsi émises ont été souscrites par "LaSalle German Retail Venture L.P.", prénommée, payées
par un apport en nature consistant en une créance détenue par "LaSalle German Retail Venture L.P." contre la Société
pour un montant total de quatre-vingt-dix mille quatre cent soixante-quinze euros (90.475.- EUR).
45926
L'apport de quatre-vingt-dix mille quatre cent soixante-quinze euros (90.475.- EUR) sera alloué comme suit: quatre-
vingt-deux mille deux cent cinquante euros (EUR 82.250,-) au capital social pour le montant de huit mille deux cent vingt-
cinq euros (8.225.- EUR) pour le compte de prime d'émission.
Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de l'augmentation de capital, les Associés décident de modifier le premier alinéa de l'article 5 des
statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 5. (premier alinéa). Le capital social émis par la Société est fixé à quatre cent cinquante-quatre mille six cent
cinquante euros (EUR 454.650.-) divisé en dix-huit mille cent quatre-vingt-trois (18.183) Parts Sociales de Catégorie A
(les "Parts Sociales de Catégorie A") et trois (3) Parts Sociales de Catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B"), ayant
une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et chaque Part Sociale étant entièrement libérée. Sauf si les
Statuts disposent autrement, les Parts Sociales de catégorie A ne peuvent être émises et détenues que par la Société en
Commandite et les Parts Sociales de Catégorie B ne peuvent être émises et détenues que par les associés commandités
de la Société en Commandite (autre que son associé commanditaire spécial)."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués
approximativement à quatre mille euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des
mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant par
nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. BLONDEL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 janvier 2008. Relation: EAC/2008/254. — Reçu neuf cent quatre Euros soixante-
quinze Cents (90.475.- à 1% = 904,75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Belvaux, le 20 MARS 2008.
Jean-Joseph WAGNER.
Référence de publication: 2008042594/239/145.
(080045663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.
Patrimoine Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4201 Esch-sur-Alzette, 25, rue de Lallange.
R.C.S. Luxembourg B 67.853.
EXTRAIT
Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 février
2008, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, LAC/2008/8062, concernant la société anonyme «PATRIMOINE
IMMO S.A.», ayant son siège social à L-4201 Esch/AIzette, 25, rue de Lallange, constituée suivant acte reçu par Maître
Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 15 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 179 du 17 mars 1999, qui:
- Confirme le mandat d'administrateur de:
- Monsieur José-Manuel DOS SANTOS MARTINS, né à Villa Nova de Famalicao (Portugal), le 12 mars 1970, demeurant
à L-5650 Mondorf-les-Bains, 16, route de Remich,
- Monsieur Thierry GIACOMETTI, né à Luxembourg, le 20 janvier 1982, demeurant à L-7626 Larochette, 24, Chemin
J.A. Zinnen.
- Décide de nommer, en remplacement de Monsieur José-Antonio Valdivia Bravo, décédé, un troisième administrateur:
- Monsieur Giancarlo GIACOMETTI, né à Gubbio (Italie), le 9 novembre 1953, demeurant à L-4201 Esch/AIzette, 25,
rue de Lallange.
Le mandat des administrateurs expirera à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui aura lieu en 2013.
- Nomme Monsieur Thierry GIACOMETTI, comme administrateur-délégué pour engager la société par sa seule si-
gnature pour les matières de gestion journalière.
POUR EXTRAIT CONFORME délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
45927
Luxembourg, le 13 mars 2008.
Henri HELLINCKX
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008042866/242/28.
(080045847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
3P Automation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 98.755.
<i>Beschlussfassungi>
Die unterzeichnenden Aktionäre, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, beschließen mehrheitlich:
Als weiteres Mitglied des Verwaltungsrates wird Herr Andreas SCHMITT, Dipl.-Ing., geboren in Bitburg (Bundesre-
publik Deutschland), am 08. Februar 1966, wohnhaft in D-54634 Bitburg, Bodenheckstrasse, 9 (Bundesrepublik Deutsch-
land) mit sofortiger Wirkung berufen. Die Dauer seines Mandats geht bis zur Generalversammlung des Jahres 2009.
Echternach, 16.11.2007.
Paul Anke / Jürgen Chluba / Carsten Meier / Uwe Ebert / Andreas Schmitt / Hen-
ning Meincke.
Référence de publication: 2008042892/725/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06709. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080045990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Dexia Global, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 84.727.
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 29 février 2008 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
Monsieur Naïm ABOU JAOUDE, Global Head of Alternative Investment Management, 40, rue Washington, F-75408
Paris Cedex 08,
Monsieur Luc HERNOUX, Senior Vice President, Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-2953
Luxembourg,
Monsieur Benoît HOLZEM, Managing Director, Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-2953
Luxembourg,
Monsieur Hugo LASAT, Conseiller du Comité de Direction, Dexia Asset Management Luxembourg, route d'Arlon,
283, L-1150 Luxembourg,
en leur qualité d'administrateurs pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2009,
- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, RCS B 65.477,
en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2009.
<i>Pour DEXIA GLOBAL, Société d'Investissement à Capital Variable
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2008042875/1126/27.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2008, réf. LSO-CO03248. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Richnou S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 41.968.
Statuts coordonnés suivant acte du 18 février 2008, reçu par M
e
Urbain Tholl, de résidence à Mersch déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
45928
Urbain THOLL
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008042895/232/12.
(080045939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
3P Solutions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 100.858.
<i>Beschlussfassungi>
Die unterzeichnenden Aktionäre, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, beschließen mehrheitlich:
Als weiteres Mitglied des Verwaltungsrates wird Herr Andreas SCHMITT, Dipl.-Ing., geboren in Bitburg (Bundesre-
publik Deutschland), am 08. Februar 1966, wohnhaft in D-54634 Bitburg, Bodenheckstrasse, 9 (Bundesrepublik Deutsch-
land) mit sofortiger Wirkung berufen. Die Dauer seines Mandats geht bis zur Generalversammlung des Jahres 2009.
Echternach, 16.11.2007.
Paul Anke / Jürgen Chluba / Carsten Meier / Uwe Ebert / Andreas Schmitt / Hen-
ning Meincke.
Référence de publication: 2008042893/725/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06711. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080045993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Dumanet S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 114.864.
Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DUMANET S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008043422/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO06023. - Reçu 34,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.
DIT Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 151.800,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 117.502.
RECTIFICATIF
- Par correction des publications faites suivant les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du
12 avril 2007, la nomination de M. Olivier Christophe Laurent Jarny en tant que gérant de la société est a remplacer par
la nomination en tant que gérant de la société M. Rolf Caspers, Banquier, résidant professionnellement au 2, boulevard
Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg.
- Le mandat de nouveau gérant prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012 statuant sur
les comptes annuels de 2011.
- Le conseil de gérance est en conséquence composé des personnes suivantes: M. Rolf Caspers, Mme Anja Lakoudi
en M. Viktor Patrick Hoog Antink.
45929
Luxembourg, le 6 mars 2008.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008042853/1463/22.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04806. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080045994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Perseus Immobilien Gesellschaft 1, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 127.221.
In the year two thousand and eight, on the twentieth of March.
Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
The private limited liability company "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", with registered office at L-2311
Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B
127.199,
duly represented by Hassane DIABATE, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under
private seal, given on March 20, 2007.
Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary shall stay affixed to
the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act that it is the sole actual
shareholder of the public limited company "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 1", (hereafter the "Company"), with
registered office at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register, under number B 127.221, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster,
on April 17, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1200 of June 19, 2007,
and that it takes, through its representative, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the legal form of the Company, in order to transform it from a public limited
company ("Aktiengesellschaft" - "AG") into a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung" -
"G.m.b.H.").
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to fully restate the articles of association of the Company so as they read as follows:
Art. 1. There exists a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") under the name of
"PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 1", (hereafter the "Company"), which will be governed by these articles of
association (the "Articles") as well as by the relevant legal dispositions.
Art. 2. The purpose of the Company is the purchase and sale of immoveable properties as well as real estate man-
agement.
It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of
any securities of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire
by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever securities, to
realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities, to grant to the companies,
in which it has participating interests either directly or indirectly or to the companies which are controlled by the same
persons as the Company, any support, loans, advances or guarantees.
Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security
for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible
notes), preferred equity certificates, convertible preferred equity certificates and debentures.
The Company may also undertake any commercial, industrial and financial transactions, which it might deem useful for
the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The duration of the Company is unlimited.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a collective decision of the
shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
45930
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR), divided into one hundred (100) shares
with a par value of three hundred and ten euro (310.- EUR) each.
All the shares have been subscribed and fully paid up.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. The share capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law governing
commercial companies.
Art. 7. Each share entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.
Art. 8. Shares shall be freely transferable between shareholders.
They can only be transferred inter vivos or upon death to non-shareholders with the unanimous approval of all the
shareholders.
Art. 9. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders.
Art. 10. For no reason and in no case, the heirs or creditors of the shareholders are allowed to pursue the sealing of
property or documents of the Company.
Art. 11. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected
by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.
If the post of a Manager elected by the general meeting becomes vacant, the remaining Managers thus elected, may
provisionally fill the vacancy.
In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 12. The Board of Managers chooses among its members a chairman.
If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the Managers present at the meeting designated
to that effect by the board.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any two Managers.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented; proxies
between Managers being permitted, with the restriction that a Manager can only represent one of his colleagues.
The Company will be validly bound by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person(s)
whom such signatory power will be delegated by the Board of Managers.
The Managers may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, fax or e-mail, confirmed by letter.
Written resolutions, approved and signed by all Managers, shall have the same effect as resolutions voted at the
Managers' meetings.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.
If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg
if the call is initiated from Luxembourg.
Art. 13. Decisions of the Board of Managers are taken by an absolute majority of the votes cast.
In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.
Art. 14. The minutes of the meetings of the Board of Managers shall be signed by all the Managers having assisted at
the debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one Manager or by a proxy.
Art. 15. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposition
in the Company's interest within the limits of the Company's purpose.
All powers not expressly reserved to the general meeting of the shareholders of the Company by the law of August
10th, 1915 on commercial companies as subsequently modified (the "Law"), or by the present Articles of the Company,
fall within the competence of the Board of Managers.
Art. 16. The Board of Managers may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons, who need not be shareholders of the Company.
Art. 17. In the execution of their mandate, the Managers are not held personally responsible.
As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.
45931
Art. 18. The Company is supervised by one independent auditor who is appointed by the general meeting of the
shareholders, which determines its remuneration. The independent auditor can be dismissed at any time by the general
meeting of the shareholders.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of the shareholders for a period
not exceeding six years.
Art. 19. Every shareholder may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number
of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.
Art. 20. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.
However, decisions concerning the amendment of the Articles are taken by a majority of the shareholders representing
seventy-five percent of the capital.
In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law or the
Articles, are assigned to the general meeting are exercised by the sole shareholder.
Art. 21. The business year begins on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.
Art. 22. Every year, the annual accounts are drawn up by the Managers.
Art. 23. The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 24. Out of the net profit, five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be
compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.
The balance is at the disposal of the shareholders.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions: (i) interim accounts are drawn up
by the Board of Managers; (ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share
premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits
made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, increased by carried
forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal
reserve; (iii) the decision to pay interim dividends is taken by the General Meeting of shareholders within two (2) months
from the date of the interim accounts; (iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into
account the assets of the Company; and (v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end
of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.
Art. 25. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need
not to be shareholder and who are appointed by the shareholders who will specify their powers and remuneration.
Art. 26. For all points not regulated by these Articles, reference is made to the provisions of the Law and its modifying
acts, concerning trading companies.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that the current directors of the Company as listed below be requalified as managers
of the Company and shall continue their management duties for an undetermined duration:
a) Mr Nico HANSEN, manager, born in Differdange, (Grand-Duchy of Luxembourg), on 31st of March 1969, profes-
sionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;
b) Mrs Sophie BATARDY, private employee, born in Lille, (France), on 22nd of January 1963, professionally residing
in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;
c) Mr Peter MATHIS, manager, born in Wolfenschiessen, (Switzerland), on 17th of January 1953, residing in CH-8400
Winterthur, Sonnenbergstraße, 39.
<i>Expensesi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately 1,820.- €.
The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the
above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing party, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to person appearing, known to the notary by name, given name, civil status and residence,
the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the German version:
Im Jahre zwei tausend und acht, den zwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul FRIEDERS, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
45932
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", mit Sitz in L-2311 Lu-
xemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der
Nummer 127.199,
vertreten durch Hassane DIABATE, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter
Privatschrift vom 20. März 2008.
Besagte Vollmacht bleibt, nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten
Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden,
dass sie einziger aktueller Aktionär der Aktiengesellschaft "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 1", (hiernach die
"Gesellschaft"), mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 127.221, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean
Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, am 17. April 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, Nummer 1200 vom 19. Juni 2007 ist,
und dass sie, durch ihren Vertreter, folgende Beschlüsse fasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Komparentin beschließt die Rechtsform der Gesellschaft abzuändern, um sie von einer Aktiengesellschaft ("AG")
in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (G.m.b.H.) umzuwandeln;
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Komparentin beschließt die Statuten, vollständig neu zu fassen, um sie der neuen Rechtsform der Gesellschaft
anzupassen:
Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "PERSEUS IMMOBILIEN GE-
SELLSCHAFT 1", welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.
Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien.
Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen
Sicherheiten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb
durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten, deren Veräu-
ßerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst wie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vor-
schüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist oder an Unternehmen,
die von denselben Personen kontrolliert werden wie die Gesellschaft.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen und kann Schuldinstrumente sowie nicht verzinslichen PEC,
CPEC, Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Wertpapieren ausgeben.
Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, und jede Art finanzieller Operationen die sich direkt oder indirekt auf
vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
Er kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen, die für eine Sat-
zungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrats
verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch
im Ausland haben.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt ein und dreißig tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in ein hundert (100)
Anteile mit einem Nominalwert von je drei hundert zehn Euro (310,- EUR).
Alle Anteile wurden vollständig eingezahlt.
Jeder verfügbare Betrag des Anteilagios soll ausgeschüttet werden.
Art. 6. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-
schaftsrechts festgelegt ist.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen
sowie am Gewinn.
Art. 8. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter,
bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.
45933
Art. 9. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit
eines Gesellschafters.
Art. 10. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Do-
kumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschrän-
ken könnten.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch mindestens drei Geschäftsführer geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen,
und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.
Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten
verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.
In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.
Art. 12. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.
Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; Voll-
machten unter Verwaltungsratsmitgliedern sind erlaubt, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen
vertreten kann.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die alleinige Unterschrift
jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Verwaltungsrat übertragen wor-
den ist.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme per Brief, Fernschreiben, Telefax oder E-Mail abgeben, welche
schriftlich bestätigt werden müssen.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-
nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Außerdem soll jedes Verwaltungsratsmitglied - welches an einer Vorstandssitzung im Wege einer Kommunikationshilfe
(einschließlich Telefon) teilnimmt, welche es den anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern erlaubt, die anderen Verwal-
tungsratsmitglieder jederzeit während der Sitzung zu hören und selbst gehört zu werden - als für diese Vorstandssitzung
anwesend gelten und soll bei der Aufstellung des Quorums und mit seiner Stimme bei Abstimmungen während einer
solchen Sitzung berücksichtigt werden.
Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst
gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.
Art. 13. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 14. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 15. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft, alle Angelegenheiten
zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie durch die späteren Änderungen, oder
durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Ver-
waltungsrates.
Art. 16. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, die
Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.
Art. 17. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.
Art. 18. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen Kommissar, welcher nicht Gesellschafter sein muss, überwacht,
welcher von der Generalversammlung, die seine Vergütung festlegt, ernannt wird. Er kann beliebig durch die General-
versammlung der Gesellschafter abberufen werden.
Die Amtszeit des Kommissars wird von der Generalversammlung festgelegt, welche die Dauer von sechs Jahren nicht
überschreiten kann.
Art. 19. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten
vertreten lassen.
Art. 20. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden.
45934
Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche
mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.
Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder
Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.
Art. 21. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 22. Jedes Jahr wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.
Art. 23. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.
Art. 24. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage
zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.
Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Zwischendividenden können jederzeit unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden: (i) eine Zwischenbilanz
wird vom Geschäftsführungsrat aufgesetzt; (ii) die Zwischenbilanz zeigt, dass genügend Profit und andere Reserven (in-
klusive Aktienprämie) zur Ausführung der Ausschüttung vorhanden sind; allerdings sollte der Betrag der auszuzahlen ist
den Profit seit dem Ende des letzten Finanzjahres, für das die Bilanz angenommen wurde, vermehrt durch den vorgetra-
genen Profit und ausschüttbare Reserven aber reduziert durch vorgetragene Verluste und Summen, die in die gesetzliche
Rücklage einzustellen sind, nicht überschreiten, (iii) die Entscheidung, Zwischendividenden auszuzahlen, wird von der
Hauptversammlung der Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Datum der Einrichtung der Zwischen-
konten getroffen; (iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft sind nicht beeinträchtigt, wenn die Vermögenswerte der
Gesellschaft in Betracht gezogen werden; und (v) im Falle, dass die gezahlten Zwischendividenden die ausschüttbaren
Gewinne am Ende des Bilanzjahres übertreffen, müssen die Gesellschafter den Überschuss an die Gesellschaft zurücker-
statten.
Art. 25. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt,
welche keine Gesellschafter sein müssen und die von den Gesellschaftern ernannt werden, welche ihre Befugnisse und
ihre Entschädigung festlegen.
Art. 26. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften, verwiesen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Komparentin beschließt, dass die derzeit bestellten Verwaltungsräte (wie unten aufgelistet) der Gesellschaft für
eine unbestimmte Dauer ihre Managementtätigkeiten weiterführen sollen:
a) Herr Nico HANSEN, Gesellschaftsverwalter, geboren in Differdingen, (Großherzogtum Luxemburg), am 31. März
1969, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;
b) Frau Sophie BATARDY, Privatangestellte, geboren in Lille, (Frankreich), am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft in
L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;
c) Herr Peter MATHIS, Gesellschaftsverwalter, geboren in Wolfenschiessen, (Schweiz), am 17. Januar 1953, wohnhaft
in CH-8400 Winterthur, Sonnenbergstraße, 39.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 1.820.-€.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der
erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen
derselben erschienenen Partei und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird die
englische Fassung maßgeblich sein.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zuna-
men, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H. Diabate, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mars 2008. LAC / 2008 / 12056. — Reçu 12 €.- (douze euros).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Franck Schneider.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 25. März 2008.
Paul FRIEDERS.
Référence de publication: 2008042536/212/314.
(080046077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
45935
Phone Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.825.000,00.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 108.309.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MERCURIA SERVICES
8-10, rue Mathias Hardt, B.P. 3023, L-1030 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2008042793/1005/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07541. - Reçu 28,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080046265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Delamain S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 129.696.
Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008042817/587/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2008, réf. LSO-CO05606. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Adho Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 117, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 84.086.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 5 mars 2008 à 14.00 heures que:
1) Conformément à l'article 9 des statuts, le conseil d'administration a délégué la gestion journalière et la représentation
de la société à:
- Monsieur SAKREF Thierry, né le 18 octobre 1961 à Bizerte (Tunisie), demeurant à F 69000 Solaize, 395, rue de
l'Ozon.
Lequel pourra engager la société, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes
opérations bancaires.
Le 5 mars 2008
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008042845/1123/21.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07673. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080045841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
45936
249 Saint Denis
3P Automation S.A.
3P Solutions S.A.
Adho Immo S.A.
Akeler Property Investments Sàrl
Alimede Luxembourg S.à.r.l.
Aria Europe S.A.
Arnage Holding S.A.
BCF Photonics II S.à r.l.
BCF Photonics I S.à r.l.
Clay Tiles Participations S.à.r.l.
Cognetas II German Holdings S.à r.l.
Delamain S.à r.l.
Dexia Global
DIT Luxembourg 1 S.à r.l.
Dumanet S.A.
EP Holding S.à.r.l.
EP Holding S.à.r.l.
Euro - Celtique S.A.
F.I.B.M. S.A.
Fortis LDI Solution
Golf Management Company S.A.
ILP III S.C.A., SICAR
ILP III S.C.A., SICAR
Immopam S.à.r.l.
Kensington S.A.
LaSalle German Retail Investments S.à r.l.
Luxembourgeoise de Construction Immobilière S.A.
Miscanthus-Nawaro-Innovations S.A.
MK Helicopter Participation S.à r.l.
Patrimoine Immo S.A.
Perseus Immobilien Gesellschaft 1
Perseus Immobilien Gesellschaft 11
Pert V S.A.
Phone Luxembourg Holdings S.à r.l.
Pilkington Luxembourg No. 1 S.à r.l.
Promotions Rante S.àr.l.
Richnou S.A.
Saveurs Lao Thaï S.à r.l.
Silver Star S.A.
Société Générale des Assaisonnements S.A.
Sportime Capital Management S.à r.l.
Tower 2008 (Luxco 1) S.à r.l.
United in Sports Management S.à r.l.
Urna S.A.
U.S. Fixed Income Fund Management Company S.A.