This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 954
17 avril 2008
SOMMAIRE
2000 Volts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45772
Amele-Work S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45778
Amele-Work S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45787
Amele-Work S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45787
Ascara Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45779
Bescha s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45761
Blumen beim Anja S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
45780
Brasilia Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45778
Brasilia Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45787
Brasilia Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45787
Cadeaux Shop Err S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
45779
Campbell Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
45778
Carbati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45776
Charterhouse TVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45779
Commercial Union Management Services
(Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45764
Copenhagen Retail Exclusive Lux S. à r. l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45765
Ecoprest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45777
Enop 4 A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45766
Enop 5 A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45766
Entreprise de Construction Lemos Sàrl . .
45792
Ernest Hermes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45765
Exprima Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
45791
FAM Sports S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45774
Fip Productions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45787
Franzen und Brandt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45747
Gio - Mimmo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45765
Glashaus in München S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
45747
GPB Asset Management S.A. . . . . . . . . . . .
45774
Immobilienbüro Lëtzebuerg S.A. . . . . . . . .
45778
Ioors Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45760
IVG EuroSelect The Square Verwaltungs-
gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45748
J.P. Morgan Capital Holdings Limited . . . .
45764
Lark Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45774
LogAxes Austria III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
45759
LogAxes Austria IV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
45760
LogAxes Investment Properties S.à r.l. . .
45762
Lutzenberg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45783
M&G European Property Finance Compa-
ny S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45775
M&G European Property Holding Compa-
ny S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45776
Neerveld 101-103 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
45746
Net Services GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45788
Oliver Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45775
Peinture Laruccia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45780
Perola Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45782
Perseus Real Estate Investment S.A. . . . . .
45767
Perseus Real Estate Investment S.à r.l. . . .
45767
PETROLEUM (Luxembourg) S.A. . . . . . . .
45746
R.F. Trans S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45787
Saba Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45783
Salfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45763
Santander Asset Management Luxem-
bourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45786
Schopaagri, Groupement agricole . . . . . . .
45781
Self A Three S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45748
Sensata Investment Company S.C.A. . . . .
45775
Société Financière de la Chaussée S.A. . . .
45781
Société Financière de la Chaussée S.A. . . .
45781
Steel and Logistic Services S.à r.l. . . . . . . .
45746
Tinsel Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45783
Unlimited Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
45777
Yaborandi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45747
45745
PETROLEUM (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 68, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 81.725.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 12/02/2008i>
Le mandat des administrateurs est prolongé pour la durée de 6 ans. Leur mandat expirera avec l'assemblée générale
ordinaire statuant sur l'année 2012.
Composition du conseil d'administration:
Marc REIFF
Mario REIFF
Joseph MEYER
Claude BAER
M. Marc REIFF est confirmé dans son mandat d'Administrateur délégué.
Le mandat du commissaire Edith REIFF est prolongé pour la durée de 6 ans. Son mandat expirera avec l'assemblée
générale ordinaire statuant sur l'année 2012.
Pour extrait conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Référence de publication: 2008040825/591/23.
Enregistré à Diekirch, le 20 février 2008, réf. DSO-CN00148. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(080045780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Steel and Logistic Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
R.C.S. Luxembourg B 97.042.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, den 20. März 2008.
<i>Für die Gesellschaft
i>Jean SECKLER
<i>Der Notari>
Référence de publication: 2008042425/231/13.
(080045248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.
Neerveld 101-103 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.778.
En date du 6 mars 2008, l'Associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- d'accepter la démission de Monsieur David George Bannerman en tant que Gérant de la Société avec effet au 17
mars 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2008.
<i>Neerveld 101-103 S.àr.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008042443/250/18.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07652. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
45746
Glashaus in München S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 122.018.
En date du 6 mars 2008, l'Associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- d'accepter la démission de Monsieur David George Bannerman en tant que Gérant de la Société avec effet au 17
mars 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2008.
<i>Glashaus in München S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008042444/250/18.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07651. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080046311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Yaborandi Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 98.627.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 16 août 2007i>
- La démission des sociétés DMC SARL, EFFIGI SARL et LOUV SARL de leur mandat d'Administrateurs est acceptée.
- Mademoiselle Noëlle PICCIONE, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg, Monsieur Daniel PIERRE, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg et Madame Céline BONVALET, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg, sont nommés comme nouveaux Administrateurs en leur remplacement. Leur mandat viendra à
échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.
Fait à Luxembourg, le 16 août 2007.
Certifié sincère et conforme
<i>POUR YABORANDI HOLDING S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008041643/795/21.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO05835. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080044340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2008.
Franzen und Brandt, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6470 Echternach, 24, rue de la Montagne.
R.C.S. Luxembourg B 128.391.
Le bilan de clôture au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2008.
FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2008042057/1218/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO03106. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080045240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.
45747
IVG EuroSelect The Square Verwaltungsgesellschaft, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 134.364.
<i>Beschluss des alleinigen Gesellschafters der Gesellschaft vom 6. Dezember 2007i>
Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hat folgenden Beschluss genommen:
- Herrn Bernhard Michael Veithen, geboren am 19. August 1963 in St.Vith, Belgien wohnhaft in Mechelsesteenweg 42,
B-3071 Erps-Kwerps, Belgien
mit Wirkung zum 6. Dezember 2007 als Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen, und auf unbegrenzte Zeit zu
bestellen.
Zum Vermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 13. März 2008.
IVG EuroSelect The Square Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften
Référence de publication: 2008041980/250/19.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06603. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080045404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.
Self A Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 137.247.
STATUTES
In the year two thousand and eight, on the seventeenth day of January.
Before Maître Paul BETTINGEN, notary, residing in Niederanven.
There appeared:
SCHRODER PROPERTY INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l., a company incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Lu-
xembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 102.436, acting in its own name but on behalf of
Aareal, a fonds commun de placement, organised under Luxembourg law; and in particular the sub-funds Aareal Eurolo-
gistics Fund A and Aareal Eurologistics Fund B;
here represented by Ms Cecile Gadisseur, lawyer, residing professionally at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by
virtue of a power of attorney, given under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. Name. There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of
SELF A THREE S.à r.l. (the Company), which shall be governed by the law dated 10th August, 1915 on commercial
companies, as amended (the 1915 Law), as well as by these Articles.
Art. 2. Corporate object.
2.1 The purpose of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of
participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development
of those participations.
2.2 In particular, the Company may use its funds for the acquisition and sale of real estate either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad as well as for all operations relating to real estate, including (i) direct or indirect shareholdings
in companies and participations in limited partnerships (including German Kommanditgesellschaften) or other legal entities
in whatever form, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease
of real estate, (ii) acting as a trustee in relation to real estate or real estate companies and (iii) the subscription to
convertible and other debt securities or loan notes, the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in
relation to the above activities. For the purposes of financing its activities, the Company may issue debt securities, loan
notes or other debt instruments and enter into credit arrangements or other loan facilities.
2.3 The Company may carry out any industrial or commercial activity, which, directly or indirectly, favours the reali-
sation of its purpose.
45748
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office is established in the municipality of Luxembourg.
4.2 It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of shareholders.
4.3 The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the manager
(s).
4.4 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital.
5.1 The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 17,000 (seventien thousand euros), represented by 250,000
(two hundred fifty thousand) class A shares with no nominal value, 10,000 (ten thousand) class B shares with no nominal
value, 10,000 (ten thousand) class C shares with no nominal value, 10,000 (ten thousand) class D shares with no nominal
value, 10,000 (ten thousand) class E shares with no nominal value, 10,000 (ten thousand) class F shares with no nominal
value, 10,000 (ten thousand) class G shares with no nominal value, 10,000 (ten thousand) class H shares with no nominal
value, 10,000 (ten thousand) class I shares with no nominal value, 10,000 (ten thousand) class J shares with no nominal
value.
5.2 The authorised share capital of the Company (including, for the avoidance of doubt, the issued share capital from
time to time) is set at EUR 40,000,000.- (forty million euros).
5.3 No more than ten classes of shares which shall be distinguished with reference to a letter of the alphabet (class A
to class J share) may be created and shares may be issued within one or more of the ten class of shares from time to
time at the occasion of share capital increase by the manager/board of managers or the general meeting of shareholders.
5.4 The subscribed share capital may be changed at any time by a resolution of the shareholders' meeting deliberating
in the manner provided for amendments to the articles of association (the Articles) or by a resolution of the manager/
board of managers acting pursuant to article 7 of the present Articles, within the ten existing classes of shares.
Art. 6. Shares.
6.1 Vis-à-vis the Company, the Company's shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
The number of shareholders in the Company may not exceed thirty (30).
6.2 The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the share-
holders will not bring the Company to an end.
6.3 The capital contribution, including any share premium, made in consideration for the issuance of shares of a certain
class of shares (regardless of the time of issue of the shares), as well as any other funds allocated by the shareholders
(such as loans granted by the shareholders to the Company) (the Funds) relating to a class of shares (such capital con-
tribution and Funds being allocated by the manager/board of managers in accordance with article 6.4. below), shall be
used to directly or indirectly invest in one and the same investment (the Targeted Investment) by decision of the manager/
board of managers and the unanimous approval of the shareholders of this class of shares. Consequently, each class of
shares will be linked to a particular Targeted Investment.
6.4 The Company shall keep accounts on behalf of each class of shares (collectively the Accounts and each an Account).
Any capital contribution, including any share premium and Funds made to the Company by or on behalf of the holder
(s) of the different classes of shares, the reinvested proceeds from the respective Targeted Investments and the related
and/or deriving assets and liabilities shall be applied in the books of the Company to the corresponding Accounts, res-
pectively.
Upon the liquidation of the Company, each class of shares is entitled to the proceeds resulting from the liquidation of
the assets held by the Company in the Account set up for that class of shares, as provided for in article 20 hereof.
6.5 With regard to each class of shares, the net asset value per share shall be calculated by the Company at a frequency
determined by the manager/board of managers, such date on which the net asset value shall be calculated being referred
to herein as the Valuation Day. The net asset value of shares of a class of shares shall be calculated as a per share figure
and shall be determined in respect of any Valuation Day by dividing the value (as determined consistently and in good
faith by the manager/board of managers of the Company) of the assets of the Account relating to each class of shares
less the liabilities (also determined consistently and in good faith by the manager/board of managers of the Company)
attributable to such class, by the number of shares of the relevant class then issued and outstanding.
The assets and liabilities shall be allocated as follows:
(a) All capital contributions to be received from the issue of shares of a certain class of shares and Funds relating to
that class of shares shall be applied in the books of the Company to the Account of that class of shares and the relevant
amount shall increase the assets of such Account, and assets and liabilities and income and expenditure attributable to
such Account shall be applied to that class of shares subject to the provisions of these Articles.
45749
(b) Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same Account as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant Account.
(c) Where the Company incurs a liability, expense or cost which is caused by or relates to any asset of a particular
Account or to any action taken in connection with an asset of a particular Account, such liability, expense or cost shall
be allocated to the relevant Account.
(d) If any asset, liability, expense or cost of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
Account, such asset or liability shall be allocated to all the Accounts pro rata to the net asset values of the respective
Accounts relative to each other or in such other manner as determined by the manager/board of managers acting rea-
sonably and in good faith. When so doing, the manager/board of managers has to allocate assets or liabilities in a way
considered to be fair, consistent and reasonable having regard to all relevant circumstances.
6.6 Shares of the Company may not be subscribed by or transferred to any natural persons. The Company will not
give effect to any transfer of shares of the Company to natural persons.
Art. 7. Authorisation of the manager/board of managers.
7.1 The manager/board of managers is authorised and instructed, without any need of a further decision by the general
meeting of shareholders, after having acknowledged in writing that the terms and conditions of these Articles are complied
with and have been fulfilled, (i) to render effective any increase of the issued share capital under this article 7, up to the
authorised share capital, in whole or in part, with or without the payment of a share premium and within one or more
of the ten existing class of shares, (ii) to see to the recording of such increase(s) and the consequential amendments of
the Articles before a Luxembourg notary and, (iii) to proceed to such issues on the basis of a report to be made to the
general meeting of shareholders on the circumstances and price of the issue(s) of shares within the authorised share
capital.
7.2 The authorised share capital of the Company and the authorisation referred to in article 7.1 above given to the
manager/board of managers shall be valid for five years from 17 January 2008 and may be renewed for additional periods
of up to five years each by resolution of the general meeting of shareholders by way of an extraordinary general meeting
resolving on the amendments of the Articles.
7.3 Each time the manager/board of managers shall issue shares within the authorised share capital as provided for
herein and act to render effective the increase of the issued capital, the Articles shall be amended accordingly so as to
reflect the result of such action. The manager/board of managers shall take or authorise any person to take any necessary
steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendments, including the recording of such increase,
the creation of new classes of shares, as the case may be, and the consequential amendments of the Articles before a
notary.
Art. 8. Transfer of shares.
8.1 In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
8.2 In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the
general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
8.3 The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the survivors.
8.4 The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the Companies Act) will apply.
Art. 9. Redemption of shares.
9.1 The Company shall have the power, subject to due observance of the provisions of the Companies Act, to acquire
shares in its own capital.
9.2 The manager/board of managers of the Company may redeem the shares of any class of shares provided that all
shares of that class of shares are redeemed. Such redemption shall be decided by an unanimous resolution of an ex-
traordinary general meeting of the shareholder(s), representing the entirety of the subscribed capital of the Company.
9.3 However, such redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available.
9.4 Such redeemed shares shall be cancelled and the subscribed share capital shall be reduced accordingly.
9.5 The redemption price will be equal to the net asset value of the shares calculated in accordance with article 6.5.
on the Valuation Day on which the redemption is carried out.
Art. 10. Management.
10.1 The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of
managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision
of the general meeting of the shareholders, adopted ad nutum (without having to state any reason).
10.2 The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appoint-
ment of each of the managers.
45750
Art. 11. Meetings of the board of managers.
11.1 Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.
11.2 The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency,
which will be specified in the convening notice, at least eight days' written notice of board meetings shall be given.
11.3 The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
11.4 The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
11.5 The notice may be waived by the consent in writing or by \ facsimile or by any other suitable telecommunication
means of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule
previously adopted by a resolution of the board of managers.
11.6 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any
other suitable telecommunication means another manager as his proxy.
11.7 A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are
present at the meeting.
11.8 Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference
call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
11.9 The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.
11.10 Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast.
11.11 In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed
at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.
Art. 12. Representation.
12.1 In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.
12.2 All powers not expressly reserved by the Companies Act or by the Articles to the general meeting of shareholders
fall within the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
12.3 In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager and, in case of
plurality of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers.
12.4 The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/its powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
12.5 The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent's responsibilities
and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders.
14.1 An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such
other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.
14.2 Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the
respective notices of meeting.
14.3 As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority.
15.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
15.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Collective
decisions are validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital.
15.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality
of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.
45751
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31st December, the Company's accounts are established
and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication
of the value of the Company's assets and liabilities.
Art. 18. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts
at the Company's registered office.
Art. 19. Appropriation of profits - Reserves.
19.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is
allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital.
19.2 The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.
19.3 Any losses, as the case may be, shall be allocated to the Accounts respectively, commensurate to the proportion
of the losses derived from the assets and liabilities of the Accounts respectively.
19.4 Dividends, when payable, will be declared and paid by a resolution of the general meeting of shareholders at the
time and place fixed by the manager/board of managers subject to such resolution.
19.5 Interim dividends may be declared and paid by the general meeting of shareholders or by the manager/board of
managers at any time out of distributable profits.
Art. 20. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders
deliberating in accordance with the requirements applicable for amendments of the Articles.
Art. 21. Liquidation.
21.1 Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether
shareholders or not, appointed by the general meeting of the shareholder(s) who will determine their powers and re-
muneration.
21.2 The liquidator(s) shall liquidate the Company's business as quickly as the circumstances of the business allow, and
within a reasonable period shall sell the assets of the Company or make use of another method for the liquidation of the
Company's assets. After having paid or constituted the appropriate provisions by setting up reserves for all the Company's
commitments to its creditors, he/she/they shall distribute the Company's assets amongst the shareholders in accordance
with the provisions of this article 21.
21.3 Upon the Company's liquidation, all of the Company's assets or the proceeds arising therefrom shall be distributed
or used as follows and in the following order of priority:
(a) For the payment of the Company's debts and commitments and liquidation expenses including the setting-up of all
provisions which the liquidator(s) shall consider reasonably necessary for any uncertain or unforeseen commitments and
liabilities of the Company made in accordance with the allocations as set forth in article 6.5 hereof;
(b) For the payment to the shareholders of each class of shares of the proceeds from the disposal of the assets held
by the Company in the Accounts respectively and reduced respectively (for the purpose of calculation) by the relevant
charges, debts, liabilities and expenditures attributable (or, as the case may be, portions thereof) to each of the classes
of shares as determined in accordance with article 6.5 hereof.
Art. 22. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders.
Art. 23. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and paymenti>
The appearing party hereby declares that it subscribes to the three hundred fourty thousand (340,000) shares repre-
senting the total subscribed share capital as follows:
- Schroder Property Investment Management (Luxembourg) S. à r.l. acting in its own name but on behalf of Aareal, a
fonds commun de placement, and in particular the sub-fund Aareal Eurologistics Fund A.
- 200,425 class A shares
- 8,017 class B shares
- 8,017 class C shares
- 8,017 class D shares
- 8,017 class E shares
- 8,017 class F shares
- 8,017 class G shares
- 8,017 class H shares
45752
- 8,017 class I shares
- 8,017 class J shares
- Schroder Property Investment Management (Luxembourg) S. à r.l. acting in its own name but on behalf of Aareal, a
fonds commun de placement, sub-fund Aareal Eurologistics Fund B:
- 49,575 class A shares
- 1,983 class B shares
- 1,983 class C shares
- 1,983 class D shares
- 1,983 class E shares
- 1,983 class F shares
- 1,983 class G shares
- 1,983 class H shares
- 1,983 class I shares
- 1,983 class J shares
That the class A, B, C, D, E, F, G, H, I, J shares have been entirely subscribed and fully paid up by contribution in cash
Proof of the following payments, making a total amount of EUR 17,000 has been given to the undersigned notary, by
the following:
- sub-fund Aareal Eurologistics Fund A: 13,628.90 euros
- sub-fund Aareal Eurologistics Fund B: 3,371.10 euros
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2008.
<i>Estimate Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately two thousand five hundred euros (EUR 2,500.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company have
herewith adopted the following resolutions:
1. The number of managers is set at 3 (three). The meeting appoints as manager(s) of the Company for an unlimited
period of time:
- Mr Edwoud Boekhout, managing director, born in Leeuwarden (the Netherlands), on July 2, 1969, residing at entree
260, 1101 EE Amsterdam Z.O., The Netherlands;
- Mr Robbert van Zinnicq Bergmann, managing director, born in 's-Gravenhage (the Netherlands), on June 16, 1948,
residing at entree 260, 1101 EE Amsterdam Z.O., The Netherlands; and
- Mr Joseph El Gammal, managing director, born in Paris 12th (France), on November 30, 1928, residing at 11, boulevard
Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg.
2. The registered office is established at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Senningerberg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendacht, am siebzehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitz in Niederanven.
Ist erschienen:
SCHRODER PROPERTY INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l., eine Gesellschaft luxemburgischen
Rechts, mit Gesellschaftssitz in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg, eingetragen im R.C.S. Luxemburg unter
der Nummer B 102.436, in ihrem eigenen Namen handelnd für die Rechnung von Aareal, einem fonds commun de
placement gegründet nach Luxemburger Recht und speziell für die Sub-funds Aareal Eurologistcs Fund A und Aareal
Eurologistics Fund B;
vertreten durch Ms Cecile Gadisseur, Anwältin, mit Berufsanschrift in 5, Höhenhof, L-1736 Senningerberg, aufgrund
einer Vollmacht unter Privatschrift.
45753
Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch die Vertreterin des Erschienenen und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter
der Bezeichnung SELF A THREE S.à r.l. (die Gesellschaft), welche dem abgeänderten Gesetz von 10ten August 1915 über
die Handelsgesellschaften (nachfolgend das Gesetz von 1915), sowie der nachfolgenden Satzung unterliegt.
Art. 2. Gesellschaftszweck.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Geschäfte welche, direkt oder indirekt, mit dem Erwerb von
Beteiligungen an jeglichen rechtlichen Unternehmen, gleich in welcher Form, zu tun haben, sowie die Verwaltung, das
Management, die Kontrolle und die Entwicklung dieser Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zum Kauf oder Verkauf von Immobilien, im Grossherzogtum Lu-
xemburg oder im Ausland verwerten, sowie für jegliche Geschäfte betreffend Immobilien, einschließlich (i) die direkte
oder indirekte Beteiligung in Gesellschaften und in Partnerschaften mit beschränkter Haftung (einschließlich deutscher
Kommanditgesellschaften) oder die Beteiligung in jegliche andere rechtlichen Unternehmen, gleich in welcher Form, deren
Hauptzweck der Kauf, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, das Management und/oder das Vermieten von Im-
mobilien ist, (ii) das Handeln als Treuhänder im Zusammenhang mit Immobilien oder Immobiliengesellschaften und (iii)
das Zeichnen von Wandel- und anderen Schuldverschreibungen oder Anleihen, die Bewilligung von Darlehen, Garantien
oder anderen Sicherheiten im Zusammenhang mit den obengenannten Tätigkeiten. Um ihre Tätigkeiten zu finanzieren,
kann die Gesellschaft Schuldverschreibungen, Anleihen oder andere Schuldinstrumente ausgeben und Kreditvereinba-
rungen eingehen oder andere Kreditfazilitäten gewähren.
2.3 Die Gesellschaft kann alle industriellen oder geschäftlichen Tätigkeiten ausführen, welche direkt oder indirekt, der
Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes dient.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Gesellschaftssitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
4.2 Er kann, durch Beschluss einer außergewöhnlichen Gesellschafterversammlung, in irgendeine andere Ortschaft des
Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann durch einfachen Beschluss des oder der Geschäftsführer(s) innerhalb der
Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.
4.4 Die Gesellschaft ist ermächtigt, in Luxemburg und im Ausland, Vertretungen und Zweigniederlassungen zu eröffnen.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 17.000.- (siebzehntausend Euro) eingeteilt in 250.000 (zweihundertfünfzig-
tausend) Anteile der Klasse A ohne Nennwert, 10.000 (zehntausend) Anteile der Klasse B ohne Nennwert, 10.000
(zehntausend) Anteile der Klasse C ohne Nennwert, 10.000 (zehntausend) Anteile der Klasse D ohne Nennwert, 10.000
(zehntausend) Anteile der Klasse E ohne Nennwert, 10.000 (zehntausend) Anteile der Klasse F ohne Nennwert, 10.000
(zehntausend) Anteile der Klasse G ohne Nennwert, 10.000 (zehntausend) Anteile der Klasse H ohne Nennwert, 10.000
(zehntausend) Anteile der Klasse I ohne Nennwert, 10.000 (zehntausend) Anteile der Klasse J ohne Nennwert.
5.2 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft (einschließlich, der Klarheit halber, das von Zeit zu Zeit gezeichnete
Gesellschaftskapital) ist auf EUR 40.000.000,- (vierzig Millionen Euro) festgesetzt.
5.3 Bis zu zehn zusätzliche Anteilklassen, welche durch Referenz eines Buchstaben des Alphabets (Anteilklasse A bis
Anteilklasse J) unterschieden werden, können von Zeit zu Zeit bei einer Kapitalerhöhung durch Beschluss des Geschäfts-
führers/Geschäftsführerrates oder der Gesellschafterversammlung geschaffen werden und Anteile innerhalb einer oder
mehrerer der zehn Klassen ausgegeben werden.
5.4 Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abgeändert werden und dies gemäß den
Bestimmungen für eine Satzungsänderung oder durch Beschluss des Geschäftsführers/Geschäftsführerrates gemäß Artikel
7 dieser Satzung, innerhalb der zehn bestehenden Anteilklassen.
Art. 6. Gesellschaftsanteile.
6.1 Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar und nur ein Inhaber pro Anteil ist zugelassen. Gemein-
same Co-Inhaber müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen.
Die Anzahl der Anteilinhaber darf nicht mehr als dreißig (30) betragen.
6.2 Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, die Einstellung von bürgerlichen Rechten, die Zahlungs-
unfähigkeit sowie den Konkurs des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter.
6.3 Die Kapitaleinlagen einschließlich jeglicher Emissionsagios, welche als Gegenleistung für die Ausgabe von Anteilen
einer bestimmten Anteilklasse (unabhängig vom Zeitpunkt der Ausgabe der Anteile) eingebracht wurden, sowie jegliche
andere von den Gesellschaftern zugeteilten Fonds (wie beispielsweise von den Gesellschaftern an die Gesellschaft bewil-
45754
ligte Darlehen) (die Fonds) bezüglich einer Anteilklasse (solche Kapitaleinlagen und Fonds werden vom Geschäftsführer/
Geschäftsführerrat in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des nachstehenden Artikels 5.4. zugeteilt), werden, durch
Beschluss des Geschäftsführers/Geschäftsführerrates und der einstimmigen Genehmigung der Gesellschaftern der ent-
sprechenden Anteilklasse, genutzt um direkt oder indirekt in ein und dasselbe Investment zu investieren (das Zielinvest-
ment). Folglich wird jede Anteilklasse mit einem bestimmten Zielinvestment verbunden sein.
6.4 Die Gesellschaft hält separate Konten für jede Anteilklasse (zusammen die Konten, einzeln das Konto).
Jede Kapitaleinlage, einschließlich jeglicher Emissionsagios und Fonds, welche durch oder auf Rechnung des (der) An-
teilinhaber(s) der verschiedenen Anteilklassen in die Gesellschaft eingebracht wurden, sowie die wieder investierten
Erträge aus den entsprechenden Zielinvestments und die diesbezüglichen und/oder abgleitenden Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten werden in den Büchern der Gesellschaft den entsprechenden Konten gutgeschrieben.
Im Falle einer Abwicklung der Gesellschaft hat jede Anteilklasse, gemäß Artikel 20 der vorliegenden Satzung, Anspruch
auf die Liquidationserlöse der Vermögenswerte welche von der Gesellschaft auf dem Konto, welches für diese Anteilklasse
eröffnet wurde, gehalten werden.
6.5 Für jede Anteilklasse wird der Nettoinventarwert der Anteile durch die Gesellschaft in den von dem Geschäfts-
führer/Geschäftsführerrat zu bestimmenden Abständen berechnet, wobei der Tag, an welchem diese Bewertung vorge-
nommen wird, als Bewertungstag bezeichnet wird. Der Nettoinventarwert der Anteile einer Anteilklasse wird pro Anteil
berechnet und wird an jedem Bewertungstag durch Division des Wertes (so wie vom Geschäftsführer/Geschäftsführerrat
folgerichtig und in gutem Glauben festgelegt) der Vermögenswerte des Kontos einer Anteilklasse unter Abzug der dieser
Anteilklasse zuzuordnenden Verbindlichkeiten (wie ebenfalls vom Geschäftsführer/Geschäftsführerrat folgerichtig und in
gutem Glauben festgelegt) durch die Anzahl der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen und ausstehenden Anteile, erhalten.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden wie folgt zugeordnet:
(a) Kapitaleinlagen, welche der Gesellschaft bezüglich der Ausgabe von Anteilen einer bestimmten Anteilklasse zuflie-
ßen, und Fonds bezüglich dieser Anteilklasse, werden in den Büchern der Gesellschaft auf dem Konto dieser Anteilklasse
gutgeschrieben und dieser Betrag steigert die dem Konto zuzuordnenden Vermögenswerte, und Vermögenswerte und
Verpflichtungen, Einkünfte und Ausgaben bezüglich dieses Kontos werden dieser Anteilklasse, gemäß den Bestimmungen
der vorliegenden Satzung, zugeordnet.
(b) Die Vermögenswerte die aus anderen Vermögenswerten bezogen werden, werden in den Büchern der Gesellschaft
dem Konto zugeteilt aus dem die Vermögenswerte bezogen wurden und jede Neuwertung eines Vermögenswertes sowie
jede Wertsteigerung bzw. -minderung werden dem entsprechenden Konto zugeordnet.
(c) Die Verpflichtungen, Ausgaben oder Kosten, welche bezüglich der Vermögenswerte eines bestimmten Kontos oder
bezüglich der Aktivitäten welche in Bezug auf die Vermögenswerte eines bestimmten Kontos getätigt werden, entstehen,
werden diesem Konto zugeordnet.
(d) Im Falle wo Vermögenswerte, Verpflichtungen, Ausgaben oder Kosten der Gesellschaft nicht einem bestimmten
Konto zugeordnet werden können, werden diese entweder proportional zu den eigentlichen Werten der jeweiligen
Konten aufgeteilt, oder auf jede andere Weise welche nach billigem Ermessen folgerichtig und gutem Glauben vom Ge-
schäftsführer/Geschäftsführerrat festgelegt wurde, aufgeteilt. Im letzteren Fall muss der Geschäftsführer/Geschäftsfüh-
rerrat die Verteilung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf fair und den Umständen angemessene Weise
vornehmen.
6.6 Anteile der Gesellschaft dürfen weder von natürlichen Personen gezeichnet werden noch an natürliche Personen
übertragen werden. Die Gesellschaft wird der Übertragung von Anteilen an natürliche Personen keine Wirkung geben.
Art. 7. Befugnis des Geschäftsführers/Geschäftsführerrates.
7.1 Der Geschäftsführer/Geschäftsführerrat ist nach einer schriftlichen Bestätigung, dass die Satzungsbedingungen be-
achtet und erfüllt worden sind, befugt und beauftragt, und dies ohne zusätzliche Bestimmung der Generalversammlung
der Gesellschafter, (i) jegliche Kapitalerhöhung gemäß Artikel 7 in Höhe des genehmigten Gesellschaftskapital, ganz oder
teilweise, mit oder ohne Zahlung eines Emmissionsagio und innerhalb einer oder mehrerer der zehn bestehenden An-
teilklassen durchzuführen, (ii) die Eintragung von solcher (solchen) Kapitalerhöhung(en) vorzunehmen und die notwen-
digen Schritte zur Satzungsänderung vor einem luxemburgischen Notar durchzuführen und, (iii) die Ausgabe von Anteilen
anhand eines Berichts an die Gesellschafterversammlung betreffend die Umstände und den Preis der auszugebenden
Anteile, vorzunehmen.
7.2 Das genehmigte Gesellschaftskapital und die Befugnis des Geschäftsführers/Geschäftsführerrates gemäß obenge-
nanntem Artikel 7.1. sind für einen Zeitraum von fünf Jahren gültig beginnend am 17. Januar 2008 und können durch eine
Bestimmung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung, welche gemäß den Bedingungen einer Satzungsumände-
rung tagt, für einen weiteren Zeitraum von jeweils fünf Jahren erneuert werden.
7.3 Jedes Mal wo der Geschäftsführer/Geschäftsführerrat Anteile innerhalb des genehmigten Gesellschaftskapitals,
gemäß den Bedingungen dieser Satzung, ausgibt, und eine dementsprechende Kapitalerhöhung vornimmt, muss die Satzung
dementsprechend abgeändert werden um diese Handlungen widerzuspiegeln. Der Geschäftsführer/Geschäftsführerrat
muss die notwendigen Schritte unternehmen damit die Änderung, einschließlich die Einschreibung der Kapitalerhöhung,
die Schaffung neuer Anteilklassen, je nachdem, und die sich daraus ergebende Änderungen vor dem Notar ausgeführt und
veröffentlicht werden oder Dritte damit beauftragen.
45755
Art. 8. Übertragung von Gesellschaftsanteilen.
8.1 Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
8.2 Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter
Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.
8.3 Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von
mindestens drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.
8.4 In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.
Art. 9. Rückkauf von Gesellschaftsanteilen.
9.1 Die Gesellschaft ist ermächtigt Anteile an seinem eigenen Gesellschaftskapital, gemäß den Bestimmungen des Ge-
setzes von 1915, zu kaufen.
9.2 Der Geschäftsführer/Geschäftsführerrat der Gesellschaft kann die Anteile einer jeglichen Anteilklasse zurückkau-
fen, vorausgesetzt, dass alle Anteile dieser Anteilklasse zurückgekauft werden. Solcher Rückkauf wird durch den
einstimmigen Beschluss einer außerordentlichen Generalgesellschafterversammlung entschieden, welche das gesamte ge-
zeichnete Gesellschaftskapital vertritt.
9.3 Solch ein Rückkauf kann jedoch nur beschlossen werden soweit genügend ausschüttbare Beträge verfügbar sind.
9.4 Solche zurückgekauften Anteile werden annulliert und das gezeichnete Gesellschaftskapital wird dementsprechend
reduziert.
9.5 Der Rückkaufpreis ist der Nettoinventarwert der Anteile, welcher gemäß Artikel 6.5 am Bewertungstag an dem
der Rückkauf durchgeführt wird, berechnet wird.
Art. 10. Geschäftsführung.
10.1 Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Bei einer Mehrzahl von Geschäftsführern wird ein
Geschäftsführerrat aufgestellt. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Die Gesellschafter-
versammlung kann jederzeit und ad nutum (ohne einen Grund zu nennen) den (die) Geschäftsführer abrufen und ersetzen.
10.2 Die Gesellschafterversammlung bestimmt das Gehalt sowie die Bedingungen der Bestellung eines jeden Ge-
schäftsführers.
Art. 11. Sitzungen des Geschäftsführerrates.
11.1 Sitzungen des Geschäftsführerrates können durch jeden einzelnen Geschäftsführer einberufen werden.
11.2 Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrates einberufen. Ausgenommen in
Dringlichkeitsfällen, welche im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen, werden die Geschäftsführer acht Tage
vor der Sitzung schriftlich einberufen.
11.3 Die Sitzung kann ohne vorherige Benachrichtigung ordnungsgemäß gehalten werden, falls sämtliche Geschäfts-
führer anwesend oder vertreten sind.
11.4 Die Sitzung erfolgt an Ort, Tag und Uhrzeit, welche im Einberufungsschreiben festgelegt sind.
11.5 Auf die Einberufung kann, durch die Zustimmung jedes Geschäftsführers, schriftlich oder per Fax oder durch jedes
andere angemessene Kommunikationsmittel, verzichtet werden. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch
der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten
Einberufung.
11.6 Jeder Geschäftsführer kann sich in jeder Geschäftsführerratssitzung durch einen anderen Geschäftsführer ver-
treten lassen, indem er ihn per Schreiben, Fax oder jedem anderen angemessenen Kommunikationsmittel zu seinem
Bevollmächtigten ernennt.
11.7 Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten, vorausgesetzt, dass mindestens zwei Ge-
schäftsführer an der Sitzung teilnehmen.
11.8 Jeder und alle Geschäftsführer kann oder können an einer Sitzung per Telefon oder Videokonferenzschaltung
oder einer ähnlichen Kommunikationstechnik, welche die gegenseitige Verständigung aller teilnehmenden Personen ge-
währt, teilnehmen. In diesem Fall gilt das entsprechend teilnehmende Mitglied des Geschäftsführerrates als persönlich
anwesend.
11.9 Die Beratungen und Entscheidungen des Geschäftsführerrates sind nur rechtskräftig wenn die Mehrzahl seiner
Mitglieder vorhanden oder vertreten sind.
11.10 Entscheidungen des Geschäftsführerrates werden durch die Stimmenmehrheit der Mitglieder getroffen.
11.11 Im Dringlichkeitsfall sind Umlaufbeschlüsse, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet werden, gültig und
verbindlich, als wären sie bei Gelegenheit einer einberufenen Sitzung gefasst worden. Die Unterschriften können auf einer
einzigen Urkunde erscheinen, aber auch auf mehreren Kopien eines identischen Beschlusses und diese Unterschriften
können per Brief, Fax oder Telex erfolgen.
45756
Art. 12. Vertretung.
12.1 Im Umgang mit Drittparteien, hat der/die Geschäftsführer die Befugnis zu jeder Zeit im Namen der Gesellschaft
zu handeln, sowie alle Geschäfte und Vorgänge, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind, durchzuführen und zu
genehmigen.
12.2 Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz von 1915 oder durch die Satzung der Gesellschaft für die
Gesellschafterversammlung bestimmt sind, fallen in die Kompetenz des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl
von Geschäftsführern, des Geschäftsführerrates.
12.3 Im Falle eines alleinigen Geschäftsführers ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterzeichnung des Geschäfts-
führers und, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterzeichnung von je zwei Mitgliedern
des Geschäftsführerrates gebunden.
12.4 Der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, kann einen oder
mehrere ad hoc Bevollmächtigte mit verschiedenen Befugnissen für spezifische Aufgaben beauftragen.
12.5 Der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat wird die Ver-
antwortlichkeiten und Vergütung (falls vorhanden), die Tätigkeitsdauer sowie alle weiteren erheblichen Bedingungen des
Mandats des Bevollmächtigten bestimmen.
Art. 13. Verbindlichkeiten der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en nicht persönlich für
im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten.
Art. 14. Gesellschafterversammlungen.
14.1 Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der
Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes
befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.
14.2 Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter
können jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.
14.3 Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse
schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss
ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).
Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit.
15.1 Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
15.2 Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen
teilzunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
15.3 Änderungen der Satzung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern
verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten; die Änderung des Gesell-
schaftsstatus (d.h. der Nationalität der Gesellschaft) kann nur einstimmig beschlossen werden, soweit nicht das Gesetz
von 1915 etwas anderes zulässt.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.
Art. 18. Einsicht der Gesellschafter. Am Gesellschaftssitz kann jeder der Gesellschafter Einsicht in die Bilanz und in die
Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 19. Gewinnverteilung - Rücklagen.
19.1 Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach Abzug aller Kosten und Abschrei-
bungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung einer gesetzlichen Rücklage
einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht.
19.2 Der Saldo des Nettogewinns wird auf die jeweiligen Konten, proportional zu ihrem Anteil an den aus den Ver-
mögenswerten des jeweiligen Kontos bezogenen Gewinnen, verteilt.
19.3 Jegliche Verluste, falls dies der Fall sein sollte, werden auf die jeweiligen Konten, proportional zu den aus den
Vermögenswerten des jeweiligen Kontos entstandenen Verpflichtungen und Verlusten, verteilt.
19.4 Dividenden, falls solche auszuschütten sind, werden durch Beschluss einer Generalgesellschaftsversammlung be-
stimmt und an einem Ort und an einer Zeit welche vom Geschäftsführer/ Geschäftsführerrat festgelegt werden,
ausgeschüttet.
45757
19.5 Zwischendividenden können von der Gesellschafterversammlung oder vom Geschäftsführer/Geschäftsführerrat
zu jeder Zeit aus den verteilbaren Gewinnen bestimmt und ausgeschüttet werden.
Art. 20. Auflösung. Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher gemäß
den Bedingungen für Satzungsänderungen gefasst wird, aufgelöst werden.
Art. 21. Abwicklung.
21.1 Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren, ob Gesellschafter
oder nicht, durchgeführt. Diese werden durch die Gesellschafter, welche gleichzeitig ihre Befugnisse und Vergütungen
festlegen, ernannt.
21.2 Der/Die Liquidator(en) wird/werden die Gesellschaft so schnell wie es der Geschäftsbetrieb erlaubt abwickeln
und wird/werden innerhalb eines angemessenen Zeitraumes die Vermögenswerte der Gesellschaft veräußern oder die
Vermögenswerte der Gesellschaft auf eine andere Art abwickeln. Nachdem alle Gläubiger bezahlt bzw. ihnen angemessene
Rücklagen zur Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft geschaffen wurden, werden die Vermögenswerte der
Gesellschaft unter den Gesellschaftern, gemäß den Bestimmungen dieses Artikels 21, durch den/die Liquidator(en) verteilt.
21.3 Bei Abwicklung der Auflösung der Gesellschaft, werden die Vermögenswerte der Gesellschaft oder Erlöse aus
diesen Vermögenswerten wie folgt und in dieser Reihenfolge verteilt oder genutzt:
(a) zur Begleichung, gemäß den Zuteilungsprinzipien, welche in Artikel 6.5. dieser Satzung festgelegt sind, der Ver-
bindlichkeiten, Verpflichtungen und Abwicklungskosten der Gesellschaft, inklusive zur Bildung von Rücklagen, welche der/
die Liquidator(en) als notwendig und angemessen zur Begleichung von unvorhersehbaren oder unbestimmbaren Ver-
bindlichkeiten oder Verpflichtungen der Gesellschaft, erachtet/en;
(b) zur Auszahlung an die Anteilinhaber einer jeden Anteilklasse des Verkaufserlöses von der Gesellschaft auf den
jeweiligen Konten gehaltenen Vermögenswerten nach Abzug (zu Kalkulationszwecken) der den Konten zugeordneten
Kosten, Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und Ausgaben (oder, falls dies der Fall sein sollte, Teile davon) welche der
jeweiligen Anteilklasse gemäß Artikel 6.5. der vorliegenden Satzung zugeteilt sind.
Art. 22. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-
prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat.
Art. 23. Verweis auf Gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Der Erschienene erklärt die dreihundertvierzigtausend (340.000) Anteile, welche das gesamte Kapital bilden, wie folgt
zu zeichnen:
- Schroder Property Investment Management (Luxembourg) S. à r.l. handelnd in eigenem Namen aber für Rechnung
von Aareal, ein fonds commun de placement, speziell für den Sub-fund Aareal Eurologistics Fund A, zeichnet:
- 200,425 Anteile der Klasse A
- 8,017 Anteile der Klasse B
- 8,017 Anteile der Klasse C
- 8,017 Anteile der Klasse D
- 8,017 Anteile der Klasse E
- 8,017 Anteile der Klasse F
- 8,017 Anteile der Klasse G
- 8,017 Anteile der Klasse H
- 8,017 Anteile der Klasse I
- 8,017 Anteile der Klasse J
- Schroder Property Investment Management (Luxembourg) S. à r.l. handelnd in eigenem Namen aber für Rechnung
of Aareal, ein fonds commun de placement, sub-fund Aareal Eurologistics Fund B, zeichnet:
- 49,575 Anteile der Klasse A
- 1,983 Anteile der Klasse B
- 1,983 Anteile der Klasse C
- 1,983 Anteile der Klasse D
- 1,983 Anteile der Klasse E
- 1,983 Anteile der Klasse F
- 1,983 Anteile der Klasse G
- 1,983 Anteile der Klasse H
- 1,983 Anteile der Klasse I
- 1,983 Anteile der Klasse J
45758
Die Anteile der Klasse A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, wurden voll gezeichnet und voll in bar eingezahlt
Der Nachweis über die Einzahlung über EUR 17.000.- wie folgt:
- sub-fund Aareal Eurologistics Fund A: 13.628,90 euro
- sub-fund Aareal Eurologistics Fund B: 3.371,10 euro
wurde dem Notar erbracht.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2008.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat oben genannter Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Ge-
sellschaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Geschäftsführerrat hat 3 (drei) Mitglieder. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden folgende Personen für
eine unbestimmte Zeit, ernannt:
- Herr Edwoud Boekhout, Geschäftsführer, geboren in Leeuwarden (Niederlande), am 2. Juli 1969, wohnhaft in entree
260, 1101 EE Amsterdam, Z.O., die Niederlande;
- Herr Robbert van Zinnicq Bergmann, Geschäftsführer, geboren in 's-Gravenhage (Niederlande), am 16. Juni 1948,
wohnhaft entree 260, 1101 EE Amsterdam, Z.O., die Niederlande; und
- Herr Joseph El Gammal, Geschäftsführer, geboren in Paris 12 (Frankreich), am 30. November 1928, wohnhaft in 11,
boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxemburg.
2. Die Adresse des Gesellschaftssitzes befindet sich in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.
Worüber die vorliegende Urkunde, zum eingangs genannten Datum in Senningerberg erstellt wird.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden hat der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unterzeich-
neten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Gadisseur, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 25 janvier 2008. LAC/2008/3631. — Reçu à 0,50%: quatre-vingt cinq euros (€ 85.-).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis Sandt.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg,le 12 février 2008.
Paul BETTINGEN.
Référence de publication: 2008042296/202/626.
(080045521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.
LogAxes Austria III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 135.928.
Hiermit erkläre ich,
- dass ausweislich der Circular Board Resolutions vom 26. Februar 2008 ein Wechsel der Geschäftsführung von den
Geschäftsführern von LogAxes Investment Properties S.à r.l. als alleinige Anteilseignerin beschlossen worden ist.
Folgender Geschäftsführer wurden abberufen:
- M. Eric Bley, Geschäftsadresse: 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- M. Winfried Wolf
Folgende Geschäftsführer wurden ernannt:
- M. Mark Phillips, Geschäftsadresse: 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- M. Stefan Pfisterer, Geschäftsadresse: Hans-Stießberger-Str. 2A, D-85540 Haar bei München, Allemagne.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
45759
Luxemburg, den 12. Februar 2008.
Sabine Hahn
<i>Company Secretaryi>
Référence de publication: 2008041984/649/22.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01384. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080045191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.
Ioors Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 100.937.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 janvier 2008i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 29 janvier 2008, que:
1. L'assemblée a pris acte des démissions, avec effet immédiat, des sociétés Myddleton Assets Limited et Langcraft
Investments Limited, de leurs mandats d'administrateurs, et de la démission de la société Fidugroup Holding S.A.H., de
ses mandats d'administrateur et administrateur-délégué.
2. L'assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat, Monsieur François Georges, expert-comptable, né le 20 mars
1967 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A, bd Grande-Duchesse Charlotte, comme
administrateur de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013, et donne pouvoir au Conseil
d'administration de nommer ce dernier à la fonction d'administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager la société en toutes
circonstances par sa seule signature.
3. L'assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Edouard Georges, employé privé, né le 10 février
1968 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A, bd Grande-Duchesse Charlotte, comme
administrateur de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
4. L'assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Ahmed Mechachti, employé privé, né le 3 juillet
1968 à Fès (Maroc), demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A, bd Grande-Duchesse Charlotte, comme
administrateur de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
5. L'assemblée a pris acte de la démission de la société Fid'Audit Limited de son mandat de commissaire. Elle a décidé
de nommer Mademoiselle Anne-Marie Pratiffi, employée privée, née le 17 avril 1971 à Mont Saint Martin, demeurant
professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A, bd Grande-Duchesse Charlotte, aux fonctions de commissaire, jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.
Pour extrait conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations
Luxembourg, le 29 janvier 2008.
IOORS LUXEMBOURG S.A.
François Georges / Ahmed Mechachti
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008042698/5710/35.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04915. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
LogAxes Austria IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 135.929.
Hiermit erkläre ich,
- dass ausweislich der Circular Board Resolutions vom 26. Februar 2008 ein Wechsel der Geschäftsführung von den
Geschäftsführern von LogAxes Investment Properties S.à r.l. als alleinige Anteilseignerin beschlossen worden ist.
Folgender Geschäftsführer wurden abberufen:
- M. Eric Bley, Geschäftsadresse: 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- M. Winfried Wolf
Folgende Geschäftsführer wurden ernannt:
- M. Mark Phillips, Geschäftsadresse: 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- M. Stefan Pfisterer, Geschäftsadresse: Hans-Stießberger-Str. 2A, D-85540 Haar bei München, Allemagne
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
45760
Luxemburg, den 12. Februar 2008.
Sabine Hahn
<i>Company Secretaryi>
Référence de publication: 2008041985/649/22.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01392. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080045188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.
Bescha s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7595 Reckange (Mersch), 2, rue du Moulin.
R.C.S. Luxembourg B 41.057.
DISSOLUTION
L'an deux mille sept, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,
Ont comparu:
1
o
Monsieur Jean-Jacques BETZ, employé privé, demeurant à Mondercange, ici représenté par Monsieur Camille
BETZ, nommé ci-après, en vertu d'une procuration sous seing privé;
2
o
Monsieur Camille BETZ, commerçant, demeurant à Leudelange;
3
o
Madame Marie-Alice BETZ, épouse SCHAEFERS, sans état particulier, demeurant à Mersch, ici représentée par
Monsieur Paul ELSEN, demeurant à Reckange/Mersch, en vertu d'une procuration sous seing privé;
4
o
Madame Claudette BETZ, épouse ELSEN, sans état particulier, demeurant à Reckange/Mersch, ici représentée par
Monsieur Paul ELSEN, demeurant à Reckange/Mersch, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Les trois procurations prédécrites, après avoir été signées «ne varietur» par les comparants et le notaire soussigné,
resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentaire:
Que la société dénommée BESCHA, S.à r l., avec siège social à L-7595 Reckange, 2, rue du Moulin, inscrite au Registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 41.057,
ci-après nommée la "Société",
a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Wiltz, le 25 juin 1992, publié au
Mémorial C numéro 554 du 28 novembre 1992.
Que le capital social de la Société est de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (€
12.394,68) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf
cents (€ 24,79) chacune, entièrement libérées.
Que les comparants déclarent être seuls associés de la Société.
L'activité de la Société ayant cessé, ils déclarent expressément vouloir procéder à sa dissolution.
Que les associés se désignent comme liquidateurs de la Société, qu'en cette qualité ils requièrent le notaire instru-
mentant d'acter qu'ils déclarent que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la
liquidation est dûment approvisionné; en outre ils déclarent que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuelle-
ment inconnus et non payés à l'heure actuelle, ils assument irrévocablement et solidairement l'obligation de payer tout
ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la dite Société est réglé;
Que l'actif restant éventuel est attribué aux associés prédésignés;
Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société;
Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société.
<i>Déclarationi>
Les comparants susmentionnés déclarent que la société BESCHA S.à r.l. est actuellement propriétaire d'un chemin
nommé «An der Gewaennchen» situé à Differdange et Sanem, inscrit au cadastre comme suit:
Commune de Differdange, section C d'Obercorn
- numéro 688/6792, lieu-dit «rue de Soleuvre», 2,06 ares
- numéro 688/6806, lieu-dit «Bei Woiwer», 0,06 ares
- numéro 688/6817, même lieu-dit, 22,71 ares
- numéro 688/6818, même lieu-dit, 0,29 ares
- numéro 688/6820, même lieu-dit, 0,01 ares
45761
- numéro 688/7028, même lieu-dit, 0,88 ares
- numéro 688/7029, même lieu-dit, 19,31 ares commune Sanem, section B de Soleuvre
- numéro 205/7189, lieu-dit «Auf der Gruenheck», 4,38 ares
- numéro 205/7560, même lieu-dit, 4,69 ares
- numéro 205/8056, même lieu-dit, 3,81 ares
- numéro 205/8057, même lieu-dit, 5,49 ares
<i>Titre de propriétéi>
La société BESCHA SARL a acquis les parcelles prédécrites en vertu d'un acte de vente reçu par le notaire soussigné
le 28 mars 1997, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg le 29 avril 1997, volume 1090, numéro
32.
Les associés déclarent attribuer ce chemin, y compris le trottoir, les lampadaires, la zone verte et toute l'infrastructure
à Monsieur Camille BETZ, mentionné sous 2
o
, en vue que celui-ci procède à des actes de cession gratuite de la prédite
rue à l'administration communale de Differdange respectivement de Sanem.
Monsieur Camille BETZ aura pouvoir de fixer les charges et conditions des actes de cession, de donner aux acquéreurs
respectifs toutes garanties légales et conventionnelles et de passer et signer tous actes, élire domicile, substituer et
généralement faire le nécessaire.
DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et
demeures, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Camille Betz, Paul Elsen, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2007. LAC/2007/42313. — Reçu douze euros (12.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare certifier l'état civil des associés sur base d'extraits des registres de l'état civil et que:
1) Monsieur Jean-Jacques BETZ, est né à Mersch, le 07 octobre 1947 (n
o
de matricule 1947 10 07 334)
2) Monsieur Camille BETZ, est né à Mersch, le 18 février 1950 (n
o
de matricule 1950 02 18 110)
3) Madame Marie Alice BETZ, est née à Mersch, le 01
er
septembre 1951 (n
o
de matricule 1951 09 01 145)
4) Madame Claudette BETZ, est née à Mersch, le 18 septembre 1953 (n
o
de matricule 1953 09 18 168)
Signé: Paul Bettingen.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 21 mars 2008.
Paul BETTINGEN.
Référence de publication: 2008042332/202/80.
(080045132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.
LogAxes Investment Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 126.265.
<i>Change of Boardi>
Hiermit erkläre ich,
- dass ausweislich der Circular Board Resolutions vom 20. Dezember 2007 und 25. Februar 2008 ein Wechsel der
Geschäftsführung von den Geschäftsführern von AVIVA FUND SERVICES als alleinige Anteilseignerin beschlossen worden
ist.
Folgende Geschäftsführer wurden abberufen:
- M. Klaus Schmidt (Circular Board Resolution vom 20. Dezember 2007);
- M. Winfried Wolf (Circular Board Resolution vom 20. Dezember 2007).
Folgende Geschäftsführer wurden ernannt:
- M. William Gilson, Geschäftsadresse: 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Circular Board Resolution vom
20. Dezember 2007);
- M. Thorsten Steffen, Geschäftsadresse: 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Circular Board Resolution
vom 20. Dezember 2007);
- M. Mark Phillips, Geschäftsadresse: 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Circular Board Resolution vom
25. Februar 2008)
45762
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 14. März 2008.
Sabine Hahn
<i>Company Secretaryi>
Référence de publication: 2008042196/649/28.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06986. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080045180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.
Salfin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 43.276.
DISSOLUTION
L'an deux mille huit, le six mars.
Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de SALFIN SA, L-1740 Luxembourg, 20, rue de
Hollerich, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 43.276, constituée suivant acte Marc
ELTER de Luxembourg en date du 15 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
Numéro 267 du 4 juin 1993, modifiée suivant acte Marc ELTER de Luxembourg du 30 septembre 1994, publié au dit
Mémorial, Numéro 10 du 7 janvier 1995, modifiée suivant acte Frank MOLITOR de Mondorf-les-Bains du 6 mars 1995,
publié au dit Mémorial, Numéro 296 du 28 juin 1995, modifiée suivant procès verbal d'assemblée générale extraordinaire
sous seing privé du 13 juillet 2001, publié au dit Mémorial, Numéro 225 du 9 février 2002.
L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Muriel LEHMANN, employée privée, demeurant à Hayange (France),
qui désigne comme secrétaire Manuel MOROCUTTI, employé privé, demeurant à Dudelange.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Pasquale CITRO, consultant, demeurant à Luxembourg.
Le Président expose d'abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Dissolution de la société.
2) Décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes.
3) Désignation du lieu où seront conservés les livres de la Société.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-
tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.
Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-
blement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée dissout avec effet immédiat la Société aux droits de l'associé unique, lequel se considère comme liquida-
teur et déclare reprendre personnellement tous les actifs et passifs même inconnus de la Société.
L'associé-liquidateur reconnaît avoir été rendu attentif par le notaire sur la portée de cette disposition.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée donne décharge aux administrateurs Pasquale CITRO, consultant, demeurant à Luxembourg, Elena LU-
DOVICO, sans état, demeurant à Vigy (France) et Sergio BRUSAMOLINO, expert-comptable, demeurant à Cassano
d'Adda/Milan (Italie), pour l'exécution de leurs mandats d'administrateurs, respectivement administrateur-délégué pour
Pasquale CITRO.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée donne décharge au commisaire aux comptes FIDU-CONCEPT SARL avec siège social à L-2132 Luxem-
bourg, 36, avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 38.136, pour
l'exécution de son mandat.
45763
<i>Quatrième résolutioni>
Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans à L-1740 Luxembourg, 20,
rue de Hollerich.
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Findel.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Lehmann, Morocutti, Citro et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 14 mars 2008, Relation: EAC/2008/3639. - Reçu douze euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Sand.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 20 mars 2008.
Frank MOLITOR.
Référence de publication: 2008042515/223/60.
(080046193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Commercial Union Management Services (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 25.076.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société qui s'est tenue le 28 juin 2007i>
<i>à 12.30 heuresi>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société en date du 28 juin 2007 que:
- Les gérants ont vu leurs mandats respectifs renouvelés pour une période jusqu'à la prochaine Assemblée Générale
devant approuver les comptes de l'exercice 2007.
* Mr. Gerhard Trubel, Gérant Délégué, 38, rue Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, né le 17 février 1965, Neunkirchen,
Allemagne
* Mr. Andrew Drinkwater, Gérant, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, né le 23 juillet 1963, Woking, Grande-
Bretagne
- Le réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers a vu son mandat renouvelé pour une période jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale devant approuver les comptes de l'exercice 2007.
* PricewaterhouseCoopers S. à r.l., 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg. R.C.S. Luxembourg B 65.477.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2008.
Gerhard Trubel
<i>Gérant Déléguéi>
Référence de publication: 2008042864/4105/26.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07235. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
J.P. Morgan Capital Holdings Limited, Société Anonyme.
Siège de direction effectif: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 73.205.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration du 12 mars 2008i>
<i>Co-optationi>
Le Conseil d'Administration a décidé de co-opter M. Sanjiv Sawhney en tant qu'Administrateur de la société en rem-
placement de M. Charles Macdonald, avec effet au 12 mars 2008.
<i>Composition du Conseil d'Administrationi>
Au 12 mars 2008, le Conseil d'Administration se compose comme suit:
M. Jonathan P. Griffin, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Administrateur;
M. Alain Picherit, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Administrateur;
Mme Dale Quarry, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Administrateur ;
45764
M. Adam M. Gilbert, 270 Park Avenue, USA 10017 New York, Administrateur;
Mme Helen Valentine, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Administrateur;
M. Sanjiv Sawhney, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Administrateur.
Certifié conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Anne D'Alimonte
<i>Company Secretaryi>
Référence de publication: 2008042432/2205/25.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06851. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Ernest Hermes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7333 Steinsel, 33A, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 74.555.
<i>Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 6 mars 2008i>
L'assemblée générale accepte la démission de Madame Sharon HERMES de son poste d'administrateur et nomme en
remplacement Madame Rita HARNACK demeurant professionnellement à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
Le mandat viendra à échéance à l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2012.
Signature.
Référence de publication: 2008042434/680/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06900. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Gio - Mimmo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8140 Bridel, 64-66, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 86.060.
Par la présente je soussigné, DELLI-CARPINI Domenico, demeurant à 10A, Juddegaass, L-8281 KEHLEN, N
o
Matricule
1963 0131 017, vous envoie ma démission en tant que gérant technique de la société GIO-MIMMO Sàrl avec effet immédiat
KEHLEN, le 26 mars 2008.
DELLI-CARPINI Domenico
10A, Juddegaass, L-8281 KEHLEN
Signature
Référence de publication: 2008042455/8806/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08191. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Copenhagen Retail Exclusive Lux S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 135.834.
EXTRAIT
Il résulte de la cession de parts intervenue en date du 31 janvier 2008 que:
The Governor and Company of The Bank of Ireland, ayant son siège social à Lower Baggot Street, Dublin 2, Irlande,
a cédé les 100 parts sociales qu'elle détenait dans la société Copenhagen Retail Exclusive Lux S.à r.l., ayant son siège social
à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle à European Property Portfolio Nominees Limited, ayant son siège
social au 40, Mespil Road, Dublin 4, Irlande.
La cession de parts a été notifiée et acceptée par la société Copenhagen Retail Exclusive Lux S.à r.l. en date du 31
janvier 2008 conformément à l'article 1690 du Code Civil et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Suite à cette cession, le capital social de la société Copenhagen Retail Exclusive Lux S.à r.l.
45765
est détenu comme suit:
European Property Portfolio Nominees Limited, ayant son siège social au 40, Mespil Road, Dublin 4, Irlande: 100 parts
sociales
Luxembourg, le 4 mars 2008.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2008042437/534/25.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO07050. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Enop 5 A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 76.813.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 10 mars 2008i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2012:
- Monsieur Herbert MÜLLER, Diplom-Ingenieur, demeurant au 14, Wengertswee, L-5485 Wormeldange-Haut, Pré-
sident du Conseil d'Administration;
- Monsieur Joachim Albert WÖRZ, Diplom-Kaufmann, demeurant au 47, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;
- Monsieur Robert SCHINTGEN, Privatbeamter,' demeurant au 113, rue de Bridel, L-7217 Bereldingen;
- Monsieur Frank NIMAX, Privatbeamter, demeurant au 21B, Cité Patton, L-9068 Ettelbruck.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2009:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil, des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2008.
Signatures.
Référence de publication: 2008042435/534/22.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO07052. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Enop 4 A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 76.812.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 10 mars 2008i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2012:
- Monsieur Herbert MÜLLER, Diplom-Ingenieur; demeurant au 14, Wengertswee, L-5485 Wormeldange-Haut, Pré-
sident du Conseil d'Administration;
- Monsieur Joachim Albert WÖRZ, Diplom-Kaufmann, demeurant au 47, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;
- Monsieur Robert SCHINTGEN, Privatbeamter, demeurant au 113, rue de Bridel, L-7217 Bereldingen;
- Monsieur Frank NIMAX, Privatbeamter, demeurant au 21B, Cité Patton, L-9068 Ettelbruck.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2009:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2008.
Signatures.
Référence de publication: 2008042436/534/22.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO07051. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
45766
Perseus Real Estate Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Perseus Real Estate Investment S.A.).
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 127.199.
In the year two thousand and eight, on the nineteenth day of March.
Before the undersigned notary Paul BETTINGEN, residing in Niederanven, (Grand Duchy of Luxembourg);
APPEARED:
"Equilibrium Holding Establishement", with registered office in FL-9490 Vaduz, Austrasse 61, (Principality of Liechten-
stein), inscribed in the "Öffentlichkeitsregister" of Liechtenstein under the number FL-0002.232.967-1 (the "Sole
Shareholder"),
represented by Mr. Hassane DIABATE, attorney, professionally residing in L-2661 Luxembourg, 44, rue de Vallée, by
virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the
officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act:
- that it is the Sole Shareholder of the public limited company "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.A", (hereafter
the "Company"), a société anonyme, with registered office at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, inscribed in
the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 127.199, incorporated pursuant to a
deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on March 27th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 1202 of the 19th of June 2007, and
- that it takes the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the legal form of the Company, in order to transform it from a public limited
company ("'Aktiengesellschaft" - "AG") into a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung"
- "G.m.b.H.").
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company into "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à
r.l."
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to fully restate the articles of association of the Company notably to reflect the reso-
lutions recorded here-above and so as they read as follows:
" Art. 1. There exists a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") under the name of
"PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", (hereafter the "Company"), which will be governed by these articles of
association (the "Articles") as well as by the relevant legal dispositions.
Art. 2. The purposes of the Company are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development
of these participating interests.
It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of
any securities of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire
by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever securities, to
realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities, to grant to the companies,
in which it has participating interests either directly or indirectly or to the companies which are controlled by the same
persons as the Company, any support, loans, advances or guarantees.
Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security
for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible
notes), preferred equity certificates, convertible preferred equity certificates and debentures.
The Company may also undertake any commercial, industrial and financial transactions, which it might deem useful for
the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The duration of the Company is unlimited.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a collective decision of the
shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
45767
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at one hundred thousand Euros (100,000.- EUR), divided into
one hundred (100) shares with a par value of one thousand Euros (1,000.- EUR) each.
All the shares have been subscribed and fully paid up.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. The share capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law governing
commercial companies.
Art. 7. Each share entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.
Art. 8. Shares shall be freely transferable between shareholders.
They can only be transferred inter vivos or upon death to non-shareholders with the unanimous approval of all the
shareholders.
Art. 9. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders.
Art. 10. For no reason and in no case, the heirs or creditors of the shareholders are allowed to pursue the sealing of
property or documents of the Company.
Art. 11. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected
for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time
by the general meeting.
If the post of a Manager elected by the general meeting becomes vacant, the remaining Managers thus elected, may
provisionally fill the vacancy.
In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 12. The Board of Managers chooses among its members a chairman.
If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the Managers present at the meeting designated
to that effect by the board.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any two Managers.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented; proxies
between Managers being permitted, with the restriction that a Manager can only represent one of his colleagues.
The Company will be validly bound by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person(s)
whom such signatory power will be delegated by the Board of Managers.
The Managers may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, fax or e-mail, confirmed by letter.
Written resolutions, approved and signed by all Managers, shall have the same effect as resolutions voted at the
Managers' meetings.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.
If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg
if the call is initiated from Luxembourg.
Art. 13. Decisions of the Board of Managers are taken by an absolute majority of the votes cast.
In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.
Art. 14. The minutes of the meetings of the Board of Managers shall be signed by all the Managers having assisted at
the debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one Manager or by a proxy.
Art. 15. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposition
in the Company's interest within the limits of the Company's purpose.
All powers not expressly reserved to the general meeting of the shareholders of the Company by the law of August
10th, 1915 on commercial companies as subsequently modified (the "Law"), or by the present Articles of the Company,
fall within the competence of the Board of Managers.
Art. 16. The Board of Managers may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons, who need not be shareholders of the Company.
Art. 17. In the execution of their mandate, the Managers are not held personally responsible.
As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.
45768
Art. 18. The Company is supervised by one independent auditor who is appointed by the general meeting of the
shareholders, which determines its remuneration. The independent auditor can be dismissed at any time by the general
meeting of the shareholders.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of the shareholders for a period
not exceeding six years.
Art. 19. Every shareholder may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number
of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.
Art. 20. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.
However, decisions concerning the amendment of the Articles are taken by a majority of the shareholders representing
seventy-five percent of the capital.
In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law or the
Articles, are assigned to the general meeting are exercised by the sole shareholder.
Art. 21. The business year begins on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.
Art. 22. Every year, the annual accounts are drawn up by the Managers.
Art. 23. The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 24. Out of the net profit, five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be
compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.
The balance is at the disposal of the shareholders.
Art. 25. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need
not to be shareholder and who are appointed by the shareholders who will specify their powers and remuneration.
Art. 26. For all points not regulated by these Articles, reference is made to the provisions of the Law and its modifying
acts, concerning trading companies."
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that the current directors of the Company as listed below be requalified as managers
of the Company and shall continue their management duties for an undetermined duration:
a) Mr Nico HANSEN, manager, born in Differdange, (Grand Duchy of Luxembourg), on the 31st of March 1969,
professionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;
b) Mrs Sophie BATARDY, private employee, born in Lille, (France), on the 22nd of January 1963, professionally residing
in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;
c) Mr Peter MATHIS, manager, born in Wolfenschiessen, (Switzerland), on the 17th of January 1953, residing in
CH-8400 Winterthur, Sonnenbergstraße, 39.
<i>Expensesi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand six hundred
Euros (EUR 1,600.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the
above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing party, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day stated at the beginning of this
document.
The deed having been read to the proxy-holder of the appearing party, known to the notary by his first and last name,
civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, the present deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendacht, den neunzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz in Niederanven, (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Die Anstalt "Equilibrium Holding Establishement", mit Sitz in FL-9490 Vaduz, Austrasse 61, (Fürstentum Liechtenstein),
eingetragen im Öffentlichkeitsregister von Liechtenstein unter der Nummer FL-0002.232.967-1,
hier vertreten durch Herr Hassane DIABATE, Jurist, beruflich wohnhaft in L-2661 Luxemburg, 44, rue de Vallée, auf
Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht von dem Bevollmächtigten und dem amtie-
45769
renden Notar "ne varietur" unterschrieben wurde und gegenwärtigen Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben
einregistriert zu werden.
Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt und den amtierenden Notar ersucht zu beurkunden,
- dass sie die einzige Aktionärin der Aktiengesellschaft "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.A.", (hiernach die
"Gesellschaft"), mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 127.199, ist, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar
Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, am 27. März 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 1202 vom 19. Juni 2007,
- und dass sie folgende Beschlüsse fasst:
<i>Erster Beschlussi>
Der einzige Aktionär beschließt die Rechtsform der Gesellschaft abzuändern, um sie von einer Aktiengesellschaft
("AG") in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (G.m.b.H.) umzuwandeln;
<i>Zweiter Beschlussi>
Der einzige Aktionär beschließt die Gesellschaftsbezeichnung in "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S. à r.l."
abzuändern.
<i>Dritter Beschlussi>
Infolge der vorangehenden Beschlüsse beschliesst der einzige Aktionär die Statuten vollständig neu zu fassen, so dass
diese nunmehr lauten wie folgt:
" Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "PERSEUS REAL ESTATE
INVESTMENT S. à r.l." ("die Gesellscahft"), welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestim-
mungen unterliegt.
Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der
Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kon-
trolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.
Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen
Sicherheiten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb
durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten, deren Veräu-
ßerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst wie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vor-
schüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist oder an Unternehmen,
die von denselben Personen kontrolliert werden wie die Gesellschaft.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen und kann Schuldinstrumente sowie nicht verzinslichen PEC,
CPEC, Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Wertpapieren ausgeben.
Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, und jede Art finanzieller Operationen die sich direkt oder indirekt auf
vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg-Stadt, Grossherzogtum Luxemburg.
Er kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen, die für eine Sat-
zungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrats
verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch
im Ausland haben.
Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einhunderttausend Euro (100.000,- EUR), eingeteilt in einhundert
(100) Anteile mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR).
Alle Anteile wurden vollständig eingezahlt.
Jeder verfügbare Betrag des Anteilagios soll ausgeschüttet werden.
Art. 6. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-
schaftsrechts festgelegt ist.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen
sowie am Gewinn.
Art. 8. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
45770
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter,
bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.
Art. 9. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit
eines Gesellschafters.
Art. 10. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Do-
kumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschrän-
ken könnten.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch mindestens drei Geschäftsführer geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen,
und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können
Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Geschäftsführers frei, können die so ernannten ver-
bleibenden Geschäftsführer das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.
In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.
Art. 12. Der Geschäftsführerrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.
Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Geschäftsführerrat bestimmte anwesende Mitglied
dessen Aufgabe.
Der Geschäftsführerrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Geschäftsführern einberufen.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; Voll-
machten unter Geschäftsführern sind erlaubt, wobei ein Geschäftsführer jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die alleinige Unterschrift
jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführerrat übertragen
worden ist.
Die Geschäftsführer können ihre Stimme per Brief, Fernschreiben, Telefax oder E-Mail abgeben, welche schriftlich
bestätigt werden müssen.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Geschäftsführern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso
rechtswirksam wie ein anlässlich einer Geschäftsführerratssitzung gefasster Beschluss.
Außerdem soll jeder Geschäftsführer - welcher an einer Geschäftsführerratssitzung im Wege einer Kommunikations-
hilfe (einschließlich Telefon) teilnimmt, welche es den anwesenden Geschäftsführern erlaubt, den anderen Geschäftsführer
jederzeit während der Sitzung zu hören und selbst gehört zu werden - als für diese Geschäftsführerratssitzung anwesend
gelten und soll bei der Aufstellung des Quorums und mit seiner Stimme bei Abstimmungen während einer solchen Sitzung
berücksichtigt werden.
Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst
gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.
Art. 13. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 14. Die Protokolle der Sitzungen des Geschäftsführerrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mit-
gliedern unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch einen Geschäftsführer oder durch einen Bevollmächtigten.
Art. 15. Der Geschäftsführerrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft, alle Angele-
genheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie durch die späteren Änderungen, oder
durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Ge-
schäftsführerrates.
Art. 16. Der Geschäftsführerrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen,
die Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.
Art. 17. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.
Art. 18. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare, welche nicht Aktionäre sein
müssen, überwacht, welche von der Generalversammlung, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt, ernannt werden; sie
können beliebig abberufen werden.
Die Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt, welche die Dauer von 6 Jahren nicht
überschreiten kann.
Art. 19. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen. Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner
Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
45771
Art. 20. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden.
Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche
mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.
Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder
Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.
Art. 21. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 22. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.
Art. 23. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.
Art. 24. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage
zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.
Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 25. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein
Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung
festlegen.
Art. 26. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften, verwiesen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Komparentin beschließt, dass die derzeit bestellten Verwaltungsräte (wie unten aufgelistet) der Gesellschaft für
eine unbestimmte Dauer ihre Managementtätigkeiten weiterführen sollen:
a) Herr Nico HANSEN, Gesellschaftsverwalter, geboren in Differdingen, (Großherzogtum Luxemburg), am 31. März
1969, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;
b) Frau Sophie BATARDY, Privatangestellte, geboren in Lille, (Frankreich), am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft in
L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;
c) Herr Peter MATHIS, Gesellschaftsverwalter, geboren in Wolfenschiessen, (Schweiz), am 17. Januar 1953, wohnhaft
in CH-8400 Winterthur, Sonnenbergstraße, 39.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausendsechshundert
Euro (EUR 1.600,-).
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der
erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen
derselben erschienenen Partei, und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird
die englische Fassung maßgeblich sein.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Senningerberg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparentin, dem instrumentierenden Notar
nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe Person mit Uns, dem Notar, gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Diabate, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 20 mars 2008, LAC / 2008 / 11933. - Reçu € 12.- (douze Euros).
<i>Pr. Le Receveuri> (signé): Franck Schneider.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 26. März 2008.
Paul BETTINGEN.
Référence de publication: 2008042508/202/309.
(080045843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
2000 Volts, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 262, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 80.736.
L'an deux mille huit, le vingt-cinq février.
Par devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
45772
1. Monsieur Thierry SMETS, administrateur de société, né à Wilrijk, Belgique, le 1
er
décembre 1956, demeurant à
Bereldange,
2. Monsieur Chi-Taï TRÂN, ingénieur industriel, né à Louvain, Belgique, le 6 février 1962, demeurant à Ehner,
ici représenté par Monsieur Thierry SMETS, préqualifié,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Strassen, en date du 18 février 2008,
3. Global Media Systems S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2610 Howald,
212, route de Thionville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.390
ici représentée par Monsieur Thierry SMETS, préqualifié,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Strassen, en date du 18 février 2008,
Lesdites procurations, signées "ne varietur" par le mandataire et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Messieurs Thierry SMETS, Chi-Taï TRÂN, et la société anonyme Global Media Systems S.A., déclarent être ensemble
avec Monsieur Peter BYSSZ, né à Budapest, Hongrie, le 11 août 1974, demeurant à L-6460 Echternach, 21, Place du
Marché, les seuls associés de la société à responsabilité limitée 2000 VOLTS, ayant son siège social à L-8010 Strassen,
262, route d'Arlon, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 80.736, con-
stituée suivant acte notarié en date du 16 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
812 du 26 septembre 2001.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 25 mai 2005, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1094 du 25 octobre 2005 (ci après la "Société").
La présente assemblée a été convoquée par lettre recommandée du 18 février 2008.
Les comparants prennent acte du fait que, par déclaration écrite datée du 27 novembre 2007, l'associé Monsieur Peter
BYSSZ, préqualifié, refuse toute modification des statuts ainsi que l'augmentation du capital social prévue aux présentes.
D'autre part, il déclare ne pas vouloir souscrire de nouvelles parts sociales. Ladite déclaration restera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps.
Les comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, représentant trois quarts (3/4) du capital social, prennent à
l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés Messieurs Thierry SMETS, Chi-Taï TRÂN, et la société anonyme Global Media Systems S.A., tous pré-
qualifiés, décident d'augmenter le capital social à concurrence de cinquante mille euros (EUR 50.000) pour le porter de
son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500)
par l'émission de deux mille (2.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.
Les deux mille (2.000) parts sociales sont souscrites par Color Center Lucien Steinhäuser S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée, ayant son siège social à L-8010 Strassen, 262, route d'Arlon, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg section B numéro 33.948,
ici représentée par un de ses gérants, Monsieur Thierry SMETS, préqualifié, avec tous pouvoirs pour engager la société
Color Center Lucien Steinhäuser S.à r.l. en toutes circonstances sous sa seule signature,
pour un prix total de cinquante mille euros (EUR 50.000) entièrement affecté au capital social.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces par Color Center Lucien Steinhäuser S.à r.l.,
préqualifiée, et le montant total de cinquante mille euros (EUR 50.000) est à la disposition de la Société, tel qu'il a été
démontré au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution ci-dessus, les deux premiers alinéas de l'article 6 des statuts de la Société sont modifiés
et auront désormais la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500) représenté par
deux mille cinq cents (2.500) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.
Ces parts sociales sont souscrites comme suit:
Monsieur Chi-Taï TRÂN, préqualifié, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Monsieur Thierry SMETS, préqualifié, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Monsieur Peter BYSSZ, préqualifié, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Global Media Systems S.A., préqualifiée, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Color Center Lucien Steinhäuser S.à r.l., préqualifiée, deux mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000
Total: deux mille cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500"
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
raison de sa constitution, sont estimés approximativement à EUR 1.000,00.
45773
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: Thierry SMETS et Joëlle BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 février 2008. LAC / 2008 / 8725. - Reçu à 0,5 %: deux cent cinquante euros (250
€).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 2008.
Joëlle BADEN.
Référence de publication: 2008042439/7241/75.
(080045400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.
GPB Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 130.596.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration de la Société en date du 13 mars 2008i>
Il résulte des résolutions circulaires prises par le Conseil d'Administration de la Société en date du 13 mars 2008 que:
- le Conseil d'Administration a coopté M. Michel Wolter, administrateur, né le 13 septembre 1962 à Luxembourg,
demeurant à 1, rue Jean-Pierre Origer, L-4937 Hautcharage, en tant qu'administrateur de la Société en remplacement de
M. Henri Grethen; le mandat de M. Michel Wolter a pris effet le 13 mars 2008, pour une durée expirant lors de la
prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2008.
<i>Pour GPB Asset Management S.A.
i>Max Kremer
Référence de publication: 2008042440/250/19.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07656. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Lark Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 62.604.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LARK CORPORATION S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Référence de publication: 2008042807/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06665. - Reçu 30,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
FAM Sports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 118.717.
<i>Extrait de la résolution prise par l'associé unique de la Société en date du 21 décembre 2007i>
En date du 21 décembre 2007, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- d'accepter la démission de Monsieur Olten Ayres DE ABREU de son mandat de gérant de la Société avec effet au
31 décembre 2007.
45774
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
- Madame Maria Cecilia ROSSI
- Monsieur Daniel JÄGGI
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2008.
<i>FAM SPORTS S.A R.L.
i>Signatures
Référence de publication: 2008042441/250/21.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07660. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080046325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Sensata Investment Company S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 114.729.
En date du 11 décembre 2007, l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société a pris la résolution suivante:
de nommer
- Ernst & Young, une société constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 7, parc d'Activité
Syrdall, L-5365 Munsbach, enregistré dans le Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro
B47771, en tant que Réviseur d'Entreprises avec effet au 8 février 2006 et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra
en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2008.
<i>SENSATA INVESTMENT COMPANY S.C.A
i>Signature
Référence de publication: 2008042442/250/19.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07653. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Oliver Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 22.053.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>OLIVER HOLDINGS S.A.
i>A. RENARD / F. DUMONT
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008042808/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO05861C. - Reçu 26,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
M&G European Property Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 86.034.900,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 120.471.
En date du 6 mars 2008, l'Associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- d'accepter la démission de Monsieur David George Bannerman en tant que Gérant de la Société avec effet au 17
mars 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
45775
Luxembourg, le 18 mars 2008.
<i>M&G European Property Finance Company S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008042445/250/18.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07649. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Carbati, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8369 Hivange, 3A, route de Kahler.
R.C.S. Luxembourg B 133.444.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 19 février 2008i>
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission du gérant
2. Nomination du nouveau gérant technique
3. Pouvoir de signature
<i>Résolutions prisesi>
Les associés:
1) Monsieur Belmiro Ferreira Martins, gérant de société, né à Coimbra (P) le 7 avril 1962, demeurant à L-2263 Lu-
xembourg, 15, rue Guido Oppenheim (25 parts);
2) Madame Paula Cristina Da Conceiçao Quaresma, femme au foyer, née à Figueiro Dos Vinhos (P) le 1
er
avril 1974,
demeurante L-3522 Dudelange, 38, rue Emile Mayrisch (50 parts);
3) Monsieur José Carlos Batista Antunes, employé, né à Figueiro Dos Vinhos (P) le 17 juillet 1975, demeurant à L-3522
Dudelange, 38, rue Emile Mayrisch (25 parts);
de la société à responsabilité limitée CARBATI, ayant son siège social à L-8369 Hivange, 3A, route de Kahler.
Ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Monsieur José Carlos Batista Antunes démissionne de sa fonction de gérant.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé gérant technique de la société, Monsieur Da Costa Sousa Lucas Antonio, né le 12 juin 1947 à Santo Antonio
Olivais (P), demeurant à L-8369 Hivange, 3A, rue de Kahler.
<i>Troisième résolutioni>
La société ne pourra dorénavant être engagée que par la signature du gérant technique et ceci en toutes circonstances,
et ceci pour une période indéterminée.
Fait en 3 exemplaires.
Luxembourg, le 19 février 2008.
Belmiro Ferreira Martins, Paula Cristina Da
Conceiçao Quaresma, José Carlos Batista An-
tunes.
Référence de publication: 2008042701/8753/36.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02844. - Reçu 89,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
M&G European Property Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 34.253.300,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 92.191.
En date du 6 mars 2008, l'Associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- d'accepter la démission de Monsieur David George Bannerman en tant que Gérant de la Société avec effet au 17
mars 2008.
45776
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2008.
<i>M&G European Property Holding Company S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008042447/250/18.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07648. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Ecoprest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 74.773.
<i>Extrait de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2007i>
L'Assemblée des actionnaires, constatant que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ac-
tuellement en fonction arrivent à échéance, décide de nommer pour une période de six années, c'est-à-dire jusqu'à l'issue
de l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2013
- comme administrateurs de la société
* Monsieur Armand Distave, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt
* Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri
Schnadt
* Monsieur Raymond Piré, industriel, demeurant à D-54296 Trier, Sickingenstrasse, 15, Allemagne
- comme commissaire aux comptes de la société:
* LUX-AUDIT S.A. ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 25.797.
Luxembourg, le 8 mai 2007.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Les actionnairesi>
Référence de publication: 2008042448/3083/25.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO04007. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Unlimited Company S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 91.000,00.
Siège social: L-4993 Sanem, 7, Cité Schmiedenacht.
R.C.S. Luxembourg B 80.648.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2007i>
L'an deux mille sept,le douze juin à dix heures, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale
ordinaire au siège social à Sanem et ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
I) L'assemblée générale, constatant que les mandats d'administrateurs de:
- Monsieur Alain IERACE (également administrateur-délégué), et
- Monsieur Nino IERACE,
sont arrivés à leur terme, décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six années, soit
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
L'assemblée générale décide d'accepter la démission de
Monsieur François PLETSCHETTE, conseil fiscal, demeurant à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch,
de son poste d'administrateur avec effet au 15 mai 2007.
L'assemblée générale décide de nommer, avec effet au 15 mai 2007:
Monsieur Alex VERMAST, employé privé, demeurant à L-4040 Esch-sur-Alzette, 14, rue Brasseur,
en qualité d'administrateur, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de six années, soit
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
45777
En conséquence, le conseil d'administration de la société est dès lors composé de la manière suivante et ce jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013:
- Monsieur Alain IERACE, employé privé, demeurant à L-4993 Sanem, 7,Cité Schmiedenacht, (également administrateur
délégué)
- Monsieur Nino IERACE, retraité, demeurant à L-5960 Itzig, 106, rue de l'Horizon,
- Monsieur Alex VERMAST, employé privé, demeurant à L-4040 Esch-sur-Alzette, 14, rue Brasseur.
II) W.M.A., WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE SARL, ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard
Napoléon 1
er
(RCS Luxembourg B 65.434), est révoquée de son poste de commissaire aux comptes avec effet au 15
mai 2007.
L'assemblée générale décide de nommer:
Monsieur Boris ANGELSBERG, employé privé, demeurant à L-2680 Luxembourg, 3, rue de Vianden, en qualité de
commissaire aux comptes, avec effet au 15 mai 2007, pour une durée de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2013.
Sanem, le 12 juin 2007.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2008042450/503/41.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO05894. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080046269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Campbell Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 137.160.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Joëlle BADEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008042898/7241/11.
(080045917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Brasilia Sàrl, Société à responsabilité limitée,
(anc. Amele-Work S.à r.l.).
Siège social: L-5440 Remerschen, 77, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 48.707.
Le bilan au 31 décembre 1996 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remerschen, le 27 mars 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008042470/2065/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04575. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Immobilienbüro Lëtzebuerg S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 30.986,69.
Siège social: L-3730 Rumelange, 13, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 73.965.
<i>Extrait de résolution d'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 décembre 2007i>
Les actionnaires de la société IMMOBILIENBÜRO LETZEBUERG S.A.,réunis en Assemblée Générale Extraordinaire
du 18 décembre 2007, ont décidé, à l'unanimité, de prendre la résolution suivante:
La démission de Madame Josiane ROSSI-HOETT, retraitée, demeurant à Fennange, avec effet au 7 septembre 2007
(adresse complète: 28, rue des Alouettes, L-3332 Fennange)
45778
et de
Monsieur Armand DISTAVE, conseiller économique et fiscal, demeurant à Luxembourg ,
avec effet au 17 décembre 2007 (4, rue Henri Schnadt , L-2530 Luxembourg)
de leur poste d'administrateur de la société, est acceptée.
Luxembourg, le 18 décembre 2007.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2008042451/503/22.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO05860. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Ascara Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 88.989.
<i>Constatation de cession de parts socialesi>
Suite à une convention de cession de parts sociales sous-seing privé,signée par le cédant et le cessionnaire en date du
3 janvier 2008 et acceptée par la gérante au nom de la société, il résulte que le capital social de la société ASCARA S.à
r.l. est désormais réparti comme suit:
Parts sociales
1. - Madame Caroline LA UER, quatre-vingt dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
2.- Madame Astrid LAUER, neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
3.- Monsieur Rakeskumar BHANA, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Luxembourg, le 03.01.2008.
Pour extrait conforme
Signatures
Référence de publication: 2008042453/503/21.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04804. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Charterhouse TVC, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 124.503.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
49019 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Joseph ELVINGER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008042903/211/11.
(080045868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Cadeaux Shop Err S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4734 Pétange, 4, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 19.939.
Le bilan au 18.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008042458/762/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03931. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
45779
Peinture Laruccia, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3327 Crauthem, 8, Z.I. Am Bruch.
R.C.S. Luxembourg B 21.675.
L'an deux mille huit, le treize février.
Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
A comparu:
1.- Mario LARUCCIA, peintre, né à Turi/Bari (Italie) le 16 juillet 1946, matricule n°1946 0716 155, demeurant à L-7217
Bereldange, 84, rue de Bridel, propriétaire de deux cent quarante-cinq (245) parts de PEINTURE LARUCCIA SARL,
inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 21.675 avec siège social à L-1133 Luxembourg, 17,
rue des Ardennes, constituée suivant acte Jean SECKLER de Junglinster en date du 15 mai 1984, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 182 du 7 juillet 1984, modifiée suivant acte Frank MOLITOR de
Mondorf-les-Bains du 1 juin 1989, publié au dit Mémorial, Numéro 308 du 28 octobre 1989, modifiée suivant acte sous
seing privé du 4 décembre 2001, publié au dit Mémorial, Numéro 479 du 26 mars 2002,
2.- Stephanie LARUCCIA, employée privée, née à Luxembourg le 29 octobre 1973, matricule n° 1973 1029 221,
célibataire, demeurant à L-2312 Luxembourg, 25, rue de la Paix, propriétaire de deux cent cinquante-cinq (255) parts de
PEINTURE LARUCCIA SARL.
Les comparants, agissant en leurs qualités d'associés, se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils
se considèrent dûment convoqués, et prennent, sur ordre du jour conforme et à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Ils transfèrent le siège social de Luxembourg à Crauthem.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la première résolution, l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
" Art. 5. Le siège social est établi à Crauthem. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg par simple décision des associés."
<i>Troisième résolutioni>
Ils fixent l'adresse de la Société à L-3327 Crauthem, Zône Industrielle 8 Am Bruch (Hall 6), Business Center Pauli.
<i>Quatrième résolutioni>
Ils modifient l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500.-) euros, représenté par cinq cents (500) parts de
vingt-cinq (25.-) euros chacune, entièrement libérées en numéraire."
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont Acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Laruccia, Laruccia et Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 février 2008, Relation: EAC/2008/2400. — Reçu douze euros 12.-
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 11 mars 2008.
Frank MOLITOR.
Référence de publication: 2008042575/223/42.
(080045922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Blumen beim Anja S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4909 Bascharage, 2, rue Belair.
R.C.S. Luxembourg B 114.883.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008042459/762/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03926. - Reçu 20,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
45780
Société Financière de la Chaussée S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 66.319.
Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008042461/762/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03937. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080046050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Société Financière de la Chaussée S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 66.319.
Le bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008042462/762/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03936. - Reçu 16,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Schopaagri, Groupement agricole, Société Civile.
Siège social: L-9770 Rumlange, Haus Nummer 1.
R.C.S. Luxembourg E 740.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendacht am zwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Léonie GRETHEN, mit Amtssitze zu Rambrouch.
SIND ERSCHIENEN:
1.- Herr Aloyse Jean Joseph SCHON, Landwirt, ledig, geboren in Doennange, am 22. Mai 1948, wohnend in L-9745
Doennange, Haus Nummer 39,
2.- Herr Jean Joseph genannt Johny PALER, Landwirt, Ehegatte von Dame Carole SCHON, geboren in Clerf, am 19.
Januar 1967, wohnend in L-9770, Rumlange, Haus Nummer 1,
Welche Komparenten erklären:
Dass sie die alleinigen Gesellschafter sind der zivilrechtlichen Gesellschaft "SCHOPAAGRI", mit Sitz in L-9770 Rum-
lange, Haus Nummer 1,
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Marc CRAVATTE mit damaligem Amtssitz in Ettelbruck, am
30. April 2001, veröffentlicht im Memorial C Nummer 1101 vom 4. Dezember 2001,
die Statuten wurden abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar am 11 Mai 2001, veröffentlicht
im Memorial C Nummer 1101 vom 4. Dezember 2001,
die Statuten wurden ein weiteres abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am
30. März 2006, veröffentlicht im Memorial C Nummer 1381 vom 18. Juli 2006
Die Gesellschaft hat ein Gesellschaftskapital von sechshundertfünfundvierzigtausendfünfhundertzwanzig Euro (Eur
645.520.-) und ist eingeteilt in neunundzwanzigtausend siebenhundertachtzig (29.780) Anteile ohne Wertabschätzung,
welche den Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt sind:
Anteile
a) Herr Aloyse SCHON, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.298
b) Herr Johny PALER, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.482
Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.780
45781
Die vorgenannten Komparenten erklären, dass sie sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen-
gefunden haben und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst haben, welche sie den instrumentierenden Notar ersuchen
zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Herr Aloyse SCHON, vorbenannt, erklärt seine 1.298 Anteile an der Gesellschaft SCHOPAAGRI Groupement Ag-
ricole an seinen Mitgesellschafter Herr Johny PALER zu übertragen, so dass das gesamte Gesellschaftskapital Herrn Johny
PALER gehört.
Die Abtretung geschieht gegen Zahlung einer Entschädigung von neunzehntausend zweihundertdreiundsechtzig Kom-
ma sechzig Euro (Eur 19.263,60), von welchem Betrag Herr Aloyse SCHON bekennt vor Unterschrift gegenwärtiger
Urkunde einen Betrag von achtzehntausenddreihundertsiebenundfünfzig Komma null acht Euro (Eur 18.357,08) erhalten
zu haben worüber hiermit Quittung und Titel. Herr Johny PALER verpflichtet sich ausdrücklich den Restbetrag von
neunhundertsechs Komma zweiundfünfzig Euro (Eur 906,52) in vier (4) Monatsraten an Herrn Aloyse SCHON auszu-
zahlen.
In der vorgenannten Abtretung sind die Betriebsprämienansprüche (Jetons) betreffend den Betrieb Nummer 475001,
welche auf Herrn Aloyse SCHON zufallen, enthalten, so dass diese im Betrieb SCHOPAAGRI Groupement Agricole
verbleiben. Der Anteil Jetons von Herrn Aloyse SCHON wird demzufolge auf Herrn Johny PALER übertragen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Herr Aloyse SCHON tritt als Verwalter der Gesellschaft SCHOPAAGRI Groupement Agricole zurück - Entlastung
wird ihm durch den Gesellschafter erteilt.
<i>Dritter Beschlussi>
Da gemäss vorerwähnter Anteilsabtretung Herr Johny PALER alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft SCHOPAAGRI
Groupement Agricole ist, erklärt er:
- die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen
- dass die gesamten Aktiva und Passiva der Gesellschaft vom alleinigen Gesellschafter übernommen wurden so dass
die Liquidation der Gesellschaft als abgeschlossen zu betrachten ist,
- dass alle eventuellen noch anfallenden Kosten und Lasten der Gesellschaft vom alleinigen Gesellschafter übernommen
werden,
- dass besagte Gesellschaft ab heute als aufgelöst zu betrachten ist,
- dass den derzeitigen Geschäftsführern Entlastung erteilt wird,
- dass die Geschäftsbücher und Unterlagen der Gesellschaft für die gesetzliche Frist von fünf Jahren an folgender
Adresse hinterlegt werden: L-9770, Rumlange, Haus Nummer 1.
Die Kosten und Gebühren gegenwärtiger Urkunde sind zu Lasten von Herrn Johny PALER, vorbenannt.
Da nichts Weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
WORUEBER URKUNDE, aufgenommen zu Rambrouch in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Schon, Paler, GRETHEN.
Enregistré à Redange, le 21 mars 2008, Relation: RED/2008/326. — Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): KIRSCH.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.
Rambrouch, den 25. März 2008.
LEONIE GRETHEN.
Référence de publication: 2008042517/240/72.
(080046163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Perola Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 123.818.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008042463/762/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03925. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
45782
Lutzenberg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 116.884.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008042464/762/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03935. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080046056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Saba Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 80.792.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008042465/762/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03933. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Tinsel Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 515.440,00.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 121.180.
In the year two thousand eight, on the third day of March.
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
for an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Tinsel Group S.à r.l., a Luxembourg private limited
liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 121.180, incorporated pursuant to a deed
of the undersigned notary, then residing in Mersch, dated October 26, 2006 (the Company) and the articles of association
(the Articles) of which have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary, dated January 4, 2008:
Stichting Administratiekantoor Tinsel Group, a foundation with limited liability incorporated under the laws of the
Netherlands, having its registered office at 90, Lichtenauerlaan, 3062 ME Rotterdam, The Netherlands, registered with
the Kamer Van Koophandel Rotterdam under number 24401160 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mrs. Solange Wolter, private employee, with professional address in Luxembourg, acting under
a proxy given on February 28, 2008 in Rotterdam,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to create the following new classes of shares having the rights and obligations set forth
in the Articles (as to be amended):
- the class E1 shares;
- the class E2 shares;
- the class E3 shares;
45783
- the class E4 shares;
- the class E5 shares; and
- the class E6 shares.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to convert some of the existing shares of the Company as follows:
- 266 class A shares into 14 class E1 shares, 202 class E2 shares and 50 class E5 shares;
- 182 class RA shares into 182 class E6 shares;
- 394 class S1 shares into 90 class E1 shares, 120 class E3 shares, 75 class E4 shares and 109 class E6 shares; and
- 399 class RS1 shares into 399 class E6 shares
and to allocate to the share premium reserve account of the class E1 shares, the class E2 shares, the class E3 shares,
the class E4 shares, the class E5 shares and the class E6 shares such portion of the share premium reserve account which
pertained to the class A shares, the class RA shares, the class S1 shares and the class RS1 shares so converted into class
E1 shares, the class E2 shares, the class E3 shares, the class E4 shares, the class E5 shares and the class E6 shares
respectively.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend articles 5.1 and 5.2 of the Articles which shall henceforth read as follows:
5.1 "The Company's corporate capital is fixed at five hundred fifteen thousand four hundred forty United States Dollars
(USD 515,440) represented by two thousand three hundred ninety-five (2,395) class A shares, five thousand (5,000) class
S1 shares, four hundred ninety-five (495) class RS1 shares, thirty-five (35) class T1 shares, three thousand seven hundred
twenty (3,720) class S2 shares, one hundred and four (104) class E1 shares, two hundred and two (202) class E2 shares,
one hundred twenty (120) class E3 shares, seventy-five (75) class E4 shares, fifty (50) class E5 shares and six hundred
ninety (690) class E6 shares, each in registered form with a nominal value of forty United States Dollars (USD 40), all
subscribed and fully paid-up."
5.2 "The class A shares, the class S1 shares, the class T1 shares, the class S2 shares, the class RS1 shares, the class E1
shares, the class E2 shares, the class E3 shares, the class E4 shares, the class E5 shares and the class E6 shares shall reflect
the performance of a given underlying combination in shares of VITOL HOLDING II S.A., a Luxembourg limited liability
company, having its registered office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, registered with the Register of Trade
and Companies of Luxembourg under number B 43.512, as initially determined by the resolutions of the shareholders of
the Company at the time of the contribution to the capital of the Company of the consideration for such shares and of
issuances of shares of the Company in consideration thereof, as such combination may be amended from time to time
in accordance with article 5.4 of these Articles."
<i>Fourth resolutioni>
For the purpose of articles 5.2. and 5.4. of the Articles, the Sole Shareholder resolves that the class A shares, the class
S1 shares, the class T1 shares, the class S2 shares the class RS1 shares, the class E1 shares, the class E2 shares, the class
E3 shares, the class E4 shares, the class E5 shares and the class E6 shares respectively in the Company shall represent
the following underlying combination in shares of Vitol Holding II S.A., a public limited liability company (société anonyme)
incorporated and organized under the Laws of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746
Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 43.512 (Vitol Holding
II):
- 1 class A share: 1 class P 2005 share and 2 class D 2007 shares of Vitol Holding II;
- 1 class S1 share: 1 class P 2005 share and 2 class D 2007 shares of Vitol Holding II;
- 1 class T1 share: 9/7 class P 2005 share and 12/7 class D 2007 share of Vitol Holding II;
- 1 class S2 share: 1 class D 2007 share of Vitol Holding II;
- 1 class RS1 share: 1 class P 2005 share of Vitol Holding II;
- 1 class E1 shares: 120/104 P 2005 share of Vitol Holding II;
- 1 class E2 shares: 240/202 P 2005 share of Vitol Holding II;
- 1 class E3 shares: 1 P 2005 share of Vitol Holding II;
- 1 class E4 shares: 100/75 P 2005 share and 42/75 D 2007 shares of Vitol Holding II;
- 1 class E5 shares: 1 P 2005 share and 18/75 D 2007 shares of Vitol Holding II; and
- 1 class E6 shares: 1 P 2005 share and 1260/690 D 2007 shares of Vitol Holding II.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party it is stated
that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with us,
the notary, the present original deed.
45784
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le troisième jour de mars.
Par-devant nous, Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Pour une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de Tinsel Group S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés sous de Luxembourg le numéro B 121.180, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 26 octobre 2006 (la Société) et dont les statuts (les Statuts)
ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, prénommé, en date du 4
janvier 2008:
Stichting Administratiekantoor Tinsel Group, une fondation organisée et constituée sous loi néerlandaise, ayant son
siège social au 90 Lichtenauerlaan, 3062 ME Rotterdam, au Pays-Bas, inscrite au Kamer Van Koophandel Rotterdam sous
le numéro 24401160 (l'Associé Unique),
représentée par Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg par la
procuration donné le 28 février 2008, à Rotterdam,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistré avec le présent acte auprès des autorités d'enregis-
trement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales composant le capital social de la Société;
II. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de créer les nouvelles classes de parts sociales suivantes ayant les mêmes droits et obligations
fixés aux Statuts (tels qu'il seront modifiés):
- les parts sociales de classe E1;
- les parts sociales de classe E2;
- les parts sociales de classe E3;
- les parts sociales de classe E4;
- les parts sociales de classe E5; et
- les parts sociales de classe E6.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé unique décide de convertir certaines parts sociales existantes de la Société comme suit:
- 266 parts sociales de classe A en 14 parts sociales de classe E1, 202 parts sociales de classe E2 et 50 parts sociales
de classe E5;
- 182 parts sociales de classe RA en 182 parts sociales de classe E6;
- 394 parts sociales de classe S1 en 90 parts sociales de classe E1, 120 parts sociales de classe E3, 75 parts sociales de
classe E4 et 109 parts sociales de classe E6; et
- 399 parts sociales de classe RS1 en 399 parts sociales de classe E6;
et d'affecter au compte de réserve de la classe de parts sociales E1, de la classe de parts sociales E2, de la classe de
parts sociales E3, de la classe de parts sociales E4, de la classe de parts sociales E5 et de la classe de parts sociales E6 la
portion du compte de réserve de la classe de parts sociales A, de la classe de parts sociales RA, de la classe de parts
sociales S1 et de la classe de parts sociales RS1 ainsi converties en classe de parts sociales E1, en classe de parts sociales
E2, en classe de parts sociales E3, en classe de parts sociales E4, en classe de parts sociales E5 et en classe de parts sociales
E6, respectivement.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier les articles 5.1 et 5.2 des Statuts lesquels auront dorénavant la teneur suivante:
5.1 "Le capital social de la Société est fixé à cinq cent quinze mille quatre cent quarante dollars des Etats-Unis (USD
515.440) représenté par deux mille trois cent quatre-vingt quinze (2.395) parts sociales de classe A, cinq mille (5.000)
parts sociales de classe S1, quatre cent quatre-vingt quinze (495) parts sociales de classes RS1, trente-cinq (35) parts
sociales de classe T1, trois mille sept cent vingt (3.720) parts sociales de classe S2, cent et quatre (104) parts sociales de
classe E1, deux cent et deux (202) parts sociales de classe E2, cent vingt (120) parts sociales de classe E3, soixante quinze
(75) parts sociales de classe E4, cinquante (50) parts sociales de classe E5 et six cent quatre-vingt dix (690) parts sociales
de classe E6 chacune sous forme nominative, avec une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis (USD 40,-)
toutes souscrites et intégralement libérées.
5.2 "Les parts sociales de classe A, les parts sociales de classe S1, les parts sociales de classe T1, les parts sociales de
classe S2, les parts sociales de classes RS1, les parts sociales de classe E1, les parts sociales de classe E2, les parts sociales
45785
de classe E3, les parts sociales de classe E4, les parts sociales de classe E5 et les parts sociales de classe E6 devront refléter
la performance d'une combinaison donnée des actions sous-jacente de VITOL HOLDING II S.A., une société anonyme
de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 43.512, tel que initialement déterminé par une résolutions des associés de
la Société au nomment de l'apport concerné au capital de la Société, et de l'émission des parts sociales de la Société en
contrepartie, et telle que cette combinaison peut être modifiée le cas échéant conformément à l'article 5.4 des Statuts."
<i>Quatrième résolutioni>
Pour les besoins des articles 5.2 et 5.4 des Statuts, l'Associé Unique décide que les parts sociales de classe A, les parts
sociales de classe S1, les parts sociales de classe T1, les parts sociales de classe S2, les parts sociales de classe RS1, les
parts sociales de classe E1, les parts sociales de classe E2, les parts sociales de classe E3, les parts sociales de classe E4,
les parts sociales de classe E5 et les parts sociales de classe E6 respectivement dans la Société devront refléter la per-
formance des combinaisons suivantes d'actions sous-jacente de Vitol Holding II S.A., une société anonyme constituée et
organisée sous loi luxembourgeoise, ayant son siège social à 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 43.512 (Vitol Holding II) de la façon suivante:
- 1 part sociale de classe A: 1 action de classe P 2005 et 2 actions de classe D 2007 de Vitol Holding II;
- 1 part sociale de classe S1: 1 action de classe P 2005 and 2 actions de classe D 2007 de Vitol Holding II;
- 1 part sociale de classe T1: 9/7 d'action de classe P 2005 et 12/7 d'action de classe D2007 de Vitol Holding II;
- 1 part sociale de classe S2: 1 action de classe D 2007 de Vitol Holding II;
- 1 part sociale de classe RS1: 1 action de classe P 2005 de Vitol Holding II;
- 1 part sociale de classe E1: 120/104 d'action de classe P2005 de Vitol Holding II;
- 1 part sociale de classe E2: 240/202 d'action de classe P2005 de Vitol Holding II;
- 1 part sociale de classe E3: 1 action de classe P 2005 de Vitol Holding II;
- 1 part sociale de classe E4: 100/75 d'action de classe P 2005 et 42/75 d'action de classe D2007 de Vitol Holding II;
- 1 part sociale de classe E5: 1 action de classe P 2005 et 18/75 d'action de classe D2007 de Vitol Holding II; et
- 1 part sociale de classe E6: 1 action de classe P 2005 et 1260/690 d'action de classe D2007 de Vitol Holding II.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 mars 2008, Relation: LAC/2008/10547. — Reçu douze euros (12,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2008.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2008042578/242/180.
(080045956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Santander Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 57.043.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 11 mars 2008i>
L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires reconduit, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des
actionnaires, qui se tiendra en mars 2009, les mandats d'Administrateurs de Messieurs Paul L. SAUREL, Javier VIANI
DESPLATS-REDIER et Robert DeNORMANDIE.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EURO-VL Luxembourg S.A.
16, bd Royal, L-2449 Luxembourg
Signatures
Référence de publication: 2008042705/3451/17.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO07035. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
45786
R.F. Trans S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4720 Pétange, 55, rue de la Chiers.
R.C.S. Luxembourg B 101.200.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008042466/762/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03930. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080046062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Fip Productions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8254 Mamer, 5A, rue du Millénaire.
R.C.S. Luxembourg B 107.656.
Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008042467/762/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03929. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Brasilia Sàrl, Société à responsabilité limitée,
(anc. Amele-Work S.à r.l.).
Siège social: L-5440 Remerschen, 77, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 48.707.
Le bilan au 31 décembre 1997 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remerschen, le 27 mars 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008042471/2065/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04577. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Brasilia Sàrl, Société à responsabilité limitée,
(anc. Amele-Work S.à r.l.).
Siège social: L-5440 Remerschen, 77, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 48.707.
Le bilan au 31 décembre 1998 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remerschen, le 27 mars 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008042477/2065/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04579. - Reçu 18,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080046020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
45787
Net Services GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6755 Grevenmacher, 1, place du Marché.
R.C.S. Luxembourg B 137.273.
STATUTES
In the year two thousand eight, on the twentieth day of February.
Before us Maître Karine REUTER, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Paul BET-
TINGEN, notary, residing in Niederanven.
THERE APPEARED:
Web Investments AG, a company incorporated under the laws of Switzerland with registered office in CH-6343
Rotkreuz, Blegi 14 (Suisse), registered under the number CH-170.3.031.588-9, represented by ODIN INTERNATIONAL,
L-5804 Bous, 60, route de Luxembourg, here represented by Catherine LE BOURGEOIS, private employee, with pro-
fessional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
Said power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the
undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Which appearing party has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a
société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung):
Art. 1. There is hereby formed a limited liability company under the name of "Net Services GmbH".
Art. 2. The registered office is established in the municipality of Grevenmacher.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting
of Shareholders.
By simple decision of the Managers, the Company may establish branch offices, agencies and representation offices in
the Grand Duchy of Luxembourg as well as abroad.
Art. 3. The object of the Company is to create, operate and manage websites for matching individuals and for services
related to interpersonal relationships as well as related and similar businesses as well as related editorial content.
The Company may also use its funds for the creation, management, development and the realisation of a portfolio
comprising all types of transferable securities, take part in the creation, development and control of all enterprises, acquire
all securities, either by way of contribution, subscription, purchase or otherwise, option, as well as realise them by sale,
transfer, or exchange.
The Company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to any company in which it has a direct
or indirect substantial interest.
In general, the Company may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity
as well as all transactions and operations which it may deem useful to promote and facilitate directly or indirectly the
accomplishment and development of its purpose.
Art. 4. The Company is incorporated for an unlimited duration.
Art. 5. The Company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each
year.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), divided into one hundred
(100) shares of one hundred twenty-five Euro (125.- EUR) each.
Art. 7. The shares shall be freely transferable between shareholders. They can only be transferred inter vivos or upon
death to non-shareholders with the unanimous approval of all shareholders. If the approval is not granted, the remaining
shareholders engage to purchase the shares to be transferred.
Art. 8. The Company is managed by one or several Managers, shareholders or not. The Managers are appointed by
the General Meeting of Shareholders who determines their powers and their remuneration; they may be revoked at any
time by the General Meeting of Shareholders. In case of plurality of Managers, the Company is engaged by the sole signature
of any Manager; by decision of the Managers, the co-signature of a determined Manager may be required to validly engage
the Company.
Art. 9. The Managers do not enter any personal liability by executing their mandate with respect to the transactions
regularly performed in the name of the Company; as representants of the Company, they are only liable for the execution
of their mandate.
Art. 10. Every year on 31st December, the Company draws up an inventory of the assets and the liabilities of the
Company. The net profit, after deduction of the general costs, salaries and amortizations, will be distributed as follows:
- 5% (five per cent) will be allocated to the legal reserve according to the legal stipulations, until this legal reserve has
reached to 10% (ten per cent of the Company's corporate capital;
45788
- the balance remains at the free disposal of the Shareholders.
If profits are distributed to the Shareholders, every Shareholder shall receive a part equal to their percentage in the
corporate capital.
Art. 11. The death, the interdiction, the bankruptcy or the insolvency of a Shareholder will not lead to the dissolution
of the Company.
The creditors or heirs of a Shareholder may in no case and for no reason pursue the sealing of property or documents
of the Company or take part in any way in the administration of this property or these documents.
Art. 12. Any Shareholder may take part in common decisions independent from the number of shares held. Every
Shareholder has a number of votes corresponding to the number of shares held and may be represented by a special
attorney at Shareholders' Meetings.
Art. 13. Shareholder's decisions are validly taken only if the majority of the corporate capital has voted in favour.
Modifications of these Articles of Association require a qualified majority of three quarters of the corporate capital.
Art. 14. The legal stipulations in force shall apply to any points not provided for in these Articles of Association.
<i>Transitory provisionsi>
Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31st December 2008.
<i>Subscription and paymenti>
All one hundred (100) shares have been subscribed by Web Investments AG, prenamed.
All these shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-
EUR) is forthwith at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears witness
to it.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation have been estimated at about one thousand six hundred Euro (EUR
1,600.-).
<i>Constitutive meetingi>
After having stated the due constitution of the Meeting, the sole shareholder has taken the following decisions:
1.- The Company shall have its registered office at 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher.
2.- The number of Managers is fixed at two (2).
3.- The followings have been appointed Managers for an unlimited duration:
- Heinz LAUMANN, Gesellschaftsverwalter, born in Nürnberg (Germany) on August 10, 1971, residing in D-66787
Wadgassen, Johannes-Kirschweng-Strasse 19 (Germany);
- Eberhard NEUMAIER, Gesellschaftsverwalter, born in Vöhrenbach (Germany) on July 7, 1965, residing in D-66787
Wadgassen, Johannes-Kirschweng-Strasse 19 (Germany).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same
appearing party and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned
in Senningerberg.
The document having been read to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed together with Us,
the notary, the present original deed.
Deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahr zweitausendacht, den zwanzigsten Februar.
Vor dem Notar Karine REUTER, mit Amtswohnsitz in Redange-sur-Attert, handelnd in Vertretung des Notars Paul
BETTINGEN, mit Amtswohnsitz in Niederanven,
IST ERSCHIENEN:
Web Investments AG, eine Gesellschaft gegründet nach Schweizer Recht mit Sitz in CH-6343 Rotkreuz, Blegi 14
(Schweiz), eingetragen im Handelsregister des Kantons Zug unter der Nummer CH-170.3.031.588-9, vertreten durch
ODIN INTERNATIONAL, L-5804 Bous, 60, route de Luxembourg, hier vertreten durch Frau Catherine LE BOURGEOIS,
Privatangestellte, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht,
welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur-Unterzeichnung durch den Vertreter der erschienenen Partei und durch
den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde zur Registrierung bei den zuständigen Behörden beigefügt bleibt.
Die Erschienene ersuchte den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren:
45789
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "Net Services GmbH"
gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Grevenmacher.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafter kann der Sitz der Gesellschaft an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden.
Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführer können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl
im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Einrichtung und Pflege von Webseiten mit Online-Partnervermittlungsdiensten
sowie das Management dieser Online-Partnervermittlungsdienste und erstellen und publizieren entsprechender redakti-
oneller Inhalte.
Sie kann ihre Gelder weiterhin verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und zum Erwerb eines
Portfolios aus Sicherheiten oder Patenten, sowie zur Beteiligung an Unternehmen und zur Gründung, Entwicklung und
Kontrolle von Unternehmen. Sie kann diese Sicherheiten, Patente oder Beteiligungen durch Verkauf, Abretung, Tausch
oder auf andere Art verwerten und die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, durch Darlehen, Vorschüsse oder Ga-
rantien unterstützen.
Die Gesellschaft kann besicherte und unbesicherte Darlehen aufnehmen und sich für andere Personen oder Gesell-
schaften verbürgen.
Die Gesellschaft darf weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit den Hauptzwecken in
Verbindung stehen; sie kann jede andere Tätigkeit, die mit den Hauptzwecken direkt oder indirekt in Verbindung steht,
im In- oder Ausland ausüben.
Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) festgesetzt, unterteilt in ein-
hundert (100) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR)
Art. 7. Die Gesellschaftsanteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Durch Verfügung unter Lebenden oder
von Todes wegen an Nichtgesellschafter können Gesellschaftsanteile nur unter der Bedingung der Zustimmung aller
Gesellschafter übertragen werden. Im Fall der Verweigerung der Zustimmung verpflichten sich die verbleibenden Ge-
sellschafter, die zu übertragenden oder vererbten Gesellschaftsanteile zu übernehmen.
Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet und vertreten, die nicht Gesell-
schafter zu sein brauchen. Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung ernannt, die ihre Befugnisse
und ihre Vergütung festlegt; sie können jederzeit von der Gesellschafterversammlung abberufen werden. Im Fall der
Bestellung von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die Zeichnung jedes einzelnen Geschäftsführern
berechtigt und verpflichtet; durch Beschluss der Geschäftsführer kann festgelegt werden, dass die Zeichnung eines be-
stimmten Geschäftsführers zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft erforderlich ist.
Art. 9. Der oder die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung des Mandates keine persönliche Verpflichtung in bezug
auf die von ihnen im Namen der Gesellschaft regelmäßig vorgenommen Geschäfte ein; sie haften als einfache Vertreter
nur für die Ausübung des Vertretungsmandates.
Art. 10. Es wird jedes Jahr am 31. Dezember ein Inventar des Aktivs und des Passivs der Gesellschaft aufgestellt. Der
Nettogewinn, nach Abzug der generellen Kosten, Gehälter und Abschreibungen, wird wie folgt verteilt:
- 5% (fünf Prozent) werden in die gesetzliche Rücklage nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften eingestellt, bis
diese 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht hat;
- der Saldo verbleibt zur freien Verfügung der Gesellschafter.
Falls Gewinne an die Gesellschafter ausgezahlt werden, erhält jeder Gesellschafter einen seiner Beteiligung am Ge-
sellschaftskapital entsprechenden Anteil.
Art. 11. Der Tod, die Entmündigung, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters führen nicht zur
Beendigung der Gesellschaft.
Die Gläubiger oder Rechtsnachfolger eines Gesellschafters können aus keinem Grund die Vermögensgüter und Un-
terlagen der Gesellschaft pfänden oder sich in irgendeiner Weise an der Verwaltung dieser Güter oder Unterlagen
beteiligen.
Art. 12. Jeder Gesellschafter kann an den gemeinsamen Beschlüssen unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen
Gesellschaftsanteile teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat eine der Anzahl der von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile
entsprechende Anzahl von Stimmen und kann sich auf Gesellschafterversammlungen durch einen Sonderbevollmächtigten
wirksam vertreten lassen.
45790
Art. 13. Gesellschafterbeschlüsse sind nur dann wirksam gefasst, wenn mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
für den Beschluss gestimmt hat. Änderungen dieser Satzung bedürfen einer qualifizierten Mehrheit von drei Vierteln des
Gesellschaftskapitals.
Art. 14. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, verweisen die Gesellschafter auf die geltenden
gesetzlichen Vorschriften.
<i>Übergangsbestimmungi>
Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr mit dem heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2008.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Gesellschaftsanteilei>
Alle einhundert (100) Gesellschaftsanteile wurden gezeichnet von der Gesellschaft Web Investment AG, vorbezeich-
net.
Sämtliche Gesellschaftsanteile wurden vollständig bar eingezahlt, so dass sich der Betrag von zwölftausendfünfhundert
Euro (12.500,- EUR) zur freien Verfügung der Gesellschaft befindet, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde
und was dieser ausdrücklich bestätigt.
<i>Kosteni>
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die in irgendeiner Form der Gesellschaft aufgrund der
Gründung zu Lasten fallen oder sonst von ihr zu tragen sind, wird auf eintausendsechshundert Euro (EUR 1.600,-) ge-
schätzt.
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Nachdem die ordnungsgemäße Zusammensetzung der Gesellschafterversammlung festgestellt wurde, hat der Gesell-
schafter die folgenden Beschlüsse gefasst:
1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6755 Grevenmacher, 1, place du Marché.
2.- Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf zwei (2) festgelegt.
3.- Zu Geschäftsführern auf unbestimmte Zeit werden ernannt:
- Heinz LAUMANN, Gesellschaftsverwalter, geboren in Nürnberg (Deutschland), am 10. August 1971, wohnhaft in
D-66787 Wadgassen, Johannes-Kirschweng-Strasse 19 (Deutschland);
- Eberhard NEUMAIER, Gesellschaftsverwalter, geboren in Vöhrenbach (Deutschland), am 7. Juli 1965, wohnhaft in
D-66787 Wadgassen, Johannes-Kirschweng-Strasse 19 (Deutschland).
Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei
die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung ni deutscher Sprache; auf
Ersuchen dieser vorgenannten Partei und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text
ist die englische Fassung maßgebend.
Aufgenommen und geschlossen am eingangs erwähnten Datum zu Senningerberg.
Und nach Verlesung des Vorstehenden und Erklärung an den Vertreter der erschienenen Partei hat dieser Vertreter
mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Le Bourgeois, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 29 février 2008, LAC / 2008 / 8951. — Reçu à 0,5%: soixante-deux euros, Cinquante
cents (62,50 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 18. März 2008.
Paul BETTINGEN.
Référence de publication: 2008042639/202/203.
(080046191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Exprima Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 92.701.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
45791
Luxembourg, le 26 mars 2008.
CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.
<i>International Tax Planners
i>P.O. Box 156 LU-2011 LUXEMBOURG, 60, Grand-Rue / Niveau 2
Signature
Référence de publication: 2008042478/816/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06515. - Reçu 14,0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080045869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Entreprise de Construction Lemos Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 147, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 54.989.
L'an deux mille huit, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
Ont comparu:
1.- Cesar Augusto LEMOS, entrepreneur, né à Longroiva/Meda (Portugal), le 1
er
janvier 1950, demeurant à L-5962
Itzig, 5, Montée Saint Hubert,
2.- Carlos Filipe AFONSO LEMOS, étudiant, né à Poco do Canto (Portugal), le 17 mai 1977, demeurant à L-5962 Itzig,
5, Montée Saint Hubert,
seuls associés de ENTREPRISE DE CONSTRUCTION LEMOS avec siège social à L-5962 Itzig, 5, Montée Saint Hubert,
inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 54.989, constituée suivant acte du notaire Frank
MOLITOR de Dudelange du 23 mai 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro
413 du 26 août 1996, modifié suivant acte sous seing privé du 18 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, Numéro 180 du 1
er
février 2002, modifié suivant acte sous seing privé du 23 avril 2002, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 1051 du 10 juillet 2002.
Les comparants, agissant en leur qualité d'associés, se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils
se considèrent dûment convoqués, et prennent, sur ordre du jour conforme et à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Ils décident de transférer le siège social de Itzig à Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la première résolution, le premier alinéa de l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
" Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
..."
<i>Troisième résolutioni>
Ils fixent l'adresse de la Société à L-1741 Luxembourg, 147, route de Hollerich
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
Dont Acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Lemos, Afonso Lemos et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 27 février 2008, Relation: EAC/2008/2796. - Reçu douze euros 12.-
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 11 mars 2008.
Frank MOLITOR.
Référence de publication: 2008042564/223/38.
(080045933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
45792
2000 Volts
Amele-Work S.à r.l.
Amele-Work S.à r.l.
Amele-Work S.à r.l.
Ascara Sàrl
Bescha s.à r.l.
Blumen beim Anja S.àr.l.
Brasilia Sàrl
Brasilia Sàrl
Brasilia Sàrl
Cadeaux Shop Err S.àr.l.
Campbell Luxembourg S.à r.l.
Carbati
Charterhouse TVC
Commercial Union Management Services (Luxembourg) S.à r.l.
Copenhagen Retail Exclusive Lux S. à r. l.
Ecoprest S.A.
Enop 4 A.G.
Enop 5 A.G.
Entreprise de Construction Lemos Sàrl
Ernest Hermes S.A.
Exprima Holding S.à r.l.
FAM Sports S.à r.l.
Fip Productions S.à r.l.
Franzen und Brandt
Gio - Mimmo S.à r.l.
Glashaus in München S.à r.l.
GPB Asset Management S.A.
Immobilienbüro Lëtzebuerg S.A.
Ioors Luxembourg S.A.
IVG EuroSelect The Square Verwaltungsgesellschaft
J.P. Morgan Capital Holdings Limited
Lark Corporation S.A.
LogAxes Austria III S.à r.l.
LogAxes Austria IV S.à r.l.
LogAxes Investment Properties S.à r.l.
Lutzenberg S.A.
M&G European Property Finance Company S.à r.l.
M&G European Property Holding Company S.à r.l.
Neerveld 101-103 S.à r.l.
Net Services GmbH
Oliver Holdings S.A.
Peinture Laruccia
Perola Invest S.A.
Perseus Real Estate Investment S.A.
Perseus Real Estate Investment S.à r.l.
PETROLEUM (Luxembourg) S.A.
R.F. Trans S.àr.l.
Saba Invest S.A.
Salfin S.A.
Santander Asset Management Luxembourg S.A.
Schopaagri, Groupement agricole
Self A Three S.à r.l.
Sensata Investment Company S.C.A.
Société Financière de la Chaussée S.A.
Société Financière de la Chaussée S.A.
Steel and Logistic Services S.à r.l.
Tinsel Group S.à r.l.
Unlimited Company S.A.
Yaborandi Holding S.A.