logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 807

3 avril 2008

SOMMAIRE

ALESRAA Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

38698

Andreapolsky Refinery AG  . . . . . . . . . . . . . .

38724

Art Consult S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38722

attrax S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38712

Biotelgy VC S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38695

Blue Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38698

Boston Mere Property Holdings S.A. . . . . .

38719

Brim S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38723

Broad Street Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

38704

C156 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38736

Centuria Monaco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

38700

Centuria Vauban S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

38711

CI-ERRE LUX S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38721

Emeraude Participations S.A.  . . . . . . . . . . .

38718

Espace Concept S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38710

Etoile QIB S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38719

Euxin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38701

Event & Com S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38699

Famer S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38714

FIRST LuxCo 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38721

Hanse Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38695

IDR Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38721

IH International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38733

Ingenia Lux Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38732

LaSalle UK Ventures Property 9 . . . . . . . . .

38696

Lucis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38722

Luxding Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38700

Luxhosting Networks S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

38735

Menuiserie Dirk Berens S.à r.l.  . . . . . . . . . .

38701

M&G Packaging s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38732

MZ Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38697

Phicolux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38723

Realm Enterprises S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

38690

REDK 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38720

REDK 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38720

REDK 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38720

Renoir Holding SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38723

Robien S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38690

RREEF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38690

Sidex International Limited, succursale Lu-

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38717

Slawka S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38723

Sobel Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

38690

Steyn Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38722

Tevege Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38721

Thornwood Capital, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

38718

Tootal Silk S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38695

Van Lanschot Trust Company (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38732

Verdon Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38701

WestBox S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38736

Zunis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38722

38689

Robien S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 86.718.

Annule et remplace le précédent bilan enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2006, sous la référence LSO-BX00455

et dépose au registre de commerce et des sociétés Luxembourg, le 6 décembre 2006, sous le numéro L060132177.05

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G H TRUST, Département Domiciliation de Godfrey-Higuet
<i>Avocats
Signature

Référence de publication: 2008033536/4286/16.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08649A. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080033013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

Sobel Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 86.511.

Le compte consolidé au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 22 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008033540/578/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2008, réf. LSO-CM02371. - Reçu 150,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080012059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2008.

RREEF, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 118.790.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2008.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2008035729/5770/12.
(080037535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Realm Enterprises S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 136.857.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the eighteenth day of February.
Before us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

CALM  ENTERPRISES  LIMITED,  having its  registered office at  APO, 4  Floor,  Cayman National  Building,  200 Elgin

Avenue, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies

here represented by Mr Max Mayer, employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on February 14th, 2008.
Said proxy after being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to

the present deed.

38690

Such appearing party, represented as fore-said, has drawn up the following articles of a limited liability company to be

incorporated.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.
The name of the company is REALM ENTERPRISES S.à.r.l.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form what so ever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

Furthermore, the purposes for which the company is formed are the acquisition, the sale, the management and the

development of all real estate located in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) divided

into 500 (five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial

Companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate units transfer inter vivos to non-

members is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members' general meeting or of at least seventy-
five percent of the company's capital. In the case of the death of a member, the corporate units transfer to non-members
is subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the
remaining members have a pre-emption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to
a non-member.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to

pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by one or several managers who need not to be members and who are appointed

by the general meeting of members.

Towards third parties the managers have, by the joint signature of any two of them or the sole manager, the most

extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances. If the managers are temporarily unable to act, the
company's affairs can be managed by two members acting under their joint signature or the sole manager.

The managers may vote in a circular resolution, by letter, fax or video conference. Such a written decision is only valid

if it is taken and approved by all the managers.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

The members may vote in a circular resolution, by letter, fax or video-conference. Such a written decision is only valid

if it is taken and approved by all the members.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the

capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the
members representing three quarters of the capital.

Art. 15. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

Art. 16. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

38691

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year has to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution

will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the corporate capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not be

members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,

pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant

legislation.

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2008.

<i>Subscription and payment

The 500 (five hundred) corporate units have been subscribed to by the sole member CALM ENTERPRISES LIMITED,

prenamed.

All the corporate units have been entirely paid up in cash so that the company has now at its disposal the sum of EUR

12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

EUR 1,550.-

<i>Resolutions of the sole member

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital, passed

the following resolutions:

<i>First resolution

The following has been elected as manager:
WILMINGTON TRUST SP SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., with registered address at 52-54, avenue du X Septem-

bre, L-2550 Luxembourg (RCS-L N 

o

 B 58.628) represented by Mrs. PJ.S. Dunselman, or Mr. J.M.J. Borgt.

with the powers indicated in article 11 of the Articles of Incorporation.
The manager may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The manager is elected for an undetermined period.

<i>Second resolution

The company's registered office is located at L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X September.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above person

appearing, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person appearing
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the

notary by his surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with us, Notary,
the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil huit, le dix-huit février.
Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

CALM ENTERPRISES LIMITED avec siège social à APO, 4th Floor, Cayman National Building, 200 Elgin Avenue, George

Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies

38692

ici représentée par Monsieur Max Mayer, employé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 14 février 2008,
laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant restera annexée

aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les dispositions légales.

La société prend la dénomination de REALM ENTERPRISES S.à.r.l..

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision collective des

associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a pour en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés

au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des

associés.

Vis-à-vis des tiers, les gérants ont, par les signatures conjointes de deux d'entre eux ou celle du gérant unique, les

pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances. En cas d'empêchement temporaire
des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par deux associés, agissant conjointement.

Les gérants peuvent voter par vote circulaire par lettre, fax, ou visioconférence. Une telle décision sera uniquement

valable si elle a été prise et approuvée par tous les gérants.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Les associés peuvent voter par vote circulaire par lettre, fax, ou visioconférence. Une telle décision sera uniquement

valable si elle a été prise et approuvée par tous les associés.

38693

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2008.

<i>Souscription et paiement

Les 500 (cinq cents) parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associée unique, La société CALM ENTERPR-

SIES LIMITED, prénommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de

12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant
été donnée au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 1.550,- EUR.

<i>Résolutions de l'associe unique

L'associée unique prédésignée, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Est appelée aux fonctions de gérante:
La société anonyme WILMINGTON TRUST SP SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. ayant son siège social à 52-54, avenue

du X Septembre, L-2550 Luxembourg (RCS-L N 

o

 B 58.628) représentée par Mme. P.J.S. Dunselman, ou Mr. J.M.J. Borgt.

avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts.
Elle pourra nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat de la gérante est établie pour une durée indéterminée.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par noms, prénoms, états et demeures,

le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Mayer, P. Decker.

38694

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2008. Relation: LAC/2008/8251. — Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 6 mars 2008.

P. Decker.

Référence de publication: 2008035779/206/230.
(080038420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Tootal Silk S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 60.186.

Mention rectificative du dépôt du 11 janvier 2008 (No L080004696.04)
Le bilan modifié au 28 février 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008033550/24/15.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08333. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080033352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2008.

Biotelgy VC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 90.934.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par  jugement  en  date  du  10  janvier  2008,  le  tribunal  d'arrondissement  de  et  à  Luxembourg,  siégeant  en  matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme BIOTELGY VC S.A. avec siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, de fait inconnue à

cette adresse, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 90.934.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles Mathay, juge, et liquidateur Maître Donald Venkatapen,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

e

 D. Venkatapen

L <i>e Liquidateur

Référence de publication: 2008035455/280/21.
Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN08739. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Hanse Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 111.753.

EXTRAIT

En date du 27 décembre 2007, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Duncan Macaulay, en tant que gérant, est acceptée avec effet au 13 juin 2007.
- M. Abdulhakeem Kamkar, né le 3 avril 1961 à Dubai, domicilié au Villa #1, Abu Hail Road, Dubai, United Arab Emirates,

est élu nouveau gérant de la société avec effet au 13 juin 2007 et ce pour une durée indéterminée.

38695

Luxembourg, le 12 février 2008.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2008035756/724/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN08033. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

LaSalle UK Ventures Property 9, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 131.872.

In the year two thousand and eight, on the eighth of February.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

LaSalle UK VENTURES, a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, registered with

the Trade and Companies Register in Luxembourg under number B 116.220, having its registered office at 41, avenue de
la Liberté, L-1931 Luxembourg,

here represented by Mrs Cathy Blondel, legal assistant, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxem-

bourg, on 6 February 2008.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of LaSalle UK VENTURES PROPERTY 9 (hereinafter the «Company»), a

société à responsabilité limitée, having its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.872, incorporated pursuant to a notarial deed
on August 29, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2386 on October 23,
2007.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to increase the Company's share capital by an amount of nine hundred pound sterling (GBP

900.-), so as to raise it from its current amount of eight thousand seven hundred pound sterling (GBP 8,700.-) up to nine
thousand six hundred pound sterling (GBP 9,600.-) through the issue of forty-five (45) shares, having a nominal value of
twenty-pound sterling (GBP 20.-) each.

The new shares are to be subscribed by LaSalle UK VENTURES, prenamed, in exchange for a contribution in cash of

a total amount of nine hundred pound sterling (GBP 900.-).

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the

Company is amended and now reads as follows:

« Art. 5. first paragraph. The Company's share capital is set at nine thousand six hundred pound sterling (GBP 9,600.-)

represented by four hundred and eighty (480) shares with a par value of twenty pound sterling (GBP 20.-) each.»

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to one thousand euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing known to the notary by name, first name,

civil status and residence, this proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le huit février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

38696

LaSalle UK VENTURES, une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Luxembourg, enregistrée au Registre

du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.220, ayant son siège social au 41, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg,

représentée par Madame Cathy Blondel, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé

donnée à Luxembourg, le 6 février 2008.

La procuration paraphée ne varietur par la mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant est l'associé unique de LaSalIe UK VENTURES PROPERTY 9 (ci-après la «Société»), une société à

responsabilité limitée ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.872, constituée selon un acte notarié en date du 29
août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2386 du 23 octobre 2007.

Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.
Lequel comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de neuf cents livres sterlings (900,- GBP) afin de

le porter de son montant actuel de huit mille sept cents livres sterlings (8.700,- GBP) jusqu'à neuf mille six cents livres
sterlings (9.600,- GBP) par l'émission de quarante-cinq (45) parts sociales d'une valeur de vingt livres sterlings (20,- GBP)
chacune.

Les parts sociales nouvelles sont souscrites par LaSalle UK VENTURES, prénommée, par un apport en numéraire d'un

montant de neuf cents livres sterlings (900,- GBP).

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. premier alinéa. Le capital social est fixé à la somme de neuf mille six cents livres sterlings (9.600,- GBP)

représentée par quatre cent quatre-vingt (480) parts sociales d'une valeur de vingt livres sterlings (20,- GBP) chacune.»

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Blondel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 14 février 2008. Relation: EAC/2008/2197. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 21 février 2008.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2008029229/239/90.
(080030039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2008.

MZ Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 113.740.

EXTRAIT

En date du 27 décembre 2007, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Duncan Macaulay, en tant que gérant, est acceptée avec effet au 13 juin 2007.
- M. Abdulhakeem Kamkar, né le 3 avril 1961 à Dubai, domicilié au Villa #1, Abu Hail Road, Dubai, United Arab Emirates,

est élu nouveau gérant de la société avec effet au 13 juin 2007 et ce pour une durée indéterminée.

38697

Luxembourg, le 12 février 2008.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2008035761/724/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN08027. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

ALESRAA Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 108.197.

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Il y'a lieu de lire:
Il résulte des Résolutions de l'Associé Unique prises en date du 15 novembre 2007 que:
- Mme Claudia Schweich, née le 1 

er

 août 1979, à Arlon, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue

du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommée gérant de Catégorie B avec effet au 15 novembre 2007;

- M. Renaud Labye, né le 11 septembre 1977, à Liège, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue du

Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg été nommé gérant de Catégorie B avec effet au 15 novembre 2007.

Les nouveaux gérants ont été nommés pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, en novembre 2007.

<i>Pour ALESRAA LUXEMBOURG S.à r.l.
N. Akhertous
<i>Mandataire

Au lieu de:
Il résulte des Résolutions de l'Associé Unique prises en date du 15 novembre 2007 que:
- Mme Claudia Schweich, née le 1 

er

 août 1977, à Arlon, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue

du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommée gérant de Catégorie B avec effet au 15 novembre 2007;

- M. Renaud Labye, né le 11 septembre 1977, à Liège, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue du

Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg été nommé gérant de Catégorie B avec effet au 15 novembre 2007.

Les nouveaux gérants ont été nommés pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, en novembre 2007.

<i>Pour ALESRAA LUXEMBOURG S.à r.l.
N. Akhertous
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008035523/6654/36.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01582. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080036987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Blue Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 79.348.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire, réunie à Luxembourg en date du 4 décembre 2007, a pris à l'unanimité les ré-

solutions suivantes:

1. L'assemblée décide de transférer le siège social du 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg au 6, rue Adophe, L-1116

Luxembourg.

38698

2. L'assemblée prend acte de la démission de quatre des cinq administrateurs, à savoir:
- Monsieur Marc Koeune, né à Luxembourg le 4 octobre 1969, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau,

L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Jean-Yves Nicolas, né à Vielsalm (Belgique) le 16 janvier 1975, domicilié professionnellement au 18, rue de

l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Nicole Thommes, née à Arlon (Belgique) le 28 octobre 1961, domiciliée professionnellement au 18, rue de

l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Andrea Dany, née à Trèves (Allemagne) le 14 août 1973, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau,

L-1449 Luxembourg;

et nomme en leur remplacement:
- Monsieur José Correia, né à Palmeira (Portugal) le 4 octobre 1971, domicilié professionnellement au 6, rue Adolphe,

L-1116 Luxembourg;

- Madame Violène Rosati, née à Mont-Saint-Martin (France) le 23 avril 1977, domiciliée professionnellement au 6, rue

Adolphe, L-1116 Luxembourg;

- Madame Géraldine Schmit, née à Messancy (Belgique) le 12 novembre1969, domiciliée professionnellement au 6, rue

Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Monsieur Damiano Luigi Della Ca continuera son mandat. Suite à cette Assemblée, les administrateurs seront au

nombre de quatre. Les nouveaux administrateurs termineront les mandats de leurs prédécesseurs. Tous les mandats
viendront donc à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2011.

3. L'assemblée prend acte de la démission du commissaire aux comptes, à savoir la société CeDerLux SERVICES S.à.r.l.,

ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, et nomme en son remplacement la société WOOD
APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES Sàrl, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, RCS
B 74.623, qui achèvera le mandat de son prédécesseur échéant à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an
2011.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008035451/693/40.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO02045. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080036869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Event &amp; Com S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 109.923.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 7

<i>février 2008

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:
- d'accepter la démission de la société EUROPEAN MANAGEMENT FIDUCIARY S.A., de sa fonction de commissaire

aux comptes et de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société FGS CONSULTING LLC, société
établie et ayant son siège social à NV 89101 Las Vegas, 520 S. 7th Street, Suite C et enregistrée au Secretary of State
Nevada sous le numéro E0048502007-7. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en
2011.

- d'accepter les démissions de Monsieur Guy Feite, Madame Michèle Feite et de Monsieur Sébastien Vachon de leurs

fonctions d'administrateurs et de nommer comme nouveaux administrateurs:

- Monsieur Gianluca Ninno, fiscaliste, né le 7 avril 1975 à Policoro (Italie) et demeurant professionnellement à L-2522

Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider,

- Monsieur Natale Capula, employé privé, né le 1 

er

 novembre 1961 à Villa San Giovanni (Italie) et demeurant profes-

sionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider,

- La société LUXEMBOURG MANAGEMENT SERVICES SARL, ayant son siège social à L-2522 Luxembourg 12, rue

Guillaume Schneider et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.551.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2011.
- de transférer le siège social de la société au 12, rue Guillaume Schneider à L-2522 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

38699

Luxembourg, le 7 février 2008.

Certifié sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2008035462/1383/32.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01668. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Luxding Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 29.936.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CORFI
<i>Experts Comptables
Signature

Référence de publication: 2008035859/642/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO01937. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080036934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Centuria Monaco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 130.408.

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Il y'a lieu de lire:
Il résulte des Résolutions de l'Associé Unique prises en date du 15 novembre 2007 que:
- M. Emmanuel Limido, né le 5 janvier 1959, à Paris, (France), ayant comme adresse professionnelle le 203, rue du

Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris, a démissionné de son mandat de gérant avec effet immédiat;

- Mme Claudia Schweich, née le 1 

er

 août 1979, à Arlon, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue

du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommée gérant avec effet au 15 novembre 2007;

- M. Renaud Labye, né le 11 septembre 1977, à Liège, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue du

Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommé gérant avec effet au 15 novembre 2007.

Les nouveaux gérants ont été nommés pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, en février 2008.

<i>Pour CENTURIA MONACO S.à r.l
N. Akhertous
<i>Mandataire

Au lieu de:
Il résulte des Résolutions de l'Associé Unique prises en date du 15 novembre 2007 que:
- M. Emmanuel Limido, né le 5 janvier 1959, à Paris, (France), ayant comme adresse professionnelle le 203, rue du

Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris, a démissionné de son mandat de gérant avec effet immédiat;

- Mme Claudia Schweich, née le 1 

er

 août 1977, à Arlon, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue

du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommée gérant avec effet au 15 novembre 2007;

- M. Renaud Labye, né le 11 septembre 1977, à Liège, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue du

Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommé gérant avec effet au 15 novembre 2007.

Les nouveaux gérants ont été nommés pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

38700

Luxembourg, en novembre 2007.

<i>Pour CENTURIA MONACO S.à r.l
N. Akhertous
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008035525/6654/40.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01573. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080036944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Euxin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 109.196.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EUXIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008035925/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00385. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Verdon Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 83.850.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour VERDON FINANCES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008035927/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2008, réf. LSO-CO00384. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Menuiserie Dirk Berens S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6470 Echternach, 14, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 136.819.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, den sechsundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Herr Dirk Berens, Schreinermeister, wohnhaft in D-54657 Gindorf, Orsfelder Straße 8.
Der Komparent erklärt zwischen ihm und allen denjenigen, welche im nachhinein Gesellschafter werden könnten, eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des Ge-
setzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung lautet MENUISERIE DIRK BERENS S.à r.l.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Schreinerei, der Trockenausbau, der Handel mit, der Einkauf,

Verkauf, Ein- und Aufbau von Möbeln, Einbauküchen, von Einrichtungsgegenständen, von Teppichen und Bodenbelägen,

38701

von Dekorationsartikel, von Kunstgegenständen und Antiquitäten, Elektroartikel, Waren, Maschinen, Materialien jeder
Art, sowie der Transport derselbigen.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-

nehmen beteiligen.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Ver-

vollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich kapitalmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen.
Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.
Sie kann durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters, oder, im Falle von mehreren Gesellschaftern, durch Beschluss

der  Generalversammlung  der  Gesellschafter,  welche  mit  der  zur  Änderung  der  Satzung  erforderlichen  Mehrheit
beschließen, aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Echternach. Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen

Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

Es ist der Gesellschaft gestattet Niederlassungen, Büros, Zweigstellen oder Vertretungen durch einfachen Beschluss

der Geschäftsführung oder der Gesellschafter sowohl im In- als auch im Ausland zu errichten.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend-fünfhundert (12.500,-) Euro eingeteilt in hundert

(100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig (125,-) Euro.

Art. 6. Die Anteilabtretung durch den alleinigen Gesellschafter ist frei. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die

Anteile zwischen Gesellschaftern, im Verhältnis der jeweils gehaltenen Gesellschaftsanteile frei übertragbar.

Anteilübertragungen unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Ge-

sellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich. In jedem Fall besitzen die anderen
Gesellschafter im Verhältnis der von Ihnen gehaltenen Anteile ein Vorkaufsrecht.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter, außer wenn es sich um den überlebenden Ehepartner oder

den/die Erben handelt denen ein Pflichtteil zusteht, nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der Gesellschafter, welche
mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Jede Anteilübertragung an Nichtgesellschafter unterliegt ferner einem Vorzugsrecht zu Gunsten der anderen Gesell-

schafter.

Im  Falle,  dass  die  Parteien  keine  Einigkeit  über  den  zwischen  ihnen  zu  zahlenden  Preis  erzielen,  wird,  gemäß  den

Bestimmungen von Artikel 189 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, der
Wert eines Anteils auf Basis der letzten drei Handelsbilanzen der Gesellschaft bewertet.

Zählt die Gesellschaft weniger als drei Geschäftsjahre, wird der Wert auf Grund der Handelsbilanz(en) der bestehen-

den  Geschäftsjahre  bewertet.  Zu  diesem  Zweck  benennt  jede  Partei  einen  Gutachter,  die,  ihrerseits  einen  dritten
Gutachter benennen, für den Fall, wo beide Gutachter keine Einigkeit über den zu zahlenden Preis erlangen.

Sollte bei einem oder mehreren Gesellschaftern, die eine juristische Person sind, die wirtschaftlichen Nutznießer oder

Berechtigten in einer Weise ändern, die den jetzigen wirtschaftlichen Nutznießern oder Berechtigten weniger als ei-
nundfünfzig (51%) Prozent der Stimmrechte in dieser juristischen Person zugestehen, wird dies mit einer Veräußerung
der Gesellschaftsanteile im Sinne von Absatz zwei gleichgesetzt.

Diese Veränderung muss der Gesellschaft und den verbleibenden Gesellschaftern wie vorstehend beschrieben mitge-

teilt werden. Die Bestimmungen der Abschnitte zwei bis sechs sind anwendbar.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft auf. Die Gesellschaftsanteile sind unpfändbar.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters können in keinem Fall Antrag auf

Siegelan-legung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von dem einzigen Gesellschafter oder durch die Generalversammlung aller Gesellschafter, ernannt
werden. Der oder die Geschäftsführer sind jederzeit abrufbar.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandate werden bei ihrer Ernennung

festgelegt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterzeichnung des oder der Geschäftsführer.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen

ein.

Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Der alleinige Gesellschafter nimmt die Rechte der Gesellschafterversammlung wahr.

38702

Bei mehreren Gesellschaftern ist jeder Gesellschafter stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so

viele Stimmen abgeben wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf
Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Die Gesellschafterversammlung wird durch den oder die Geschäftsführer einberufen.
Bei mehreren Gesellschaftern können die Gesellschafter von dem oder den Geschäftsführern die Einberufung einer

Gesellschafterversammlung verlangen.

Bei Einberufung der Gesellschafterversammlung sind Ort, Tagungsort und Zeit bekannt zu geben.
Die Einberufung geschieht durch eingeschriebenen Brief mit einer Frist von 14 Tagen. Der Tag der Absendung und

der Tag der Versammlung werden nicht mitgerechnet.

Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt eine von der Gesellschafterversammlung zu bestimmende Person.
Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig wenn mindestens drei Viertel des Stammkapitals vertreten sind.
Die Beschlüsse ergehen, soweit das Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag nichts anderes vorschreibt, mit einfacher

Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Mit Einverständnis aller Gesellschafter können Beschlüsse der Gesellschaft ohne Einberufung einer Gesellschafterver-

sammlung im Wege schriftlicher, telegrafischer oder fernmündlicher Abstimmung gefasst werden.

Beschlüsse der Gesellschafter sind - soweit sie nicht notariell zu beurkunden sind - in einer Niederschrift festzuhalten.
Ein Gesellschafter ist auch zur Abstimmung in ihn selbst betreffenden Angelegenheiten berechtigt.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer

erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen, Steuern und sonstigen Lasten, verbleibende Betrag stellt den

Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat.

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von dem einzigen

Gesellschafter oder von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch-
geführt. Der einzige Gesellschafter oder, bei mehreren Gesellschaftern, die Generalversammlung legen deren Befugnisse
und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreißigsten Dezember zweitausendacht.

<i>Zeichnung der Anteile

Sämtliche Anteile wurden vollständig und in bar von dem vorgenannten Komparenten, alleiniger Gesellschafter in

einbezahlt und gezeichnet, so daß die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur
Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde, welcher
dieses bestätigt.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein mögen, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden auf 1.000,- EUR abgeschätzt.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Und sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Gesellschafter, welcher das gesamte Kapital vertritt, folgende

Beschlüsse gefasst:

Die Adresse der Gesellschaft ist in L-6471 Echternach, 14, rue de la Montagne.
Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.
Zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer wird Herr Dirk Berens vorbenannt ernannt.
Die Gesellschaft ist durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers in allen Bereichen rechtsgültig vertreten, Selbst-

kontrahierung einbegriffen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

38703

Und nach Vorlesung und Erklärung an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Berens, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, Relation: LAC/2008/8700. — Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, den 6. März 2008.

P. Decker.

Référence de publication: 2008035953/206/132.
(080037723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Broad Street Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 119.929.

In the year two thousand and seven, on the twenty-third day of May.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY PLC, a public limited company with registered office at 11/12 Dawson

Street, Dublin 2, Ireland, registered in Ireland under No.7336,

represented by Mr Marc Albertus, private employee, with professional address at 5, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the attorney in fact and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
That the said appearing person is the sole shareholder of BROAD STREET LUX, S. à r. l., (the «Company»), with

registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register, at section B under number 119.929, incorporated by deed of the undersigned notary on the 12th day of Sep-
tember 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 2134 of the 15th day of November
2006.

All this being declared, the appearing party, represented as stated hereabove, holding one hundred percent (100%) of

the share capital of the Company, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has taken by
unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder decides to convert the company's share capital currency into GBP at the conversion rate agreed

between both parties of 1.- EUR= 0.6756 GBP.

The Sole Shareholder decides to increase the current share capital in the amount of GBP 4,055.- (four thousand fifty-

five Sterling pounds), without creation of new shares, in order to raise it to GBP 12,500.- (twelve thousand five hundred
Sterling pounds) divided into 500 (five hundred) shares of GBP 25.- (twenty-five Sterling pounds) each.

The amount of GBP 4,055.- (four thousand fifty-five Sterling pounds) is as of now available to the Company, as it has

been justified to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder decides to increase the share capital in the amount of GBP 1,487,500.- (one million four hundred

eighty-seven thousand five hundred Sterling pounds) in order to raise it from GBP 12,500.- (twelve thousand five hundred
Sterling pounds) to GBP 1,500,000.- (one million five hundred thousand Sterling pounds) by the issue of 59,500 (fifty-nine
thousand five hundred) new shares of GBP 25.- (twenty-five Sterling pounds) each, benefiting of the same rights and
advantages as the presently issued shares.

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to accept that the 59,500 (fifty-nine thousand five hundred)

new shares are subscribed and fully paid up by contribution in cash of an aggregate amount of GBP 1,487,500.- (one million
four hundred eighty-seven thousand five hundred Sterling pounds) as follows:

(1) 14,500 (fourteen thousand five hundred) shares by NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY PLC, prenamed,

represented as stated above,

which declares to subscribe for 14,500 (fourteen thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by

contribution in cash amounting to GBP 362,500.- (three hundred sixty-two thousand five hundred Sterling pounds);

38704

(2) 3,000 (three thousand) shares by GLENHAVEN HOLDINGS LIMITED, a company limited by shares with registered

office in Kabride Industrial Estate, Arklow, CO Wicklow, Ireland, registered in Ireland under No.219665,

which declares to subscribe for 3,000 (three thousand) newly issued shares and to pay them up by contribution in cash

amounting to GBP 75,000.- (seventy-five thousand Sterling pounds);

(3) 3,000 (three thousand) shares by JJSED PARTNERSHIP, with registered office at Rickardstown, Newbridge, CO

Kildare, Ireland, represented by its Managing Partner Mr James Kelly,

which declares to subscribe for 3,000 (three thousand) newly issued shares and to pay them up by contribution in cash

amounting to GBP 75,000.- (seventy-five thousand Sterling pounds);

(4) 3,000 (three thousand) shares by Mr Seamus Hill, born on November 10, 1963 in Galway, residing in 7 Saint Mary's

Road, Galway City, Ireland,

who declares to subscribe for 3,000 (three thousand) newly issued shares and to pay them up by contribution in cash

amounting to GBP 75,000.- (seventy-five thousand Sterling pounds);

(5) 3,000 (three thousand) shares by Mr Myles O'Malley, born on March 4, 1930 in Mayo, residing in 2, Beach Court,

Grattan Road, Galway, Ireland,

who declares to subscribe for 3,000 (three thousand) newly issued shares and to pay them up by contribution in cash

amounting to GBP 75,000.- (seventy-five thousand Sterling pounds);

(6) 3,000 (three thousand) shares by Mr Patrick Quinn, born on March 6, 1945 in Clare, residing in Claremount House,

Clarecastle, Ennis, Co Clare, Ireland,

who declares to subscribe for 3,000 (three thousand) newly issued shares and to pay them up by contribution in cash

amounting to GBP 75,000.- (seventy-five thousand Sterling pounds);

(7) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mr Donal Spring, born on August 3, 1956 in Ireland, residing in 29,

Belgrave Square, Monkstown, Co Dublin, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds);

(8) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mrs Geraldine Shanley, born on March 3, 1959 in Galway, residing in

29, Belgrave Square, Monkstown, Co Dublin, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds);

(9) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mr Denis Fay, born on March 5, 1946 in Dublin, residing in Ayrton,

Littleconnell, Newbridge, Co Kildare, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds);

(10) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mrs Katherine Fay, born on April 9, 1949 in Dublin, residing in

Ayrton, Littleconnell, Newbridge, Co Kildare, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds);

(11) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mr David O'Flaherty, born on October 1, 1959 in Ireland, residing

in 19 Bachelors Walk, Ballinasloe, Co Galway, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds);

(12) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mr Colman O'Flaherty, born on May 15, 1961 in Ireland, residing in

12, Dun Daingean, Newcastle, Galway, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds);

(13) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mr Franck Brady, born on October 26, 1926 in Ireland, residing in

Cruicetown, Nobber, Co Meath, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds);

(14) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mrs Mary-Patricia Brady, born on July 14, 1929 in Dublin, residing

in Cruicetown, Nobber, Co Meath, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds);

(15) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mr Robert Quinn, born on February 7, 1951 in Wexford, residing

in The Locks, Milford, Carlow, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds);

38705

(16) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mrs Mary Quinn, born on January 5, 1955 in Waterford, residing in

The Locks, Milford, Carlow, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds);

(17) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mr Conor Phelan, born on September 12, 1963 in Waterford, residing

in Ngong, Kilnagleary, Carrigaline, Co Cork, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds);

(18) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mrs Annmary Denise Phelan, born on July 28, 1965 in Waterford,

residing in Ngong, Kilnagleary, Carrigaline, Co Cork, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds);

(19) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mr Eamonn Tattan, born on March 13, 1944 in Ireland, residing in

Ballinabortagh, Carrignavar, Co Cork, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds);

(20) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mrs Abina Tattan, born on July 22, 1944 in Cork, residing in Balli-

nabortagh, Carrignavar, Co Cork, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds);

(21) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mr Michael Hannan, born on December 17, 1940 in Dublin, residing

in Sunnymeade, The Ward, Co Dublin, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds);

(22) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mrs Nessa Hannan, born on June 14, 1941 in Dublin, residing in

Sunnymeade, The Ward, Co Dublin, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds);

(23) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mr James Dowling, born on May 18, 1943 in Laois, residing in Brynoge,

Wesminster Road, Foxrock, Dublin 18, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds);

(24) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mrs Ursula Dowling, born on March 12, 1950 in Cork, residing in

Brynoge, Wesminster Road, Foxrock, Dublin 18, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds);

(25) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mr Denis Oliver O'Mahony, born on July 10, 1945 in Cork, residing

in 14 Ashboro, Shanakiel, Cork, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds); and

(26) 1,500 (one thousand five hundred) shares by Mr Patrick Kelliher, born on July 26, 1945 in Kerry, residing in 57

Richmond Wood, Glanmire, Co Cork, Ireland,

who declares to subscribe for 1,500 (one thousand five hundred) newly issued shares and to pay them up by contri-

bution in cash amounting to GBP 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Sterling pounds),

each of them being here represented by Mr Marc Albertus, prenamed, by virtue of proxies given under private seal.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the attorney in fact and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

All the 59,500 new shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of GBP 1,487,500.- (one million

four hundred eighty-seven thousand five hundred Sterling pounds) is as of now available to the Company, as it has been
justified to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the shareholders decide to restate the 1st paragraph of article 5 of

the by-laws, which henceforth will read as follows:

«  Art. 5.1  The  corporate  capital  is  fixed  at  GBP  1,500,000.-  (one  million  five  hundred  thousand  Sterling  pounds)

represented by 60,000 (sixty thousand) shares of GBP 25.- (twenty-five Sterling pounds) each (hereafter referred to as
the «Shares»). The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».»

38706

<i>Fourth resolution

The shareholders decide to empower each manager to bind the company by his sole signature and, consequently, to

amend article 10 of the by-laws in order to read as follows:

« Art. 10. Representation of the company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager,

bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case or plurality of managers, by the sole signature of any manager
or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager
or, in case of plurality of managers, by any two managers.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with the present deed have been estimated at about EUR 25,000.- (twenty-five thousand
EURO).

For the purposes of the registration the amount of the capital increase (GBP 1,491,555.-) is evaluated at EUR 2,181,082.-

(exchange rate of 22nd May 2007: 1.- GPB = 1.46229 EUR).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties as represented hereabove, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of
the same appearing parties and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will
prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney in fact of the appearing parties acting in his hereabove stated capacities,

he signed together with the notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY PLC, société anonyme ayant son siège social à 11/12 Dawson Street, Dublin

2, Irlande, immatriculée en Irlande sous le numéro N 

o

 7336,

représentée par Monsieur Marc Albertus, employé privé, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Elle est la seule et unique associée de la société BROAD STREET LUX, S. à r. l., (la «Société»), ayant son siège social

au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg à la section B sous le numéro 119.929 constituée par acte du notaire instrumentant le 12 septembre 2006,
publié dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2134 du 15 novembre 2006.

Tout ceci ayant été déclaré, la partie comparante représentée comme dit ci-avant, détenant cent pour-cent (100%) du

capital de la Société, a immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L'Associée Unique décide de convertir la devise du capital social en GBP au taux de conversion convenu entre parties

de EUR 1,- = 0,6756 GBP.

L'Associée Unique décide d'augmenter le capital social, sans création de parts sociales nouvelles, à concurrence de

GBP 4.055,- (quatre mille cinquante-cinq livres sterling) afin de le porter à GBP 12.500,- (douze mille cinq cents livres
sterling) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales de GBP 25,- (vingt-cinq livres sterling) chacune.

La somme de GBP 4.055,- (quatre mille cinquante-cinq livres sterling) est dès maintenant à la disposition de la Société,

ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

L'Associée Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de GBP 1.487.500,- (un million quatre cent

quatre-vingt-sept mille cinq cents livres sterling) pour porter son montant actuel de GBP 12.500,- (douze mille cinq cents
livres sterling) à GBP 1.500.000,- (un million cinq cent mille livres sterling) par émission de 59.500 (cinquante-neuf mille
cinq cents) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de GBP 25,- (vingt-cinq livres sterling) chacune, ayant les mêmes
droits et obligations que les parts sociales existantes.

38707

<i>Souscription - Libération

L'Associée Unique, représentée comme dit ci-avant, déclare accepter la souscription des 59.500 (cinquante-neuf mille

cinq cents) nouvelles parts sociales et leur entière libération par des apports en espèces d'un montant total de GBP
1.487.500,- (un million quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents livres sterling) comme suit:

(1) 14.500 (quatorze mille cinq cents) parts sociales par NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY PLC, préqualifiée,

représentée comme dit ci-avant,

qui déclare souscrire à 14.500 (quatorze mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un

apport en espèces de GBP 362.500,- (trois cent soixante-deux mille cinq cents livres sterling);

(2) 3.000 (trois mille) parts sociales par GLENHAVEN HOLDINGS LIMITED, société à responsabilité limitée ayant

son  siège  social  à  Kabride  Industrial  Estate,  Arklow,  CO  Wicklow,  Irlande,  immatriculée  en  Irlande  sous  le  numéro
219.665,

qui déclare souscrire à 3.000 (trois mille) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en espèces

de GBP 75.000,- (soixante-quinze mille livres sterling);

(3) 3.000 (trois mille) parts sociales par JJSED PARTNERSHIP, ayant son siège social à Rickardstown, Newbridge, CO

Kildare, Irlande, représentée par l'Associé Gérant, Monsieur James Kelly,

qui déclare souscrire à 3.000 (trois mille) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en espèces

de GBP 75.000,- (soixante-quinze mille livres sterling);

(4) 3.000 (trois mille) parts sociales par Monsieur Seamus Hill, né le 10 novembre 1963 à Galway, demeurant à 7 Saint

Mary's Road, Galway City, Irlande,

qui déclare souscrire à 3.000 (trois mille) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en espèces

de GBP 75.000,- (soixante-quinze mille livres sterling);

(5) 3.000 (trois mille) parts sociales par Monsieur Myles O'Malley, né le 4 mars 1930 à Mayo, demeurant à 2, Beach

Court, Grattan Road, Galway, Irlande,

qui déclare souscrire à 3.000 (trois mille) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en espèces

de GBP 75.000,- (soixante-quinze mille livres sterling);

(6) 3.000 (trois mille) parts sociales par Monsieur Patrick Quinn, né le 6 mars 1945 à Clare, demeurant à Claremount

House, Clarecastle, Ennis, Co Clare, Irlande,

qui déclare souscrire à 3.000 (trois mille) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en espèces

de GBP 75.000,- (soixante-quinze mille livres sterling);

(7) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Monsieur Donal Spring, né le 3 août 1956 en Irlande, demeurant à 29,

Belgrave Square, Monkstown, Co Dublin, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500 (trente-sept mille cinq cents livres sterling);

(8) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Madame Geraldine Shanley, née le 3 mars 1959 à Galway, demeurant à

29, Belgrave Square, Monkstown, Co Dublin, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling);

(9) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Monsieur Denis Fay, né le 5 mars 1946 à Dublin, demeurant à Ayrton,

Littleconnell, Newbridge, Co Kildare, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling);

(10) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Madame Katherine Fay, née le 9 avril 1949 à Dublin, demeurant à Ayrton,

Littleconnell, Newbridge, Co Kildare, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling);

(11) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Monsieur David O'Flaherty, né le 1 

er

 octobre 1959 en Irlande, de-

meurant à 19 Bachelors Walk, Ballinasloe, Co Galway, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling);

(12) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Monsieur Colman O'Flaherty, né le 15 mai 1961 en Irlande, demeurant

à 12, Dun Daingean, Newcastle, Galway, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling);

(13) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Monsieur Franck Brady, né le 26 octobre 1926 en Ireland, demeurant

à Cruicetown, Nobber, Co Meath, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling);

38708

(14) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Madame Mary-Patricia Brady, née le 14 juillet 1929 à Dublin, demeurant

à Cruicetown, Nobber, Co Meath, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling);

(15) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Monsieur Robert Quinn, né le 7 février 1951 à Wexford, demeurant à

The Locks, Milford, Carlow, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling);

(16) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Madame Mary Quinn, née le 5 janvier 1955 à Waterford, demeurant à

The Locks, Milford, Carlow, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling);

(17) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Monsieur Conor Phelan, né le 12 septembre 1963 à Waterford, de-

meurant à Ngong, Kilnagleary, Carrigaline, Co Cork, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling);

(18) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Madame Annmary Denise Phelan, née le 28 juillet 1965 à Waterford,

demeurant à Ngong, Kilnagleary, Carrigaline, Co Cork, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling);

(19) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Monsieur Eamonn Tattan, né le 13 mars 1944 en Irlande, demeurant à

Ballinabortagh, Carrignavar, Co Cork, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling);

(20) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Madame Abina Tattan, née le 22 juillet 1944 à Cork, demeurant à

Ballinabortagh, Carrignavar, Co Cork, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling);

(21) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Monsieur Michael Hannan, né le 17 décembre 1940 à Dublin, demeurant

à Sunnymeade, The Ward, Co Dublin, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling);

(22) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Madame Nessa Hannan, née le 14 juin 1941 à Dublin, demeurant à

Sunnymeade, The Ward, Co Dublin, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling);

(23) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Monsieur James Dowling, né le 18 mai 1943 à Laois, demeurant à

Brynoge, Wesminster Road, Foxrock, Dublin 18, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling);

(24) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Madame Ursula Dowling, née le 12 mars 1950 à Cork, demeurant à

Brynoge, Wesminster Road, Foxrock, Dublin 18, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling);

(25) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Monsieur Denis Oliver O'Mahony, né le 10 juillet 1945 à Cork, de-

meurant à 14 Ashboro, Shanakiel, Cork, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling); et

(26) 1.500 (mille cinq cents) parts sociales par Monsieur Patrick Kelliher, né le 26 juillet 1945 à Kerry, demeurant à

57 Richmond Wood, Glanmire, Co Cork, Irlande,

qui déclare souscrire à 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvellement émises et les libérer par un apport en

espèces de GBP 37.500,- (trente-sept mille cinq cents livres sterling),

chacun d'eux étant ici représenté par Monsieur Marc Albertus, prénommé, en vertu de procurations données sous

seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire

instrumentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

38709

Toutes les 59.500 nouvelles parts souscrites ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de

GBP 1.487.500,- (un million quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents livres sterling) est dès maintenant à la disposition
de la Société, ce dont il a été justifie au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les associés décident de procéder à la refonte de l'article 5.1 des statuts de la

Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5.1. Le capital social souscrit est fixé à GBP 1.500.000,- (un million cinq cent mille livres sterling) représenté par

60.000 (soixante mille) parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de GBP 25,- (vingt-cinq livres
sterling) chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».»

<i>Quatrième résolution

Les associés décident d'autoriser chaque gérant à engager la société par sa signature individuelle et, par conséquent,

de modifier l'article 10 des Statuts afin de leur donner la teneur suivante:

« Art. 10. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée

par la seule signature de son Gérant Unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chaque
gérant ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant
Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros).

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de l'augmentation de capital (GBP 1.491.555,-) est évalué à EUR

2.181.082,- (cours de change du 22 mai 2007: 1,- GBP = 1,46229 EUR).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants, représentés comme dit

ci-avant, a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits
comparants, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: M. Albertus, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 1 

er

 juin 2007, Relation: LAC/2007/10782. — Reçu 21.954 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 2 juillet 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2008036126/202/358.
(080038258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Espace Concept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle Um Monkeler.

R.C.S. Luxembourg B 28.822.

L'assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du com-

missaire aux comptes pour une durée de 6 années. Les mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra
en l'an 2013.

<i>Conseil d'Administration:

- Monsieur Jan-Peter Seligson, Administrateur-délégué, demeurant à L-1363 Howald, rue du Couvent, 3.
- Monsieur Stefan Seligson, demeurant à F-00100 Helsinki, Mechelininkatu, 13
- Madame Manuela Gietz, demeurant à F-00100 Helsinki, Mechelininkatu, 13

<i>Commissaire aux comptes:

- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING SARL avec siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

38710

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 18 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008035713/680/20.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01676. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080037221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Centuria Vauban S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 130.616.

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Il y a lieu de lire:
Il résulte des Résolutions de l'Associé Unique prises en date du 15 novembre 2007 que:
- M. Emmanuel Limido, né le 5 janvier 1959, à Paris, (France), ayant comme adresse professionnelle le 203, rue du

Faubourg Saint Honoré, F-75008 Paris, a démissionné de son mandat de gérant avec effet immédiat;

- M. Guy Alves, né le 7 septembre 1972, à Paris, (France), ayant comme adresse professionnelle le 203, rue du Faubourg

Saint Honoré, F-75008 Paris, a démissionné de son mandat de gérant avec effet immédiat;

- Mme Claudia Schweich, née le 1 

er

 août 1979, à Arlon, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue

du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommée gérant avec effet au 15 novembre 2007;

- M. Renaud Labye, né le 11 septembre 1977, à Liège, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue du

Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommé gérant avec effet au 15 novembre 2007.

Les nouveaux gérants ont été nommés pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, en février 2008.

<i>Pour CENTURIA VAUBAN S.à r.l
N. Akhertous
<i>Mandataire

Au lieu de:
Il résulte des Résolutions de l'Associé Unique prises en date du 15 novembre 2007 que:
- M. Emmanuel Limido, né le 5 janvier 1959, à Paris, (France), ayant comme adresse professionnelle le 203, rue du

Faubourg Saint Honoré, F-75008 Paris, a démissionné de son mandat de gérant avec effet immédiat;

- M. Guy Alves, né le 7 septembre 1972, à Paris, (France), ayant comme adresse professionnelle le 203, rue du Faubourg

Saint Honoré, F-75008 Paris, a démissionné de son mandat de gérant avec effet immédiat;

- Mme Claudia Schweich, née le 1 

er

 août 1977, à Arlon, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue

du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommée gérant avec effet au 15 novembre 2007;

- M. Renaud Labye, né le 11 septembre 1977, à Liège, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue du

Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommé gérant avec effet au 15 novembre 2007.

Les nouveaux gérants ont été nommés pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, en novembre 2007.

<i>Pour CENTURIA VAUBAN S.à r.l
N. Akhertous
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008035528/6654/44.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01557. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080036929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

38711

attrax S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 77.836.

Im Jahre zweitausendacht, am vierzehnten Februar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft attrax S.A. mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 308, route d'Esch, eingetragen im

Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 77.836, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar
Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg am 23. August 2000, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 152 vom 28. Februar 2001, zu einer Generalversammlung zusammen getreten.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Petra Hauer, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in L-1471 Lu-

xemburg, 308, route d'Esch, eröffnet.

Die Vorsitzende ruft zur Schriftfüherin Frau Corinne Petit, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in L-1750 Luxemburg,

74, avenue Victor Hugo.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herr Raymond Thill, maître en droit, mit Berufsanschrift in

L-1750 Luxemburg, 74, avenue Victor Hugo.

Die Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
1) Abänderung der Satzung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, wie sie als vorgeschlagene Neufassung den Aktionären

vorab zugegangen ist.

2) Verschiedenes.
II. Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste ein-

getragen sind. Diese Liste wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigeführt und ordnungsgemäß von den anwesenden
Aktionären, von den bevollmächtigten Aktionärsvertretern sowie vom Versammlungsvorstand unterschrieben.

III. Dass das gesamte Gesellschaftskapital in gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten ist und alle anwe-

senden oder vertretenen Aktionäre erklären Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben und somit keine Einladungen
erforderlich waren.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster und einziger Beschluss

Die  Generalversammlung  beschließt,  die  Satzung  der  Gesellschaft  in  ihrer  Gesamtheit,  wie  sie  als  vorgeschlagene

Neufassung den Aktionären vorab zugegangen ist, abzuändern.

Der Wortlaut der neuen Gesellschaftssatzung ist demnach folgender:

«I. Name, Sitz, Gegenstand und Dauer der Gesellschaft

Art. 1.
(1) Die Gesellschaft ist als Luxemburger Gesellschaft in Form einer «Société Anonyme» (Aktiengesellschaft) errichtet.
(2) Sie führt den Namen attrax S.A.

Art. 2.
(1) Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg; die Adresse des Sitzes kann durch Beschluss des Verwaltungsrates

jederzeit innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

(2) Falls durch politische Ereignisse oder höhere Gewalt die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit und der reibungslose Verkehr

zwischen ihrem in Absatz 1 festgelegten Sitz und dem Ausland beeinträchtigt wird oder eine solche Beeinträchtigung
vorauszusehen ist, kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegen.

(3) Die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft soll unbeeinflusst durch eine derartige vorübergehende Sitzver-

legung beibehalten werden.

Art. 3.
(1) Zweck der Gesellschaft ist
a. die nach Artikel 24 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor in seiner jeweiligen Fassung als Anlage-

berater gewerbsmäßig ausgeübte Tätigkeit der Abgabe von persönlichen Empfehlungen an einen Kunden, die sie entweder
aus Eigeninitiative oder auf Aufforderung der Kunden abgeben und die sich auf eine oder mehrere Geschäfte mit Finan-
zinstrumenten beziehen.

b. die nach Artikel 24-1 des genannten Gesetzes als Makler gewerbsmäßig ausgeübte Tätigkeit der Entgegennahme und

Weitergabe  von  Aufträgen  über  ein  oder  mehrere  Finanzinstrumente  für  Rechnung  von  Kunden,  ohne  Gelder  oder
Finanzinstrumente von Kunden zu halten.

38712

c. die nach Artikel 24-2 des genannten Gesetzes als Kommissionär gewerbsmäßig ausgeübte Tätigkeit der Ausführung

von Aufträgen über ein oder mehrere Finanzinstrumente für Rechnung von Kunden.

(2) Daneben kann die Gesellschaft als Nebendienstleistungen nach Anhang II, Abschnitt B des genannten Gesetzes die

Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten für Rechnung von Kunden einschließlich der Depotverwahrung und
verbundener Dienstleistungen wie Cash Management oder Sicherheitenverwaltung sowie die Ausführung von Devisen-
geschäften, die im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen stehen, tätigen.

(3) Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen

Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland beteiligen, sowie alle sonstigen Geschäfte be-
treiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

II. Kapital und Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt vier Millionen neunhundertvierzehntausend Euro (4.914.000,- EUR), eingeteilt

in viertausend neunhundertvierzehn (4.914) nennwertlose Aktien, die voll in bar eingezahlt sind.

Art. 6. Die Aktien sind Namensaktien.

Art. 7.
(1) Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, die nicht Aktionäre

der Gesellschaft zu sein brauchen.

(2) Die Verwaltungsratsmitglieder werden für die Dauer von bis zu sechs Jahren von der Generalversammlung bestellt;

sie können von ihr jederzeit abberufen werden.

(3) Die Wiederwahl ist möglich.
(4) Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds endet vor Ablauf dieser Zeit, wenn es aus einer für die Bestellung

maßgebenden Funktion ausscheidet. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die
verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einen  vorläufigen  Nachfolger  bestimmen,  dessen  Bestellung  von  der
nächstfolgenden Generalversammlung bestätigt werden muss.

Art. 8.
(1) Der Verwaltungsrat hat die Befugnisse, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung

des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten der Gesellschaft,
soweit sie nicht nach dem Gesetz oder nach dieser Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

(2) Der Verwaltungsrat kann seinen Vorsitzenden bestimmen, der in den Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz hat.

Der Verwaltungsrat kann einen oder mehrere Stellvertreter bestimmen. In Abwesenheit des Vorsitzenden wird der
Vorsitz dem jeweils nach Lebensjahren ältesten Stellvertreter übertragen.

(3) Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein

Verwaltungsratsmitglied  kann  sich  durch  ein  anderes  Verwaltungsratsmitglied  vertreten  lassen,  das  dazu  durch  Brief,
Telegramm, Telekopie oder Fernschreiben bevollmächtigt wurde. In Dringlichkeitsfällen kann die Beschlussfassung auch
durch Brief, Telegramm, Telekopie oder Fernschreiben erfolgen.

(4) Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet der

Vorsitzende.

(5) Die Gesellschaft wird grundsätzlich durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens zwei Mitgliedern des Ver-

waltungsrates rechtsverbindlich verpflichtet.

(6) Der Verwaltungsrat kann auch einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern oder Dritten für die Gesamtheit oder einen

Teil der täglichen Geschäftsführung die Vertretung der Gesellschaft übertragen.

(7) Die Übertragung auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der Einwilligung der Generalversammlung.

Art. 9.
(1) Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates sind vom Vorsitzenden der jeweiligen Sitzung und einem zu Beginn

der Sitzung vom Vorsitzenden bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen. Vollmachten sind dem Protokoll anzuheften.

(2) Ein Mitglied des Verwaltungsrates und ein gemäß Artikel 8, Absatz 6 bestellter Dritter sind ermächtigt, gemeinsam

Kopien oder Auszüge solcher Sitzungsprotokolle zu unterzeichnen.

Art. 10. Die Kontrolle der Jahresabschlüsse der Gesellschaft ist einem unabhängigen externen Wirtschaftsprüfer zu

übertragen, welcher von der Generalversammlung bestellt wird.

Art. 11.
(1) Die jährliche Generalversammlung findet am 20. April um elf Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in

der Einladung angegebenen Ort statt. Fällt dieser Tag auf einen Tag, der nicht Bankarbeitstag ist, wird die Generalver-
sammlung am nächsten Bankarbeitstag abgehalten.

38713

(2)  Generalversammlungen  einschließlich  der  jährlichen  Generalversammlung  können  auch  im  Ausland  abgehalten

werden, wenn der Verwaltungsrat dies aus Gründen der höheren Gewalt beschließt; eine solche Entscheidung ist unan-
fechtbar.

Art. 12.
(1) Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Einberufung von Generalversammlungen kann abge-

sehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind.

(2) Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten ausüben, der nicht Aktionär zu sein

braucht. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 13. Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden.
Insbesondere sind der Generalversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:
(1) die Satzung zu ändern;
(2) Mitglieder des Verwaltungsrates und den unabhängigen externen Wirtschaftsprüfer zu bestellen und abzuberufen

und ihre Vergütungen festzusetzen;

(3) die Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates zu

erteilen;

(4) die Berichte des Verwaltungsrates und des unabhängigen externen Wirtschaftsprüfers entgegenzunehmen;
(5) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
(6) den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen;
(7) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
(8) die Gesellschaft aufzulösen;

Art. 14. Gemäß den in Artikel 72 des Gesetzes von 1915 enthaltenen Bestimmungen ist der Verwaltungsrat ermächtigt,

Interimdividenden an die Gesellschafter auszuzahlen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 16. Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und diejenigen des abgeänderten Gesetzes vom

5. April 1993 über den Finanzsektor.»

<i>Abschätzung der Kosten

Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft aufgrund dieser Satzungsänderung aufzukommen hat, beläuft sich auf

ungefähr eintausend Euro (1.000,- EUR).

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt und nach Vorlesung und Erklärung

alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Woh-
nort bekannten, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Hauer, C. Petit, R. Thill, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008. LAC/2008/7996. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008035280/5770/148.
(080037214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Famer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 118.765.

L'an deux mille huit, le vingt et un février,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FAMER S.A., avec siège social

à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 3 août 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1994 du 24 octobre 2006, modifiée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 11 août 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, numéro 1990 du 24 octobre 2006, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du
19 octobre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2327 du 13 décembre 2006,
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 août 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés

38714

et Associations C, numéro 2161 du 2 octobre 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
sous la section B et le numéro 118.765.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Micael Da Silva Carneiro, employé privée, demeurant à Esch-

sur-AIzette,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Laurence Tran, employée privée, demeurant à Mersch.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Houbert, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Suppression du nombre et de la valeur nominale des actions existantes.
2. Augmentation du capital social à concurrence de deux millions trois cent mille euros (EUR 2.300.000,-), pour le

porter de son montant actuel d'un million quatre-cent mille euros (EUR 1.400.000,-) à trois millions sept cent mille euros
(EUR 3.700.000,-), sans création d'actions nouvelles, par apport en espèces.

Souscription et libération des actions nouvelles.
3. Fixation du nombre des actions à trois mille sept cents (3.700), et de la valeur nominale des actions à mille euros

(EUR 1.000,-).

4. Modification subséquente du premier alinéa de l'article trois des statuts.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de supprimer le nombre et la valeur nominale des actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux millions trois cent mille euros (EUR

2.300.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un million quatre cent mille euros (EUR 1.400.000,-) à trois millions
sept cent mille euros (EUR 3.700.000,-), sans création d'actions nouvelles.

L'assemblée générale décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée l'actionnaire

majoritaire, à savoir AGIR I&amp;S LIMITED, société de droit britannique, ayant son siège social à GB-EC1N 8SS Londres,
20-23 Greville Street, l'actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.

Est ensuite intervenu AGIR I&amp;S LIMITED, prénommée,
ici représentée par Monsieur Patrick Houbert, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 11 février 2008,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite intervenante, représentée comme indiqué ci-avant, a déclaré souscrire l'augmentation de capital ci-avant déci-

dée.

L'augmentation de capital a été libérée par un versement en espèces, de sorte que la somme de deux millions trois

cent mille euros (EUR 2.300.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentaire.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de fixer le nombre d'actions à trois mille sept cent (3.700) actions et la valeur nominale

des actions à mille euros (EUR 1.000,-) par action.

<i>Quatrième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article trois

des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

38715

« Art. 3. (premier alinéa). Le capital social est fixé à un trois millions sept cent mille euros (EUR 3.700.000,-), divisé

en trois mille sept cents (3.700) actions de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombent à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en français suivi d'une traduction anglaise; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres

du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and eight, on twenty-first February,
Before Us Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of FAMER S.A., a joint stock company under Luxembourg

Law, having its registered office in L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve, incorporated by deed of the
undersigned notary on 3 August 2006, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 1994
of 24 October 2006, modified by deed of the undersigned notary on 11 August 2006, published in the «Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C», number 1990 of 24 October 2006, modified by deed of the undersigned notary on 19
October 2006, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 2327 of 13 December 2006,
modified by deed of the undersigned notary on 7 August 2007, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C», number 2161 of 2 October 2007, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City
under section B and number 118.765.

The meeting was opened with Mr. Micael Da Silva Carneiro, private employee, residing professionally in Esch-sur-

Alzette, in the chair,

who appointed as secretary Miss Laurence Tran, private employee, residing professionally in Mersch.
The meeting elected as scrutineer Mr. Patrick Houbert, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Suppression of the number and par value of the existing shares.
2. Increase of the share capital by two millions three hundred thousand euro (EUR 2,300,000.-) so as to raise it from

its current amount of one million four hundred thousand euro (EUR 1,400,000.-) to three million seven hundred thousand
euro (EUR 3,700,000.-), without creation of new shares, by contribution in cash.

3. Fixing of the number of shares at three thousand seven hundred (3,700) and of the par value of the shares at one

thousand euro (EUR 1,000.-) per share.

4. Subsequent amendment of the first paragraph of article three of the Articles of Incorporation.
5. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

Shall also remain attached to this deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed ne varietur

by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to suppress the number and the par value of the existing shares.

38716

<i>Second resolution

The  general  meeting  decides  to  increase  the  share  capital  by  two  million  three  hundred  thousand  euro  (EUR

2,300,000.-), in order to raise it from its current amount of one million four hundred thousand euro (EUR 1,400,000.-)
to three million seven hundred thousand euro (EUR 3,700,000.-), without creation of new shares.

The general meeting decides to admit to the subscription of the capital increase hereabove decided the majority

shareholder AGIR I&amp;S LIMITED, a company incorporated under the laws of the United Kingdom, having its registered
office in GB-EC1N 8SS London, 20-23 Greville Street, the minority shareholder having waived his preferential subscription
right.

Then intervened the majority shareholder AGIR I&amp;S LIMITED, previously named,
here represented by Mr. Patrick Houbert, previously named,
by virtue of a proxy under private seal given on 11 February 2008,
which proxy, initialled ne varietur, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the

registration authorities.

Said appearing party, represented as stated hereabove, declares to subscribe to the capital increase here above decided.
The increase of capital has been entirely paid up by contribution in cash, so that the amount of two million three

hundred thousand euro (EUR 2,300,000.-) is forthwith at the free disposal of the company, as has been proved to the
notary.

<i>Third resolution

The general meeting decides to fix the number of shares at three thousand seven hundred (3,700) and the par value

of the shares at one thousand euro (EUR 1,000.-) per share.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing, the general meeting decides to amend the first paragraph of article three of the

Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

«  Art.  3.  (first  paragraph).  The  corporate  capital  is  fixed  at  three  million  seven  hundred  thousand  euro  (EUR

3,700,000.-), divided into three thousand seven hundred (3,700) shares with a par value of one thousand euro (EUR
1,000.-) each, entirely paid up.»

<i>Expenses

The expenses to be borne by the Company as a result of the foregoing are estimated at fifteen thousand euro (EUR

15,000.-).

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the French and the English texts, the French text will be prevailing.

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and

residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary this original deed.

Signé: M. Da Silva Carneiro, L. Tran, P. Houbert, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, LAC/2008/8009. — Reçu 11.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2008.

E. Schlesser.

Référence de publication: 2008035141/227/165.
(080037427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Sidex International Limited, succursale Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2543 Luxembourg, 32, Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 80.051.

DISSOLUTION

Il résulte d'une dissolution de succursale du 1 

er

 février 2008 reçue par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de

résidence  à  Mondorf-les-Bains,  concernant  la  société  SIDEX  INTERNATIONAL  LIMITED,  SUCCURSALE  LUXEM-

38717

BOURG, avec siège social à L-2543 Luxembourg, 32, Dernier Sol, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 80.051, que:

1) SIDEX INTERNATIONAL LIMITED, avec siège à Hong Kong, 68, Connaught Road Central, déclare fermer pure-

ment et simplement la succursale.

2) Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.
Enregistré à Remich, le 12 février 2008, REM 2008/195. Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Molling.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 20 février 2008.

R. Arrensdorff
<i>Notaire

Référence de publication: 2008035443/218/21.
(080037266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Thornwood Capital, S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 124.664.

Pursuant to letters dated March 5, 2008, the following persons have resigned from their respective mandate as directors

of the Company which they held since February 16, 2007, with effect as of March 5, 2008:

- Mr. Franck Ruimy, residing professionally at 25, Knightsbridge, London SW1X 7RZ, United Kingdom; and
- Mr. Ely Michel Ruimy, residing professionally at 25, Knightsbridge, London SW1X 7RZ, United Kingdom.
As a consequence, since March 5, 2008, Mr. David Smith, residing at 17, Chester Square, London SW1W 9HS, United

Kingdom, is the sole director of the Company.

March 7, 2008.

By virtue of a power of attorney
G. t'Serstevens

En vertu de lettres datées du 5 mars 2008, les personnes suivantes ont démissionné de leurs fonctions en tant qu'ad-

ministrateurs de la Société qu'ils occupaient depuis le 16 février 2007, avec effet au 5 mars 2008:

- Monsieur Franck Ruimy, demeurant professionnellement au 25, Knightsbridge, Londres SW1X 7RZ, Royaume-Uni;

et

Monsieur Ely Michel Ruimy, demeurant professionnellement au 25, Knightsbridge, Londres SW1X 7RZ, Royaume-Uni.
Par conséquent, depuis le 5 mars 2008, Monsieur David Smith, demeurant au 17, Chester Square, Londres SW1W

9HS, Royaume-Uni, est l'administrateur unique de la Société.

7 mars 2008.

En vertu d'une procuration
G. t'Serstevens

Référence de publication: 2008035542/7091/29.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02621. - Reçu 91,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Emeraude Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 114.240.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société EMERAUDE PARTICIPATIONS SA

qui s'est tenue en date du 11 février 2008 que:

1. Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore avec

effet à ce jour.

2. La société MBC AUDITORS LIMITED, établie et ayant son siège social au 64 Baker Street, W1U 7GB London;

ANGLETERRE a été nommée en tant que nouveau Commissaire aux Comptes de la société avec effet à ce jour, jusqu'à

38718

l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011, en remplacement de la société UNITED CAPITAL CONTROL-
LERS démissionnaire.

3. Monsieur Filipe Capinha Heliodoro, avec adresse professionnelle au 6, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, a été

nommé Administrateur de la société avec effet à ce jour, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011,
en remplacement de Mademoiselle Cindy Reiners démissionnaire.

Luxembourg, le 11 février 2008.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2008035435/309/25.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO01750. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080037529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Boston Mere Property Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 100.225.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur François-Marc Lanners. Ce dernier
assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Luxembourg, le 30 mai 2007.

I. Schul / J.F. Detaille
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2008035557/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2008, réf. LSO-CO00866. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Etoile QIB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 132.005.

EXTRAIT

Il y'a lieu de lire:
Il résulte des Résolutions de l'Associé Unique prises en date du 15 novembre 2007 que:
- M. Emmanuel Limido, né le 5 janvier 1959, à Paris, (France), ayant comme adresse professionnelle le 203, rue du

Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris, a démissionné de son mandat de gérant avec effet immédiat;

- Mme Claudia Schweich, née le 1 

er

 août 1979, à Arlon, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue

du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommée gérant avec effet au 15 novembre 2007;

- M. Renaud Labye, né le 11 septembre 1977, à Liège, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue du

Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommé gérant avec effet au 15 novembre 2007.

Les nouveaux gérants ont été nommés pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, en février 2008.

<i>Pour ETOILE QIB S.à r.l
N. Akhertous
<i>Mandataire

Au lieu de:
Il résulte des Résolutions de l'Associé Unique prises en date du 15 novembre 2007 que:
- M. Emmanuel Limido, né le 5 janvier 1959, à Paris, (France), ayant comme adresse professionnelle le 203, rue du

Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris, a démissionné de son mandat de gérant avec effet immédiat;

38719

- Mme Claudia Schweich, née le 1 

er

 août 1977, à Arlon, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue

du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommée gérant avec effet au 15 novembre 2007;

- M. Renaud Labye, né le 11 septembre 1977, à Liège, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue du

Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommé gérant avec effet au 15 novembre 2007.

Les nouveaux gérants ont été nommés pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, en novembre 2007.

<i>POUR ETOILE QIB S.à r.l
N. Akhertous
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008035531/6654/39.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01552. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080036912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

REDK 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 121.465.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008035697/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2008, réf. LSO-CN06266. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080036863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

REDK 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 121.604.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008035698/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2008, réf. LSO-CN06267. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080036866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

REDK 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 121.605.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008035700/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2008, réf. LSO-CN06269. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080036870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

38720

FIRST LuxCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 123.325,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 123.453.

<i>Extrait des résolutions de l'associé du 7 janvier 2008

L'associé de FIRST LuxCo 2 S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Phillip Williams de sa fonction de gérant de la Société, avec effet au 7 janvier 2008;
- de nommer la personne suivante aux fonctions de gérant de la Société avec effet au 7 janvier 2008, et ce pour une

durée illimitée:

- Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg;

D. Beaucé.

Référence de publication: 2008035751/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01601. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080036893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Tevege Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 39.469.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>TEVEGE HOLDING S.A.
N. Thirion / F. Lanners
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008035894/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01427. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

IDR Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 50.781.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>IDR HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008035895/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01398. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

CI-ERRE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 61.674.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

38721

<i>CI-ERRE LUX S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008035899/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01406. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Zunis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 37.930.

Le bilan au 31 décembre 2006 et annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008035860/317/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01472. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080036840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Art Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 110, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 110.280.

Le bilan au 31 décembre 2006 et les documents y annexés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008035861/317/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01475. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080036844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Steyn Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 31.697.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A.
Signatures / Signatures

Référence de publication: 2008035884/695/13.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO01852. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Lucis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 78.834.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

38722

Mamer, le 25 février 2008.

VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

Référence de publication: 2008035885/695/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO01843. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Brim S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 29.694.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 12 février 2008.

<i>VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A
Signatures / Signatures

Référence de publication: 2008035891/695/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO01851. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Slawka S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 108.917.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

Référence de publication: 2008035886/695/13.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO01845. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Phicolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 113.698.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>PHICOLUX S.A.
F. Mangen / J.-H. Antoine
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008035904/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01413. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Renoir Holding SA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 82.373.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

38723

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RENOIR HOLDING SA
Th. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008035909/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO01894. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080037374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

Andreapolsky Refinery AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 136.871.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the eighth day of February
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

The public limited liability company NEW STREAM AG incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a

deed  of  the  undersigned  notary  dated  this  8th  of  February  2008,  with  registered  office  at  37,  rue  d'Anvers,  L-1130
Luxemburg, duly represented by two of its directors

- Mr Atanas Borissov Zafirov, director, residing in Spiegelhofstrasse 52, CH-8032 Zürich;
- Mr Dmitry Mazurov, director, residing in 119590 Moscow, Russia, Minskaya str. 1g-2-215.
Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a public limited liability company, which will be governed by the Luxembourg laws as well as the
present articles of association.

Title I. Name - Duration - Registered office - Purpose

Art. 1. Form - Name. There is hereby established a public limited liability company («société anonyme»), under the

name of ANDREAPOLSKY REFINERY AG (hereafter called the «Company»).

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place within Luxembourg City by a resolution of the board of directors. It may be

transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of the share-
holders.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
If extraordinary events of a political, economic or social nature, likely to impair the normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.

Art. 4. Purpose. The object of the Company is the taking of participating interests, in any form whatsoever, in other

companies either Luxembourg or foreign, as well as the ownership, management and development of such participating
interests.

The purpose of the Company is, in particular, the acquisition of any type of securities, whether negotiable or not,

stock, bonds, debentures, notes and other securities, including those issued by any Government or any other international,
national or local authority, and of any rights attached thereto, either by way of purchase, contribution, subscription, option
or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner.

Moreover, the Company may proceed to the acquisition and development of connected patents and licenses.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of convertible or non convertible bonds, and

debentures.

The Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a direct or indirect

participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company.

The Company may further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any form whatsoever in any enterprise or any private corporation as well as to the administration, manage-
ment, control and development of these participating interests.

38724

In general, the Company may carry out any commercial, industrial and financial operations, which it may deem useful

to enhance or to supplement its purpose.

Title II. Share capital - Shares

Art. 5. Subscribed share capital. The subscribed capital of the Company is set at one hundred thousand euro (€

100,000.-) represented by one hundred thousand (100,000) shares with a nominal value of one euro (€ 1.-) each, which
have been entirely paid up.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a usufruct holder («usu-
fruitier») and a bare owner («nu-propriétaire») or between a pledgor and a pledgee.

Title III. General meetings of shareholders

Art. 7. Powers. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body

of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the Company.

Art. 8. Place and date of the annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of the shareholders

shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg City as may
be specified in the notice of meeting on the twenty first day of June at 10.00 a.m. and for the first time in 2009.

If such day is a legal holiday in the Grand-Duchy of Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next

following business day.

Except as otherwise required by law or the articles of association, resolutions at a meeting of the shareholders duly

convened will be passed by a simple majority of those present or represented. Each share is entitled to one vote.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing another person as his proxy in writing.
If all the shareholders are present or represented at a meeting of the shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Any shareholder may participate in any meeting of the shareholders by conference call or by other similar means of

communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall be approved and signed by all the
directors present at such a meeting.

The articles of association may be validly amended if at least one-half of the capital is present or represented, by a

majority of shareholders representing at least two third (2/3) of the votes of the shareholders present or represented.
If the quorum is not satisfied at the first meeting, a second meeting may be convened. The second meeting shall validly
deliberate regardless of the proportion of the capital represented. The nationality of the Company may only be changed
and the commitments of the shareholders may only be increased with the unanimous consent of the shareholders.

Art. 9. Creditors, Legal Successors or Heirs. The creditors, legal successors or heirs are not allowed to seal assets or

documents of the Company.

Art. 10. Sole Shareholder. If the Company has only one shareholder, this sole shareholder exercises all the powers of

the general meeting.

The resolutions of the sole shareholder which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes.

Title IV. Board of directors

Art. 11. Number of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than 3

(three) members who need not be shareholders of the Company.

Notwithstanding the afore paragraph, if the Company has been incorporated by one shareholder of if a general meeting

of the shareholders acknowledges that the Company has only one shareholder left, the board of directors may be com-
posed of one member only until the ordinary general meeting of the shareholders following the acknowledgment of the
existence of more than one shareholder.

Art. 12. Appointment.  The  director(s)  are  appointed  by  the  general  meeting  of  the  shareholders,  or  by  the  sole

shareholder, as the case may be, which shall determine their number, fix the term of their office which may not be less
than 5 (five) years and not exceed 6 (six) years as well as their remuneration. The director(s) shall hold office until his
(their) successor(s) is (are) elected.

A director may only be removed for valid grounds inherent to its own person, by a resolution of the general meeting

of the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be.

38725

In the event of one or more vacancies at the board of directors by reason of death, retirement or otherwise, the

remaining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting
ratifies the election at its next meeting.

Art. 13. Chairman and Secretary. The board of directors chooses from among its members a chairman, and may choose

from among its members a vice-chairman.

In case of a board of directors composed of one member, such sole director shall be the chairman of the board.
The board of directors may also choose a secretary, who needs not be a director, who shall be responsible for keeping

the minutes of the meetings of the board of directors.

The chairman shall preside at all meetings of the board of directors. In his absence the board of directors may appoint

a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Art. 14. Convening and Holding of meetings. The board of directors shall meet upon call by the chairman, or 2 (two)

directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The directors will be convened separately to each meeting of the board of directors.
Except in cases of urgency, which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled

to attend, at least an eight days' written notice of the board meetings shall be given. If all the directors are present or
represented at a meeting of directors, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the
meeting may be held without prior notice or publication.

The notice may be waived by consent in writing of each director.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director in writing.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of

communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another.

A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a

participation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall however be approved and signed by all
the directors present at such a meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Resolutions shall be passed by a majority of votes of the directors present or
represented at such meeting.

Art. 15. Powers. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and

disposition in the Company's interests.

All powers not expressly reserved by law or by the articles of association to the general meeting of the shareholders

fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of the share-
holders, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be directors)
deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any person(s), who need(s) not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.

Art. 16. Representation. The Company is bound towards third parties in all circumstances by the joint signature of

any 2 (two) directors or by the single signature of the sole director or by the sole signature of any person(s) to whom
such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Title V. Supervision of the Company

Art. 17. Statutory auditor. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s)

(«commissaire aux comptes»), which may be shareholders or not. The general meeting of the shareholders shall appoint
the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six
years.

Title VI. Accounting year - Annual Accounts

Art. 18. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall

terminate on December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the incor-
poration of the Company and shall terminate on December 31st, 2008.

Art. 19. Annual Accounts. The annual accounts are drawn up by the board of directors as at the end of each accounting

year and will be at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

38726

Art. 20. Allocation of results. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the

reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of the shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the

annual net profits will be disposed of.

All shares will rank equally to dividend distributions.
In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-up amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Title VII. Winding up - Liquidation

Art. 21. Winding up / Liquidation. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one

or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of the shareholders
resolving such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Title VIII. Final clause - Applicable law

Art. 22. Applicable law. All matters not expressly governed by these articles of association shall be determined in

accordance  with  the  laws  of  the  Grand-Duchy  of  Luxembourg  and  in  particular  with  the  law  of  August  10,1915  on
commercial companies as amended.

<i>Subscription and Payment

The subscriber has subscribed and has paid in cash the amount as mentioned hereafter:

Shareholder

Subscribed

Paid-up

Number

capital (€) capital (€)

of shares

NEW STREAM AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000.- 100,000.-

100,000

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000.- 100,000.-

100,000

The one hundred thousand (100,000) shares of the Company have been fully paid-up by NEW STREAM AG, so that

the amount of one hundred thousand euro (€ 100,000.-) is as of now available to the Company, proof of which payment
having been given to the undersigned notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10,1915 on commercial companies as amended and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately € 2,700.-

<i>Extraordinary General Meeting of the shareholders

Then the sole shareholder, representing the entire share capital of the Company, represented as stated above, has

taken the following resolutions:

1. The number of directors is fixed at 3 (three) and the number of statutory auditors at 1 (one).
2. The following persons are appointed directors:
- Mr. Atanas Borissov Zafirov, businessman, born in Sofia (Bulgaria) on September 16, 1960, residing in CH-8032

Zurich, Spiegelhofstrasse 52;

- Mr. Dmitry Mazurov, businessman, born in Kazakhstan on January 25, 1976, residing in 119590 Moscow, Russia,

Minskaya str. 1g-2-215;

- Mr. Pierre Metzler, lawyer, born in Luxembourg on December 28, 1969, professionally residing in L-2320 Luxem-

bourg, 69, boulevard de la Petrusse.

3. OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., in short form OPTIO, with registered office 37, rue d'Anvers,

L-1130 Luxembourg, has been appointed statutory auditor.

4. The registered office of the Company is at L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor will end at the end of the annual general meeting of

the shareholders approving the annual accounts as at 2012.

6. The board of directors is authorised to delegate the daily management and affairs of the Company and the repre-

sentation of the Company for such management and affairs to any member or members of the board or to any committee
(the members of which need not be directors).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

38727

The document having been read to the said persons appearing, known to the undersigned notary by name, given name,

civil status and residence, the said appearing persons signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung:

Im Jahre zweitausendacht, den achten Februar,
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul Frieders, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts NEW STREAM AG mit Gesellschaftssitz in L-1130 Luxemburg, 37, rue

d'Anvers, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 8. Februar 2008, ordnungs-
gemäß vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsräte:

- Herrn Atanas Borissov Zafirov, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in CH-8032 Zürich, Spiegelhofstrasse 52,
- Herrn Dmitry Mazurov, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in Russland, 119590 Moskau, Minskaya str. 1g-2-215.
Die erschienene Partei, vertreten wie vorerwähnt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die Satzung einer von ihr

zu gründenden Aktiengesellschaft, welche dem luxemburgischen Recht, sowie der folgenden Satzung unterlegen ist, wie
folgt festzuhalten.

Titel I. Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck

Art. 1. Gesellschaftsform - Firma. Hiermit wird eine Aktiengesellschaft («société anonyme») unter der Bezeichnung

ANDREAPOLSKY REFINERY AG (hiernach die «Gesellschaft» genannt) gegründet.

Art. 2. Gesellschaftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.

Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg begründet. Er kann durch Beschluss des

Verwaltungsrats an jeden beliebigen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden. Er kann durch Beschluss der
Hauptversammlung der Aktionäre an jeden beliebigen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Durch Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen oder andere Büros sowohl in Luxemburg als auch im

Ausland gegründet werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art, welche die normale Tätigkeit am

Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Sitz und ausländischen Staaten beeinträchtigen
könnten,  auftreten  oder  sollten  diese  bevorstehen,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  vorübergehend  ins  Ausland  verlegt
werden. Die einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, die, unge-
achtet der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 4. Gesellschaftszweck. Gesellschaftszweck ist der Erwerb von Beteiligungen in welcher Form auch immer an

anderen Gesellschaften, seien sie luxemburgische oder ausländische Gesellschaften, sowie das Eigentum, die Verwaltung
und die Verwertung von solchen Beteiligungen.

Der Gesellschaftszweck ist, insbesondere, der Erwerb jeder Art von Wertpapieren, seien sie übertragbar oder nicht,

Aktien, Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldscheine und andere Papiere, einschließlich derer, die durch eine Regie-
rung oder eine andere internationale, nationale oder örtliche Behörde herausgegeben werden, und aller dazu gehörigen
Rechte, sei es durch Kauf, Einlage, Zeichnung, Kaufoption oder in jeder anderen Weise, als auch die Übertragung mittels
Verkauf, Tausch oder in jeder anderen Weise.

Zudem kann die Gesellschaft verbundene Patentrechte und Lizenzrechte erwerben und verwerten.
Die Gesellschaft kann in jedweder Form leihen und wandelbare sowie unwandelbare Anleihen und Schuldverschrei-

bungen ausgeben. Die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder Gesell-
schaften,  die  derselben  Gesellschaftsgruppe  wie  die  Gesellschaft  angehören,  jede  Art  von  Unterstützung,  Darlehen,
Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann ferner alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die direkt oder indirekt den Erwerb von Beteiligungen,

in jedweder Form an jedem Unternehmen oder jeder Personengesellschaft als auch die Verwaltung, Kontrolle, und Ver-
wertung dieser Beteiligungen betreffen.

Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännische, industrielle oder finanzielle Geschäftsvorgänge durchführen, die den

Gesellschaftszweck zu fördern oder zu unterstützen geeignet sind.

Titel II. Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Gezeichnetes Aktienkapital. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einhunderttausend Euro

(100.000,- €), eingeteilt in einhunderttausend (100.000) Aktien zum Nennwert von je einem Euro (1,- €), voll eingezahlt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 6. Aktien. Die Aktien der Gesellschaft werden die Form von Inhaberaktien haben. Die Gesellschaft wird nur einen

einzigen Eigentümer pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie im Besitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft
das Recht die Ausübung aller Rechte der betreffenden Aktie aufzuheben, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer in
den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde. Die gleiche Bestimmung ist anzuwenden im Falle eines Wider-

38728

streites  zwischen  einem  Nießbraucher  (usufruitier)  und  dem  bloßen  Eigentümer  (nu-propriétaire)  oder  zwischen
Pfandschuldner und Pfandgläubiger.

Titel III. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 7. Befugnisse. Jede ordnungsgemäß zusammengesetzte Aktionärsversammlung wird die Gesamtheit der Aktionäre

der Gesellschaft vertreten. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der
Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu ratifizieren.

Art. 8. Ort und Datum der jährlichen Hauptversammlung. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet in

Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort in Luxemburg-Stadt
am einundzwanzigsten Tag im Monat Juni um 10.00 Uhr, und zum ersten Mal im Jahre 2009 statt.

Sofern dieser Tag ein Feiertag im Großherzogtum Luxemburg ist, findet die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre

am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Sofern das Gesetz oder die Satzung nichts Gegenteiliges vorsehen, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einbe-

rufenen Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Dabei gewährt jede Aktie eine Stimme.

Ein Aktionär kann auf jeder Hauptversammlung der Aktionäre durch eine andere Person mittels schriftlicher Vollmacht

handeln.

Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass

sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung der Aktionäre ohne vorherige Einberufung
oder Bekanntmachung abgehalten werden.

Jeder  Aktionär  kann  auf  jeder  Sitzung  der  Aktionärsversammlung  durch  Konferenzschaltung  oder  durch  ähnliche

Kommunikationsmittel teilnehmen, welche alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, befähigen sich gegenseitig zu
hören und miteinander zu kommunizieren. Eine Sitzung kann ebenfalls allein durch Konferenzschaltung abgehalten werden.
Diese Art der Teilnahme an einer Sitzung ist gleichbedeutend mit der persönlichen Teilnahme an solch einer Sitzung. Die
Protokolle solcher Verwaltungsratssitzungen sind von allen auf der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern zu
genehmigen und zu unterschreiben.

Die Satzung kann wirksam abgeändert werden, sofern mindestens die Hälfte des Kapitals anwesend oder vertreten

ist, durch eine Mehrheit von mindestens zweidrittel (2/3) der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre.
Sollte das Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht werden, kann zu einer zweiten Versammlung geladen
werden. Die zweite Versammlung ist beschlussfähig ungeachtet der Kapitalvertretung. Die Änderung der Staatsangehö-
rigkeit  der  Gesellschaft  und  die  Erhöhung  der  Verpflichtungen  der  Aktionäre  können  nur  durch  die  einstimmige
Zustimmung aller Aktionäre herbeigeführt werden.

Art. 9. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben. Den Gläubigern, Rechtsnachfolgern oder Erben ist es nicht gestattet

Vermögensgegenstände oder Dokumente der Gesellschaft mit einem Siegel zu versehen.

Art. 10. Alleiniger Aktionär. Hat die Gesellschaft nur einen Aktionären, besitzt dieser alleinige Aktionär alle Befugnisse

der Hauptversammlung der Aktionäre.

Die im Rahmen des vorhergehenden Absatzes gefassten Beschlüsse des alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll

festgehalten.

Titel IV. Verwaltungsrat

Art. 11. Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus

mindestens 3 (drei) Mitgliedern, welche nicht Aktionäre sein müssen, besteht.

Wurde die Gesellschaft von einem einzigen Aktionären gegründet oder wurde in einer Hauptversammlung der Akti-

onäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur noch einen Aktionären besitzt, so kann die Zusammensetzung des Verwal-
tungsrates, bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre die der Feststellung der Anwesenheit von mehr als
einem Aktionär folgt, auf ein Mitglied beschränkt werden.

Art. 12. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder.  Die  (Das)  Verwaltungsratsmitglied(er)  werden  (wird)  von  der

Hauptversammlung der Aktionäre oder, je nach dem, von dem alleinigen Aktionär ernannt, die (der) ihre Anzahl bestimmt
und sowohl die Dauer des Mandats, welche nicht weniger als 5 (fünf), jedoch 6 (sechs) Jahre nicht überschreiten darf, als
auch ihre Vergütung festsetzt. Sie(Es) werden (wird) das Mandat so lange innehaben, bis ihre (sein) Nachfolger gewählt
sind(ist).

Ein Verwaltungsratsmitglied kann nur für gültige, auf seine Person bezogene Gründe, durch Beschluss der Hauptver-

sammlung der Aktionäre oder des alleinigen Aktionärs seines Mandates enthoben werden.

Im Falle eines oder mehrerer freien/freier Sitze(s) im Verwaltungsrat aufgrund eines Todesfalles, Rücktritts oder aus

sonstigem Grund, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des
Gesetzes einen solchen freien Sitz besetzen. In einem solchen Falle stimmt die Hauptversammlung der Aktionäre über
die Ernennung auf ihrer nächsten Sitzung ab.

38729

Art. 13. Verwaltungsratsvorsitzender und Sekretär. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und

einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen.

Im Falle eines Verwaltungsrats bestehend aus einem Mitglied wird dieses alleinige Mitglied der Vorsitzende des Ver-

waltungsrats sein.

Der  Verwaltungsrat  kann  ebenfalls  einen  Sekretär  wählen,  der  nicht  Verwaltungsratsmitglied  sein  muss  und  dafür

verantwortlich ist, die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen zu führen.

Der Vorsitzende hat auf allen Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz inne. In seiner Abwesenheit kann der Verwal-

tungsrat einen pro tempore Vorsitzenden durch Mehrheitswahl der auf einer solchen Sitzung Anwesenden einsetzen.

Art. 14. Einberufung und Abhalten der Versammlungen. Der Verwaltungsrat kommt auf Einberufung durch den Vor-

sitzenden  oder  durch  zwei  Verwaltungsratsmitglieder  an  dem,  in  der  Einberufung  festgesetzten,  Ort  zusammen.  Die
Verwaltungsratsmitglieder werden einzeln zu jeder Verwaltungsratssitzung geladen.

Außer im Dringlichkeitsfalle, welcher in der Einberufung angegeben sein muss oder mit vorhergehender Zustimmung

all derer, die berechtigt sind zugegen zu sein, hat die schriftliche Einberufung zur Verwaltungsratssitzung mindestens
innerhalb von acht Tagen zu erfolgen. Falls alle Verwaltungsratsmitglieder an der Verwaltungsratssitzung anwesend oder
vertreten sind und falls sie erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Verwaltungsratssitzung
ohne vorherige Einberufung oder Bekanntmachung abgehalten werden.

Auf die Einberufung kann durch schriftliche Zustimmung jedes Verwaltungsratsmitgliedes verzichtet werden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf jeder Sitzung des Verwaltungsrates durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied

mittels schriftlicher Vollmacht handeln.

Jedes  Verwaltungsratsmitglied  kann  auf  jeder  Sitzung  des  Verwaltungsrates  durch  Konferenzschaltung  oder  durch

ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, befähigen sich gegen-
seitig zu hören und miteinander zu kommunizieren.

Eine Sitzung kann ebenfalls allein durch Konferenzschaltung abgehalten werden. Diese Art der Teilnahme an einer

Sitzung ist gleichbedeutend mit der persönlichen Teilnahme an solch einer Sitzung. Die Protokolle solcher Verwaltungs-
ratssitzungen sind von allen auf der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern zu genehmigen und zu unterschrei-
ben.

Der Verwaltungsrat kann, einstimmig, Beschlüsse auf einem oder mehreren gleichen Dokumenten durch Rundschrei-

ben fassen, sofern dem schriftlich zugestimmt wurde. Die Gesamtheit der Dokumente bildet das Beschluss beweisende
Protokoll.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf der Ver-

waltungsratssitzung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden mit Mehrheit der Stimmen der Verwaltungsrats-
mitglieder gefasst, die auf solch einer Sitzung anwesend oder vertreten sind.

Art. 15. Befugnisse. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Ver-waltungs- und Verfügungs-

handlungen im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz
oder durch die Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwal-
tungsrates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesell-

schaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem voraus-
gehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Aktionäre, an ein oder mehrere Mitglied(er) des Verwaltungsrates
oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingend Verwaltungsratsmitglieder sein müssen) übertragen, welche unter
den Bedingungen und Befugnissen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beraten. Er kann außerdem jegliche Be-
fugnisse und Sondervollmachten an jede Person oder Personen, welche nicht zwingend Verwaltungsratsmitglied(er) sein
muss (müssen), übertragen, Funktionsträger und Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

Art. 16. Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Umständen

durch die gemeinsame Unterschrift von 2 (zwei) Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des allei-
nigen Verwaltungsratsmitglieds oder der Person oder Personen, welcher (n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungs-
rat übertragen wird, verpflichtet.

Titel V. Überwachung der Gesellschaft

Art. 17. Aufsichtskommissar. Die Überwachung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Auf-

sichtskommissar(en) («commissaire aux comptes»), die Aktionäre sein können oder nicht. Die Hauptversammlung der
Aktionäre ernennt die Aufsichtskommissare und legt ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates fest, welches
sechs Jahre nicht überschreiten kann.

Titel VI. Geschäftsjahr - Jahresabschlüsse

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31.

Dezember, mit der Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Gründungstag der Gesellschaft beginnt und am
31. Dezember 2008 endet.

38730

Art. 19. Jahresabschluss. Die Jahresabschlüsse werden jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, vom Verwaltungsrat

erstellt und stehen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.

Art. 20. Reingewinnverteilung. Vom jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) für die Bildung

der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese Verwendungsverpflichtung erlischt, wenn und soweit die gesetzliche Rücklage
zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesellschaftskapitals, oder des von Zeit zu Zeit in Übereinstimmung mit Artikel 5
erhöhten oder herabgesetzten gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Auf Empfehlung des Verwaltungsrates bestimmt die Hauptversammlung der Aktionäre über die Verfügung des jährli-

chen Reingewinns.

Alle Aktien nehmen hinsichtlich der Dividendenausschüttung den gleichen Rang ein.
Im Falle von teilweise einbezahlten Aktien werden die Dividenden anteilig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.
Vorschüsse auf Dividenden können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden.

Titel VII. Auflösung - Liquidation

Art. 21. Auflösung - Liquidation. In Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere

Liquidatoren (welche natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung
der Aktionäre ernannt werden, welche über diese Auflösung entscheiden und die Befugnisse und Vergütungen des Li-
quidators /der Liquidatoren festlegen wird.

Titel VIII. Schlussbestimmung - Anwendbares Recht

Art. 22. Anwendbares Recht. Alle Punkte, die nicht ausdrücklich durch die vorliegende Satzung geregelt sind, werden

in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburgs, insbesondere durch das Gesetz vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert, bestimmt.

Zeichnung und Zahlung Die Zeichnerin hat wie folgt gezeichnet und den folgenden Betrag bar eingezahlt:

Aktionär

Gezeichnetes Eingezahltes

Anzahl der

Kapital (€)

Kapital (€)

Aktien

NEW STREAM AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000,-

100.000,-

100.000

Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000,-

100.000,-

100.000

Die einhunderttausend (100.000) Aktien der Gesellschaft wurden durch NEW STREAM AG vollständig eingezahlt, so

dass der Betrag von einhunderttausend Euro (100.000,- €) ab sofort zur Verfügung der Gesellschaft steht; der Nachweis
dieser Zahlungen ist dem unterzeichneten Notar erbracht worden.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 26 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsge-

sellschaften wie abgeändert vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt
worden sind.

<i>Kosten

Die aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch

immer, werden durch die Gesellschaft getragen und werden auf ungefähr 2.700,- € geschätzt.

<i>Außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre

Alsdann hat der alleinige Aktionär, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, vertreten wie vorerwähnt,

folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3 (drei) und die Zahl der Aufsichtskommissare auf 1 (eins)

festgesetzt.

2. Die folgenden Personen werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
- Herr Atanas Borissov Zafirov, Geschäftsmann, geboren in Sofia (Bulgarien) am 16. September 1960, wohnhaft in

CH-8032 Zürich, Spiegelhofstrasse 52;

- Herr Dmitry Mazurov, Geschäftsmann, geboren in Kazachstan am 25. Januar 1976, wohnhaft in 119590 Moskau,

Russland, Minskaya str. 1g-2-215;

- Herr Pierre Metzler, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg am 28. Dezember 1969, beruflich wohnhaft in L-2320

Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse;

3. OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., abgekürzt OPTIO, mit Gesellschaftssitz 37, rue d'Anvers, L-1130

Luxemburg, wurde zum Aufsichtskommissar ernannt.

4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1130 Luxemburg, 37, rue d'Anvers.
5. Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissars erlischt am Ende der jährlichen Haupt-

versammlung der Aktionäre, welche den Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2012 genehmigt.

6. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesellschaft sowie die

Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten an ein oder mehrere Mitglied(er)

38731

des Verwaltungsrates oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingend Verwaltungsratsmitglieder sein müssen) zu
übertragen.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der oben-

genannten  erschienenen  Personen,  die  vorliegende  Urkunde  in  englischer  Sprache  verfasst  wurde,  gefolgt  von  einer
deutschen Übersetzung. Gemäß dem Wunsch der erschienenen Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem
englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie am Anfang des Dokuments erwähnt.
Nach Verlesung der Urkunde an die erschienenen Personen, dem unterzeichneten Notar nach Namen, Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: A.B. Zafirov, D. Mazurov, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, Relation: LAC / 2008 / 6522. — Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Sandt.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 28. Februar 2008.

P. Frieders.

Référence de publication: 2008035980/212/444.
(080038502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Van Lanschot Trust Company (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 35.270.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 décembre 2006, acte n° 700 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2008036205/208/13.
(080038072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

M&amp;G Packaging s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 86.908.

Statuts coordonnés en date du 27 décembre 2007, suite à un acte n° 968, déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2008036206/208/12.
(080038080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Ingenia Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 136.587.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2008.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2008036201/242/12.
(080037996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

38732

IH International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 103.797.

In the year two thousand and eight, the fifth of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of IH INTERNATIONAL S.A. (the Company) a société

anonyme, having its registered office at 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under section B, number 103.797, incorporated following a deed of Maître Joseph Elvinger
of October 22, 2004, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 29, page 1364 on January
12, 2005. The Company's articles of association (the «Articles of Association») have last been amended by a deed of
Maître Joseph Elvinger of May 31, 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1716,
page 82.367.

The meeting is presided by Mr Regis Galiotto, jurist, with professional address at 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Flora Gibert, jurist, residing at 15, côte

d'Eich, L-1450 Luxembourg.

The chairman requested the notary to act:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 9,000 (nine thousand) shares, representing the whole capital of the Com-

pany, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Change of the Company's financial year closing date, from December 31st to the last day of the month of February.
2.- Appointment of Christopher Masek and Dan Soudry as Class A Directors of the Company.
3.- Subsequent amendment of Article 17 of the Articles of Association.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to change the Company's financial year closing date, from December 31st to the last day of

February.

<i>Second resolution

The meeting acknowledge the appointment of Mr Christopher Masek, residing at Brettenham House 5, Lancaster

Place, London WC2E 7EN (United Kingdom)born at Boston (USA) on the 22th March 1964 and Mr Dan Soudry, residing
at F-75008 Paris, 6, rue Christophe Colomb, born at Rabat (Morocco) on the 10th August 1970 as new Class A directors
of the Company who, having received previous notice of their possible designation, have accepted by written in a letter
of acceptance, their position and assumed the obligation to faithfully and properly to carry out their duties.

Consequently the board of directors of the Company is composed as follows:
- James Yates, Class A Director, residing at Brettenham House 5, Lancaster Place, London WC2E 7EN (United King-

dom)

- Andrew Townend, Class A Director, residing at Brettenham House 5, Lancaster Place, London WC2E 7EN (United

Kingdom)

- Xavier Pauwels, Class A Director, residing at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg
- Philippe Leclercq, Class A Director, residing at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg
- Christopher Masek, Class A Director, residing at Brettenham House 5, Lancaster Place, London WC2E 7EN (United

Kingdom)

- Dan Soudry, Class A Director, residing at F-75008 Paris, 6, rue Christophe Colomb

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend Article 17 of the Articles of Association,

to read as follows:

« Art. 17. The accounting year of the company shall begin on the first of March of each year and shall terminate on

the last day of February of the following year.»

<i>Transitory disposition

The financial year that began on January 1st, 2007 will end on February 29th, 2008.
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

38733

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la version en langue française:

L'an deux mille huit, le cinq février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IH INTERNATIONAL S.A., ayant

son siège social au 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés à
Luxembourg sous le numéro B 103.797, constituée suivant un acte du 22 octobre 2004, publié le 12 janvier 2004 au
mémorial C numéro 29, page 1364. Cet acte a été modifié pour la dernière fois le 31 mai 2007 suivant un acte du notaire
Joseph Elvinger, publié au Mémorial C numéro 1.716, page 82.367.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Régis Galiotto, juriste, avec adresse professionnelle au 15, côte d'Eich,

L-1450 Luxembourg.

Le  président  désigne  comme  secrétaire  et  l'assemblée  choisit  comme  scrutateur  Mme  Flora  Gibert,  juriste,  avec

adresse professionnelle au 15, côte d'Eisch, L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 9,000 (neuf mille) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la date de clôture de l'exercice social de la Société du 31 décembre au dernier jour du mois de

février.

2.- Nomination de M. Christopher Masek et de M. Dan Soudry au poste de directeur de Classe A de la Société.
3.- Modification subséquente de l'Article 17 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de clôture de l'exercice social de la Société du 31 décembre au dernier jour du

mois de février.

<i>Seconde résolution

L'assemblée acquiesce aux nominations de M. Christopher Masek résidant à Brettenham House 5, Lancaster Place,

Londres, WC2E 7EN (Royaume-Uni) né à Boston (USA) le 22 mars 1964 et de M. Dan Soudry avec résidant à F-75008
Paris, 6, rue Christophe Colomb, né à Rabat (Maroc) le 10 août 1970 en tant que nouveaux directeurs de Classe A de la
Société; ayant été informés de leur possible nomination, ils ont accepté par écrit leur nomination aux termes d'une lettre
d'acceptation, et ont déclaré accepter de mener à bien leur mission.

Par conséquent le conseil d'administration de la Société est composé comme suit:
- M. James Yates, Directeur de Classe A, résidant au Brettenham House 5, Lancaster Place, Londres, WC2E 7EN

(Royaume-Uni)

- M. Andrew Townend, Directeur de Classe A, résidant au Brettenham House 5, Lancaster Place, Londres, WC2E

7EN (Royaume-Uni);

- M. Xavier Pauwels, Directeur de Classe A, résidant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg;
- M. Philippe Leclercq, Directeur de Classe A, résidant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg;
- M. Christopher Masek, Directeur de Classe A, résidant au Brettenham House 5, Lancaster Place, Londres, WC2E

7EN (Royaume-Uni);

- M. Dan Soudry, Directeur de Classe A, résidant au 6, rue Christophe Colomb, F-75008 Paris;

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l' Article

17 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 17. L'exercice social commence le premier mars de l'année et se termine le dernier jour du mois de février de

l'année suivante».

38734

<i>Disposition transitoire

L'exercice social commencé le 1 

er

 janvier 2007 se terminera le 29 février 2008.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Galiotto, F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008. Relation LAC/2008/5725. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008036139/211/125.
(080038182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Luxhosting Networks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8034 Strassen, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 99.322.

L'an deux mille huit, le vingt-huit février;
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

Madame Emanuela Marchione, employée privée, née à Luxembourg, le 7 juin 1971, demeurant à L-5414 Canach, 25,

rue de la Fontaine;

Laquelle comparante déclare qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée LUXHOSTING

NETWORKS Sàrl (No. Matricule 20042402657), avec siège social à L-5414 Canach, 25, rue de la Fontaine;

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 99.322;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 février 2004, publié au Mémorial C de 2004,

page 19.487;

Laquelle comparante s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Canach à L-8034 Strassen, 7, rue Michel

Rodange.

<i>Deuxième et dernière résolution

Suite au prédit transfert de siège, l'article 1 

er

 , premier alinéa des statuts est à lire comme suit:

«  Art. 1 

er

 . premier alinéa.  Le siège de la société est établi à Strassen.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de l'assemblée générale extraordi-

naire, s'élève approximativement à la somme de six cent vingt euro (620,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes;
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue de nous notaire par son nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Marchione, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette, le 5 mars 2008, Relation: EAC/2008/3179. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Bettembourg, le 6 mars 2008.

C. Doerner.

Référence de publication: 2008036138/209/37.
(080038124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

38735

WestBox S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,

(anc. C156 S.à r.l.).

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 106.008.

L'an deux mille huit, le cinq février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société à responsabilité limitée InterConseils, ayant son siège social à L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre

Dupong, R.C.S. Luxembourg B 60.879,

ici représentée par son gérant Monsieur Carlo Arend, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, pouvant

engager celle-ci par sa seule signature.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que suite à une cession de parts datée du 28 janvier 2008, dûment acceptée par la société, en conformité avec l'article

190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, InterConseils précitée, est la seule et unique associée
de la société C156 S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant,
en date du 27 janvier 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 330 du 14 avril 2005. Les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant en date du 28 juin 2007, publié au Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1974 du 13 septembre 2007.

Ladite cession de parts, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide de modifier la dénomination de la société en WestBox S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L'associée unique décide modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de WestBox S.à r.l.»

<i>Troisième résolution

L'associée unique décide de transférer le siège social de la société de L-1255 Luxembourg, 52, rue de Bragance à L-1430

Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

<i>Quatrième résolution

L'associée unique constate le changement de dénomination ainsi que le transfert de siège social du gérant:
InterConseils société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong,

R.C.S. Luxembourg B 60.879.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à environ neuf cents euros (900,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Arend, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2008, LAC/2008/5481. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008036122/220/48.
(080038372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

38736


Document Outline

ALESRAA Luxembourg S.à r.l.

Andreapolsky Refinery AG

Art Consult S.A.

attrax S.A.

Biotelgy VC S.A.

Blue Finance S.A.

Boston Mere Property Holdings S.A.

Brim S.A.

Broad Street Lux S.à r.l.

C156 S.à r.l.

Centuria Monaco S.à r.l.

Centuria Vauban S.à r.l.

CI-ERRE LUX S.A.

Emeraude Participations S.A.

Espace Concept S.A.

Etoile QIB S.à r.l.

Euxin S.A.

Event &amp; Com S.A.

Famer S.A.

FIRST LuxCo 2 S.à r.l.

Hanse Holdings S.à r.l.

IDR Holding S.A.

IH International S.A.

Ingenia Lux Sicav

LaSalle UK Ventures Property 9

Lucis S.A.

Luxding Holding S.A.

Luxhosting Networks S.à r.l.

Menuiserie Dirk Berens S.à r.l.

M&amp;G Packaging s.àr.l.

MZ Holdings S.à r.l.

Phicolux S.A.

Realm Enterprises S.à.r.l.

REDK 1 S.à r.l.

REDK 2 S.à r.l.

REDK 3 S.à r.l.

Renoir Holding SA

Robien S.A.

RREEF

Sidex International Limited, succursale Luxembourg

Slawka S.A.

Sobel Luxembourg S.à r.l.

Steyn Holding S.A.

Tevege Holding S.A.

Thornwood Capital, S.A.

Tootal Silk S.A.

Van Lanschot Trust Company (Luxembourg) S.A.

Verdon Finances S.A.

WestBox S.à r.l.

Zunis S.A.