This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 599
11 mars 2008
SOMMAIRE
AFS Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
28725
Aximo II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28727
Aximo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28726
Bellissimmo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28734
Berin Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28741
B.G.D.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28728
Bios S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28752
Cap Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28734
Cogeco Cable GP S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . .
28725
CONEXIA SA, Courtiers en assurances
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28752
CONEXIA SA, Courtiers en assurances
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28749
CONEXIA SA, Courtiers en assurances
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28751
Ed. Meyers & Cie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
28748
Euroluxconstruction S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
28752
Euroluxconstruction S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
28750
General Shale Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . .
28750
Genpact Investment Co. (Lux) SICAR S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28730
Gravolux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28749
HeidelbergCement Holding S.à r.l. . . . . . .
28710
HeidelbergCement Holding S.à r.l. . . . . . .
28706
HeidelbergCement Holding S.à r.l. . . . . . .
28716
HeidelbergCement Holding S.à r.l. . . . . . .
28719
HeidelbergCement Holding S.à r.l. . . . . . .
28722
Jupiter S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28734
LSFAP Euro-Asian Holdings S.àr.l. . . . . . . .
28730
LSFAP Euro-Asian Holdings S.àr.l. . . . . . . .
28749
LVSC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28729
Mag Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28729
Maxtorgraben S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28735
Servico S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28750
Solidus Private Equity S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
28742
T.C.F. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28749
Turnham Green S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . .
28706
Volux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28752
Zerno S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28750
28705
HeidelbergCement Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Turnham Green S. à r. l.).
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 131.709.
In the year two thousand and seven, on the thirty-first day of August,
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx,
notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.
There appeared:
For an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of TURNHAM GREEN S.à r.l., a Luxem-
bourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register, incor-
porated pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, dated August 17, 2007 (the
Company),
HeidelbergCement AG, a German stock corporation company incorporated under the laws of Germany, having its
registered office at Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, (Germany), registered with the lower district court in Mannheim
under the number HRB 330082 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Dr Ingo Schaffernak, general counsel, with professional address in Berliner Strasse 6, 69120
Heidelberg, Germany, acting under a proxy given on August 30, 2007,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company into HeidelbergCement HOLDING S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to change article 1 of the articles of
association of the Company (the Articles) which shall henceforth read as follows:
« Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under
the name HeidelbergCement HOLDING S.à r.l. («the Company») governed by the present Articles of incorporation and
by current Luxembourg Laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and
the law of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».»
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to replace the existing one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares
of the Company having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares
having a nominal value of ten euro (EUR 10.-) each.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eighty-seven thousand
five hundred euro (EUR 87,500.-) and to issue eight thousand seven hundred and fifty (8,750) new shares having a par
value of ten euro (EUR 10.-) each so as to bring the share capital of the Company from its current amount of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to an amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-).
<i>Subscription - paymenti>
The Sole Shareholder declares to subscribe for three thousand one hundred seventy-six (3,176) new shares and to
fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to thirty-one thousand seven hundred sixty euro (EUR
31,760.-).
The Sole Shareholder waives, to the extent necessary, its preferential subscription rights in respect of the following
subscription:
HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, a German limited liability company, incorporated under
the laws of Germany, having its registered office at Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Germany, registered with the
lower district court in Mannheim under the number HRB 334775,
hereby represented by Dr. Ingo Schaffernak, prenamed, by virtue of a proxy under private seal given on August 30,
2007,
28706
the said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities,
declares to subscribe for five thousand five hundred seventy-four (5,574) new shares and to fully pay them up by way
of a contribution in cash of an amount of fifty-five thousand seven hundred forty euro (EUR 55,740.-).
The amount of eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 87,500.-) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it.
(HeidelbergCement AG and HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH are hereinafter collectively
referred to as the Shareholders.)
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the first paragraph of article 5 of the Articles which shall henceforth read as follows:
«The capital of the Company is set at EUR 100,000.- (one hundred thousand euro) represented by ten thousand
(10,000) shares, with a nominal value of EUR 10 (ten euro) each.»
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the second paragraph of article 9 of the Articles as follows:
«The board of managers shall meet when convened by one manager and must hold at least two meetings per year in
the Grand Duchy of Luxembourg.»
<i>Seventh resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 11 of the Articles by inserting the following paragraph at the end of article
11:
«Without prejudice to the foregoing, the following matters shall require the prior approval of the general meeting of
shareholders:
a) Adoption of the investment and finance plan that is to be prepared on time every year;
b) Purchase, sale or mortgaging of property as well as other transactions relating to property;
c) Purchase of businesses or interests in such businesses or sale or mortgaging thereof;
d) Establishment, expansion and closing down of branches and permanent establishments or points of sale;
e) Conclusion and amendment of any kind of intercompany agreements and agreements on acquisition or surrender
of operations;
f) Conclusion, amendment and termination of agreements concerning regular payments, in particular contracts on
rights of use in connection with property as well as rent and lease agreements when such rent or lease amounts to more
than Euro 10,000.- a month or the term is more than one year; Conclusion, amendment and termination of any agreements
with suppliers or customers when the term is more than one year;
g) Investments of more than Euro 20,000.- in each case and a total of Euro 50,000.- per financial year, if such investments
are not included in the annual investment plan adopted;
h) Granting and raising of loans. Conclusion and implementation of any kind of derivatives transactions, forward trans-
actions or differential transactions as well as hedge agreements, in particular purchase and sale of goods, currency and
interest rate transactions. Conclusion and implementation of any kind of options which financially may be compared to
the above-mentioned types of business or may imply similar risks;
i) Provision of guarantee and conclusion of contracts comparable to guarantees, guarantee agreements, co-guarantees
for debt, submission of letters of intent and similar commitments;
j) Institution of legal proceedings and actions and statements concluding legal proceedings when the claim in question
exceeds Euro 50,000.00;
k) Conclusion, amendment and termination of contracts with shareholders/partners in the Company or their relations
or with companies in which the majority is dominated by shareholders/partners in the Company and/or their relations;
I) Admission of silent shareholders/partners;
m) Sale and leasing of the total company assets;
n) Joining or termination of memberships;
o) Admission of new business areas;
p) All structural changes in the Company;
q) Granting and revocation of powers of procuration and powers of attorney;
r) Granting of bonus and similar remunerations;
s) Cost-free transactions or actions to the disadvantage of the Company,
t) Acquisition or leasing of motor vehicles;
u) Other business transactions not included in the Company's ordinary operations.»
28707
<i>Eighth resolutioni>
The Shareholders acknowledge the resignation of MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. as manager of the company with
immediate effect and therefore resolve to appoint two new managers and to designate them as follows:
Dr. Ingo Schaffernak, general counsel, born on April 27, 1963 in Graz (Austria) with professional address at Berliner
Strasse 6, 69120 Heidelberg (Germany) as class A manager of the Company with immediate effect and for an unlimited
period; and
Mrs Susanne Kortekaas, lawyer, born on March 11, 1967 in Roosendaal en Nispen, (The Netherlands) with professional
address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as class B manager of the Company with immediate effect and
for an unlimited period.
<i>Declaration - Estimate of costsi>
The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately 3,800.- euros.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with
us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le trente et un août.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.
A comparu:
Pour une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de TURNHAM GREEN S.à r.I., une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée
suivant acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 17 août 2007 (la Société),
HeidelbergCement A.G., une société anonyme de droit allemand constituée selon les lois allemandes, ayant son siège
social Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Allemagne, immatriculée auprès du lower district court de Mannheim sous
le numéro HRB 330082 (l'Associé Unique)
ici représentée par Dr. Ingo Schaffernak, general counsel, avec adresse professionnelle à Berliner Strasse 6, 69120
Heidelberg, Allemagne, en vertu d'une procuration donnée le 30 août 2007;
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités
d'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de changer la dénomination sociale de la Société en HeidelbergCement HOLDING S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 1
er
des statuts de la Société
(les Statuts) qui aura désormais la teneur suivante:
«Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination HeidelbergCement
HOLDING S.à r.l. (la «Société») régit par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur
et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi») et les lois du 18 septembre 1933 et 28
décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de remplacer les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de la société
déjà existantes d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune par mille deux cent cinquante (1.250) parts
sociales ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-sept mille cinq cents
euros (EUR 87.500,-) par l'émission de huit mille sept cent cinquante (8.750) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale
28708
de dix euros (EUR 10,-) chacune de manière à le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) à un montant de cent mille euros (EUR 100.000,-).
<i>Souscription - paiementi>
L'Associé Unique déclare souscrire à trois mille cent soixante-seize (3.176) parts sociales nouvelles et les libérer
intégralement par un apport en numéraire d'un montant de trente et un mille sept cent soixante euros (EUR 31.760,-).
L'Associé Unique renonce, pour autant que de besoin, à son droit de souscription préférentiel s'agissant de la sou-
scription suivante:
HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, une société à responsabilité limitée de droit allemand con-
stituée selon les lois allemandes, ayant son siège social Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Allemagne, immatriculée
auprès du lower district court de Mannheim sous le numéro HRB 334775,
ici représentée par Dr. Ingo Schaffernak, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 30 août 2007,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles,
laquelle société déclare souscrire cinq mille cinq cent soixante-quatorze (5.574) nouvelles parts sociales et les libérer
entièrement par un apport en numéraire d'un montant de cinquante-cinq mille sept cent quarante euros (EUR 55.740,-).
Le montant de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 87.500,-) est à la disposition de la Société, ainsi que cela
a été prouvé au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.
(HeidelbergCement A.G. and HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH seront dénommés ci après
les «Associés»)
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de modifier le premier alinéa de l'article 5 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros) représenté par dix mille (10.000) parts
sociales d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»
<i>Sixième résolutioni>
Les Associés décident de modifier le second alinéa de l'article 9 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil de gérance se réuni sur convocation de l'un des gérants et au moins deux fois par an au Grand Duché de
Luxembourg.»
<i>Septième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 11 des Statuts en insérant le paragraphe suivant à la fin de l'article 11:
«Sans préjudice des dispositions précédentes, les transactions suivantes doivent recueillir l'approbation préalable de
l'assemblée générale des actionnaires:
a) Approbation du bilan financier et d'investissement qui doit être préparé à temps chaque année;
b) Achat, vente ou hypothèque de propriété aussi bien que toute autre transaction relative à la propriété;
c) Achat d'entreprises ou d'intérêts dans une entreprise donnée, ou vente ou hypothèque de celle-ci;
d) Etablissement, expansion ou fermeture de succursales et d'établissement permanent ou de point de vente;
e) Conclusion et modifications de tout type d'accord d'inter-société et les accords sur l'acquisition ou la cession
d'opérations;
f) Conclusion, modifications ou résiliation de contrats concernant des paiements réguliers, particulièrement dans les
contrats sur les droits d'utilisation de la propriété aussi bien que le loyer et les contrats de bail quand un tel loyer ou un
bail s'élèvent à plus de 10.000,- euros par mois ou bien dont le terme est de plus d'un an; Conclusion, modification ou
résiliation de n'importe quel contrat avec un fournisseur ou un client dont le terme est de plus d'un an;
g) Tout investissements de plus de 20.000,- euro par transaction chaque cas et un total de 50.000,- euros par année
financière, si de tels investissements ne sont pas inclus dans le rapport annuel d'investissement adopté;
h) Octroi et levée de prêts. Conclusion et mise en oeuvre de transactions financières sur produits dérivés tels que les
opérations de «forward» et contrats de couvertures sur achats, ventes de biens et marchandises, devises et taux d'intérêt.
Conclusion et mise en oeuvre de toutes sortes d'options qui financièrement peuvent être comparées aux opérations
précédentes ou qui impliquent des risques similaires;
i) Octroi de garantie et conclusion de contrats comparables avec les garanties, contrats de garantie, cogarantie, sou-
mission de lettres d'intention et d'engagements semblables;
j) Introduction de poursuites judiciaires et actions et déclarations concluant des poursuites judiciaires quand la reven-
dication en question excède 50,000.00 euros;
k) Conclusion, modification ou résiliation de contrats avec les actionnaires/associés de la société ou leurs affiliés ou
avec des sociétés contrôlées par les actionnaires/associés sont majoritaires et/ou leurs affiliés;
I) Entrée d'un «silent» actionnaire/associé;
m) Vente ou location de la totalité des biens de la Société;
28709
n) Entrée ou fin de partenariat;
o) Admission de nouveaux domaines d'affaires;
p) Tout changement dans la structure de la Société;
q) Octroi et annulation de procurations et pouvoirs;
r) Allocation de prime ou de rémunérations identiques;
s) Transaction non rémunérée ou action désavantageant pour la Société;
t) Acquisition ou location d'un véhicule motorisé;
u) Toute autre transaction commerciale non comprise dans les opérations courantes de la Société.»
<i>Huitième résolutioni>
Les Associés prennent acte de la démission de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. aux fonctions de gérant de la Société
avec effet immédiat et décide de nommer les deux gérants suivants:
Dr. Ingo Schaffernak, general counsel, né le 27 avril 1963 à Graz (Autriche) avec adresse professionnelle à Berliner
Strasse 6, 69120 Heidelberg (Germany) aux fonctions de gérant A de la Société avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée, et
Madame Susanne Kortekaas, juriste, née le 11 mars 1967 à Roosendaal en Nispen (Pays-Bas) avec adresse profes-
sionnelle à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg aux fonctions de gérant B de la Société avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais en raison du présent acte, s'élève à environ 3.800,- euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. À la demande desdites parties comparantes, il est précisé qu'en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé avec nous, le notaire, le présent
acte.
Signé: I. Schaffernak, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2007. Relation: LAC/2007/25315. — Reçu 875 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2008025541/242/248.
(080025220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
HeidelbergCement Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.227.779.130,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 131.709.
In the year two thousand seven, on the thirteenth day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. HeidelbergCement AG, a German stock corporation company incorporated under the laws of Germany, having its
registered office at Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, (Germany), registered with the lower district court in Mannheim
under number HRB 330.082;
represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, with professional address in Luxembourg by virtue of a proxy given on
September 13, 2007; and
2. HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, a German limited liability company, incorporated under
the laws of Germany, having its registered office at Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Germany, registered with the
lower district court in Mannheim under number HRB 334775,
represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, with professional address in Luxembourg by virtue of a proxy given on
September 13, 2007,
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
28710
(HeidelbergCement AG and HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH are hereinafter collectively
referred to as the Shareholders)
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the following:
I The Shareholders hold all the shares of HeidelbergCement HOLDING S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorpo-
rated pursuant to a deed of notary Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, dated August 17, 2007, the
articles of which
having been amended pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed dated August 31, 2007, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).
II The Company's share capital is presently set at one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) divided into ten thousand
(10,000) shares in registered form with a par value of ten euro (EUR 10.-) each, all subscribed and fully paid-up.
Therefore, the appearing parties, acting through their proxy holder, have requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the corporate capital of the Company by an amount of one billion two hundred
and twenty-seven million six hundred and seventy-nine thousand one hundred thirty Euro (EUR 1,227,679,130.-) in order
to bring it from its present amount of one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) to one billion two hundred and twenty-
seven million seven hundred and seventy-nine thousand one hundred and thirty Euro (EUR 1,227,779,130.-) by the
issuance of one hundred and twenty-two million seven hundred and sixty-seven thousand nine hundred and thirteen
(122,767,913) new shares with a par value of EUR 10.- each, having the same rights as the already existing shares.
<i>Intervention - subscription - paymenti>
Thereupon, HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, prenamed and represented as stated here
above declares to subscribe for sixty-eight million four hundred and thirty thousand eight hundred and forty (68,430,840)
new shares of the Company and to fully pay them up by way of a contribution in kind (the HCIH Contribution) consisting
of twelve million eight hundred and eighty-eight thousand fifty-five (12,888,055) shares (the HCIH Shares) in the capital
of CIMENTERIES CBR S.A., a joint stock company (société anonyme) under Belgian law, having its registered office address
at chaussée de La Hulpe 185, 1170 Brussels, Belgium and registered with the Legal Entities Register in Brussels under
number 0400.465.290 (CBR S.A.) representing approximately 55.7 % of the share capital of CBR S.A.
The HCIH Contribution has, as of the date hereof, a fair market value in an aggregate amount of two billion five hundred
and nine million three hundred and twelve thousand seven hundred and ninety-five Euro eighty Cent (EUR
2,509,312,795.80). The HCIH Contribution shall be allocated as follows:
(i) Six hundred and eighty-four million three hundred and eight thousand four hundred Euro (EUR 684,308,400.-) shall
be allocated to the Company's share capital; and
(ii) One billion eight hundred and twenty-five million four thousand three hundred and ninety-five Euro eighty Cent
(EUR 1,825,004,395.80) shall be allocated to the share premium account of the Company.
HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, prenamed and represented as stated hereabove further
declares that:
- it is the full owner of the HCIH Shares;
- it is solely entitled to the HCIH Shares and possesses the power to dispose of the HCIH Shares;
- the HCIH Shares are not encumbered with any pledge or usufruct, there exist no rights to acquire any pledge or
usufruct on the HCIH Shares and the HCIH shares are not subject to any attachment;
- there exist no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that
the HCIH Shares be transferred to him;
It results from the certificate issued on the date hereof by the management of CBR S.A. that, as of the date hereof:
- HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH is the registered owner of the HCIH Shares;
- the HCIH Shares are fully paid up;
- all the necessary authorisations have been obtained and all the necessary formalities have been performed in Belgium
so that the HCIH Shares are freely transferable in accordance with the laws of Belgium and the articles of association of
CBR S.A.;
- the HCIH Shares are worth at least two billion five hundred and nine million three hundred and twelve thousand
seven hundred and ninety-five Euro eighty Cent (EUR 2,509,312,795.80), this estimation being derived from a balance
sheet of CBR S.A. drawn up as per August 31, 2007 established in accordance with applicable generally accepted ac-
countancy principles (the CBR Balance Sheet), it being understood that from August 31, 2007 until and including the date
hereof, no event which could have had a significant effect on the values shown in the CBR Balance Sheet has occurred.
It results from the certificate issued on the date hereof by the managers of the Company that the managers of the
Company unanimously approve and agree that the HCIH Contribution has a fair market value of at least two billion five
28711
hundred and nine million three hundred and twelve thousand seven hundred and ninety-five Euro eighty Cent (EUR
2,509,312,795.80).
Thereafter, HeidelbergCement AG, prenamed and represented as stated hereabove declares to subscribe for fifty-
four million three hundred and thirty-seven thousand seventy-three (54,337,073) new shares in the Company and to fully
pay them up by way of a contribution in kind (the HCAG Contribution) consisting of 10,231,946 corresponding to all its
shares but one in the capital of CBR S.A. (the HCAG Shares), representing approximately 44.3 % of the share capital of
CBR S.A.
The HCAG Contribution has, as of the date hereof, a fair market value in an aggregate amount of one billion nine
hundred and ninety-two million five hundred and four thousand two hundred and four Euro twenty Cent (EUR
1,992,504,204.20). The HCAG Contribution shall be allocated as follows:
(iii) five hundred and forty-three million three hundred and seventy thousand seven hundred and thirty Euro (EUR
543,370,730.-) shall be allocated to the Company's share capital; and
(iv) one billion four hundred and forty-nine million one hundred and thirty-three thousand four hundred and seventy-
four Euro twenty Cent (EUR 1,449,133,474.20) shall be allocated to the share premium account of the Company.
HeidelbergCement AG, prenamed and represented as stated hereabove further declares that:
- it is the full owner of the HCAG Shares;
- it is solely entitled to the HCAG Shares and possesses the power to dispose of the HCAG Shares;
- the HCAG Shares are not encumbered with any pledge or usufruct, there exist no rights to acquire any pledge or
usufruct on the HCAG Shares and the HCAG shares are not subject to any attachment;
- there exist no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that
the HCAG Shares be transferred to him;
It results from the certificate issued on the date hereof by the management of CBR S.A. that, as of the date hereof:
- HeidelbergCement AG is the registered owner of the HCAG Shares;
- the HCAG Shares are fully paid up;
- all the necessary authorisations have been obtained and all the necessary formalities have been performed in Belgium
so that the HCAG Shares are freely transferable in accordance with the laws of Belgium and the articles of association
of CBR S.A.;
- the HCAG Shares are worth at one billion nine hundred and ninety-two million five hundred and four thousand two
hundred and four Euro twenty Cent (EUR 1,992,504,204.20), this estimation being derived from the CBR Balance Sheet,
it being understood that from August 31, 2007 until and including the date hereof, no event which could have had a
significant effect on the values shown in the CBR Balance Sheet has occurred.
It results from the certificate issued on the date hereof by the managers of the Company that the managers of the
Company unanimously approve and agree that the HCAG Contribution has a fair market value of at least one billion nine
hundred and ninety-two million five hundred and four thousand two hundred and four Euro twenty Cent (EUR
1.992.504.204,20).
The aforesaid certificates and the CBR Balance Sheet, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing
parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders resolve to amend article 5 of the articles of association
of the Company, which will henceforth read as follows:
«5.1. The capital of the Company is set at EUR 1,227,779,130.- (one billion two hundtred and twenty seven million
seven hundred and seventy nine thousand one hundred and thirty euro) represented by 122,777,913 (one hundred and
twenty two million seven hundred and seventy-seven thousand nine hundred and thirteen) shares, with a nominal value
of EUR 10.- (ten euro) each.»
<i>Third resolutioni>
The Shareholders acknowledge the resignation of Dr. Ingo Schaffernak as manager A of the company with effect as
per September 14, 2007 and therefore resolve to appoint new managers and to designate them as follows:
Mr Daniel Gauthier, director, born on January 20, 1957 in Charleroi (Belgium) with professional address at chaussée
de La Hulpe 185, 1170 Brussels (Belgium) as class A manager of the Company with effect from September 14 and for an
unlimited period;
Dr. Bernd Scheifele, director, born on May 5, 1958 in Freiburg in Breisgau (Germany) with professional address at
Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, (Germany) as class A manager of the Company with effect from September 14 and
for an unlimited period;
Dr. Lorenz Näger, director, born on May 22, 1960 in Ravensburg (Germany) with professional address at Berliner
Strasse 6, 69120 Heidelberg, (Germany) as class A manager of the Company with effect from September 14 and for an
unlimited period;
28712
Mrs Maria Tkachenko, business executive, born on May 3, 1974 in Moscow (Russia) with professional address at 46A,
avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as class B manager of the Company with effect from September 14 and for
an unlimited period; and
Mr Frank Welman, business executive, born on September 21, 1963 in Heerlen (The Netherlands) with professional
address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as class B manager of the Company with effect from September
14 and for an unlimited period;
<i>Declarations - costsi>
Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring more than 65% of the quota capital of a company
having its registered office in a Member State of the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated
December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 8,000.-.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, such person signed together with the notary the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le treize septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
1. HeidelbergCement AG, une société anonyme de droit allemand, ayant son siège social à Berliner Strasse 6, 69120
Heidelberg, (Allemagne), immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Mannheim sous le numéro HRB 330.082,
Ici représentée par M
e
Céline Pignon, avocat, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg en vertu d'une pro-
curation donnée le 13 septembre 2007;
2. HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, une société à\ responsabilité limitée de droit allemand,
ayant son siège social à Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, (Allemagne), immatriculée auprès du Registre des Sociétés
de Mannheim sous le numéro HRB 334.775,
Ici représentée par M
e
Céline Pignon, avocat, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg en vertu d'une pro-
curation donnée le 13 septembre 2007;
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
(HeidelbergCement AG et HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH seront dénommés ci après les
«Associés»)
Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Les Associés détiennent l'entièreté du capital social de HeidelbergCement Holding S.à r.l., une société à responsabilité
limitée ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître
Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg, en date du 17 août 2007, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dont les statuts ont été modifiés par acte de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg, en date du 31 août 2007, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par dix mille
(10.000) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
Les parties comparantes, représentées par le mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société par un montant de un milliard deux cent vingt-sept
millions six cent soixante-dix-neuf mille cent trente Euros (EUR 1.227.679.130,-) pour le porter de son montant actuel
de cent mille Euros (EUR 100.000,-) à un milliard deux cent vingt-sept millions sept cent soixante-dix-neuf mille cent
trente Euros (EUR 1.227.779.130,-) par l'émission de cent vingt-deux millions sept cent soixante-sept mille neuf cent
treize (122.767.913) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, ayant les mêmes
droits que les parts sociales déjà existantes.
28713
<i>Intervention - souscription - libérationi>
Ces faits exposés, HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, préqualifiée et représentée comme dé-
crit ci-dessus, déclare souscrire à soixante-huit millions quatre cent trente mille huit cent quarante (68.430.840) nouvelles
parts sociales dans la Société et les libérer entièrement par un apport en nature (l'Apport HCIH) consistant en douze
millions huit cent quatre-vingt-huit mille cinquante-cinq (12.888.055) actions (les Actions HCIH) de la société CIMEN-
TERIES CBR S.A., une société anonyme de droit belge, ayant son siège social au 185, Chaussé de La Hulpe, 1170 Bruxelles
(Belgique), immatriculée auprès du Registre commercial de la Chambre de commerce de Bruxelles sous le numéro
0400.465.290 (CBR S.A.) représentant environ 55.7% du capital social de CBR S.A.
L'Apport HCIH a, ce jour, une valeur de marché d'un montant total de deux milliards cinq cent neuf millions trois cent
douze mille sept cent quatre-vingt-quinze Euros quatre-vingts Cents (EUR 2.509.312.795,80). L'Apport HCIH sera affecté
de la manière suivante:
(i) six cent quatre-vingt-quatre millions trois cent huit mille quatre cents Euros (EUR 684.308.400,-) sont affectés au
capital social de la Société;
(ii) un milliard huit cent vingt-cinq millions quatre mille trois cent quatre-vingt-quinze Euros quatre-vingts Cents (EUR
1.825.004.395,80) sont affectés au compte prime d'émission de la Société.
HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, dé-
clare que:
- elle est la propriétaire des Actions HCIH;
- elle est la seule titulaire des droits sur les Actions HCIH et possède le pouvoir de disposer des Actions HCIH;
- les Actions HCIH ne sont pas grevées d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un
nantissement ou un usufruit sur les Actions HCIH et les Actions HCIH ne sont sujettes à aucune saisie;
- il n'existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que
les Actions HCIH lui soit cédées.
Il résulte du certificat délivré par les administrateurs de CBR S.A., qu'à ce jour:
- HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH est inscrite au registre des actions de CBR S.A. en tant
que détenteur des Actions HCIH;
- les Actions HCIH sont entièrement libérées;
- toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues et toutes les formalités ont été remplies en Belgique pour que
les Actions HCIH soient librement cessibles conformément aux lois belges et des statuts de CBR S.A.;
- Les Actions HCIH ont une valeur au moins égale à deux milliards cinq cent neuf millions trois cent douze mille sept
cent quatre-vingt-quinze Euros quatre-vingts Cents (EUR 2.509.312.795,80), cette estimation étant basé sur le bilan du
31 août 2007 de CBR S.A. établi conformément aux principes comptables généralement acceptés (le Bilan de CBR S.A.),
étant entendu que du 31 août 2007 jusqu'à la date de ce jour, aucun évènement qui pourrait avoir eu un effet significatif
sur les valeurs déclarées dans le Bilan de CBR S.A. n'est apparu.
Il résulte du certificat délivré ce jour par les gérants de la Société que tous les gérants de la Société unanimement
approuvent que l'Apport HCIH ait une valeur de marché d'un montant d'au moins deux milliards cinq cent neuf millions
trois cent douze mille sept cent quatre-vingt-quinze Euros quatre-vingts Cents (EUR 2.509.312.795,80).
Ensuite, est intervenue HeidelbergCement AG, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire
à cinquante-quatre millions trois cent trente-sept mille soixante-treize (54.337.073) nouvelles parts sociales dans la Société
et les libérer entièrement par un apport en nature (l'Apport HCAG) consistant en dix millions deux cent trente et un
mille neuf cent quarante-six (10.231.946) correspondant à toutes les actions sauf une (les Actions HCAG) détenues par
HeidelbergCement AG dans le capital CBR S.A., représentant environ 44.3% du capital social de CBR S.A.
L'Apport HCAG a, ce jour, une valeur de marché d'un montant total de EUR 1.992.504.204,20. L'Apport HCAG sera
affecté de la manière suivante:
(iii) Cinq cent quarante-trois millions trois cent soixante-dix mille sept cent trente euro (EUR 543.370.730,-) sont
affectés au capital social de la Société;
(iv) Un milliard quatre cent quarante-neuf millions cent trente-trois mille quatre cent soixante-quatorze Euros vingt
Cents (EUR 1.449.133.474,20) sont affectés au compte prime d'émission de la Société.
HeidelbergCement AG, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare que:
- elle est la propriétaire des Actions HCAG;
- elle est la seule titulaire des droits sur les Actions HCAG et possède le pouvoir de disposer des Actions HCAG;
- les Actions HCAG ne sont pas grevées d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un
nantissement ou un usufruit sur les Actions HCAG et les Actions HCAG ne sont sujettes à aucune saisie;
- il n'existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que
les Actions HCAG lui soit cédées.
Il résulte du certificat délivré par les administrateurs de la CBR S.A., qu'à ce jour:
HeidelbergCement AG est inscrite au registre des actions de CBR S.A. en tant que détenteur des Actions HCAG;
28714
- les Actions HCAG sont entièrement libérées;
- toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues et toutes les formalités ont été remplies en Belgique pour que
les Actions HCAG soient librement cessibles conformément aux lois belges et des statuts de CBR S.A.;
Les Actions HCAG ont une valeur au moins égale à un milliard neuf cent quatre-vingt-douze millions cinq cent quatre
mille deux cent quatre Euros et vingt Cents (EUR 1.992.504.204,20), cette estimation étant basé sur le Bilan de CBR S.A.,
étant entendu que du 31 août 2007 jusqu'à la date de ce jour, aucun événement qui pourrait avoir eu un effet significatif
sur les valeurs déclarées dans le Bilan de CBR S.A. n'est apparu.
Il résulte du certificat délivré ce jour par les gérants de la Société que tous les gérants de la Société unanimement
approuvent que l'Apport HCAG ait une valeur de marché d'un montant d'au moins un milliard neuf cent quatre-vingt-
douze millions cinq cent quatre mille deux cent quatre Euros et vingt Cents (EUR 1.992.504.204,20),
Lesdits certificats ainsi que le Bilan de CBR S.A., après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes
et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistre-
ment.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, les Associés décident de modifier l'alinéa 1
er
de l'article 5 des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 1.227.779.130,- (un milliard deux cent vingt sept millions sept cent
soixante-dix-neuf mille cent trente euros) représenté par 122.777.913 (cent vingt-deux millions sept cent soixante-dix-
sept mille neuf cent treize) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés prennent acte de la démission de Dr. Ingo Schaffernak aux fonctions de gérant A de la Société avec effet
au 14 septembre 2007 et décide de nommer les nouveaux gérants suivants:
M. Daniel Gauthier, administrateur, né le 20 janvier 1957 à Charleroi (Belgique) avec adresse professionnelle à Chaussé
de La Hulpe 185, 1170 Bruxelles (Belgique) aux fonctions de gérant A de la Société avec effet au 14 septembre 2007 et
pour une durée indéterminée,
Dr. Bernd Scheitele, administrateur, né le 5 mai 1958 à Freiburg im Breisgau (Allemagne) avec adresse professionnelle
à Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, (Allemagne) aux fonctions de gérant A de la Société avec effet au 14 septembre
2007 et pour une durée indéterminée,
Dr. Lorenz Näger, administrateur, né le 22 mai 1960 à Ravensburg (Allemagne) avec adresse professionnelle à Berliner
Strasse 6, 69120 Heidelberg, (Allemagne) aux fonctions de gérant A de la Société avec effet au 14 septembre 2007 et
pour une durée indéterminée,
Mme Maria Tkachenko, directeur, née le 3 mai 1974 à Moscou (Russie) avec adresse professionnelle au 46A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg aux fonctions de gérant B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indé-
terminée.
M. Frank Welman, directeur, né le 21 septembre 1963 à Heerlen (Pays-Bas) avec adresse professionnelle au 46A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg aux fonctions de gérant B de la Société avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.
<i>Fraisi>
Dans la mesure où l'apport en nature résulte de l'apport de plus de 65% du capital social d'une société ayant son siège
dans un Etat Membre de l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit
l'exonération du droit d'apport.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital à environ EUR 8.000,-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte
est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de distorsions entre la
version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentaire, les parties comparantes ont signés le
présent acte avec le notaire.
Signé: C. Pignon, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2007. Relation: LAC/2007/27910. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
28715
Luxembourg, le 5 octobre 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2008025545/242/299.
(080025241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
HeidelbergCement Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.741.263.300,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 131.709.
In the year two thousand seven, on the thirteenth day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. HeidelbergCement AG, a German stock corporation company incorporated under the laws of Germany, having its
registered office at Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, (Germany), registered with the lower district court in Mannheim
under number HRB 330082;
represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, with professional address in Luxembourg by virtue of a proxy given on
September 13, 2007,
2. HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, a German limited liability company, incorporated under
the laws of Germany, having its registered office at Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Germany, registered with the
lower district court in Mannheim under number HRB 334775,
represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, with professional address in Luxembourg by virtue of a proxy given on
September 13, 2007.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
(HeidelbergCement AG and HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH are hereinafter collectively
referred to as the Shareholders)
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the following:
I The Shareholders hold all the shares of HeidelbergCement HOLDING S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorpo-
rated pursuant to a deed of notary Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, dated August 17, 2007, the
articles of which having been amended for the last time pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed
dated September 13, 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).
II The Company's share capital is presently set one billion two hundred and twenty-seven million seven hundred and
seventy-nine thousand one hundred and thirty Euro (EUR 1,227,779,130.-) divided into one hundred and twenty-two
million seven hundred and seventy-seven thousand nine hundred and thirteen (122,777,913) shares in registered form
with a par value of ten euro (EUR 10.-) each, all subscribed and fully paid-up.
Therefore, the appearing parties, acting through their proxyholder, have requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the corporate capital of the Company by an amount of five hundred and thirteen
million four hundred and eighty-four thousand one hundred and seventy Euro (EUR 513,484,170.-) in order to bring it
from its present amount of one billion two hundred and twenty-seven million seven hundred and seventy-nine thousand
one hundred and thirty Euro (EUR 1,227,779,130) to one billion seven hundred and forty-one million two hundred and
sixty-three thousand three hundred Euro (EUR 1,741,263,300.-) by the issuance of fifty-one million three hundred and
forty-eight thousand four hundred and seventeen (51,348,417) new shares with a par value of ten euro (EUR 10.-) each,
having the same rights as the already existing shares.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon, HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, prenamed, waives, to the extent necessary,
its preferential subscription rights in respect of the following subscription:
HeidelbergCement AG, prenamed and represented as stated hereabove declares to subscribe for fifty-one million
three hundred and forty-eight thousand four hundred and seventeen (51,348,417) new shares of the Company and to
fully pay them up by way of a contribution in kind (the Contribution) consisting of all the shares (the Shares) in the capital
of HeidelbergCement U.K. HOLDING LIMITED, a company existing under the laws of England, registered at Companies
House, London under registration number 6295350 and having its registered office address at Park Square, 3160 Solihull
Parkway, Burmingham Business Park, Birmingham, B37 7YN, United Kingdom (HCUKH) representing 100% of the share
capital of HCUKH.
28716
The Contribution has, as of the date hereof, a fair market value in an aggregate amount of one billion eight hundred
and eighty-two million nine hundred and twelve thousand Euro (EUR 1,882,912,000.-). The Contribution shall be allocated
as follows:
(i) Five hundred and thirteen million four hundred and eighty-four thousand one hundred and seventy Euro (EUR
513,484,170.-) shall be allocated to the Company's share capital; and
(ii) One billion three hundred and sixty-nine million four hundred and twenty-seven thousand eight hundred and thirty
Euro (EUR 1,369,427,830.-) shall be allocated to the share premium account of the Company.
HeidelbergCement AG, prenamed and represented as stated hereabove further declares that:
- it is the full owner of the Shares;
- it is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares;
- the Shares are not encumbered with any pledge or usufruct, there exist no rights to acquire any pledge or usufruct
on the Shares and the Shares are not subject to any attachment;
- there exist no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that
the Shares be transferred to him;
It results from the certificate issued on the date hereof by the management of HCUKH that, as of the date hereof:
- HeidelbergCement AG is the registered owner of the Shares;
- the Shares are fully paid up;
- all the necessary authorisations have been obtained and all the necessary formalities have been performed in the
United Kingdom so that the Shares are freely transferable in accordance with the laws of the United Kingdom and the
articles of association of HCUKH;
- the Shares are worth at least one billion eight hundred and eighty-two million nine hundred and twelve thousand
Euro (EUR 1,882,912,000.-), this estimation being derived from a balance sheet of HCUKH drawn up as per August 31,
2007 established in accordance with applicable generally accepted accountancy principles (the HCUKH Balance Sheet),
it being understood that from August 31, 2007 until and including the date hereof, no event which could have had a
significant effect on the values shown in the HCUKH Balance Sheet has occurred.
It results from the certificate issued on the date hereof by the managers of the Company that the managers of the
Company unanimously approve and agree that the Contribution has a fair market value of at least one billion eight hundred
and eighty-two million nine hundred and twelve thousand Euro (EUR 1,882,912,000.-).
The aforesaid certificates and the HCUKH Balance Sheet, after signature ne varietur by the proxy holder of the
appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration
authorities.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders resolve to amend article 5 of the articles of association
of the Company, which will henceforth read as follows:
«5.1 The capital of the Company is set at EUR 1,741,263,300.- (one billion seven hundred forty-one million two hundred
sixty-three thousand three hundred euro ) represented by 174,126,330 (one hundred seventy-four million one hundred
twenty six thousand three hundred and thirty) shares, with a nominal value of EUR 10.- (ten euro) each.»
<i>Declarations - Costsi>
Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring more than 65% of the quota capital of a company
having its registered office in a Member State of the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated
December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 8,000.-.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, such person signed together with the notary the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le treize septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
1. HeidelbergCement AG, une société anonyme de droit allemand, ayant son siège social à Berliner Strasse 6, 69120
Heidelberg, (Allemagne), immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Mannheim sous le numéro HRB 330082,
28717
Ici représentée par M
e
Céline Pignon, avocat, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg en vertu d'une pro-
curation donnée le 13 septembre 2007;
2. HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, une société à responsabilité limitée de droit allemand,
ayant son siège social à Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, (Allemagne), immatriculée auprès du Registre des Sociétés
de Mannheim sous le numéro HRB 334775,
Ici représentée par M
e
Céline Pignon, avocat, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg en vertu d'une pro-
curation donnée le 13 septembre 2007;
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
(HeidelbergCement AG et HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH seront dénommés ci après les
«Associés»)
Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Les Associés détiennent l'entièreté du capital social de HeidelbergCement HOLDING S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par
Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg, en date du 17 août 2007,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dont les statuts ont été modifiés par acte de
Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 13 septembre
2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à un milliard deux cent vingt-sept millions sept cent soixante-
dix-neuf mille cent trente Euro (EUR 1.227.779.130,-) représenté par cent vingt-deux millions sept cent soixante-dix-sept
mille neuf cent treize (122.777.913) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, toutes sou-
scrites et entièrement libérées.
Les parties comparantes, représentées par le mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société par un montant de cinq cent treize millions quatre
cent quatre-vingt-quatre mille cent soixante-dix Euros (EUR 513.484.170,-) pour le porter de son montant actuel de un
milliard deux cent vingt-sept millions sept cent soixante-dix-neuf mille cent trente Euro (EUR 1.227.779.130,-) à un milliard
sept cent quarante et un millions deux cent soixante-trois mille trois cents Euros (EUR 1.741.263.300,-) par l'émission
de cinquante et un millions trois cent quarante-huit mille quatre cent dix-sept (51.348.417) nouvelles parts sociales d'une
valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, préqualifiée, renonce, pour autant que
de besoin, à son droit de souscription préférentiel s'agissant de la souscription suivante:
HeidelbergCement AG, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à cinquante et un mil-
lions trois cent quarante-huit mille quatre cent dix-sept (51.348.417) nouvelles parts sociales dans la Société et les libérer
entièrement par un apport en nature (l'Apport) consistant en toutes les actions (les Actions) de la société Heidelberg-
Cement UK HOLDING LIMITED, une société de droit anglais, immatriculée auprès du Companies House de Londre
sous le numéro 6295350, ayant son siège social à Park Square, 3160 Solihull Parkway, Burmingham Business Park, Bir-
mingham, B37 7YN, United Kingdom, (HCUKH) représentant 100% du capital social de HCUKH.
L'Apport a, à ce jour, une valeur de marché d'un montant total de EUR 1.882.912.000,-. L'Apport sera affecté de la
manière suivante:
(i) cinq cent treize millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille cent soixante-dix Euros (EUR 513.484.170,-) sont
affectés au capital social de la Société;
(ii) un milliard trois cent soixante-neuf millions quatre cent vingt-sept mille huit cent trente Euros (EUR 1.369.427.830,-)
sont affectés au compte prime d'émission de la Société.
HeidelbergCement AG, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare que:
- elle est la propriétaire des Actions;
- elle est la seule titulaire des droits sur les Actions et possède le pouvoir de disposer des Actions;
- les Actions ne sont pas grevées d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement
ou un usufruit sur les Actions et les Actions ne sont sujettes à aucune saisie;
- il n'existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que
les Actions lui soit cédées.
Il résulte du certificat délivré par les administrateurs de HCUKH, qu'à ce jour:
- HeidelbergCement AG est inscrite au registre des actions de HCUKH en tant que détenteur des Actions;
- les Actions sont entièrement libérées;
28718
- toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues et toutes les formalités ont été remplies en Grande Bretagne
pour que les Actions soient librement cessibles conformément aux lois anglaises et des statuts de HCUKH;
- Les Actions ont une valeur au moins égale à un milliard huit cent quatre-vingt-deux millions neuf cent douze mille
Euros (EUR 1.882.912.000,-), cette estimation étant basé sur le bilan de HCUKH (le Bilan) du 31 août 2007, étant entendu
que du 31 août 2007 jusqu'à la date de ce jour, aucun événement qui pourrait avoir eu un effet significatif sur les valeurs
déclarées dans le Bilan n'est apparu.
Il résulte du certificat délivré ce jour par les gérants de la Société que tous les gérants de la Société unanimement
approuvent que l'Apport ait une valeur de marché d'un montant d'au moins un milliard huit cent quatre-vingt-deux millions
neuf cent douze mille Euros (EUR 1.882.912.000,-)
Lesdits certificats ainsi que le Bilan, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, les Associés décident de modifier l'alinéa 1
er
de l'article 5 des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 1.741.263.300,- (un milliard sept cent quarante et un millions deux cent
soixante-trois mille trois cents euros) représenté par 174.126.330 (cent soixante-quatorze millions cent vingt-six mille
trois cent trente) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»
<i>Déclaration - Fraisi>
Dans la mesure où l'apport en nature résulte de l'apport de plus de 65% du capital social d'une société ayant son siège
dans un Etat Membre de l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit
l'exonération du droit d'apport.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital à environ EUR 8.000,-
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte
est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de distorsions entre la
version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentaire, les parties comparantes ont signés le
présent acte avec le notaire.
Signé: C. Pignon, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2007, Relation: LAC/2007/27911. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Frising.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2008025551/242/200.
(080025251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
HeidelbergCement Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.741.263.300,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 131.709.
In the year two thousand seven, on the fourteenth day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. HeidelbergCement AG, a German stock corporation company incorporated under the laws of Germany, having its
registered office at Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, (Germany), registered with the lower district court in Mannheim
under number HRB 330082;
represented by Mrs Solange Wolter-Schieres, private employee, residing in Schouweiler, by virtue of a proxy given on
September 13, 2007; and
2. HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, a German limited liability company, incorporated under
the laws of Germany, having its registered office at Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Germany, registered with the
lower district court in Mannheim under number HRB 334775,
represented by Mrs Solange Wolter-Schieres, prenamed, by virtue of proxy given on September 13, 2007.
28719
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
(HeidelbergCement AG and HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH are hereinafter collectively
referred to as the Shareholders)
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the following:
I The Shareholders hold all the shares of HeidelbergCement HOLDING S.à r.l.,
a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of notary Maître Jacques Delvaux, notary residing in
Luxembourg, dated August 17, 2007, the articles of which having been amended
for the last time pursuant to a notarial deed of the undersigned notary, dated September 13, 2007, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).
II The Company's share capital is presently set at one billion seven hundred and forty-one million two hundred and
sixty-three thousand three hundred Euro (EUR 1,741,263,300.-) divided into one hundred and seventy-four million one
hundred and twenty-six thousand three hundred and thirty (174,126,330) shares in registered form with a par value of
ten euro (EUR 10.-) each, all subscribed and fully paid-up.
Therefore, the appearing parties, acting through their proxy holder, have requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to change the first financial year of the Company so that it shall begin on the date of the
incorporation of the Company and end on September 14, 2007.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve that the following financial year shall begin on September 15, 2007 and end on December
31, 2007 and that any subsequent financial years shall start on the 1st of January and end on the 31st of December of the
same year.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 13 of the articles of association of the Company (the Articles), which will
henceforth read as follows:
«Without prejudice to article 20, the Company financial year's begins on the 1st January and closes on the 31st
December of the same year.»
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders resolve to amend article 20 of the Articles, which
will henceforth read as follows:
«Exceptionally the first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and end on the 14th
day of September 2007. The next succeeding financial year shall begin on the 15th day of September 2007 and end on
the 31st day of December 2007.»
<i>Declarations - costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 1,200.-.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, such person signed together with the notary the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
1. HeidelbergCement AG, une société anonyme de droit allemand, ayant son siège social à Berliner Strasse 6, 69120
Heidelberg, (Allemagne), immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Mannheim sous le numéro HRB 330082,
Ici représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, emprloyée privée, demeurant à Schouweiler, en vertu d'une
procuration donnée le 13 septembre 2007.
28720
2. HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, une société à responsabilité limitée de droit allemand,
ayant son siège social à Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, (Allemagne), immatriculée auprès du Registre des Sociétés
de Mannheim sous le numéro HRB 334.775,
Ici représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 13 septem-
bre 2007.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
(HeidelbergCement AG et HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH seront dénommés ci après les
«Associés»)
Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Les Associés détiennent l'entièreté du capital social de HeidelbergCement HOLDING S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg, en
date du 17 août 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 septembre 2007, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à un milliard sept cent quarante et un millions deux cent soixante-
trois mille trois cents Euros (EUR 1.741.263.300,-), représenté par cent soixante-quatorze millions cent vingt-six mille
trois cent trente (174.126.330) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées.
Les parties comparantes, représentées par le mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de changer la première année sociale de la Société de sorte qu'elle commence à la date de
constitution de la Société et se termine le 14 septembre 2007.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident que l'année sociale suivante commencera le 15 septembre 2007 et se terminera le 31 décembre
2007 et que chaque année sociale subséquente commencera le 1
er
janvier et se terminera le 31 décembre de la même
année.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 13 des statuts de la Société (les Statuts) qui aura désormais la teneur suivante:
«Sans préjudice de l'article 20, l'année sociale de la Société commence 1
er
janvier et se terminera le 31 décembre de
la même année.»
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, les Associés décident de modifier l'article 20 des Statuts qui aura désormais la
teneur suivante:
«A titre exceptionnel, la première année sociale commencera à la date de constitution de la Société et se terminera
le 14 septembre 2007. L'année sociale suivante commencera le 15 septembre 2007 et se terminera le 31 décembre 2007.»
<i>Déclaration - Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital à environ EUR 1.200,-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte
est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de distorsions entre la
version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la partie comparante a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: S. Wolter-Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2007. Relation: LAC/2007/27918. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Frising.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2008025555/242/124.
(080025259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
28721
HeidelbergCement Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.300.000.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 131.709.
In the year two thousand seven, on the fourteenth day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. HeidelbergCement AG, a German stock corporation company incorporated under the laws of Germany, having its
registered office at Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, (Germany), registered with the lower district court in Mannheim
under number HRB 330082;
represented by Mrs. Solange Wolter-Schieres, private employee, residing in Schouweiler, by virtue of a proxy given
on September 13, 2007; and
2. HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, a German limited liability company, incorporated under
the laws of Germany, having its registered office at Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Germany, registered with the
lower district court in Mannheim under number HRB 334775,
represented by Mrs Solange Wolter-Schieres, prenamed, by virtue of proxy given on September 13, 2007.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
(HeidelbergCement AG and HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH are hereinafter collectively
referred to as the Shareholders)
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the following:
I The Shareholders hold all the shares of HeidelbergCement HOLDING S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorpo-
rated pursuant to a deed of notary Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, dated August 17, 2007, the
articles of which having been amended for the last time pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, pre-named
dated September 14, 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).
Il The Company's share capital is presently set at one billion seven hundred and forty-one million two hundred and
sixty-three thousand three hundred Euro (EUR 1,741,263,300.-) divided into one hundred and seventy-four million one
hundred and twenty-six thousand three hundred and thirty (174,126,330) shares in registered form with a par value of
ten euro (EUR 10.-) each, all subscribed and fully paid-up.
Therefore, the appearing parties, acting through their proxyholder, have requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the corporate capital of the Company by an amount of five hundred and fifty-
eight million seven hundred and thirty-six thousand seven hundred Euro (EUR 558,736,700.-) in order to bring it from
its present amount of one billion seven hundred and forty-one million two hundred and sixty-three thousand three
hundred Euro (EUR 1,741,263,300.-) to two billion three hundred million Euro (EUR 2,300,000,000.-) by the issuance of
fifty-five million eight hundred and seventy-three thousand six hundred and seventy (55,873,670) new shares with a par
value of ten euro (EUR 10.-) each, having the same rights as the already existing shares.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon, HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, prenamed and represented as stated herea-
bove declares to subscribe for fifty-five million eight hundred and seventy-three thousand six hundred and seventy
(55,873,670) new shares of the Company and to fully pay them up by way of a contribution in kind (the HClH Contribution)
consisting of forty thousand eight hundred and forty (40,840) shares in the capital of LEHIGH B.V. (the LHBV Shares), a
private limited company (besloten vennootschap) under Dutch law, having its registered office address at Sint Teunislaan
1, 5231 BS S'Hertogenbosch, the Netherlands and registered with the Dutch Chamber of Commerce under number
16087893, representing 45 per cent of the share capital of LHBV (LHBV).
The HCIH Contribution has, as of the date hereof, a fair market value in an aggregate amount of two billion forty-
eight million eight hundred and fifty thousand Euro (EUR 2,048,850,000.-) The HCIH Contribution shall be allocated as
follows:
(i) Five hundred and fifty-eight million seven hundred and thirty-six thousand seven hundred Euro (EUR 558,736,700,-)
shall be allocated to the Company's share capital; and
(ii) One billion four hundred and ninety million one hundred and thirteen thousand three hundred Euro (EUR
1,490,113,300.-) shall be allocated to the share premium account of the Company.
28722
HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, prenamed and represented as stated hereabove further
declares that:
- it is the full owner of the LHBV Shares;
- it is solely entitled to the LHBV Shares and possesses the power to dispose of the LHBV Shares;
- the LHBV Shares are not encumbered with any pledge or usufruct, there exist no rights to acquire any pledge or
usufruct on the LHBV Shares and the LHBV shares are not subject to any attachment;
- there exist no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that
the LHBV Shares be transferred to him;
It results from the certificate issued on the date hereof by the management of LHBV that, as of the date hereof:
- HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH is the registered owner of the LHBV Shares;
- the LHBV Shares are fully paid up;
- all the necessary authorisations have been obtained and all the necessary formalities have been performed in the
Netherlands so that the LHBV Shares are freely transferable in accordance with the laws of the Netherlands and the
articles of association of LHBV;
- the LHBV Shares are worth at least two billion forty-eight million eight hundred and fifty thousand Euro (EUR
2,048,850,000.-), this estimation being derived from a balance sheet of LEHIGH B.V. drawn up as per August 31, 2007
established in accordance with applicable generally accepted accountancy principles (the LHBV Balance Sheet), it being
understood that from August 31, 2007 until and including the date hereof, no event which could have had a significant
effect on the values shown in the LHBV Balance Sheet has occurred.
It results from the certificate issued on the date hereof by the managers of the Company that the managers of the
Company unanimously approve and agree that the HCIH Contribution has a fair market value of at least two billion forty-
eight million eight hundred and fifty thousand Euro (EUR 2,048,850,000.-)
The aforesaid certificate and the LHBV Balance Sheet, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing
parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders resolve to amend article 5 of the articles of association
of the Company, which will henceforth read as follows:
«5.1 The capital of the Company is set at EUR 2,300,000,000.- (two billion three hundred million euro) represented
by 230,000,000 (two hundred thirty million) shares, with a nominal value of EUR 10.- (ten euro) each.»
<i>Declarations - Costsi>
Insofar as the contribution in kind of the Shares results in the Company holding more than 65% of the shares of a
company incorporated and having its registered office in the European Union, being made in accordance with Article 4-2
of the Law dated 29 December 1971, as amended, the Company applies for the capital duty exemption.
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 8,500.-.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, such person signed together with the notary the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
1. HeidelbergCement AG, une société anonyme de droit allemand, ayant son siège social à Berliner Strasse 6, 69120
Heidelberg, (Allemagne), immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Mannheim sous le numéro HRB 330082,
Ici représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler, en vertu d'une
procuration donnée le 13 septembre 2007;
2. HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, une société à responsabilité limitée de droit allemand,
ayant son siège social à Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, (Allemagne), immatriculée auprès du Registre des Sociétés
de Mannheim sous le numéro HRB 334775,
Ici représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 13 septem-
bre 2007;
28723
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
(HeidelbergCement AG et HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH seront dénommés ci après les
«Associés»)
Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Les Associés détiennent l'entièreté du capital social de HeidelbergCement HOLDING S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par
Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg, en date du 17 août 2007,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 septembre 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (la Société).
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé un milliard sept cent quarante et un millions deux cent soixante-
trois mille trois cents Euros (EUR 1.741.263.300,-) représenté par cent soixante-quatorze millions cent vingt-six mille
trois cent trente (174.126.330) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées.
Les parties comparantes, représentées par le mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société par un montant de cinq cent cinquante-huit millions
sept cent trente-six mille sept cents Euros (EUR 558.736.700,-) pour le porter de son montant actuel de un milliard sept
cent quarante et un millions deux cent soixante-trois mille trois cents Euros (EUR 1.741.263.300,-) à deux milliards trois
cent millions d'Euros (EUR 2.300.000.000,-) par l'émission de cinquante-cinq millions huit cent soixante-treize mille six
cent soixante-dix (55.873.670) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, ayant les
mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, dé-
clare souscrire à cinquante-cinq millions huit cent soixante-treize mille six cent soixante-dix (55.873.670) nouvelles parts
sociales dans la Société et les libérer entièrement par un apport en nature (l'Apport HCIH) consistant en quarante mille
huit cent quarante (40.840) actions (les Actions LHBV) de la société LEHIGH B.V., une société de droit néerlandais,
immatriculée auprès du Registre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 16087893, ayant son siège social à Sint
Teunislaan 1, 5231 BS S'Hertogenbosch, Pays-Bas, (LHBV) représentant 45% du capital social de LHBV.
L'Apport HCIH a, à ce jour, une valeur de marché d'un montant total de deux milliards quarante-huit millions huit
cent cinquante mille Euros (EUR 2.048.850.000,-). L'Apport HCIH sera affecté de la manière suivante:
(i) cinq cent cinquante-huit millions sept cent trente-six mille sept cents Euros (EUR 558.736.700,-) sont affectés au
capital social de la Société;
(ii) un milliard quatre cent quatre-vingt-dix millions cent treize mille trois cents Euros (EUR 1.490.113.300,-) sont
affectés au compte prime d'émission de la Société.
HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, dé-
clare que:
- elle est la propriétaire des Actions LHBV;
- elle est la seule titulaire des droits sur les Actions LHBV et possède le pouvoir de disposer des Actions LHBV;
- les Actions LHBV ne sont pas grevées d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un
nantissement ou un usufruit sur les Actions LHBV et les Actions LHBV ne sont sujettes à aucune saisie;
- il n'existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que
les Actions LHBV lui soit cédées.
Il résulte du certificat délivré par les administrateurs de LHBV, qu'à ce jour:
- HeidelbergCement INTERNATIONAL HOLDING GmbH est inscrite au registre des actions de HCUKH en tant
que détenteur des Actions LHBV;
- les Actions LHBV sont entièrement libérées;
- toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues et toutes les formalités ont été remplies aux Pays-Bas pour
que les Actions LHBV soient librement cessibles conformément aux lois anglaises et des statuts de LHBV;
- Les Actions LHBV ont une valeur au moins égale à deux milliards quarante-huit millions huit cent cinquante mille
Euros (EUR 2.048.850.000,-) cette estimation étant basé sur le bilan de LHBV (le Bilan) du 31 août 2007, étant entendu
que du 31 août 2007 jusqu'à la date de ce jour, aucun événement qui pourrait avoir eu un effet significatif sur les valeurs
déclarées dans le Bilan n'est apparu.
28724
Il résulte du certificat délivré ce jour par les gérants de la Société que tous les gérants de la Société unanimement
approuvent que l'Apport HCIH ait une valeur de marché d'un montant d'au moins deux milliards quarante-huit millions
huit cent cinquante mille Euros (EUR 2.048.850.000,-)
Lesdits certificats ainsi que le Bilan, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, les Associés décident de modifier l'alinéa 1
er
de l'article 5 des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 2.300.000.000,- (deux milliards trois cent millions euros) représenté par
230.000.000 (deux cent trente millions) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»
<i>Déclaration - Fraisi>
Compte tenu du fait que l'apport en nature des actions résulte que la Société détient plus de 65% des actions d'une
société constituée et ayant son siège social dans un état membre de l'Union Européenne, la société requiert conformément
à l'article 4-2 de la loi datée du 29 décembre 1971 telle que modifiée, l'exonération du droit d'apport.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital à environ EUR 8.500,-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte
est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de distorsions entre la
version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentaire, la partie comparante a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: S. Wolter-Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2007, Relation: LAC/2007/27919. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): F. Sandt.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2008025560/242/194.
(080025276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
AFS Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 93.792.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2008.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Référence de publication: 2008025712/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2008, réf. LSO-CN02382. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080025310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
Cogeco Cable GP S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 213.319.200,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 118.800.
Le bilan au 31 août 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
28725
Munsbach, le 15 février 2008.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2008025019/1337/16.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2008, réf. LSO-CM09961. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2008.
Aximo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 110.078.
L'an deux mille sept, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AXIMO S.A., avec siège social
à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 110.078, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 juillet 2005, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 17 du 4 janvier 2006.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Hugues Doubet, em-
ployé privé, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de l'année sociale de sorte qu'elle commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
2) Modification afférente de l'article 24 des statuts.
3) Nouvelle fixation de la date de l'assemblée générale annuelle au 3
ème
mardi du mois de mai à 08.00 heures.
4) Modification afférente du premier alinéa de l'article 18 des statuts.
5) Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'année sociale de sorte que celle-ci commencera le 1
er
janvier et se terminera le 31
décembre de chaque année.
L'assemblée constate que l'année sociale ayant pris cours le 1
er
juillet 2007 prendra fin le 31 décembre 2007.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 24
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 24. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer la date de l'assemblée générale annuelle au 3
ème
mardi du mois de mai à 08.00 heures.
28726
La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le 13 mai 2008 à 08.00 heures.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier
alinéa de l'article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 18. (premier alinéa). L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3
ème
mardi du mois de mai à
08.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à sept cent cinquante euros.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Dont acte, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Dostert, J. H. Doubet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2008. Relation GRE/2008/248. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 14 février 2008.
J. Seckler.
Référence de publication: 2008025580/231/66.
(080025484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
Aximo II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 110.072.
L'an deux mille sept, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AXIMO II S.A., avec siège
social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 110.072, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 juillet 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 23 du 4 janvier 2006.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Hugues Doubet, em-
ployé privé, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de l'année sociale de sorte qu'elle commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
2) Modification afférente de l'article 24 des statuts.
3) Nouvelle fixation de la date de l'assemblée générale annuelle au 3
ème
mardi du mois de mai à 09.00 heures.
4) Modification afférente du premier alinéa de l'article 18 des statuts.
5) Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
28727
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'année sociale de sorte que celle-ci commencera le 1
er
janvier et se terminera le 31
décembre de chaque année.
L'assemblée constate que l'année sociale ayant pris cours le 1
er
juillet 2007 prendra fin le 31 décembre 2007.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 24
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 24. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer la date de l'assemblée générale annuelle au 3
ème
mardi du mois de mai à 09.00 heures.
La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le 13 mai 2008 à 09.00 heures.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier
alinéa de l'article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 18. (premier alinéa). L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3
ème
mardi du mois de mai à
09.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à sept cent cinquante euros.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Dont acte, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Dostert, H. Doubet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2008, Relation GRE/2008/249. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 14 février 2008
J. Seckler.
Référence de publication: 2008025583/231/66.
(080025495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
B.G.D.C., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 62.347.
Le bilan au 31 décembre 2006, le rapport de gestion ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2008025867/1801/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2008, réf. LSO-CN03220. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080025325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
28728
Mag Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 107.489.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société MAG HOLDINGS SA qui s'est tenue
en date du 24 janvier 2008 que:
AUDEX SARL établie au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg est nommée comme Commissaire aux Comptes
de la société en remplacement de UNITED CAPITAL CONTROLLERS démissionnaire avec effet immédiat jusqu'à l'issue
de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008025361/803/18.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2008, réf. LSO-CN02546. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080024869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2008.
LVSC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 10, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 115.817.
L'an deux mille huit, le huit janvier.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
A comparu:
CFLJ S.à r.l., avec siège social à L-1255 Luxembourg, 10, rue de Bragance,
ici représentée par son gérant Jacques Levy, administrateur, demeurant à Lormont (France), nommé à ces fonctions
lors de l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 26 du 5 janvier 2006, habilité à engager la société par sa seule signature,
lui-même représenté par Maître Rémi Chevalier, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du laquelle procuration, après avoir été signée
ne varietur par le comparant et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui
aux formalités de l'enregistrement, associée unique de la société LVSC S.à r.l., établie et ayant son siège à L-1255 Lu-
xembourg, 10, rue de Bragance, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 115.817, constituée
suivant acte Tom Metzler de Luxembourg du 13 avril 2006, publié au dit Memorial C, numéro 1292 du 4 juillet 2006.
La comparante, représentée comme il est dit, prend la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Elle décide de modifier l'exercice social de la société et par conséquent de modifier l'article 11 et la première phrase
de l'article 12 des statuts, lesquels auront désormais la teneur suivante:
« Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier pour finir le trente et un décembre de chaque année.»
« Art. 12. première phrase. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes de la société sont établis et le gérant
ou le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.»
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, représentée comme il est, elle a signé avec Nous,
notaire, la présente minute.
Signé: R. Chevalier, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 15 janvier 2008, REM 2008/80. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 7 février 2008.
R. Arrensdorff.
Référence de publication: 2008025523/218/36.
(080025619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
28729
LSFAP Euro-Asian Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 100.000,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 77.579.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008025811/5499/13.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04007. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080025485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
Genpact Investment Co. (Lux) SICAR S.à r.l., Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société
d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 104.546.
In the year two thousand seven, on the thirtieth day of July.
Before M
e
Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of GENPACT INVESTMENT CO. (LUX)
SICAR S.à r.l., a Luxembourg investment company in risk capital in the form of a private limited liability company (société
d'investissement en capital à risque sous forme de société à responsabilité limitée), with its registered office at 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under the number B 104.546 (the Company). The Company has been incorporated on December 6, 2004 pursuant to a
deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations - N
o
168 of February 24, 2005. The articles of association of the Company have been amended for the last
time by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, dated April 30, 2007, not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
There appeared:
1) GENERAL ATLANTIC PARTNERS (BERMUDA), L.P., a Bermuda limited partnership with registered address at c/
o CODAN SERVICES LIMITED, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM-DX, Bermuda,
hereby represented by Michaël Meylan, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given, on July 30, 2007.
2) GAP-W INTERNATIONAL, LP, a Bermuda Limited Partnership with registered address at Clarendon House, 2
Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,
hereby represented by Michaël Meylan, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given, on July 30, 2007.
3) GAPSTAR, LLC, a Delaware limited liability company with registered address at c/o NATIONAL CORPORATE
RESEARCH LTD., 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware, 19901, United States of America,
hereby represented by Michaël Meylan, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given, on July 30, 2007.
4) GAPCO GMBH & CO. KG, a German limited partnership with registered address at c/o KOENIGSALLE 62, 40212
Düsseldorf, Germany,
hereby represented by Michaël Meylan, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given, on July 30, 2007.
5) GAP COINVESTMENTS III, LLC, a Delaware limited liability company with registered address at c/o NATIONAL
CORPORATE RESEARCH LTD., 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware, 19901, United States of America,
hereby represented by Michaël Meylan, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given, on July 30, 2007.
6) GAP COINVESTMENTS IV, LLC, a Delaware limited liability company with registered address at c/o NATIONAL
CORPORATE RESEARCH LTD., 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware, 19901, United States of America,
hereby represented by Michaël Meylan, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given, on July 30, 2007.
7) OAK HILL CAPITAL PARTNERS (BERMUDA) L.P., a Bermuda limited partnership with registered address at Cidar
House, 41 Cidar Avenue, Hamilton, HM 12, Bermuda,
hereby represented by Michaël Meylan, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given, on July 30, 2007.
8) OAK HILL CAPITAL MANAGEMENT PARTNERS (BERMUDA) L.P., a Bermuda limited partnership with registered
address at Cidar House, 41 Cidar Avenue, Hamilton, HM 12, Bermuda,
hereby represented by Michaël Meylan, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given, on July 30, 2007.
28730
9) OAK HILL CAPITAL PARTNERS II (CAYMAN) L.P., a Cayman Islands limited partnership with registered address
at c/o WALKERS SPV LIMITED, Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
hereby represented by Michaël Meylan, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given, on July 30, 2007.
10) OAK HILL CAPITAL PARTNERS II (CAYMAN II) L.P., a Cayman Islands limited partnership with registered address
at C/O WALKERS SPV LIMITED, Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
hereby represented by Michaël Meylan, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given, on July 30, 2007.
11) OAK HILL CAPITAL MANAGEMENT PARTNERS II (CAYMAN) L.P., a Cayman Islands limited partnership with
registered address at c/o WALKERS SPV LIMITED, Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands,
hereby represented by Michaël Meylan, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given, on July 30, 2007.
12) GENPACT MANAGEMENT INVESTORS, LLC, a Delaware limited liability company, with its registered office at
c/o 615, South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, United States of America,
hereby represented by Michaël Meylan, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given, on July 30, 2007.
Such proxies after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.
The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that 201,158 (two hundred one thousand one hundred and fifty eight) ordinary shares, having a nominal value of
USD 31.- (thirty-one United States Dollars) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly
represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda,
hereinafter reproduced;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Approval of the redemption of 1,158 ordinary shares held by GENPACT MANAGEMENT INVESTORS, LLC (the
Redeemed Shares) having each a par value of thirty United States Dollars (USD 31.-);
3. Decision to confer all powers to the board of managers in order to implement the necessary bookkeeping amend-
ments, to the cancellation of Redeemed Shares and the reimbursement of GENPACT MANAGEMENT INVESTORS,
LLC;
4. Miscellaneous.
III. that the Meeting has taken the following resolutions unanimously:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the shareholders represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to approve the redemption of one thousand one hundred fifty eight (1,158) ordinary shares of
the Company held by GENPACT MANAGEMENT INVESTORS, LLC having each a par value of thirty United States
Dollars (USD 31.-) (the Share Redemption), a redemption notice having been sent by the Company to GENPACT MAN-
AGEMENT INVESTORS, LLC to that effect.
The Meeting acknowledges that the Share Redemption does not have the effect of reducing the net assets below the
aggregate of the subscribed capital and the non distributable reserves of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to cancel hereby the Redeemed Shares. Subsequently, the subscribed capital is reduced by an
amount of USD 35,898.- (thirty five thousand eight hundred and ninety eight United States Dollars) and is brought from
its present amount of USD 6,235,898.- (six million two hundred thirty-five thousand eight hundred and ninety-eight United
States Dollars) to USD 6,200,000.- (six million two hundred thousand United States Dollars) represented by 200,000
(two hundred thousand) shares, each with a nominal par value of USD 31.- (thirty-one United States Dollars).
The first paragraph of article 4 of the Articles shall henceforth read as follows:
«The Company's subscribed share capital is set at USD 6,200,000.- (six million two hundred thousand United States
Dollars) represented by 200,000 (two hundred thousand) shares, each with a nominal par value of USD 31.- (thirty-one
United States Dollars)»
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to confer all powers to the board of managers in order to implement the necessary bookkeeping
amendments and to organise the payment of the redemption price to GENPACT MANAGEMENT INVESTORS, LLC
and to see to any formalities in connection therewith. In particular, the board of directors shall determine the portion of
the redemption price in excess of the nominal value of the Redeemed Shares and the way to fund it.
28731
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,500.-.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le trentième jour du mois de juillet,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de GENPACT INVESTMENT CO (LUX)
SICAR S.à r.l, une société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque, ayant
pour siège social 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.546 (la Société). La Société a été constituée le 6 décembre 2004
suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n°168 du 24 février 2005. Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois le 30 avril 2007, suivant
acte de Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
Ont comparu:
1) GENERAL ATLANTIC PARTNERS (BERMUDA) L.P, une société des Bermudes ayant son siège social à C/O CO-
DAN SERVICES LIMITED, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM-DX, Bermudes,
représentée par Michaël Meylan, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée le 30 juillet
2007.
2) GAP-W INTERNATIONAL, L.P, une société des Bermudes ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton, HM 11, Bermudes,
représentée par Michaël Meylan, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée le 30 juillet
2007.
3) GAPSTAR, LLC, une société de l'Etat de Delaware ayant son siège social à c/o NATIONAL CORPORATE RE-
SEARCH LTD, 615 South dupont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique Court, Les Banques, St Peter
Port, Guernsey, Channel Islands,
représentée par Michaël Meylan, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée le 30 juillet
2007.
4) GAPCO GMBH & CO KG, une société de droit allemand ayant son siège social à c/o KOENIGSALLE 62, 40212
Düsseldorf, Allemagne,
représentée par Michaël Meylan, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée le 30 juillet
2007.
5) GAP COINVESTMENTS III, LLC, une société de l'Etat de Delaware ayant son siège social à c/o NATIONAL COR-
PORATE RESEARCH LTD, 615 South Dupont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique,
représentée par Michaël Meylan, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée le 30 juillet
2007.
6) GAP COINVESTMENTS IV, LLC, une société de l'Etat de Delaware ayant son siège social à C/O NATIONAL
CORPORATE RESEARCH LTD, 615 South Dupont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique,
représentée par Michaël Meylan, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée le 30 juillet
2007.
7) OAK HILL CAPITAL PARTNERS (BERMUDA) L.P, une société des Bermudes ayant son siège social à Cidar House,
41 Cidar Avenue, Hamilton, HM 12, Bermudes,
représentée par Michaël Meylan, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée le 30 juillet
2007.
8) OAK HILL CAPITAL MANAGEMENT PARTNERS (BERMUDA) L.P, une société des Bermudes ayant son siège
social à Cidar House, 41 Cidar Avenue, Hamilton, HM 12, Bermudes,
représentée par Michaël Meylan, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée le 30 juillet
2007.
9) OAK HILL CAPITAL PARTNERS II (CAYMAN) L.P, une société des Iles Caïman ayant son siège social à c/o WAL-
KERS SPV LIMITED, Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Caïman, Iles Caïman,
28732
représentée par Michaël Meylan, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée le 30 juillet
2007.
10) OAK HILL CAPITAL PARTNERS II (CAYMAN II) L.P, une société des Iles Caïman ayant son siège social à c/o
WALKERS SPV LIMITED, Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Caïman, Iles Caïman,
représentée par Michaël Meylan, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée le 30 juillet
2007.
11) OAK HILL CAPITAL MANAGEMENT PARTNERS II (CAYMAN) L.P, une société des Iles Caïman ayant son siège
social à c/o WALKERS SPV LIMITED, Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Caïman, Iles Caïman,
représentée par Michaël Meylan, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée le 30 juillet 2007.
12) GENPACT MANAGEMENT INVESTORS LLC, une société de l'Etat de Delaware ayant son siège social à c/o 615
South Dupont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique,
représentée par Michaël Meylan, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée le 30 juillet
2007.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant resteront annexées au présent acte pour subir les formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes représentées comme indiqué ci-dessus ont requis le notaire instrumentant d'acter que:
I.- 201.158 (deux cent un mille cent cinquante huit) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de USD 31
(trente et une dollars) chacune, représentant l'intégralité du capital souscrit de la Société, sont dûment représentées à
l'Assemblée, qui peut dès lors valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour
II.- L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux convocations d'usage;
2. Approbation du remboursement de 1.158 parts sociales ordinaires détenues par GENPACT MANAGEMENT IN-
VESTORS, LLC (les Parts Remboursées) ayant une valeur nominale de USD 31,- (trente et une dollars) chacune;
3. Décision de donner tous pouvoirs au conseil de gérance aux fins de modifier le registre des parts sociales, d'annuler
les Parts Remboursées et de rembourser GENPACT MANAGEMENT INVESTORS, LLC;
4. Divers.
III. l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social étant représenté à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux convocations d'usage, les as-
sociés se considèrent valablement convoqués et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été
communiqué en avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'approuver le remboursement de 1.158 parts sociales ordinaires détenues par GENPACT MA-
NAGEMENT INVESTORS, LLC ayant une valeur nominale de USD 31,- (trente et une dollars) chacune (le Rembourse-
ment des Parts), un avis de remboursement a été adressé par la Société à GENPACT MANAGEMENT INVESTORS, LLC
à cette fin.
L'Assemblée reconnaît que le Remboursement des Parts n'a pas pour effet de réduire les actifs nets en deçà du total
du capital souscrit et des réserves non distribuables de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'annuler les Parts Remboursées. En conséquence, le capital souscrit est réduit d'un montant de
USD 35.898,- (trente cinq mille huit cent quatre vingt dix huit dollars) et est porté de son montant actuel de USD
6.235.898,- (six millions deux cent trente cinq mille huit cent quatre vingt dix huit dollars) à USD 6.200.000,- (six millions
deux cent mille dollars) représenté par 200.000 (deux cent mille) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 31,-
(trente et une dollars) chacune.
Le premier paragraphe de l'article 4 des Statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à USD 6.200.000,- (six millions deux cent mille dollars) représenté par
200.000 (deux cent mille) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 31,- (trente et une dollars) chacune»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de donner tous pouvoirs au conseil de gérance aux fins de modifier le registre des parts sociales,
d'annuler les Parts Remboursées et de rembourser GENPACT MANAGEMENT INVESTORS, LLC, ainsi que de réaliser
les formalités afférentes. En particulier, le conseil de gérance devra déterminer la portion du prix de remboursement au
delà de la valeur nominale des Parts Remboursées et la façon de les rembourser.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent approximativement à la somme de 1.500,- €.
28733
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande des mêmes parties comparantes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état
et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Meylan, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2007. Relation: LAC/2007/21126. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2007.
P. Frieders.
Référence de publication: 2008025477/212/223.
(080025916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
Cap Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 31.641.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2008.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Référence de publication: 2008025722/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2008, réf. LSO-CN02388. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080025299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
Jupiter S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 34.202.
Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2008025814/506/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03615. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080025075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
Bellissimmo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2729 Luxembourg, 3, rue Saint Willibrord.
R.C.S. Luxembourg B 118.159.
L'an deux mille sept, le sept novembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
A comparu:
Ernad Durovic, commerçant, né à Ivangrad (Montenegro), le 27 juillet 1969 et son épouse Mirela Islamovic, employée
privée, née à Berane (Montenegro) le 4 août 1982, demeurant ensemble à L-2729 Luxembourg, 3, rue St Willibrord,
propriétaire de cent (100) parts de BELLISSIMMO SARL avec siège social à L-2729 Luxembourg, 3, rue Saint Willibrord,
inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 118.159, constituée suivant acte du notaire Tom
Metzler de Luxembourg-Bonnevoie en date du 21 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
28734
Numéro 1826 du 29 septembre 2006, modifiée suivant acte du notaire Tom Metzler de Luxembourg-Bonnevoie en date
du 19 octobre 2007, non encore publié audit Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
D'abord, les époux Durovic-Islamovic, préqualifiés, cèdent à Umer Ramdedovic, couvreur, né à Lagatore (Montenegro),
le 19 août 1963, demeurant à L-4819 Rodange, 34, rue de la Gendarmerie, cinquante (50) parts de BELLISSIMMO SARL
pour le prix de un (1) euro.
L'entrée en jouissance a lieu de suite.
À ce sujet, la cessionnaire déclare avoir eu préalablement à la signature du présent acte connaissance exacte et parfaite
de la situation financière de la Société pour en avoir examiné les bilan et comptes des pertes et profits tout comme le
cédant confirme que les parts sociales cédées ne sont grevées d'aucun gage.
Le prix de cession a été payé par la cessionnaire aux cédants avant la passation des présentes et hors la présence du
notaire. Ce dont quittance et titre.
Cette cession est acceptée au nom de la Société par Ernad Durovic et Svetlana Stoyanova, ingénieur, née à Sofia
(Bulgarie), le 26 juin 1960, demeurant à L-4031 Esch-sur-Alzette, 49, rue Zenon Bernard, agissant en leur qualité de gérant
administratif, respectivement technique de ladite Société.
Ensuite,
Les époux Durovic-Islamovic et Umer Ramdedovic, seuls associés de la Société, se réunissant en assemblée générale
extraordinaire, sur ordre du jour conforme ainsi qu'à l'unanimité, prennent les résolutions suivantes:
1) Ils donnent leur agrément en ce qui concerne la cession de parts visée ci-avant.
2) Suite à cette cession de parts, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts de cent
vingt-cinq (125,-) euros chacune.»
3) Ils confirment Ernad Durovic aux fonctions de gérant administratif et Svetlana Stoyanova aux fonctions de gérant
technique.
4) Ils nomment aux fonctions de gérant administratif Umer Ramdedovic pour une durée illimitée.
La Société est engagée par la signature conjointe du gérant technique et des deux gérants administratifs.
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Durovic, S. Islamovic, U. Ramdedovic, S. Stoyanova, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2007, Relation: EAC/2007/14311. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 12 février 2008.
F. Molitor.
Référence de publication: 2008025539/223/48.
(080025706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
Maxtorgraben S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 136.106.
STATUTES
In the year two thousand and eight, on the thirtieth of January.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
DEANERY ESTATES S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 132680, having
its registered office at 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Ms Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxem-
bourg on 21 January 2008.
Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in his hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the
articles of incorporation of which shall be as follows:
28735
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who
may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding
of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, pro-
motion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations
of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as
the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which
form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem
useful in accomplishment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of MAXTORGRABEN S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-
tered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers,
by the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case
of several managers, by the board of managers.
In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social
developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.
B. Share Capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares of one euro (EUR 1.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three-quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.
28736
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by individual signature of any manager.
Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram,
telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent
more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each
partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.
Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual Accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on October 1st, and ends on September 30th of the following year.
28737
Art. 21. Each year on September 30th, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares of one euro (EUR 1.-) each have been subscribed by DEANERY
ESTATES S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on September 30th,
2008.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.
<i>Resolutions of the sole partneri>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Max Galowich, jurist, born on July 30, 1965 in Luxembourg, residing professionally at 4, rue Henri Schnadt, L-2530
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr Steve kieffer, chartered accountant, born on April 4, 1973 in Luxembourg, residing at 4, rue Henri Schnadt, L-2530
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le trente janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
DEANERY ESTATES S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 132.680, ayant son siège
social au 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous
seing privé donnée à Luxembourg le 21 janvier 2008.
La procuration, signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
28738
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de
Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de parti-
cipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans
l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle
estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de MAXTORGRABEN S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré
dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y aurait plusieurs gérants, par décision du conseil de
gérance.
Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y aurait plusieurs gérants, par le conseil de gérance,
des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, éco-
nomique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
C. Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
28739
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature individuelle d'un des gérants.
Art. 12. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres
un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a
pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de
convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation
n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil
de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents
ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.
Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
28740
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 20. L'année sociale commence le 1
er
octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.
Art. 21. Chaque année, au 30 septembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
DEANERY ESTATES S.à.r.l., prénommée, a souscrit les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 30 septembre 2008.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une
assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Max Galowich, juriste, né le 30 juillet 1965 à Luxembourg, demeurant au 4, rue Henri Schnadt, L-2530
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Monsieur Steve Kieffer, expert-comptable, né le 4 avril 1973 à Luxembourg, demeurant au 4, rue Henri Schnadt,
L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentaire par
son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 février 2008. Relation: EAC/2008/1854. — Reçu 62,50 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 13 février 2008.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2008025334/239/336.
(080024893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2008.
Berin Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 58.617.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
28741
Luxembourg, le 14 février 2008.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Référence de publication: 2008025718/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2008, réf. LSO-CN02385. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080025306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
Solidus Private Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 136.155.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the twenty-first of December.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
1) Mr Philippe Graf Schenk Von Stauffenberg, company director, born on May 17, 1964 in Neuilly Sur Seine, France,
residing at UK-W6 9HA London, United Kingdom, Rainville Road, Thames Wharf, 2nd Floor,
2) Mr Luca Warnke, company director, born on April 13, 1970 in Cologne, Germany, residing at 50354 Hürth, Ger-
many, Steinstrasse 73, and
3) Mr Jan Giessler, company director, born on March 10, 1965 in Cologne, Germany, residing at 50933 Cologne,
Germany, Hirseweg 24,
here represented by Mr David Sana, maître en droit, professionally residing in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a three proxies given under private seal.
The said proxies signed ne varietur by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present
deed, in order to be recorded with it.
The appearing parties, represented by Mr David Sana, prenamed, requested the undersigned notary to draw up the
Constitutive Deed of a private limited company, («société à responsabilité limitée»), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company («société à responsabilité limitée») which will be governed
by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company's name is SOLIDUS PRIVATE EQUITY S.à r.l.
Art. 3. The purpose of the company is to take participations in, and/or to act as manager, general partner and / or
shareholder with unlimited liability in any company, corporation or partnership set up under any laws included Luxem-
bourg laws and more specifically the Luxembourg law of February 13, 2007 on specialised investment funds.
The company may carry out any commercial or financial activities related to the accomplishment of its purposes.
The company may also take participations and management rights, in any form whatsoever, in any commercial, indus-
trial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises, and acquire any securities and rights through participation,
contribution, option or in any other way.
The company may in addition render any kind of consulting and advisory services that are not included in its function
as manager of companies in which it holds such mandate.
The company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and
certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.
Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city of Luxembourg by simple decision of the manager
or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the
articles of association.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
28742
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and six hundred Euro (EUR 12,600.-) represented by five hundred
and four (504) sharequotas of twenty five Euro (EUR 25.-) each.
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the
amended law concerning trade
companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the
company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.
The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota.
If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has
been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict
between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary
only.
Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval
of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of share-
quotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders'
meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to
the surviving spouse.
If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their
participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an
additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end
to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company's inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.
The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting
deliberating with a majority of votes.
In case of a single manager, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature
of the manager.
In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint
signatures of any two managers.
The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a
meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any
other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company
in and out of court.
28743
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who
are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of
attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five per cent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be
compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders' free disposal.
Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the sharequotas they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory dispositionsi>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing parties, duly represented, declare to subscribe
as follows all the five hundred and four (504) sharequotas with a par value of twenty five Euro (EUR 25.-) each:
1) Mr Philippe Graf Schenk Von Stauffenberg, pre-named, one hundred and sixty-eight sharequotas . . . . . . . . . 168
2) Mr Luca Warnke, pre-named, one hundred and sixty eight sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
3) Mr Jan Giessler, pre-named, one hundred and sixty eight sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Total: five hundred and four sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
All the five hundred and four (504) sharequotas have been paid up in cash to the extent of one hundred per cent
(100%) so that the amount of twelve thousand and six hundred Euro (EUR 12,600.-) is now at the free disposal of the
company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at one thousand three hundred and fifty Euro.
<i>Resolutions of the extraordinary general shareholders' meetingi>
Immediately after the incorporation of the company, the above named persons, representing the entire subscribed
capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general
meeting.
28744
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed managers of the company for an indefinite period:
1) Mr Philippe Graf Schenk Von Stauffenberg, company director, born on May 17, 1964 in Neuilly-Sur-Seine, France,
residing at UK-W6 9HA London, United Kingdom, Rainville Road, Thames Wharf, 2nd Floor
2) Mr Luca Warnke, company director, born on April 13, 1970 in Cologne, Germany, residing at 50354 Hürth, Ger-
many, Steinstrasse 73, and
3) Mr Jan Giessler, company director, born on March 10, 1965 in Cologne, Germany, residing at 50933 Cologne,
Germany, Hirseweg 24.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the
appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status and
residence, the said attorney signed together with us, the notary, the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsieben, den einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind Erschienen:
1) Herr Philippe Graf Schenk Von Stauffenberg, Verwalter von Gesellschaften, geboren am 17. Mai 1964 in Neuilly Sur
Seine, Frankreich, wohnhaft in UK-W6 9HA London, Grossbritannien, Rainville Road, Thames Wharf, 2. Stock,
2) Herr Luca Warnke, Verwalter von Gesellschaften, geboren am 13. April 1970 in Köln, Deutschland, wohnhaft in
50354 Hürth, Deutschland, Steinstrasse 73, und
3) Herr Jan Giessler, Verwalter von Gesellschaften, geboren am 10. März 1965 in Köln, Deutschland, wohnhaft in
50933 Köln, Deutschland, Hirseweg 24,
hier vertreten durch Herrn David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, aufgrund von drei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.
Diese Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden
Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Komparenten, vertreten durch Herrn David Sana, vorgenannt, haben erklärt, dass sie eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung gegründet haben, deren Satzung sie wie folgt festgelegt haben:
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den in Kraft befindlichen Gesetzen
und insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und der vorliegenden
Satzung unterliegt.
Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung SOLIDUS PRIVATE EQUITY S.à r.l. an.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen an, sowie /oder die Ausübung der Tätigkeit des
Geschäftsführers, Komplementärs und /oder persönlich haftenden Gesellschafters von Gesellschaften, Unternehmen
oder Vereinigungen, welche ausländischem oder luxemburgischem Recht unterliegen und insbesondere dem luxembur-
gischen Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investitionsfonds.
Die Gesellschaft darf jede kommerzielle oder finanzielle Tätigkeit zum Erreichen des Gesellschaftszweckes oder in
Verbindung hiermit ausüben.
Die Gesellschaft darf auch Beteiligungen und Geschäftsführungsrechte, in welcher Form auch immer, an kommerziellen,
industriellen, finanziellen oder anderen luxembburgischen oder ausländischen Unternehmen sowie Wertpapiere und
Rechte mittels Beteiligung, Einlage, Option oder anderswie erwerben.
Ausserdem darf die Gesellschaft der von ihr geführten Gesellschaft jede Art von Beratungsdienst, der nicht bereits in
der Geschäftsführungstätigkeit enthalten ist, erweisen.
Die Gesellschaft darf Anleihen aufnehmen und private Schuldverschreibungen, Schuldscheine, Wertpapiere und Zer-
tifikate ausgeben unter der Bedingung, dass sie nicht frei übertragbar sind und nur auf den Namen lautend ausgegeben
werden.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg.
28745
Die Adresse des Gesellschaftssitzes darf innerhalb der Stadt Luxemburg durch einfachen Beschluss des Geschäftsfüh-
rers oder, im Fall von mehreren Geschäftsführern, durch den Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt werden. Der
Gesellschaftssitz kann in irgendeine andere Ortschaft des
Grossherzogtums Luxemburg durch Beschluss der ausserodentlichen Generalversammlung der Teilhaber unter Be-
rücksichtigung der Bedingungen für Satzungsänderungen verlegt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur stattfinden oder nahe bevorstehen, wel-
che die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die unbeschwerte Kommunikation dieses Gesellschaftssitzes mit dem
Ausland gefährden, dann kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung der aussergewöhn-
lichen Umstände ins Ausland verlegt werden. Ein solcher Beschluss hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft.
Die Mitteilung über die Sitzverlegung erfolgt und wird Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft übermittelt,
welches sich unter den gegebenen Umständen hierzu am besten eignet.
Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600,-) festgesetzt, dargestellt durch
fünfhundertvier (504) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, dann sind, unter anderen, die Artikel 200-1 und 200-2
des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften anzuwenden, d.h. dass jeder Beschluss des alleinigen Gesell-
schafters sowie jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft schriftlich festgehalten werden muss und dass die
Bestimmungen über die Generalversammlungen der Teilhaber nicht anwendbar sind.
Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre eigenen Anteile zu erwerben unter der Bedingung, dass sie vernichtet werden und
das Kapital verhältnismässig herabgesetzt wird.
Art. 7. Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die für jeden Anteil nur einen einzigen Eigentümer
anerkennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, dann kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden
Rechte in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, welche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso
verhält es sich bei einem Konflikt zwischen dem Niessbrauchberechtigten und dem «nackten» Eigentümer oder zwischen
dem durch Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner. Die Stimmrechte der mit dem Niessbrauch belasteten Anteile
werden jedoch nur vom Niessbrauchberechtigten ausgeübt.
Art. 8. Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Teilhaber und an Mchtteilhaber unterliegt der anlässlich einer
Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.
Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Ge-
neralversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, welches
den überlebenden Teilhabern gehört.
Diese Genehmigung ist nicht erfordert, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder an den überlebenden
Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, dann haben
die verbleibenden Teilhaber ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.
Das von einem oder mehreren Teilhabern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Teilhaber
über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden.
Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages
nach sich.
Art. 9. Ausser seiner Gesellschafteinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teilhaber,
der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein spezielles
Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu einem Satz
welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen werden als
allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht.
Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als
zusätzliche Gesellschaftseinlage zu betrachten, und der Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der
Gesellschaft anerkannt.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die
Zahlungsunfähigkeitserklärung eines Teilhabers. Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen
den überlebenden Teilhabern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.
Art. 11. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Doku-
mente der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungs-
handlungen einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche Teilhaber
oder Nichtteilhaber sein können. Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt werden, dann bilden sie einen Geschäftsfüh-
rungsrat.
28746
Das Geschäftsführungsmandat wird dem /den Geschäftsführer(n) bis zu seine/ihrer ad nutum Abberufung durch die
Generalversammlung der Teilhaber, welche mehrheitlich berät, anvertraut.
Im Falle eines Geschäftsführers wird die Gesellschaft in allen Angelegenheiten durch die Einzelunterschrift des Ge-
schäftsführers gültig gegenüber Drittpersonen verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unter-
schrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.
Der Geschäftsführungsrat kann nur beraten und gültige Beschlüsse fassen, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer
anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse müssen mehrheitlich von den in der Versammlung anwesenden oder vertretenen
Geschäftsführern getroffen werden.
Geschäftsführungsversammlungen dürfen auch per Telefon- oder Videokonferenz oder andere Kommunikationsmittel
abgehalten werden, welche den an diesen Versammlungen teilnehmenden Personen erlauben, sich gegenseitig zu hören.
Die Teilnahme an einer Versammlung durch diese Mittel hat dieselbe Gültigkeit wie eine persönliche Teinahme an dieser
Versammlung.
Der Geschäftsführungsrat darf einstimmmig Beschlüsse im Zirkularverfahren treffen, indem jedes Mitglied sein Ein-
verständnis schriftlich gibt oder per Telegramm, Telex, Telefax oder andere ähnliche Mittel, gefolgt von einer schriftlichen
Bestätigung. Das Protokoll über den Beschluss besteht aus der Gesamtheit der Schriftstücke.
Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen
und um die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.
Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer allei-
nigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.
Art. 13. In Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungsgemäss
im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung seines
Mandates verantwortlich.
Art. 14. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Teilhabern, welche mehr als die Hälfte des
Kapitals vertreten, angenommen werden. Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur von der Mehrheit
der Teilhaber getroffen werden, welche drei Viertel des Kapitals vertreten.
Zwischendividenden dürfen unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
- Zwischenbilanzen werden auf viertel- oder halbjährlicher Basis erstellt,
- diese Bilanzen müssen genügend Gewinne ausweisen, einschliesslich des Gewinnvortrages,
- der Beschluss, Zwischendividenden auszuschütten, ist von den Gesellschaftern zu treffen.
Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.
Art. 16. Jedes Jahr zum 31. Dezember wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den Teilhabern
unterbreiten.
Art. 17. Jeder Teilhaber darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den fünfzehn Tagen vor seiner
Annahme einsehen.
Art. 18. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten, der Sozialabgaben,
der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des
Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind
nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder
einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus
welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Teilhaber.
Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die
Geschäftsführung oder jede andere von den Teilhabern bestimmte Person durchgeführt.
Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, dann werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Teilhaber im
Verhältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt.
Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Teilhaber gehalten werden könnte Zahl-
ungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.
Art. 20. Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Teilhaber auf die in Kraft befindlichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 21. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern
selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch
Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.
28747
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr wird heute beginnen und wird am 31. Dezember 2007 enden.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Nachdem die Satzung somit festgelegt ist, erklären die gültig vertretenen Komparenten alle fünfhundertvier (504)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) wie folgt zu zeichnen:
1) Herr Philippe Graf Schenk Von Stauffenberg, vorbenannt, einhundertachtundsechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . 168
2) Herr Luca Warnke, vorbenannt, einhundertachtundsechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
3) Herr Jan Giessler, vorbenannt, einhundertachtundsechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Insgesamt: fünfhundertvier Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
Alle fünfhundertvier (504) Anteile sind voll in bar eingezahlt worden, so dass die Summe von zwölftausendsechshundert
Euro (EUR 12.600,-) ab sofort zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, so wie dies dem instrumentierenden Notar
nachgewiesen worden ist.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausendremundert-
fünfzig Euro.
<i>Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafteri>
Sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben die oben genannten Teilhaber, welche das gesamte gezeichnete
Kapital vertreten und sich als ordnungsgemäss einberufen wähnten, eine ausserordentliche Generalversammlung abge-
halten.
Nach Prüfung der ordnungsgemässen Bildung dieser Versammlung, haben sie folgende Beschlüsse einstimmig getroffen:
<i>Erster Beschlussi>
Folgende Personen werden zu Geschäftsführern auf unbestimmte Zeit ernannt:
1) Herr Philippe Graf Schenk Von Stauffenberg, Verwalter von Gesellschaften, geboren am 17. Mai 1964 in Neuilly Sur
Seine, Frankreich, wohnhaft in UK-W6 9HA London, Grossbritannien, Rainville Road, Thames Wharf, 2. Stock
2) Herr Luca Warnke, Verwalter von Gesellschaften, geboren am 13. April 1970 in Köln, Deutschland, wohnhaft in
50354 Hürth, Deutschland, Steinstrasse 73, und
3) Herr Jan Giessler, Verwalter von Gesellschaften, geboren am 10. März 1965 in Köln, Deutschland, wohnhaft in
50933 Köln, Deutschland, Hirseweg 24,
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische und die deutsche Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Antrag
der Komparenten diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Antrag
derselben Komparenten und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische
Fassung massgebend.
Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 2008, Relation GRE/2008/41. — Reçu 126 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 février 2008.
J. Seckler.
Référence de publication: 2008025613/231/363.
(080025606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
Ed. Meyers & Cie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1259 Senningerberg, 2, rue Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 27.904.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
28748
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2008025813/506/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03616. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080025076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
LSFAP Euro-Asian Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 100.000,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 77.579.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008025819/5499/13.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04004. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080025482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
Gravolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3355 Leudelange, 164, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 83.033.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GRAVOLUX SARL
Signature
Référence de publication: 2008025856/3206/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2007, réf. LSO-CL06503. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080025704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
T.C.F. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 62.311.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2008.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008025276/1035/15.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2008, réf. LSO-CN03286. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2008.
CONEXIA SA, Courtiers en assurances, Société Anonyme.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1er.
R.C.S. Luxembourg B 86.312.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
28749
Luxembourg, le 18 février 2008.
<i>Pour la société
i>Signatures
Référence de publication: 2008025874/2352/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2008, réf. LSO-CN02570. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080025387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
General Shale Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 118.992.
Le bilan au 31 décembre 2006 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2008.
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
Signature
Référence de publication: 2008025285/510/15.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2008, réf. LSO-CM09667. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2008.
Servico S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 14.065.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SERVICO S.A.
Signature
Référence de publication: 2008025860/3206/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2007, réf. LSO-CL06461. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080025694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
Euroluxconstruction S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3270 Bettembourg, 53, route de Peppange.
R.C.S. Luxembourg B 94.737.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008025880/2546/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN01981. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080025901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
Zerno S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Bertrange, 28, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 52.109.
Im Jahre zweitausendacht, den vierundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
28750
Fand die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft ZERNO S.A., mit Sitz in L-8069
Bertrange, 28, rue de l'Industrie, statt. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar
Francis Kesseler, mit dem Amtssitz in Esch-sur-Alzette, am 18. August 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 560
vom 2. November 1995 und ist eingetragen im Handels- und Gesellschafts-register von Luxemburg unter Nummer B
52.109. Die Satzung wurde zum letzten Mal abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar
am 17. November 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 82 vom 31. Januar 2007.
Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Karsten Dankert, Diplomkaufmann, wohnhaft in Luxemburg,
welcher Frau Marie-Jeanne Bastos, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg, zur Sekretärin bestellt.
Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn Horst Schneider, expert-comptable, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigebogen. Diese Liste wurde von
den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmenzähler
und dem instrumentierenden Notar unterschrieben.
Die von dem vertretenen Gesellschafter ausgestellte Vollmacht wird ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur
paraphiert beigebogen um mit derselben formalisiert zu werden.
II.- Da sämtliche vierhundert (400) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital von hunderttausend Euro
(100.000,- €) darstellen, in gegenwärtiger Generalversammlung vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig. Somit ist
gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:
- Änderung von Artikel 7.4. Abschnitt 6 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben: «Zur rechtsverbindlichen
Zeichnung für die Gesellschaft ist die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder die individuelle
Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes erforderlich.»
Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgenden Beschluss:
<i>Einziger beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel 7.4. Abschnitt 6 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu
geben:
«Zur rechtsverbindlichen Zeichnung für die Gesellschaft ist die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmit-
glieder oder die individuelle Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes erforderlich.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.
Worüber Urkunde, Geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates
gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: K. Dankert, M.-J. Bastos, H. Schneider, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008. LAC/ 2008/3979. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 15. Februar 2008.
P. Frieders.
Référence de publication: 2008025476/212/48.
(080025726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
CONEXIA SA, Courtiers en assurances, Société Anonyme.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1er.
R.C.S. Luxembourg B 86.312.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2008.
<i>Pour la société
i>Signatures
Référence de publication: 2008025873/2352/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04413. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080025389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
28751
Volux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5539 Remich, 8, place Nico Klopp.
R.C.S. Luxembourg B 120.388.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2008.
O. Chapovaliouk
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2008025875/7568/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04481. - Reçu 91 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080025480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
CONEXIA SA, Courtiers en assurances, Société Anonyme.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1er.
R.C.S. Luxembourg B 86.312.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2008.
<i>Pour la société
i>Signatures
Référence de publication: 2008025871/2352/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04411. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080025392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
Bios S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 3.055.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008025878/1759/13.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2008, réf. LSO-CN03332. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080025728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
Euroluxconstruction S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3270 Bettembourg, 53, route de Peppange.
R.C.S. Luxembourg B 94.737.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008025881/2546/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2007, réf. LSO-CL04891. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080025898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
28752
AFS Participations S.A.
Aximo II S.A.
Aximo S.A.
Bellissimmo S.à r.l.
Berin Holding S.A.
B.G.D.C.
Bios S.A.
Cap Holding S.A.
Cogeco Cable GP S.e.c.s.
CONEXIA SA, Courtiers en assurances
CONEXIA SA, Courtiers en assurances
CONEXIA SA, Courtiers en assurances
Ed. Meyers & Cie S.à r.l.
Euroluxconstruction S.A.
Euroluxconstruction S.A.
General Shale Finance S.à r.l.
Genpact Investment Co. (Lux) SICAR S.à r.l.
Gravolux S.à r.l.
HeidelbergCement Holding S.à r.l.
HeidelbergCement Holding S.à r.l.
HeidelbergCement Holding S.à r.l.
HeidelbergCement Holding S.à r.l.
HeidelbergCement Holding S.à r.l.
Jupiter S.A.
LSFAP Euro-Asian Holdings S.àr.l.
LSFAP Euro-Asian Holdings S.àr.l.
LVSC S.à r.l.
Mag Holdings S.A.
Maxtorgraben S.à r.l.
Servico S.A.
Solidus Private Equity S.à r.l.
T.C.F. S.A.
Turnham Green S. à r. l.
Volux S.à r.l.
Zerno S.A.