This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 580
7 mars 2008
SOMMAIRE
A.E. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27837
Aire Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
27814
Aperta Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27830
Audition International S.A. . . . . . . . . . . . . .
27832
Barclays Themis Investments S.à r.l. . . . . .
27833
Barotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27836
Bisa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27840
Bizet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27794
Cap Grisnez S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27832
Courcheval No. 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
27812
Courcheval No. 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
27814
Delphi Automotive Systems Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27823
Distri Europe S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27817
Dlux Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27820
Eucon Finanz Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .
27840
Galluspark (Bridge) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
27814
H2O FundCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27817
H2O Land S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27837
HEPP III Luxembourg Master S.à r.l. . . . .
27825
Interneptune Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27812
Invesco GT Continental European Mana-
gement S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27824
Invesco GT Investment Management
Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27833
INVESCO Maximum Income Management
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27835
Laconi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27837
Last Machine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27814
Last Machine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27818
Manacor SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27837
Martek Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27827
McCain Assets Inc. Luxembourg Branch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27819
Monarch Beach Capital (Max Bahr) No. 1
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27818
Moor Park Newday Netherlands Holdco
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27837
Moretta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27819
Orangenburger S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27823
Parndorf Bale S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27839
Parndorf Bale S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27839
Partex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27833
Postma Holding B.V. / S.ar.l. . . . . . . . . . . . .
27794
Rangiroa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27828
Resan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27817
Sebalea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27836
S.E.C. Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
27819
SIL Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27813
SunlightLuxco-A S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
27830
Supreme Entertainment S.A. . . . . . . . . . . .
27827
Timbor International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
27818
Transurb Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27840
Um Gringert S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27830
Valessore Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
27813
27793
Bizet S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 80.387.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine Schaeffer, de résidence à Luxembourg, en date
du 20 décembre 2007, enregistré à Luxembourg A.C. le 28 décembre 2007, LAC/2007/43736, aux droits de douze euros
(12,- EUR), que la société BIZET S.A., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, R.C.S. Luxembourg
Numéro B 80.387, transférée des Iles Vierges Britanniques au Grand-Duché de Luxembourg par acte de Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 12 janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
722 du 5 septembre 2001.
Les statuts de ladite société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentaire
en date du 26 juin 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2014 du 18 septembre 2007.
a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation
auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Luxembourg, le 28 janvier 2007.
M. Schaeffer
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008024748/5770/26.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN02030. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Postma Holding B.V. / S.ar.l., Société à responsabilité limitée.
Siège de direction effectif: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R.C.S. Luxembourg B 136.082.
STATUTES
In the year two thousand seven, on the thirteenth day of December.
Before Us Maître, Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr. Tjitze Jan Postma, a Dutch citizen, born on November 5, 1967, in Menaldumadeel, the Netherlands, residing at
Avotu iela 9/1, LV-1011, Riga, Latvia.
The appearing party has requested the undersigned notary to record the following:
I. that 100% of the share capital of POSTMA HOLDING B.V., a Dutch private limited liability company, having its
registered office in the Netherlands and its principal office and establishment at Rondeboslaan 35, 9936 BJ Farmsum, the
Netherlands, registered with the commercial register of the Chamber of Commerce in Groningen, the Netherlands under
number 02089991 (the Company) is represented at the present meeting;
II. that by resolution validly adopted by the directors of the Company on December 13, 2007, the Company resolved
to transfer its principal establishment and effective place of management from The Netherlands to Larochette, Grand-
Duchy of Luxembourg as from the date hereof. A copy of said resolution shall remain annexed to the present deed.
III. that it results from the balance sheet of the Company dated November 30, 2007 and of a certificate dated as per
the date hereof, that, as of the date hereof, the net assets of the Company correspond at least to the value of the share
capital of the Company, a copy of such balance sheet and the certificate, after having been signed ne varietur by the
proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the
same time with the registration authorities.
IV. that the sole shareholder of the Company (the Sole Shareholder) resolves as follows:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer the principal office and establishment (but not the registered office (in Dutch:
statutaire zetel) for Dutch corporate law purposes) and the place of effective management of the Company from the
Netherlands to Larochette, Grand-Duchy of Luxembourg as per the date hereof, without the Company being dissolved
but on the contrary with corporate continuance.
27794
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to set the principal office and establishment (but not the registered office (in Dutch:
statutaire zetel) for Dutch corporate law purposes) at 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette, Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves (i) that the Company shall operate in Grand-Duchy of Luxembourg in the form of a
société à responsabilité limitée, and thus, for the purpose of article 159 of the Luxembourg companies law of 10th August,
1915, as amended, but under the understanding that the Company continues to be considered under the laws of the
Netherlands as a validly incorporated Dutch company, (ii) to proceed to an amendment of its articles of association. The
articles of association of the Company shall henceforth read as follows:
Articles of association
Chapter I.
Art. 1. Definitions.
1.1 In these Articles of Association the following words shall have the following meanings:
a. a «Share»:
a share in the capital of the Company;
b. a «Shareholder»:
a holder of one or more Shares;
c. a «General Meeting»:
a meeting of Shareholders and other persons entitled to attend meetings of Shareholders;
d. the «General Meeting of Shareholders»:
the body of the Company consisting of Shareholders entitled to vote;
e. the «Management Board»:
the sole management board member of the Company, if only one member has been appointed and the management
board members of the Company, if more than one member has been appointed;
f. a «Subsidiary»:
a subsidiary of the Company as referred to in Section 2:24a of the Dutch Civil Code;
g. «in writing»:
by letter, by fax, by e-mail, or by message which is transmitted via any other current means of communication and
which can be received in the written form, provided that the identity of the sender can be sufficiently established;
h. the «Distributable Equity»:
the part of the Company's equity which exceeds the aggregate of the issued capital and the reserves which must be
maintained pursuant to the Law;
i. a «Company Body»:
the Management Board or the General Meeting of Shareholders;
j. the «Law»:
any applicable law or regulation.
1.2 References to Articles shall be deemed to refer to articles of these Articles of Association, unless the contrary is
apparent.
Chapter II. Name, Registered offices and Objects
Art. 2. Name, Registered Offices and Duration.
2.1 The company is a private limited liability company (the Company) and its name is:
POSTMA HOLDING B.V. / S.ar.l.
2.2 The registered offices of the Company are in Sappemeer, the Netherlands.
2.3 The principal establishment and place of effective management of the Company shall be in Larochette, Grand Duchy
of Luxembourg.
2.4 The Company may have branch offices elsewhere, also outside the Grand Duchy of Luxembourg.
2.5 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 3. Objects. The objects of the Company are:
a. to acquire participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and
the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange
or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit
and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private
entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise.
27795
It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of
any nature or origin whatsoever;
b. to borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds
and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or to any
other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over
all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of
any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person;
c. to generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient
management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange,
interest rate risks and other risks; and
d. to carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or
movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Chapter III. Share capital, Register of shareholders
Art. 4. Share Capital.
4.1 The authorized and issued capital of the Company equals eighteen thousand euro (EUR 18,000.-).
4.2 The authorized and issued capital of the Company is divided into one hundred eighty (180) Shares with a nominal
value of one hundred euro (EUR 100.-) each.
4.3 All Shares shall be registered. No share certificates shall be issued.
4.4 Towards the Company, the Shares are indivisible. Joint co-owners must appoint a sole person as their represen-
tative towards the Company.
Art. 5. Register of Shareholders.
5.1 Each Shareholder, each pledgee of Shares and each usufructuary of Shares is required to state his address to the
Company in writing.
5.2 The Management Board shall keep a register of Shareholders in which the names and addresses of all Shareholders
are recorded, showing the date on which they acquired the Shares, the date of acknowledgement by or serving upon the
Company and the nominal value paid in on each Share stating that the full nominal amount has been paid in.
5.3 The names and addresses of pledgees and usufructuaries of Shares shall also be entered into the register of Share-
holders, showing the date on which they acquired the right and the date of acknowledgement by or serving upon the
Company.
5.4 On application by a Shareholder or a pledgee or usufructuary of Shares, the Management Board shall furnish an
extract from the register of Shareholders, free of charge, insofar as it relates to the applicant's rights in respect of a Share.
5.5 The register of Shareholders shall be kept accurate and up-to-date. All entries and notes in the register shall be
signed by one or more persons authorized to represent the Company.
5.6 The Management Board shall make the register available at the Company's principal office in Luxembourg, for
inspection by the Shareholders.
Chapter IV. Issuance of shares
Art. 6. Resolution to Issue and Notarial Deed.
6.1 Shares may be issued pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders, taken by a majority in
number of Shareholders owning at least three-quarters of the Company's issued capital. The resolution to issue Shares
shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg.
6.2 A resolution to issue Shares shall stipulate the issue price and the other conditions of issue.
6.3 The issue of a Share shall furthermore require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law
notary registered in the Netherlands, to which deed those involved in the issuance shall be parties.
Art. 7. Rights of Pre-emption.
7.1 Upon issuance of Shares, each Shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nominal
value of his Shares, subject to the provisions of Articles 7.2, 7.3 and 7.4. Shareholders shall have a similar right of pre-
emption if rights are granted to subscribe for Shares.
7.2 Shareholders shall have no right of pre-emption on Shares which are issued to employees of the Company or of
a group company as defined in Section 2:24b of the Dutch Civil Code.
7.3 Prior to each single issuance of Shares, the right of pre-emption may be limited or excluded by the General Meeting
of Shareholders.
7.4 Shareholders shall have no right of pre-emption in respect of Shares which are issued to a person exercising a right
to subscribe for Shares previously granted.
27796
Art. 8. Payment on Shares.
8.1 The full nominal value of each Share must be paid upon issuance.
8.2 Payment on a Share must be made in cash insofar as no non-cash contribution has been agreed on. Payment in
foreign currency may only be made with the approval of the Company and with due observance of the provisions of the
Law.
8.3 Non-cash contributions on Shares are subject to the provisions of the Law.
Chapter V. Own shares, Reduction of the issued capital
Art. 9. Own Shares.
9.1 When issuing Shares, the Company may not subscribe for its own Shares.
9.2 The Company may acquire fully paid in Shares or depositary receipts thereof, with due observance of the limitations
prescribed by the Law.
Art. 10. Financial Assistance.
10.1 The Company may not give security, guarantee the price, or in any other way answer to or bind itself either
severally or jointly for or on behalf of third parties, with a view to a subscription for or an acquisition of Shares or
depositary receipts thereof by others. This prohibition also applies to Subsidiaries.
10.2 The Company may grant loans with a view to a subscription for or an acquisition of Shares or depositary receipts
thereof, but not in excess of the amount of the Distributable Equity.
10.3 The Company shall maintain a non-distributable reserve up to the outstanding amount of the loans referred to
in Article 10.2.
Art. 11. Reduction of the Issued Capital.
11.1 The General Meeting of Shareholders may resolve to reduce the Company's issued capital. The resolution to
reduce the Company's issued capital shall be taken by a majority in number of Shareholders owning at least three-quarters
of the Company's issued capital. The resolution to reduce the Company's issued capital shall require a deed, to be
executed for that purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg.
11.2 The reduction of the Company's issued capital shall be effected in accordance with the relevant provisions pre-
scribed by the Law and be subject to the provisions of the Law.
11.3 The notice of a General Meeting at which a resolution to reduce the Company's issued capital shall be proposed,
shall state the purpose of the capital reduction and the manner in which it is to be achieved. The provisions in these
Articles of Association relevant to a proposal to amend the Articles of Association shall apply by analogy.
Chapter VI. Transfer of shares, Blocking clause
Art. 12. Transfer of Shares; Notarial Deed.
12.1 The transfer of a Share shall require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary
registered in the Netherlands, to which deed those involved in the transfer shall be parties.
12.2 Unless the Company itself is party to the legal act, the rights attributable to the Share can only be exercised after
the Company has acknowledged said transfer or said deed has been served upon it in accordance with the relevant
provisions of the Law.
Art. 13. Blocking Clause (offer to co Shareholders).
13.1 A transfer of one or more Shares can only be effected with due observance of the provisions set out in this Article
13, unless (i) all co Shareholders have approved the intended transfer in writing, which approval shall then be valid for a
period of three months, or (ii) the Shareholder concerned is obliged by Law to transfer his Shares to a former Shareholder.
13.2 A Shareholder wishing to transfer one or more of his Shares (hereinafter: the «Offeror») shall first offer to sell
such Shares to his co-Shareholders. Such offer shall be made by the Offeror by means of a written notification to the
Management Board, stating the number of Shares he wishes to transfer. Within two weeks of receipt of this notification,
the Management Board shall give notice of the offer to the co-Shareholders. Co-Shareholders interested in purchasing
one or more of the Shares on offer (hereinafter: «Interested Parties») must notify the Management Board within one
month after said notices from the Management Board have been sent; notifications from co-Shareholders received later
shall not be taken into account. If the Company itself is a co-Shareholder, it shall only be entitled to act as an Interested
Party with the consent of the Offeror, subject to the provisions of the Law.
13.3 The price at which the Shares on offer can be purchased by the Interested Parties shall be mutually agreed between
the Offeror and the Interested Parties or by one or more experts appointed by them. If they do not reach agreement
on the price or on the expert or experts, as the case may be, the price shall be set by one or more independent experts
to be appointed on the request of one or more of the parties concerned by the chairman of the International Chamber
of Commerce. If an expert is appointed, he shall be authorized to inspect all books and records of the Company and to
obtain all such information as will be useful to him in setting the price.
13.4 Within one month of the price being set, the Interested Parties must give notice to the Management Board of
the number of the Shares on offer they wish to purchase. An Interested Party who fails to submit notice within said term
27797
shall no longer be counted as an Interested Party. Once the notice mentioned in the preceding sentence has been given,
an Interested Party can only withdraw with the consent of the other Interested Parties.
13.5 If the Interested Parties wish to purchase more Shares in the aggregate than have been offered, the Shares on
offer shall be distributed among them. The Interested Parties shall determine the distribution by mutual agreement. If
they do not reach agreement on the distribution within two weeks from the notice to the Management Board referred
to in Article 13.4, the Shares on offer shall be distributed among them by the Management Board, as far as possible in
proportion to the shareholding of each Interested Party at the time of the distribution. However, the number of Shares
on offer allocated to an Interested Party cannot exceed the number of Shares he wishes to purchase.
13.6 The Offeror may withdraw his offer up to one month after the day on which he is informed to which Interested
Party or Parties he can sell all the Shares on offer and at what price.
13.7 All notifications and notices referred to in this Article 13 shall be made by certified mail or against acknowledge-
ment of receipt. Each time the Management Board receives such notification or notice, it shall immediately send a copy
thereof to the Offeror and all Interested Parties (with the exception of the sender), unless indicated otherwise hereina-
bove.
13.8 All costs of the appointment of the expert or experts, as the case may be, and their determination of the price,
shall be borne by:
a. the Offeror if he withdraws his offer;
b. the Offeror and the buyers for equal parts if the Shares have been purchased by one or more Interested Parties,
provided that these costs shall be borne by the buyers in proportion to the number of Shares purchased;
c. the Company if the offer has not been accepted in full or only in part.
13.9 The transfer of Shares shall furthermore be subject to the transfer restrictions provided by the Law.
13.10 The preceding provisions of this Article 13 shall apply by analogy to any right to subscribe for Shares and any
right accruing from a Share, except any right to a payable distribution in cash.
Chapter VII. Pledging of shares and usufruct in shares, Depositary receipts for shares
Art. 14. Pledging of Shares and Usufruct in Shares.
14.1 The provisions of Article 12 shall apply by analogy to the pledging of Shares and to the creation or transfer of a
usufruct in Shares. The pledging of Shares and the creation or transfer of a usufruct in Share shall furthermore be subject
to the relevant provisions prescribed by the Law.
14.2 On the creation of a right of pledge in a Share and on the creation or transfer of a usufruct in a Share, the voting
rights attributable to such Share may be assigned to the pledgee or the usufructuary with due observance of the Law.
Art. 15. Depositary Receipts for Shares. The Company shall not cooperate in the issuance of depositary receipts for
Shares.
Chapter VIII. The Management Board
Art. 16. Management Board Members.
16.1 The Management Board shall be composed of A managers and B managers. Both individuals and legal entities can
be Management Board members.
16.2 Management Board members are appointed by the General Meeting of Shareholders for an indefinite period.
16.3 A Management Board member may be suspended or dismissed by the General Meeting of Shareholders at any
time.
16.4 Any suspension may be extended one or more times, but may not last longer than three months in the aggregate.
If, at the end of that period, no decision has been taken on termination of the suspension or on dismissal, the suspension
shall end.
16.5 The authority to establish remuneration and other conditions of employment for Management Board members
is vested in the General Meeting of Shareholders.
Art. 17. Duties, Decision-making Process and Allocation of Duties.
17.1 The Management Board shall be entrusted with the management of the Company.
17.2 When making Management Board resolutions, each Management Board member may cast one vote.
17.3 All resolutions of the Management Board shall be adopted by a majority of the votes cast in a meeting where the
majority of the managers present or represented.
17.4 Management Board resolutions may at all times be adopted outside of a meeting, in writing or otherwise, provided
the proposal concerned is submitted to all Management Board members then in office and none of them objects to this
manner of adopting resolutions. Adoption of resolutions in writing shall be effected by written statements from all Man-
agement Board members then in office.
17.5 Resolutions of the Management Board shall be recorded in a minute book that shall be kept by the Management
Board.
27798
17.6 The Management Board may establish further rules regarding its decision-making process and working methods.
In this context, the Management Board may also determine the duties for which each Management Board member in
particular shall be responsible. The General Meeting of Shareholders may decide that such rules and allocation of duties
must be put in writing and that such rules and allocation of duties shall be subject to its approval.
Art. 18. Representation; Conflicts of Interest.
18.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by by the joint signature of any A manager and
any B manager of the Company.
18.2 The Management Board may appoint officers with limited and specific powers to represent the Company. Each
officer shall be competent to represent the Company, subject to the restrictions imposed on him. The Management Board
shall determine each officer's title. Such officers may be registered at the Commercial Register, if required by Law,
indicating the scope of their power to represent the Company. The authority of an officer thus appointed may not extend
to any transaction where the Company has a conflict of interest with the officer concerned or with one or more Man-
agement Board members.
18.3 In the event of a conflict of interest between the Company and one or more Management Board members, the
provisions of Article 18.1 shall continue to apply unimpaired unless the General Meeting of Shareholders has appointed
one or more other persons to represent the Company in the case at hand or in general in the event of such a conflict,
subject to any provisions prescribed by Law. A resolution of the Management Board with respect to a matter involving
a conflict of interest with one or more Management Board members in a private capacity shall be subject to the approval
of the General Meeting of Shareholders, but the absence of such approval shall not affect the authority of the Management
Board or its members to represent the Company.
18.4 Without regard to whether a conflict of interest exists or not, all legal acts of the Company vis-à-vis a holder of
all of the Shares, or vis-à-vis a participant in a community property, of married or registered non-married partners, of
which all of the Shares form a part, whereby the Company is represented by such Shareholder or one of the participants,
shall be put in writing. For the application of the foregoing sentence, Shares held by the Company or its Subsidiaries shall
not be taken into account.
18.5 The provisions of Article 18.4 do not apply to legal acts which, under their agreed terms, form part of the normal
course of business of the Company.
Art. 19. Approval of Management Board Resolutions.
19.1 The General Meeting of Shareholders may require Management Board resolutions to be subject to its approval.
The Management Board shall be notified in writing of such resolutions, which shall be clearly specified.
19.2 The absence of approval by the General Meeting of Shareholders of a resolution as referred to in this Article 19
shall not affect the authority of the Management Board or its members to represent the Company.
Art. 20. Vacancy or Inability to Act. If a seat is vacant on the Management Board («ontstentenis») or a Management
Board member is unable to perform his duties («belet»), the remaining Management Board members or member shall
be temporarily entrusted with the management of the Company. If all seats in the Management Board are vacant or all
Management Board members or the sole Management Board member, as the case may be, are unable to perform their
duties, the management of the Company shall be temporarily entrusted to one or more persons designated for that
purpose by the General Meeting of Shareholders.
Chapter IX. Financial year and Annual accounts, Profits and Distributions
Art. 21. Financial Year and Annual Accounts.
21.1 The Company's financial year shall be the calendar year.
21.2 Within the period prescribed by the Law, the Management Board shall prepare annual accounts, and shall deposit
the same for inspection by the Shareholders at the Company's principal office.
21.3 The annual accounts shall consist of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes.
21.4 The annual accounts shall be signed by the Management Board members. If the signature of one or more of them
is missing, this shall be stated and reasons for this omission shall be given.
21.5 The Company may, and if the Law so requires shall, appoint an accountant to audit the annual accounts. Such
appointment shall be made by the General Meeting of Shareholders.
21.6 The Company shall ensure that the annual accounts and, insofar as required, the annual report and the information
to be added by virtue of the Law are kept at its office as from the day on which notice of the annual General Meeting is
given. Shareholders may inspect the documents at that place and obtain a copy free of charge.
21.7 The annual accounts, the annual report, the information to be added by virtue of the Law and the audit by an
accountant, as well as deposition of documents at the Commercial Register, shall furthermore be subject to the provisions
of the Law.
Art. 22. Adoption of the Annual Accounts and Discharge.
22.1 The General Meeting of Shareholders shall adopt the annual accounts.
27799
22.2 After adoption of the annual accounts, the General Meeting of Shareholders shall pass a resolution concerning
release of the Managers from liability for the exercise of their duties, insofar as the exercise of such duties is reflected in
the annual accounts or otherwise disclosed to the General Meeting of Shareholders prior to the adoption of the annual
accounts. The scope of a release from liability shall be subject to limitations by virtue of the Law.
Art. 23. Profits and Distributions.
23.1 Out of the net profits earned in a financial year, an amount of five percent (5%) of the net profits shall be added
to a statutory reserve of the Company, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the
Company
23.2 The profits remaining after application of Article 23.1 shall be determined by the General Meeting of Shareholders.
23.3 Distribution of profits shall be made after adoption of the annual accounts if permissible under the Law given the
contents of the annual accounts.
23.4 The General Meeting of Shareholders may resolve to make interim distributions on Shares and/or to make
distributions on Shares at the expense of any reserve of the Company, subject to any applicable provision of the Law.
23.5 Distributions on Shares shall be made payable immediately after the resolution to make the distribution, unless
another date of payment has been determined in the resolution.
23.6 Distributions on Shares may be made only up to an amount which does not exceed the amount of the Distributable
Equity.
23.7 A claim of a Shareholder for payment of a distribution on Shares shall be barred after five years have elapsed.
23.8 In calculating the amount of any distribution on Shares, Shares held by the Company shall be disregarded.
Chapter X. The General Meeting of Shareholders
Art. 24. Annual General Meeting.
24.1 The annual General Meeting shall be held within six months after the end of the financial year.
24.2 The agenda of this annual General Meeting shall contain, inter alia, the following subjects for discussion:
a. discussion of the annual report (unless an exemption under the Law applies to the Company);
b. discussion and adoption of the annual accounts;
c. the granting of discharge to Management Board members;
d. allocation of profits; and
e. other subjects announced with due observance of Article 26.
The agenda does not need to contain the subjects as referred to under a, b, c and d, if it contains a proposal to extend
the period to prepare the annual accounts and (if applicable) to prepare the report, or, if a resolution to that extent has
already been taken.
Art. 25. Other General Meetings.
25.1 Other General Meetings shall be held as often as the Management Board deems such necessary.
25.2 Shareholders representing in the aggregate at least one-tenth of the Company's issued capital may request the
Management Board to convene a General Meeting, stating specifically the subjects to be discussed. If the Management
Board has not given proper notice of a General Meeting within four weeks following receipt of such request such that
the meeting can be held within six weeks after receipt of the request, the applicants shall be authorized to convene a
meeting themselves.
Art. 26. Notice, Agenda and Venue of Meetings.
26.1 Notice of General Meetings shall be given by the Management Board, without prejudice to the provisions of
Article 25.2.
26.2 Notice of the meeting shall be given no later than on the fifteenth day prior to the day of the meeting.
26.3 The notice of the meeting shall specify the subjects to be discussed. Subjects which were not specified in such
notice may be announced at a later date, with due observance of the term referred to in Article 26.2.
26.4 A subject for discussion of which discussion has been requested in writing not later than thirty days before the
day of the meeting by one or more Shareholders who individually or jointly represent at least one percent of the Com-
pany's issued capital, shall be included in the notice or shall be notified in the same way as the other subjects for discussion,
provided that no important interest (zwaarwichtig belang) of the Company dictates otherwise.
26.5 The notice of the meeting shall be sent to the addresses of the Shareholders shown in the register of Shareholders.
26.6 General Meetings are held in the municipality in which, according to these Articles of Association, the Company
has its registered office. General Meetings may also be held in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg or elsewhere,
but in that case valid resolutions of the General Meeting of Shareholders may only be adopted if all of the Company's
issued capital is represented.
27800
Art. 27. Admittance and Rights at Meetings.
27.1 Each Shareholder shall be entitled to attend the General Meetings, to address the meeting and to exercise his
voting rights. Shareholders may be represented in a meeting by a proxy authorized in writing.
27.2 At a meeting, each person present with voting rights must sign the attendance list. The chairperson of the meeting
may decide that the attendance list must also be signed by other persons present at the meeting.
27.3 The Management Board members shall, as such, have the right to give advice in the General Meetings.
27.4 The chairperson of the meeting shall decide on the admittance of other persons to the meeting.
Art. 28. Chairperson and Secretary of the Meeting.
28.1 The chairperson of a General Meeting shall be appointed by more than half of the votes cast by the persons with
voting rights present at the meeting. Until such appointment is made, a Management Board member shall act as chair-
person, or, if no Management Board member is present at the meeting, the eldest person present at the meeting shall
act as chairperson.
28.2 The chairperson of the meeting shall appoint a secretary for the meeting.
Art. 29. Minutes; Recording of Shareholders' Resolutions.
29.1 The secretary of a General Meeting shall keep minutes of the proceedings at the meeting. The minutes shall be
adopted by the chairperson and the secretary of the meeting and as evidence thereof shall be signed by them.
29.2 The chairperson of the meeting or those who convened the meeting may determine that a notarial report must
be prepared of the proceedings at the meeting. The notarial report shall be co-signed by the chairperson of the meeting.
29.3 The Management Board shall keep record of all resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders. If
the Management Board is not represented at a meeting, the chairperson of the meeting shall ensure that the Management
Board is provided with a transcript of the resolutions adopted, as soon as possible after the meeting. The records shall
be deposited at the Company's principal office for inspection by the Shareholders. On application, each of them shall be
provided with a copy of or an extract from the records at not more than the actual cost.
Art. 30. Adoption of Resolutions in a Meeting.
30.1 Each Share confers the right to cast one vote.
30.2 To the extent that the Law or these Articles of Association do not provide otherwise, all resolutions of the
General Meeting of Shareholders shall be adopted by more than half of the votes cast, which majority shall represent at
least one-half of the Company's issued capital. If less than one-half of the Company's issued capital is represented, a new
meeting shall be convened by registered mail at which the resolution shall be adopted by a simple majority of the votes
cast, irrespective of the part of the Company's issued capital represented at such meeting.
30.3 If there is a tie in voting, the proposal shall be deemed to have been rejected.
30.4 If the formalities for convening and holding of General Meetings, as prescribed by Law or these Articles of
Association, have not been complied with, valid resolutions of the General Meeting of Shareholders may only be adopted
in a meeting, if in such meeting all of the Company's issued capital is represented and such resolution is carried by
unanimous vote.
30.5 In the General Meeting, no voting rights may be exercised for any Share held by the Company or a Subsidiary,
nor for any Share for which the Company or a Subsidiary holds the depositary receipts.
30.6 When determining how many votes are cast by Shareholders, how many Shareholders are present or represented,
or which part of the Company's issued capital is represented, no account shall be taken of Shares for which, pursuant to
the Law or these Articles of Association, no vote can be cast.
Art. 31. Voting.
31.1 All voting shall take place orally. The chairperson is, however, entitled to decide that votes be cast by a secret
ballot. If it concerns the holding of a vote on persons, anyone present at the meeting with voting rights may demand a
vote by a secret ballot. For the purposes of this paragraph «in writing» shall mean: by means of secret, unsigned ballot
papers.
31.2 Blank and invalid votes shall not be counted as votes.
31.3 Resolutions may be adopted by acclamation if none of the persons with voting rights present at the meeting
objects.
31.4 The chairperson's decision at the meeting on the result of a vote shall be final and conclusive. The same shall
apply to the contents of an adopted resolution if a vote is taken on an unwritten proposal. However, if the correctness
of such decision is challenged immediately after it is pronounced, a new vote shall be taken if either the majority of the
persons with voting rights present at the meeting or, where the original vote was not taken by roll call or in writing, any
person with voting rights present at the meeting, so demands. The legal consequences of the original vote shall be made
null and void by the new vote.
27801
Art. 32. Adoption of Resolutions without holding Meetings.
32.1 Resolutions of the General Meeting of Shareholders may also be adopted in writing without holding a General
Meeting, provided they are adopted by the unanimous vote of all Shareholders entitled to vote. The provision of Article
27.3 shall apply by analogy.
32.2 Each Shareholder must ensure that the Management Board is informed of the resolutions thus adopted as soon
as possible in writing. The Management Board shall keep record of the resolutions adopted and it shall add such records
to those referred to in Article 29.3.
Chapter XI. Amendment of the Articles of association, Change of corporate form, Dissolution and Liq-
uidation
Art. 33. Amendment of the Articles of Association; Change of Corporate Form.
33.1 The General Meeting of Shareholders may resolve to amend these Articles of Association by a resolution adopted
with a majority in number of Shareholders owning at least three-quarters of the Company's issued capital. The resolution
to amend these Articles of Association shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered
in the Grand Duchy of Luxembourg. When a proposal to amend these Articles of Association is to be made at a General
Meeting, the notice of such meeting must state so and a copy of the proposal, including the verbatim text thereof, shall
be deposited and kept available at the Company's principal office for inspection by the Shareholders, until the conclusion
of the meeting. From the day of deposit until the day of the meeting, a Shareholder shall, on application, be provided with
a copy of the proposal free of charge. An amendment of these Articles of Association shall further be laid down in a deed,
to be executed for that purpose before a civil law notary registered in the Netherlands.
33.2 The Company may change its corporate form into a different legal form. A change of the corporate form shall
require a resolution to change the corporate form, and a resolution to amend these Articles of Association adopted by
the General Meeting of Shareholders, both taken by a majority in number of Shareholders owning at least three-quarters
of the Company's issued capital. A change of the corporate form shall furthermore be subject to the relevant provisions
of the Law. A change of the corporate form shall not terminate the existence of the legal entity.
Art. 34. Dissolution and Liquidation.
34.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the General Meeting of Shareholders.
The resolution to dissolve the Company shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered
in the Grand Duchy of Luxembourg. The proposal to dissolve the Company must be stated in the notice of such meeting.
34.2 If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders, the Management
Board members shall become liquidators of the dissolved Company's property. The General Meeting of Shareholders
may decide to appoint other persons as liquidators.
34.3 During liquidation, the provisions of these Articles of Association shall remain in force to the extent possible.
34.4 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be transferred to the Share-
holders in proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each.
34.5 In addition, the liquidation shall be subject to the relevant provisions of the Law.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves (i) to acknowledge the resignation, effective as of the date hereof, of Mr. T.J. Postma,,
as managing director of the Company and to grant him/them full discharge for the performance of his duties as manager
of the Company, and (ii) to appoint, effective as of the date hereof, the following persons as managers of the Company
for a period of 5 years:
1. A Managers:
(a) Mr. Albert Seen, residing at 17 Leedebach, L-7618 Larochette, Luxembourg, and
(b) SuxesKey S.A., a Luxembourg public limited company (société anonyme) having its registered office at 10-12, rue
de Medernach, L-7619 Larochette, Luxembourg.
2. B Manager:
(a) Mr. T.J. Postma, a Dutch citizen, born on November 5, 1967, in Menaldumadeel, the Netherlands, residing at Avotu
iela 9/1, LV-1011, Riga, Latvia.
<i>Estimate of costsi>
The Company has been subject to capital duty in the Netherlands, an EU Member State, and therefore no Luxembourg
capital duty shall be due on this transfer of the place of effective management of the Company from the Netherlands to
Luxembourg. Reference is made to article 3 (2) of the Law of 29th December 1971.
The amount of the expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately EUR 6,000.-
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the same appearing party, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the German texts, the English version shall prevail.
27802
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with us,
the notary, the present original deed.
The German Translation follows:
Im Jahr zweitausendsieben, am dreizehnten Dezember,
Vor mir, Maître Henri Hellinckx, Notar, wohnhaft in Luxemburg:
Erschien:
Herr Tjitze Jan Postma, ein holländischer Bürger, geboren in Menaldumadeel, Niederlande, am 5. November 1967,
wohnhaft in Avotu iela 9/1, LV-1011, Riga, Lettland,
Die erschienene Partei bat den unterzeichneten Notar Folgendes aufzuzeichnen:
I. 100% des Stammkapitals der POSTMA HOLDING B.V., einer niederländischen Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung, mit Sitz in den Niederlanden und Hauptniederlassung in Rondeboslaan 35, 9936 BJ Farmsum, Niederlande, unter
der Nummer 02089991 (die Gesellschaft) beim Handelsregister der Industrie- und Handelskammer Groningen, Nieder-
lande, eingetragen, werden bei der gegenwärtigen Sitzung vertreten;
II. Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft vom 13. Dezember 2007, hat die Gesellschaft beschlossen
die Hauptniederlassung und das Unternehmen sowie den Ort der tatsächlichen Verwaltung der Gesellschaft von den
Niederlanden nach Larochette, Luxemburg zu verlegen, mit Wirkung zum heutigen Tage.
III. der Bilanz der Gesellschaft, datiert vom 30. November 2007, und einer Bestätigung zum Datum des vorliegenden
Dokuments, sind zu entnehmen, dass das Nettovermögen der Gesellschaft zum gegenwärtigen Datum mindestens dem
Wert des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht, wobei eine Kopie der Bilanz und der Bestätigung, nachdem sie durch
die Bevollmächtigte der erschienenen Parteien und dem unterzeichneten Notar «ne varietur» unterzeichnet worden sind,
an der vorliegenden Urkunde angeheftet wird und gleichzeitig mit dieser den Registrierungsbehörden vorgelegt wird;
IV. der Alleinaktionär der Gesellschaft (der Alleinaktionär) beschließt Folgendes:
<i>Erster Beschlussi>
Der Alleinaktionär beschließt, die Hauptniederlassung und das Unternehmen (jedoch nicht den Gesellschaftssitz (auf
Niederländisch: statutaire zetel) zu Zwecken des niederländischen Gesellschaftsrechts) sowie den Ort der tatsächlichen
Verwaltung des Gesellschaft zum Datum des vorliegenden Dokuments von den Niederlanden nach Larochette zu verle-
gen, ohne, dass die Gesellschaft aufgelöst wird, sondern weiterhin bestehen bleibt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Alleinaktionär beschließt, die Hauptniederlassung und das Unternehmen (jedoch nicht den Gesellschaftssitz (auf
Niederländisch: statutaire zetel) zu Zwecken des niederländischen Gesellschaftsrechts) nach 10-12, rue de Medernach,
L-7619 Larochette, Luxemburg, zu verlegen.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Alleinaktionär beschließt, (i) dass die Gesellschaft in Larochette, Luxemburg in der Form einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung betrieben wird, und zwar im Sinne des Artikels 159 des luxemburgischen Gesellschaftsrechts vom
10. August 1915 in der geänderten Fassung, jedoch mit der Vereinbarung, dass die Gesellschaft nach der niederländischen
Gesetzgebung weiterhin eine gültig eingetragene niederländische Gesellschaft bleibt; (ii) eine Änderung der Gesellschafts-
satzung vorzunehmen. Die Satzung der Gesellschaft lautet fortan wie folgt:
Satzung
Kapitel I.
Art. 1. Begriffsbestimmungen.
1.1 In der vorliegenden Satzung entsprechen folgende Begriffe folgender Bedeutung:
a. ein «Anteil (Aktie)»:
ein Anteil am Kapital der Gesellschaft (Aktie);
b. ein «Aktionär»:
ein Inhaber einer oder mehrerer Aktien;
c. eine «Hauptversammlung»:
eine Versammlung der Aktionäre und anderer Personen, die an der Aktionärsversammlung teilnehmen dürfen;
d. die «Hauptversammlung der Aktionäre»:
das Gesellschaftsorgan, das aus stimmberechtigten Aktionären besteht;
e. der «Geschäftsführung (Management Board)»:
der alleinige Geschäftsführer der Gesellschaft, sofern ein einziges Mitglied ernannt worden ist, und der Geschäftsfüh-
rungsrat der Gesellschaft, sofern mehr als ein Mitglied ernannt worden ist;
f. eine «Tochtergesellschaft»:
27803
eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft gemäß Paragraf 2:24a des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches;
g. «schriftlich»:
per Brief, Fax, E-Mail oder Nachricht, die mit Hilfe eines anderen aktuellen Kommunikationsmittels übermittelt und
in schriftlicher Form empfangen wurde, vorausgesetzt, dass die Identität des Absenders ausreichend festgestellt werden
kann;
h. das «Ausschüttbare Kapital»:
der Teil des Kapitals der Gesellschaft, der das gesamte ausgegebene Kapital und die Rücklagen, welche den gesetzlichen
Vorschriften entsprechen, übersteigt;
i. ein «Gesellschaftsorgan»:
der Geschäftsführungsrat oder die Hauptversammlung der Aktionäre;
j. das «Gesetz»:
jedwede geltende Gesetzgebung oder Regelung.
1.3 Bezugnahmen auf die Satzung gelten als Bezugnahmen auf die Artikel dieser Satzung, sofern nichts Gegenteiliges
ersichtlich ist.
Kapitel II. Firmenbezeichnung, Sitz und Gegenstand
Art. 2. Firmenbezeichnung, Sitz und Dauer.
2.1 Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die Gesellschaft) und ihre Firmenbezeichnung
lautet:
POSTMA HOLDING B.V. / S.ar.l.
2.2 Der Sitz der Gesellschaft ist in Sappemeer, Niederlande.
2.3 Die Hauptniederlassung und der Ort der tatsächlichen Verwaltung der Gesellschaft befinden sich in Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.
2.4 Die Gesellschaft kann andernorts, auch außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, Zweigniederlassungen führen.
2.5 Die Gesellschaft besteht auf unbegrenzte Dauer.
Art. 3. Gegenstand. Der Gegenstand der Gesellschaft ist folgender:
a. der Erwerb von Beteiligungen, in Luxemburg oder im Ausland, an jeder Art von Gesellschaften oder Gesellschaft
auf jede Art und Weise, sowie die Verwaltung derartiger Beteiligungen. Die Gesellschaft kann insbesondere durch die
Zeichnung, den Erwerb und den Tausch oder auf jede andere Art alle Arten von Wertpapieren, Aktien oder andere
Beteiligungssicherheiten, Obligationen, Schuldverschreibungen, Hinterlegungsscheine und andere Schuldinstrumente und
im Allgemeinen alle Sicherheiten und Finanzinstrumente, ausgegeben durch jede öffentliche oder private Einheit, erwer-
ben. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, der Entwicklung, der Führung und der Kontrolle jeder Art von
Gesellschaft oder Unternehmen beteiligen. Darüber hinaus kann sie sich an dem Erwerb und der Verwaltung eines Port-
folios von Patenten oder sonstigen gewerblichen Schutz- und Urheberrechten jedweder Art oder jedweden Ursprungs
beteiligen;
b. die Aufnahme von Krediten in jeglicher Form, außer über das öffentliche Angebot. Sie kann, ausschließlich über
private Anlagen, Noten, Obligationen und Schuldverschreibungen und jede Art von Kredit und/oder Dividendenpapier
herausgeben. Die Gesellschaft kann Kapital einschließlich, und ohne Einschränkung, des Erlöses jeden Kredites und/oder
Erträge von Anleihen ihren Tochtergesellschaften, Zweigstellen und/oder jeder anderen Gesellschaft leihen. Sie kann auch
Garantien und Bürgschaften geben, übertragen, belasten oder sonst schaffen und Sicherheiten für die Gesamtheit oder
über einen Teil ihres Vermögens anerkennen, ihre eigenen Verpflichtungen und Unternehmen und/oder Verpflichtungen
und Unternehmen jeder anderen Gesellschaft und, allgemein, zu ihrem eigenen Vorteil und/oder zum Vorteil jeder an-
deren Gesellschaft oder Person garantieren;
c. die Gesellschaft kann zum Zweck der Förderung eines effizienten Managements im Allgemeinen jede Technik und
jedes Instrument anwenden, welches mit ihren Investitionen zusammenhängt, einschließlich Techniken und Instrumenten,
die darauf ausgelegt sind, die Gesellschaft gegen Kreditrisiken, Währungsschwankungen, riskante Zinssätze und andere
Risiken, zu schützen; und
e. die Gesellschaft kann jede Art von kommerzieller oder finanzieller Tätigkeit in Zusammenhang mit Grundstücken
oder beweglichem Eigentum ausüben, welche direkt oder indirekt ihren Gesellschaftszweck fördert oder im Bezug dazu
steht.
Kapitel III. Stammkapital, Aktionärsregister
Art. 4. Stammkapital.
4.1 Das genehmigte und ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt achtzehntausend Euro (EUR 18.000,-).
4.2 Das genehmigte und ausgegebene Kapital der Gesellschaft wird auf einhundertachzig (180) Aktien mit einem No-
minalwert von jeweils hundert Euro (EUR 100,-) verteilt.
4.3 Sämtliche Aktien sind Namensaktien. Es werden keine Aktienzertifikate ausgegeben.
27804
4.5 Gegenüber der Gesellschaft sind die Aktien unteilbar. Gemeinsame Mitinhaber müssen eine einzelne Person zu
ihrem Vertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen.
Art. 5. Aktionärsregister.
5.1 Jeder Aktionär, Pfandinhaber von Aktien und jeder Nießbraucher von Aktien ist verpflichtet, der Gesellschaft seine
Anschrift schriftlich mitzuteilen.
5.2 Der Geschäftsführungsrat führt ein Aktionärsregister, in dem die Namen und Anschriften sämtlicher Aktionäre
aufgezeichnet sind, einschließlich des Datums, an dem die Aktien erworben wurden, des Datums der Bestätigung durch
die Gesellschaft oder der Zustellung an die Gesellschaft sowie des gezahlten Nominalwerts für jede einzelne Aktie und
der Angabe, dass der volle Nominalbetrag eingezahlt wurde.
5.3 Die Namen und Anschriften der Pfandinhaber und Nießbraucher von Aktien sind ebenfalls in das Aktionärsregister
einzutragen, und zwar unter Angabe des Datums, an dem das Recht erworben wurde und des Datums der Bestätigung
durch die Gesellschaft oder der Zustellung an die Gesellschaft.
5.4 Auf Antrag eines Aktionärs oder eines Pfandinhabers oder eines Nießbrauchers stellt der Geschäftsführungsrat
kostenlos einen Auszug aus dem Aktionärsregister zur Verfügung, sofern er sich auf die Rechte des Antragstellers in Bezug
auf eine Aktie bezieht.
5.5 Das Aktionärsregister ist stets präzise zu führen und zu aktualisieren. Sämtliche Eintragungen in das Register sind
von einer Person oder von mehreren Personen zu unterzeichnen, die zur Vertretung der Gesellschaft befugt ist/sind.
5.7 Der Geschäftsführungsrat legt das Register in der Hauptniederlassung der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch
die Aktionäre aus.
Kapitel IV. Ausgabe von Aktien
Art. 6. Beschluss zur Ausgabe von Aktien und notarielle Beurkundung.
6.1 Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß eines Beschlusses der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher durch die
zahlenmäßige Mehrheit der Aktionäre gefasst wird, die mindestens drei Viertel des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft
besitzen. Der Beschluss zur Ausgabe von Aktien ist zu diesem Zweck vor einem Notar, der im Großherzogtum Luxemburg
registriert ist, zu beurkunden.
6.2 Der Beschluss zur Ausgabe von Aktien umfasst den Ausgabepreis und weitere Ausgabebedingungen.
6.4 Die Ausgabe einer Aktie erfordert überdies die Erstellung einer notariellen Urkunde, die zu diesem Zweck vor
einem in den Niederlanden registrierten Notar rechtsgültig auszufertigen ist, und in der die an der Ausgabe beteiligten
Personen als Parteien aufzuführen sind.
Art. 7. Vorkaufsrechte.
7.1 Bei der Ausgabe von Aktien hat jeder Aktionär ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zur Gesamtheit des Nominalwertes
seiner Aktien gemäß den Bestimmungen der Artikel 7.2, 7.3 und 7.4. Die Aktionäre haben ein ähnliches Vorkaufsrecht,
wenn Rechte zur Zeichnung von Aktien gewährt werden.
7.2 Die Aktionäre haben gemäß Paragraf 2:24b des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches kein Vorkaufsrecht
auf Aktien, die an Mitarbeiter der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft ausgegeben werden.
7.3 Vor jeder einzelnen Aktienausgabe kann das Vorkaufsrecht durch die Hauptversammlung der Aktionäre beschränkt
oder ausgeschlossen werden.
7.5 Die Aktionäre haben kein Vorkaufsrecht auf Aktien, die an Personen ausgegeben werden, welche ein zuvor ge-
währtes Recht zur Zeichnung von Aktien ausüben.
Art. 8. Einzahlung der Aktien.
8.1 Der volle Nominalwert jeder Aktie ist bei Ausgabe einzuzahlen.
8.2 Die Einzahlung der Aktie erfolgt in bar, sofern kein unbarer Beitrag vereinbart worden ist. Eine Einzahlung in
Fremdwährung findet nur nach Genehmigung der Gesellschaft und mit sorgfältiger Einhaltung der gesetzlichen Bestim-
mungen statt.
8.4 Unbare Zahlungen für Aktien unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen.
Kapitel V. Eigene Aktien, Reduzierung des ausgegebenen Kapitals
Art. 9. Eigene Aktien.
9.1 Bei einer Aktienausgabe darf die Gesellschaft keine eigenen Aktien zeichnen.
9.3 Die Gesellschaft kann voll eingezahlte Aktien oder Hinterlegungsscheine derselben erwerben, sofern die gesetzlich
vorgeschriebenen Beschränkungen eingehalten werden.
Art. 10. Finanzielle Unterstützung.
10.1 Die Gesellschaft darf keine Sicherheiten geben, den Preis garantieren oder in anderer Weise agieren oder weder
selbst noch allein oder gemeinsam mit Anderen für oder im Namen Dritter eine Verpflichtung zwecks Zeichnung oder
Erwerb von Aktien oder Hinterlegungsscheine derselben durch Andere eingehen. Dieses Verbot gilt ebenfalls für Toch-
tergesellschaften.
27805
10.2 Die Gesellschaft kann Darlehen zwecks Zeichnung oder Erwerb von Aktien oder Hinterlegungsscheine derselben
gewähren, die jedoch nicht höher als der Betrag des Ausschüttbaren Kapitals sein dürfen.
10.4 Die Gesellschaft bildet nicht ausschüttbare Rücklagen bis zur Höhe des ausstehenden Betrags der in Artikel 10.2
erwähnten Darlehen.
Art. 11. Reduzierung des ausgegebenen Kapitals.
11.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann beschließen, das ausgegebene Kapital der Gesellschaft zu reduzieren.
Der Beschluss zur Reduzierung des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft ist von der zahlenmäßigen Mehrheit der
Aktionäre zu fassen, die mindestens drei Viertel des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft besitzen. Der Beschluss zur
Reduzierung des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft ist zu diesem Zweck vor einem im Großherzogtum Luxemburg
registrierten Notar zu beurkunden.
11.2 Die Reduzierung des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit den relevanten
gesetzlichen Bestimmungen und ist nach diesen zu regeln.
11.4 Die Mitteilung zur Hauptversammlung, in der ein Beschluss zur Reduzierung des ausgegebenen Kapitals der Ge-
sellschaft vorzuschlagen ist, erwähnt den Zweck der Kapitalreduzierung und die Art und Weise, in der diese zu erreichen
ist. Die Bestimmungen dieser Satzung in Bezug auf einen Vorschlag zur Änderung der Satzung gelten in Analogie.
Kapitel VI. Übertragung von Aktien, Sperrklausel
Art. 12. Übertragung von Aktien; notarielle Beurkundung.
12.1 Die Übertragung von Aktien erfordert eine notarielle Urkunde, die zu diesem Zweck vor einem in den Nieder-
landen registrierten Notar rechtsgültig auszufertigen ist und in der sämtliche an der Übertragung beteiligten Personen als
Parteien aufzuführen sind.
12.3 Sofern die Gesellschaft nicht selbst Partei dieser Rechtshandlung ist, können die der Aktie zurechenbaren Rechte
nur dann ausgeübt werden, nachdem die Gesellschaft die besagte Übertragung bestätigt hat oder nachdem die besagte
Urkunde in Übereinstimmung mit den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen zugestellt worden ist.
Art. 13. Sperrklausel (Angebot an Mitaktionäre).
13.1 Eine Übertragung einer oder mehrerer Aktien wird nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des vorlie-
genden Artikels 13 ausgeführt, sofern nicht (i) sämtliche Mitaktionäre der beabsichtigten Übertragung schriftlich zuge-
stimmt haben, wobei die besagte Zustimmung für einen Zeitraum von drei Monaten gültig ist, oder (ii) der betreffende
Aktionär gesetzlich verpflichtet ist, seine Aktien an einen früheren Aktionär zu übertragen.
13.2 Ein Aktionär, der eine oder mehrere Aktien übertragen möchte (im Folgenden als «Anbieter» bezeichnet), bietet
diese Aktien zunächst seinen Mitaktionären zum Verkauf an. Ein derartiges Angebot erfolgt mittels einer schriftlichen
Mitteilung seitens des Anbieters an den Geschäftsführungsrat unter Angabe der Anzahl der Aktien, die er übertragen
möchte. Innerhalb von zwei Wochen nach Eingang dieser Mitteilung gibt der Geschäftsführungsrat den Mitaktionären
dieses Angebot bekannt. Die Mitaktionäre, die am Kauf einer oder mehrerer Aktien aus diesem Angebot interessiert sind
(im Folgenden als «interessierte Parteien» bezeichnet) informieren den Geschäftsführungsrat innerhalb von einem Monat
nach Übermittlung besagter Bekanntgabe durch den Geschäftsführungsrat; Mitteilungen seitens der Mitaktionäre, die zu
einem späteren Zeitpunkt eingehen, werden nicht berücksichtigt. Wenn die Gesellschaft selbst Mitaktionär ist, ist sie nur
nach Zustimmung des Anbieters und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, als interessierte Partei zu fun-
gieren.
13.3 Der Preis, zu dem die angebotenen Aktien durch die interessierten Parteien erworben werden können, wird
zwischen dem Anbieter und den interessierten Parteien oder einem oder mehreren von ihnen ernannten Sachverstän-
digen vereinbart. Wird keine Vereinbarung über den Preis oder über den Sachverständigen bzw. die Sachverständigen
erreicht, ist der Preis durch einen oder durch mehrere unabhängige Sachverständige festzulegen, die auf Antrag einer
oder mehrerer betreffender Parteien vom Vorsitzenden der Internationalen Handelskammer zu ernennen sind. Wird ein
Sachverständiger ernannt, so ist er befugt, sämtliche Bücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft einzusehen und sämt-
liche Informationen einzuholen, die er für die Festlegung des Preises als nützlich erachtet.
13.4 Innerhalb eines Monats nachdem der Preis festgelegt worden ist, teilen die interessierten Parteien dem Ge-
schäftsführungsrat die Anzahl der angebotenen Aktien mit, die sie erwerben möchten. Interessierte Parteien, die es
versäumen, ihre Kaufabsicht innerhalb des besagten Zeitraums mitzuteilen, werden nicht länger als interessierte Parteien
erachtet. Wurde die vorerwähnte Mitteilung einmal zugestellt, kann eine interessierte Partei nur nach Zustimmung der
anderen interessierten Parteien ihre Mitteilung wieder zurückziehen.
13.5 Wenn die interessierten Parteien insgesamt mehr als die angebotenen Aktien erwerben möchten, sind die ange-
botenen Aktien unter ihnen zu teilen. Die interessierten Parteien bestimmen die Teilung in gegenseitigem Einvernehmen.
Wenn sie innerhalb von zwei Wochen nach Mitteilung an den Geschäftsführungsrat gemäß Artikel 13.4 keine Vereinbarung
über die Teilung erreichen können, sind die angebotenen Aktien durch den Geschäftsführungsrat unter ihnen aufzuteilen,
und zwar nach Möglichkeit im Verhältnis zur Aktienbeteiligung der einzelnen interessierten Parteien zum Zeitpunkt der
Teilung. Die Anzahl der angebotenen Aktien, die einer interessierten Partei zugeteilt werden, kann jedoch in keinem Fall
die Anzahl der Aktien übersteigen, die sie erwerben möchte.
27806
13.6 Der Anbieter kann sein Angebot bis zu einem Monat nach dem Tag, an dem er informiert wurde, an welche
interessierte Partei bzw. interessierten Parteien er sämtliche angebotenen Aktien zu welchem Preis verkaufen kann,
zurückziehen.
13.7 Sämtliche in diesem Artikel 13 erwähnten Mitteilungen und Bekanntgaben erfolgen per Einschreiben oder mit
Eingangsbestätigung. Jedes Mal, wenn der Geschäftsführungsrat eine derartige Mitteilung oder Bekanntgabe erhält, über-
mittelt er unverzüglich eine Kopie derselben an den Anbieter und an sämtliche interessierten Parteien (mit Ausnahme
des Absenders), sofern an anderer Stelle nichts Gegenteiliges angegeben wird.
13.8 Sämtliche Kosten der Bestellung eines Sachverständigen bzw. mehrerer Sachverständige und deren Festlegung
des Preises gehen zu Lasten
a. des Anbieters, wenn er sein Angebot zurückzieht;
b. des Anbieters und der Käufe zu gleichen Teilen, wenn die Aktien durch einen oder mehrere interessierte Parteien
erworben wurden, vorausgesetzt, dass diese Kosten von den Käufern im Verhältnis zur Anzahl der erworbenen Aktien
getragen werden;
c der Gesellschaft, wenn das Angebot nicht vollständig oder nur teilweise angenommen wurde.
13.9 Überdies unterliegt die Übertragung der Aktien den gesetzlichen Übertragungsbeschränkungen.
13.10 Die vorhergehenden Bestimmungen des vorliegenden Artikels 13 gelten in Analogie zu jedem Recht zur Zeich-
nung von Aktien und jedem Recht, das aus einer Aktie erwächst, ausgenommen jedweder Rechte auf eine in bar zahlbare
Ausschüttung.
Kapitel VII. Verpfändung von Aktien und Niessbrauch von Aktien, Hinterlegungsscheine für Aktien
Art. 14. Verpfändung von Aktien und Nießbrauch von Aktien.
14.1 Die Bestimmungen des Artikels 12 gelten in Analogie zur Verpfändung von Aktien und zur Entstehung oder
Übertragung eines Nießbrauchs von Aktien. Die Verpfändung von Aktien und die Entstehung oder Übertragung eines
Nießbrauchs von Aktien unterliegt überdies den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.
14.3 Bei der Entstehung eines Pfandrechts an einer Aktie und bei der Entstehung oder Übertragung eines Nießbrauchs
einer Aktie können die dieser Aktie zurechenbaren Stimmrechte an den Pfandnehmer oder dem Nießbraucher unter
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen übertragen werden.
Art. 15. Hinterlegungscheine für Aktien. Die Gesellschaft ist an der Ausgabe von Hinterlegungsschreinen für Aktien
nicht beteiligt.
Kapitel VIII. Der Geschäftsführungsrat (Management Board)
Art. 16. Die Geschäftsführer.
16.1 Der Geschäftsführungsrat besteht aus Geschäftsführern der Kategorie A und der Kategorie B. Sowohl natürliche
als auch juristische Personen können Geschäftsführer sein.
16.2 Der Geschäftsführungsrats wird durch die Hauptversammlung der Aktionäre auf unbestimmte Dauer gewählt.
16.3 Die Mitgliedschaft der einzelnen Geschäftsführer kann durch die Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit
vorübergehend suspendiert oder gekündigt werden.
16.4 Eine Suspension kann ein- oder mehrmalig verlängert werden, sie darf jedoch insgesamt nicht länger als drei
Monate betragen. Sollte am Ende dieses Zeitraums keine Entscheidung über eine Beendigung der Suspension oder eine
Kündigung getroffen worden sein, so endet die Suspension.
16.6 Die Befugnis zur Festlegung der Vergütungshöhe und sonstiger Beschäftigungsbedingungen für Geschäftsführer
wird in der Hauptversammlung der Aktionäre verliehen.
Art. 17. Pflichten, Entscheidungsprozess und Zuweisung von Pflichten.
17.1 Der Geschäftsführungsrat wird mit der Leitung der Gesellschaft betraut.
17.2 Bei Beschlüssen des Geschäftsführungsrats kann jeder Geschäftsführer eine Stimme abgeben.
17.3 Sämtliche Beschlüsse des Geschäftsführungsrats sind von der Stimmenmehrheit bei einer Versammlung, in der
die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist oder repräsentiert wird, anzunehmen.
17.4 Beschlüsse des Geschäftsführungsrats können jederzeit außerhalb einer Versammlung, schriftlich oder anderwei-
tig, erfasst werden, vorausgesetzt, dass der betreffende Vorschlag sämtlichen Geschäftsführer im Amt unterbreitet
worden ist und keines von ihnen Einwände gegen diese Art der Beschlussfassung vorbringt. Die schriftliche Beschluss-
fassung erfolgt mittels schriftlicher Äußerung seitens sämtlicher Geschäftsführer, die zum entsprechenden Zeitpunkt im
Amt sind.
17.5 Beschlüsse des Geschäftsführungsrats sind in einem Protokollbuch aufzuzeichnen, das vom Geschäftsführungsrat
geführt wird.
17.7 Der Geschäftsführungsrat kann weitere Regeln hinsichtlich seines Entscheidungsprozesses und seiner Arbeits-
methoden festlegen. In diesem Zusammenhang kann der Geschäftsführungsrat ebenfalls die Pflichten der einzelnen
Geschäftsführer bestimmen. Die Hauptversammlung der Aktionäre kann entscheiden, dass derartige Regeln und Zuwei-
sungen der Pflichten schriftlich zu formulieren sind und ihrer Zustimmung unterliegen.
27807
Art. 18. Vertretung; Interessenskonflikte.
18.1 Die Gesellschaft wird vertreten durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie A und
eines Geschäftsführers der Kategorie B der Gesellschaft Dritten gegenüber in allen Augelegenheiten.
18.2 Der Geschäftsführungsrat kann Direktoren mit begrenzten und spezifischen Befugnissen zur Vertretung der Ge-
sellschaft ernennen. Jeder Direktor ist im Rahmen der ihm auferlegten Beschränkungen ermächtigt, die Gesellschaft zu
vertreten. Der Geschäftsführungsrat legt die Bezeichnung der einzelnen Direktoren fest. Diese Direktoren können unter
Angabe des Umfangs ihrer Vollmacht zur Vertretung der Gesellschaft, sofern gesetzlich erforderlich, im Handelsregister
eingetragen werden. Die Befugnis eines auf diese Weise ernannten Direktors darf sich nicht auf Geschäftsvorgänge er-
strecken, die zu einem Konflikt zwischen der Gesellschaft und dem betreffenden Direktor oder einem Geschäftsführer
bzw. mehreren Geschäftsführern führen.
18.3 Im Falle eines Interessenskonflikts zwischen der Gesellschaft und einem Mitglied bzw. mehreren Mitgliedern des
Geschäftsführungsrats gelten die Bestimmungen des Artikels 18.1 weiterhin unbeeinträchtigt, sofern die Hauptversamm-
lung der Aktionäre nicht einen oder mehrere Personen zur Vertretung der Gesellschaft für diesen Fall oder für den
Konfliktfall im Allgemeinen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ernannt hat. Ein Beschluss des Geschäftsführungsrats
in Bezug auf eine Angelegenheit, die zu einem Interessenskonflikt mit einem Mitglied bzw. mit mehreren Mitgliedern des
Geschäftsführungsrats auf privater Ebene führen könnte, unterliegt der Genehmigung durch die Hauptversammlung der
Aktionäre; die Ermangelung einer derartigen Genehmigung beeinflusst jedoch nicht die Befugnis des Geschäftsführungsrats
oder seiner Mitglieder zur Vertretung der Gesellschaft.
18.4 Ungeachtet dessen, ob ein Interessenskonflikt besteht oder nicht, sind sämtliche Rechtsgeschäfte der Gesellschaft
mit einem Inhaber der gesamten Aktien oder einem Beteiligten an einem Gemeindeeigentum, seitens verheirateter oder
registrierter nicht verheirateter Partner, deren gesamte Aktien einen Teil bilden, wodurch die Gesellschaft durch diesen
Aktionär oder einen der Beteiligten vertreten wird, schriftlich zu formulieren. Im Sinne des vorhergehenden Satzes sind
Aktien, die durch die Gesellschaft oder ihre Tochtergesellschaften gehalten werden, nicht zu berücksichtigen.
18.5 Die Bestimmungen des Artikels 18.4 gelten nicht für Rechtshandlungen, die, gemäß den vereinbarten Bedingungen,
Teil des normalen Geschäftsverlaufs der Gesellschaft sind.
Art. 19. Genehmigung der Beschlüsse des Geschäftsführungsrats.
19.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann verlangen, dass Beschlüsse des Geschäftsführungsrats ihrer Geneh-
migung unterliegen. Der Geschäftsführungsrat ist über derartige Beschlüsse, die eindeutig zu spezifizieren sind, schriftlich
zu informieren.
19.3 Die Ermangelung einer Genehmigung eines Beschlusse durch die Hauptversammlung der Aktionäre gemäß vor-
liegendem Artikel 19 beeinflusst jedoch in keinem Fall die Befugnis des Geschäftsführungsrats oder seiner Mitglieder zur
Vertretung der Gesellschaft.
Art. 20. Freie Stellen oder Handlungsunfähigkeit. Ist ein Posten im Geschäftsführungsrat nicht besetzt («ontstentenis»)
oder ein Geschäftsführer nicht in der Lage, seinen Pflichten nachzukommen («belet»), sind die restlichen Geschäftsführer
vorübergehend mit der Leitung der Gesellschaft zu betrauen. Sind sämtliche Posten im Geschäftsführungsrat frei oder
sämtliche Geschäftsführer bzw. der alleinige Geschäftsführer nicht in der Lage, seinen bzw. ihren Pflichten nachzukommen,
ist die Leitung der Gesellschaft vorübergehend einer oder mehreren Personen, die zu diesem Zweck durch die Haupt-
versammlung der Aktionäre bestimmt werden/wird, zu übertragen.
Kapitel IX. Geschäftsjahr und Jahresabschluss, Gewinne und Ausschüttungen
Art. 21. Geschäftsjahr und Jahresabschluss.
21.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr.
21.2 Innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraums erstellt der Geschäftsführungsrat den Jahresabschluss und
legt diesen zur Einsichtnahme durch die Aktionäre in der Hauptniederlassung der Gesellschaft aus.
21.3 Der Jahresabschluss setzt sich aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anmerkungen zusammen.
21.4 Der Jahresabschluss ist durch die Geschäftsführer zu unterzeichnen. Fehlt die Unterschrift eines oder mehrerer
Mitglieder, ist dies anzumerken und die Gründe hierfür anzugeben.
21.5 Die Gesellschaft kann oder ist gesetzlich angehalten, einen Wirtschaftsprüfer zur Prüfung des Jahresabschlusses
zu bestellen. Diese Bestellung erfolgt durch die Hauptversammlung der Aktionäre.
21.6 Die Gesellschaft stellt sicher, dass der Jahresabschluss und, sofern erforderlich, der Jahresbericht und die kraft
Gesetzes beizufügenden Informationen ab dem Tag, an dem die entsprechende Mitteilung zur Jahreshauptversammlung
herausgegeben wird, in ihrer Niederlassung aufbewahrt werden. Die Aktionäre können die Dokumente vor Ort einsehen
und eine kostenlose Kopie erhalten.
21.8 Der Jahresabschluss, der Jahresbericht, die kraft Gesetzes beizufügenden Informationen sowie die Abschlussprü-
fung durch einen Wirtschaftsprüfer und die Niederlegung der Dokumente beim Handelsregister unterliegen überdies den
gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 22. Genehmigung des Jahresabschlusses und Entlastung.
22.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre genehmigt den Jahresabschluss.
27808
22.3 Nach Genehmigung des Jahresabschlusses fasst die Hauptversammlung der Aktionäre einen Beschluss hinsichtlich
der Entlastung der Geschäftsführer von ihrer Verantwortung zur Ausübung ihrer Pflichten, sofern die Ausübung dieser
Pflichten im Jahresbeschluss reflektiert wird oder der Hauptversammlung der Aktionäre vor Genehmigung des Jahres-
abschlusses anderweitig offen gelegt wird. Der Umfang der Entlastung unterliegt gesetzlichen Beschränkungen.
Art. 23. Gewinne und Ausschüttungen.
23.1 Aus dem Nettogewinn eines Geschäftsjahres ist ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns den
gesetzlichen Rücklagen der Gesellschaft zuzuführen, bis die Rücklagen zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Aktienka-
pitals der Gesellschaft betragen.
23.2 Der nach Anwendung des Artikels 23.1 verbleibende Gewinn wird von der Hauptversammlung der Aktionäre
ermittelt.
23.3 Die Ausschüttung des Gewinns erfolgt nach Genehmigung des Jahresabschlusses, wenn sie angesichts des Inhalts
des Jahresabschlusses gesetzmäßig erlaubt ist.
23.4 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann sich dazu entschließen, Zwischenausschüttungen auf Aktien und/oder
Ausschüttungen auf Aktien zu Lasten von Rücklagen der Gesellschaft gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen vorzunehmen.
23.5 Ausschüttungen auf Aktien sind unmittelbar nachdem der Beschluss zur Ausschüttung gefasst wurde zahlbar,
sofern im Beschluss kein anderes Zahlungsdatum bestimmt wurde.
23.6 Ausschüttungen auf Aktien können nur bis zur Höhe eines Betrags erfolgen, der den Betrag des Ausschüttbaren
Kapitals nicht übersteigt.
23.7 Der Anspruch eines Aktionärs auf die Auszahlung einer Ausschüttung auf Aktien ist nach fünf Jahren verjährt.
23.8 Bei der Berechnung des Betrags einer Ausschüttung auf Aktien, sind Aktien, die von der Gesellschaft gehalten
werden, nicht zu berücksichtigen.
Kapitel X. Die Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 24. Jahreshauptversammlung.
24.1 Die Jahreshauptversammlung findet innerhalb von sechs Monaten nach Geschäftsjahresende statt.
24.2 Die Tagesordnung dieser Jahreshauptversammlung umfasst u. a. die folgenden Themen:
a. Besprechung des Jahresberichts (sofern keine gesetzliche Ausnahmeregelung für die Gesellschaft gilt);
b. Besprechung und Genehmigung des Jahresabschlusses;
c. die Erteilung der Entlastung für Geschäftsführer;
d. Gewinnverteilung; und
e. sonstige Themen, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 26 bekannt gegeben wurden.
Die Tagesordnung muss nicht zwingend die unter Punkt a, b, c und d aufgeführten Themen enthalten, wenn sie einen
Vorschlag zur Verlängerung des Zeitraums zur Erstellung des Jahresabschlusses und (zutreffendenfalls) und des Jahres-
berichts enthält oder wenn ein Beschluss in diesem Zusammenhang bereits gefasst worden ist.
Art. 25. Sonstige Hauptversammlungen.
25.1 Sonstige Hauptversammlungen sind in der Häufigkeit zu halten, wie sie der Geschäftsführungsrat für erforderlich
erachtet.
25.3 Aktionäre, die insgesamt mindestens ein Zehntel des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft repräsentieren,
können beim Geschäftsführungsrat unter Angabe der zu besprechenden Themen die Einberufung einer Hauptversamm-
lung beantragen. Sollte der Geschäftsführungsrat keine ordnungsgemäße Mitteilung zur Hauptversammlung innerhalb von
vier Wochen, nachdem der Antrag einer solchen Versammlung eingegangen ist, ausgeben, so dass die Versammlung
innerhalb von sechs Wochen nach Eingang des Antrags stattfinden kann, sind die Antragsteller befugt, selbst eine Ver-
sammlung einzuberufen.
Art. 26. Mitteilung, Tagesordnung und Versammlungsort.
26.1 Die Mitteilungen zur Hauptversammlung sind, unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 25.2, vom Geschäfts-
führungsrat herauszugeben.
26.2 Eine Versammlungsmitteilung ist spätestens fünfzehn Tage vor dem Tag der Versammlung herauszugeben.
26.3 In einer Versammlungsmitteilung sind die zu besprechenden Themen zu spezifizieren. Themen, die in dieser
Mitteilung nicht dargelegt werden, können unter Einhaltung der Bestimmung des Artikels 26.2 zu einem späteren Zeit-
punkt bekannt gegeben werden.
26.4 Ein Besprechungsthema, dessen Besprechung spätestens dreißig Tage vor dem Versammlungstag durch einen oder
mehrere Aktionäre, die allein oder gemeinsam mindestens ein Prozent des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft re-
präsentieren, schriftlich beantragt wurde, ist in der Mitteilung aufzuführen oder in der gleichen Weise wie andere
Besprechungsthemen mitzuteilen, vorausgesetzt, dass wichtige Interessen (zwaarwichtig belang) der Gesellschaft nichts
Gegenteiliges vorschreiben.
27809
26.5 Die Versammlungsmitteilung ist an die Anschriften der Aktionäre, die im Aktionärsregister angegeben sind, zu-
zustellen.
26.7 Die Hauptversammlungen sind in der Gemeinde zu halten, in der die Gesellschaft gemäß der vorliegenden Satzung
ihre Hauptniederlassung hat. Hauptversammlungen können ebenfalls in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, oder
anderweitig gehalten werden; in diesem Fall können gültige Beschlüsse der Hauptversammlung der Aktionäre jedoch nur
angenommen werden, wenn das gesamte ausgegebene Kapital der Gesellschaft repräsentiert wird.
Art. 27. Zulassung zur Teilnahme an und Rechte bei Versammlungen.
27.1 Jeder Aktionär ist berechtigt, an Versammlungen teilzunehmen, bei Versammlungen zu sprechen sowie seine
Stimmrechte auszuüben. Aktionäre können bei einer Versammlung von einem Bevollmächtigten vertreten werden, der
schriftlich hierzu ermächtigt wird.
27.2 Bei einer Versammlung trägt sich jede anwesende stimmberechtigte Person in die Teilnahmeliste ein. Der Vor-
sitzende der Versammlung kann entscheiden, ob sich auch andere Personen, die bei der Versammlung anwesend sind, in
die Teilnahmeliste einzutragen haben.
27.3 Die Geschäftsführer haben in ihrer Funktion als solche das Recht, bei den Hauptversammlungen Rat zu erteilen.
27.5 Der Vorsitzende der Versammlung entscheidet über die Zulassung anderer Personen zur Teilnahme an der
Versammlung.
Art. 28. Vorsitzender und Schriftführer.
28.1 Der Vorsitzende der Hauptversammlung wird durch Stimmenmehrheit seitens der bei der Versammlung anwe-
senden stimmberechtigten Personen gewählt. Bis diese Wahl getroffen ist, fungiert ein Geschäftsführer als Vorsitzender
oder, wenn kein Geschäftsführer bei der Versammlung anwesend ist, die älteste Person, die bei der Versammlung an-
wesend ist.
28.3 Der Vorsitzende der Versammlung bestimmt den Schriftführer für die Versammlung.
Art. 29. Protokoll; Aufzeichnung der Aktionärsbeschlüsse.
29.1 Der Schriftführer der Hauptversammlung führt Protokoll über den Verlauf der Versammlung. Das Protokoll ist
vom Vorsitzenden und vom Schriftführer der Versammlung zu genehmigen und als Nachweis hierfür von ihnen zu un-
terzeichnen.
29.2 Der Vorsitzende der Versammlung oder die Personen, die die Versammlung einberufen haben, können bestimmen,
dass ein notarieller Bericht über den Verlauf der Versammlung zu erstellen ist. Der notarielle Bericht ist durch den
Vorsitzenden der Versammlung mit zu unterzeichnen.
29.4 Der Geschäftsführungsrat führt Aufzeichnungen über sämtliche Beschlüsse, die durch die Hauptversammlung der
Aktionäre gefasst wurden. Wenn der Geschäftsführungsrat bei einer Versammlung nicht vertreten wird, stellt der Vor-
sitzende der Versammlung sicher, dass der Geschäftsführungsrat unverzüglich nach der Versammlung eine Kopie der
angenommenen Beschlüsse erhält. Die Aufzeichnungen liegen in der Hauptniederlassung der Gesellschaft zur Einsicht-
nahme durch die Aktionäre aus. Auf Anfrage erhält jeder Aktionär eine Kopie oder einen Auszug der Aufzeichnungen
gegen Entrichtung eines Betrags, der nicht höher als die tatsächlichen Kosten sein darf.
Art. 30. Beschlussfassung bei einer Versammlung.
30.1 Jede Aktie verleiht das Recht zur Abgabe einer Stimme.
30.2 Sofern nach dem Gesetz oder in der vorliegenden Satzung nicht anderweitig festgelegt, sind sämtliche Beschlüsse
der Hauptversammlung der Aktionäre mit Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen zu fassen, wobei die Stimmen-
mehrheit mindestens die Hälfte des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft repräsentiert. Wird weniger als die Hälfte
des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft repräsentiert, ist per Einschreiben eine neue Versammlung einzuberufen, in
der der Beschluss durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu fassen ist, ungeachtet des bei dieser Versammlung
vertretenen Teils des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft.
30.3 Bei Stimmengleichheit gilt der Vorschlag als abgelehnt.
30.4 Werden die Formalitäten der Einberufung und des Abhaltens der Hauptversammlung gemäß dem Gesetz oder
der vorliegenden Satzung nicht eingehalten, können gültige Beschlüsse der Hauptversammlung der Aktionäre in einer
Versammlung nur dann gefasst werden, wenn bei dieser Versammlung das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentiert
und der Beschluss einstimmig gefasst wird.
30.5 In der Hauptversammlung dürfen weder Stimmrechte für Aktien, die von der Gesellschaft oder einer Tochter-
gesellschaft gehalten werden, noch Stimmrechte für Aktien, für diejenigen die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft
die Hinterlegungsscheine hält, ausgeübt werden.
30.7 Bei der Festlegung der Anzahl der abgegebenen Stimme, der Anzahl der anwesenden bzw. vertretenen Aktionäre
oder des repräsentierten Teils des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft, werden Aktien, die gemäß dem Gesetz oder
der vorliegenden Satzung nicht stimmberechtigt sind, nicht berücksichtigt.
Art. 31. Stimmabgabe.
31.1 Die Stimmabgabe erfolgt stets mündlich. Der Vorsitzende ist jedoch ermächtigt, eine geheime Stimmabgabe an-
zuordnen. Wenn sich die Stimmabgabe auf Personen bezieht, können die Anwesenden bei der Versammlung eine geheime
27810
Stimmabgabe verlangen. Im Sinne dieses Paragrafen bedeutet «schriftlich»: mittels geheimer, nicht unterzeichneter Stimm-
zettel.
31.2 Enthaltungen und ungültige Stimmen gelten nicht als Stimmabgabe.
31.3 Beschlüsse können durch Zuruf gefasst werden, wenn keine der bei der Versammlung anwesenden Personen
Einwände erhebt.
31.5 Die Entscheidung des Vorsitzenden bei der Versammlung über das Ergebnis einer Abstimmung ist endgültig und
entscheidend. Das Gleiche gilt für den Inhalt eines gefassten Beschlusses, wenn eine Abstimmung über einen nicht schrift-
lichen Vorschlag stattgefunden hat. Sollte jedoch die Richtigkeit einer solchen Entscheidung unverzüglich nach deren
Verkündung angezweifelt werden, ist eine weitere Abstimmung vorzunehmen, wenn entweder die Mehrheit der bei der
Versammlung anwesenden Personen mit Stimmrecht oder, sofern die ursprüngliche Abstimmung nicht per Namensaufruf
oder schriftlich stattgefunden hat, jedwede bei der Versammlung anwesende Person mit Stimmrecht danach verlangt. Die
rechtlichen Folgen der ursprünglichen Abstimmung sind nach der neuen Abstimmung nichtig.
Art. 32. Beschlussfassung ohne Versammlung.
32.1 Beschlüsse der Hauptversammlung können auch schriftlich gefasst werden, vorausgesetzt, dass sie von den
stimmberechtigten Aktionären einstimmig angenommen werden. Die Bestimmung des Artikels 27.3 gilt in Analogie.
32.3 Jeder Aktionär muss gewährleisten, dass der Geschäftsführungsrat über die auf diese Weise gefassten Beschlüsse
so schnell wie möglich schriftlich informiert wird. Der Geschäftsführungsrat führt Aufzeichnungen über die gefassten
Beschlüsse und bewahrt diese Aufzeichnungen gemäß Artikel 29.3 auf.
Kapitel XI. Änderung der Satzung, Änderung der Gesellschaftsform, Auflösung und Liquidation
Art. 33. Änderung der Satzung; Änderung der Gesellschaftsform.
33.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann sich dazu entschließen, die vorliegende Satzung durch Beschluss
seitens der zahlenmäßigen Mehrheit der Aktionäre, die mindestens drei Viertel des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft
halten, zu ändern. Der Beschluss zur Änderung der Satzung ist zu diesem Zweck vor einem im Großherzogtum Luxemburg
registrierten Notar zu beurkunden. Ist bei einer Hauptversammlung die Änderung der vorliegenden Satzung vorzuschla-
gen, ist dies in der Versammlungsmitteilung zu erwähnen sowie eine Kopie des Vorschlags, einschließlich des eigentlichen
Textinhalts, bis zur Beendigung der Versammlung in der Hauptniederlassung der Gesellschaft aufzubewahren und zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre auszulegen. Ab dem Tag der Auslegung bis zum Tag der Versammlung ist jeder Ak-
tionär berechtigt, auf Anfrage eine kostenlose Kopie des Vorschlags zu erhalten. Eine Änderung der vorliegenden Satzung
ist überdies in einer Urkunde festzuhalten, die zu diesem Zweck vor einem in den Niederlanden registrierten Notar zu
erstellen ist.
33.3 Die Gesellschaft kann ihre Gesellschaftsform in eine andere umwandeln. Eine Umwandlung der Gesellschaftsform
erfordert einen Beschluss zur Umwandlung der Gesellschaftsform und einen Beschluss zur Änderung der vorliegenden
Satzung, die beide von der Hauptversammlung der Aktionäre zu fassen sind und zwar mit einer zahlenmäßigen Mehrheit
der Aktionäre, die mindestens drei Viertel des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft halten. Eine Änderung der Ge-
sellschaftsform unterliegt ferner den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen. Eine Änderung der Gesellschaftsform
beendet nicht das Bestehen der juristischen Einheit.
Art. 34. Auflösung und Liquidation.
34.1 Die Gesellschaft kann infolge eines entsprechenden Beschlusses durch die Hauptversammlung der Aktionäre
aufgelöst werden. Der Beschluss zur Auflösung der Gesellschaft ist zu diesem Zweck vor einem im Großherzogtum
Luxemburg registrierten Notar zu beurkunden. Der Vorschlag zur Auflösung der Gesellschaft ist in der entsprechenden
Versammlungsmitteilung zu erwähnen.
34.2 Wird die Gesellschaft infolge eines Beschlusses der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst, fungieren die
Geschäftsführer als Masseverwalter des Gesellschaftsvermögens. Die Hauptversammlung der Aktionäre kann sich dazu
entschließen, andere Personen zu Masseverwaltern zu ernennen.
34.3 Während der Auflösung bleibt die vorliegende Satzung, soweit möglich, in Kraft.
34.6 Das Guthaben, das nach Begleichung der Schulden der aufgelösten Gesellschaft verbleibt, wird den Aktionären
im Verhältnis zum gesamten Nominalwert der Aktien, die von jedem einzelnen Aktionär gehalten werden, überwiesen.
34.7 Darüber hinaus unterliegt die Liquidation den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.
<i>Vierter Beschlussi>
Der Alleinaktionär beschließt, (i) den ab dem heutigen Tag wirksamen Rücktritt von Herrn J.B. Meulman als Ge-
schäftsführer der Gesellschaft anzunehmen und ihm volle Entlastung für die Ausführung seiner Aufgaben als Geschäfts-
führer der Gesellschaft zu erteilen und (ii) mit Wirkung ab dem genannten Datum die folgenden Personen für eine Dauer
von 5 Jahren als Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen:
1. Geschäftsführer der Kategorie A:
(a) Herrn Albert Seen, wohnhaft in 17, Leedebach, L-7618 Larochette, Luxemburg;
(b) SuxesKey S.A., eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Sitz in 10-12, rue de Medernach,
L-7619 Larochette, Luxemburg.
27811
2. Geschäftsführer der Kategorie B:
(a) Herr T.J. Postma, ein holländischer Bürger, geboren in Menaldumadeel, Niederlande, am 5. November 1967,
wohnhaft in Avotu iela 9/1, LV-1011, Riga, Lettland,
<i>Kostenschätzungi>
Die Gesellschaft unterliegt der Gesellschaftssteuer in den Niederlanden, einem EU-Mitgliedsstaat. Daher fällt bei der
Verlegung des Orts der tatsächlichen Verwaltung der Gesellschaft von den Niederlanden nach Luxemburg keine luxem-
burgische Gesellschaftssteuer an. Verwiesen wird hierzu auf Artikel 3 (2) des Gesetzes vom 29. Dezember 1971.
Die Höhe der Kosten in Bezug auf die vorliegende Urkunde wird ungefähr auf Euro 6.000,- geschätzt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-
kunde auf Antrag der erschienenen Partei in englischer Sprache verfasst wird, die von einer deutschen Fassung gefolgt
wird; auf Antrag der selben erschienenen Partei wird festgelegt, dass im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischen
und der deutschen Fassung die englische Fassung vorherrscht.
Zu Urkund dessen wurde gemäß oben genanntem Datum das vorliegende notarielle Dokument in Luxemburg erstellt.
Nachdem der Inhalt des Dokuments dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde unterzeichnete
dieser zusammen mit mir, dem Notar, die vorliegende Original-Urkunde.
Gezeichnet: T.J. Postma, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2007, Relation: LAC/2007/42612. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Jungers.
Für gleichlautende Kopie zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
Luxemburg, den 15. Januar 2008.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2008024575/242/993.
(080024348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Interneptune Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 18.602.
EXTRAIT
Lors de sa réunion du 23 janvier 2008, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de L-1222
Luxembourg, 16, rue Beck à L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
Pour extrait sincère et conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2008.
<i>INTERNEPTUNE HOLDING
i>F. Sassel / S. Bernard / G. Fasbender
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008024755/8473/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN01923. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Courcheval No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.546.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2008.
<i>Pour COURCHEVAL NO. 1 S.à r.l.
i>EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant
i>M. Bogers
27812
<i>Géranti>
Référence de publication: 2008024762/1084/17.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2008, réf. LSO-CN02325. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080023934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
SIL Investments S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 58.609.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine Schaeffer, de résidence à Luxembourg, en date
du 23 novembre 2007, enregistré à Luxembourg AC, le 29 novembre 2007, LAC/2007/38127, aux droits de douze euros
(12,- EUR), que la société SIL INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste,
constituée suivant acte notarié en date du 12 mars 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 352 du 4 juillet 1997. Les statuts ont été modifies pour la dernière fois suivant acte de Maître Joseph Elvinger,
de résidence à Luxembourg, le 31 août 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 134 du
21 février 2000., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B, numéro 58.609,
a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.
Les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant cinq ans, à partir de la date de la
publication des présentes dans le Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et
Associations, à l'adresse suivante:
C/O CITCO (LUXEMBOURG S.A., 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2008.
M. Schaeffer
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008024745/5770/27.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2008, réf. LSO-CN00775. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Valessore Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 29.489.
EXTRAIT
Lors de sa réunion du 22 janvier 2008, le Conseil d'Administration a pris les décisions suivantes:
1. Le Conseil d'Administration accepte la démission de Monsieur Romain Zimmer comme administrateur de la société.
2. Le Conseil d'Administration nomme comme nouvel administrateur Madame Edith Reuter, comptable, née à Lu-
xembourg, le 5 janvier 1958, demeurant à L-5366 Munsbach, 222, rue Principale.
3. Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis à
L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
4. Le Conseil d'Administration informe que le commissaire de la société VALESSORE HOLDING S.A. c'est-à-dire la
société LUXREVISION S.à r.l. a son siège social à partir du 22 janvier 2008 au 7, route d'Esch L-1470 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2008.
<i>VALESSORE HOLDING S.A.
i>F. Sassel
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008024754/8473/23.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN01920. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
27813
Courcheval No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.546.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2008.
<i>Pour COURCHEVAL NO. 1 S.à r.l.
i>PROSERVICES MANAGEMENT S.à r.l.
<i>Gérant
i>M. Bogers
<i>Géranti>
Référence de publication: 2008024765/1084/17.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2008, réf. LSO-CN02322. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080023933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Aire Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 87.944.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2008.
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008024623/805/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2008, réf. LSO-CN03356. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Last Machine S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 90.744.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008024633/751/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2008, réf. LSO-CN03328. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Galluspark (Bridge) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 119.223.
In the year two thousand and seven, on the twenty-seventh day of the month of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
MARATHON S.àr.l. (the «Undersigned»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 2-4, rue Beck,
L-1222 Luxembourg, being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés under number B 111374, being
the sole member of GALLUSPARK (BRIDGE) S.àr.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its regis-
tered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, incorporated by deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in
27814
Luxembourg, on 29th August 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») of
29 September 2006, number 1819, represented by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant
to a proxy dated 27 December 2007.
The articles of association of the Company were last amended by a deed of the undersigned notary, then residing in
Mersch, on 29 September 2006, published in the Memorial number 2195 of 23 November 2006 (the «Articles»).
The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all the shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of
the agenda.
2. The item on which a resolution is to be passed is as follows:
<i>Agenda:i>
Increase of the issued share capital of the Company by ten million seven hundred fifteen thousand five hundred seventy-
five Euro (€ 10,715,575.-) by the issue of four hundred twenty-eight thousand six hundred twenty-three (428,623) shares,
each with a nominal value and subscription price of twenty-five Euros (€ 25.-) (being a total ten million seven hundred
fifteen thousand five hundred seventy-five Euro (€ 10,715,575.-)), such shares being subscribed by the existing shareholder
MARATHON S.à r.l. (the «Contributor») by the contribution in kind of a receivable of an amount of ten million seven
hundred fifteen thousand five hundred seventy-five Euro (€ 10,715,575.-) owned by the Contributor and due by the
Company (the «Contribution»), subscription to the new shares so issued by the Contributor; approval of the valuation
of the Contribution at a total of ten million seven hundred fifteen thousand five hundred seventy-five Euro (€ 10,715,575.-)
Euro, consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation.
The above having been approved the following resolution is passed:
<i>Sole resolutioni>
It is resolved to increase the issued share capital of the Company by ten million seven hundred fifteen thousand five
hundred seventy-five Euro (€ 10,715,575.-) by the issue of four hundred twenty-eight thousand six hundred twenty-three
(428,623) shares with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each and a total subscription price of ten million seven
hundred fifteen thousand five hundred seventy-five Euro (€ 10,715,575.-), all such new shares are subscribed for and paid
by the Contributor.
The Contributor prenamed and represented as aforementioned subscribed to all the new shares so issued. The new
shares so subscribed and issued are fully paid by the Contribution as described in the agenda.
The Contribution has been the subject of a report of the board of managers of the Company dated 27 December
2007, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.
The report contains the following conclusion:
«In view of the above, the Board of Managers considers that the total value of the Contribution in Kind corresponds
to 10,715,575.- Euro being at least equal to the subscription price of 10,715,575.- Euro of the Shares to be issued against
such Contribution in Kind so that the total aggregate value of the Contribution in Kind corresponds at least to the total
subscription price of all the Shares to be issued.»
Pursuant to the above, the sole shareholder resolved to approve the valuation of the Contribution at a total of ten
million seven hundred fifteen thousand five hundred seventy-five Euro (€ 10,715,575.-).
Proof of the transfer of the Contribution to the Company has been shown to the undersigned notary.
As a result of the preceding increase of share capital, the first sentence of article 5 of the Articles is amended so as to
read as follows:
«The issued share capital of the Company is set at twenty-two million eight hundred seventy-five thousand four hundred
and fifty Euro (€ 22,875,450.-) represented by nine hundred fifteen thousand eighteen (915,018) shares, with a nominal
value of twenty-five (€ 25.-) Euro each.»
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of share capital are estimated at one hundred and thirteen thousand five hundred Euro (EUR
113,500.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day beforementionned. After reading these minutes
the proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
27815
MARATHON S.àr.l. (la «Soussignée»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2-4, rue Beck,
L-1222 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Société sous le numéro B 111.374, étant l'associé unique
de GALLUSPARK (BRIDGE) S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2-4, rue
Beck, L-1222 Luxembourg, constituée suivant acte de M
e
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 29 août
2006 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») du 29 septembre 2006, numéro 1819,
représentée par M
e
Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 27
décembre 2007.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné, alors de résidence à
Mersch, en date du 29 septembre 2006, publié au Mémorial numéro 2195 du 23 novembre 2006 (les «Statuts»).
Le mandataire a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. L'associé unique détient toutes les parts sociales émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent vala-
blement être prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.
2. Le point sur lequel une résolution doit être passée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Augmentation du capital social émis de la Société par dix millions sept cent quinze mille cinq cent soixante-quinze
Euros (€ 10.715.575,-) par l'émission de quatre cent vingt-huit mille six cent vingt-trois (428.623) parts sociales, ayant
chacune une valeur nominale et un prix de souscription de vingt-cinq Euros (€25,-) (représentant un total de dix millions
sept cent quinze mille cinq cent soixante-quinze Euros (€ 10.715.575,-)), ces parts sociales étant souscrites par l'associé
existant MARATHON S. à r.l. (l'«Apporteur») par un apport en nature d'une créance d'un montant de dix millions sept
cent quinze mille cinq cent soixante-quinze Euros (€ 10.715.575,-) détenue par l'Apporteur et due par la Société (l'«Ap-
port»), souscription des nouvelles parts sociales ainsi émises par l'Apporteur; approbation de l'évaluation de l'Apport à
un total de dix millions sept cent quinze mille cinq cent soixante-quinze Euros (€ 10.715.575,-), modification conséquente
de l'article 5 des statuts.
Ce qui précède ayant été approuvé, la résolution suivante a été passée:
<i>Résolution uniquei>
Il est décidé d'augmenter le capital social émis de la Société par dix millions sept cent quinze mille cinq cent soixante-
quinze Euros (€ 10.715.575,-) par l'émission de quatre cent vingt-huit mille six cent vingt-trois (428.623) parts sociales,
ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25,-) et un prix total de souscription de dix millions sept cent
quinze mille cinq cent soixante-quinze Euros (€ 10.715.575,-), toutes ces nouvelles parts sociales sont souscrites et
libérées par l'Apporteur.
L'Apporteur, prénommé, représenté tel que mentionné ci-dessus, a souscrit à toutes les nouvelles parts sociales ainsi
émises. Les nouvelles parts sociales ainsi souscrites et émises sont entièrement libérées par l'Apport tel que décrit dans
l'ordre du jour.
L'Apport a fait l'objet d'un rapport du conseil de gérance de la Société daté du 27 décembre 2007, qui restera annexé
au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le rapport contient la conclusion suivante:
«Au vu de ce qui précède, le Conseil de Gérance estime que la valeur totale de l'Apport en Nature correspond à €
10.715.575,- Euros, étant au moins égal au prix de souscription de 10.715.575,- Euros des Parts Sociales devant être
émises en contrepartie de l'Apport en Nature de sorte que la valeur totale de l'Apport en Nature correspond au moins
au prix total de souscription de toutes les Parts Sociales devant être émises.»
Au vu de ce qui précède, l'associé unique a décidé d'approuver l'évaluation de l'Apport à un total de dix millions sept
cent quinze mille cinq cent soixante-quinze Euros (€ 10.715.575,-).
Preuve du transfert de l'Apport à la Société a été montrée au notaire soussigné.
En conséquence de l'augmentation du capital social qui précède, la première phrase de l'article 5 des Statuts est modifiée
pour avoir la teneur suivante:
«Le capital social émis de la Société est fixé à vingt-deux millions huit cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante
Euros (€ 22.875.450,-) représenté par neuf cent quinze mille dix-huit (915.018) parts sociales ayant une valeur nominale
de vingt-cinq Euros (€ 25,-) chacune.»
<i>Dépensesi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite à
l'augmentation du capital social sont estimés à cent treize mille cinq cents Euros (EUR 113.500,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,
le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande la même partie comparante,
en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite du présent procès-verbal, le mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
27816
Signé: T. Hoss, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, Relation: LAC/2008/861. — Reçu 107.155,75 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2008.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2008024801/242/131.
(080024119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Resan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2521 Luxembourg, 26, rue Demy Schlechter.
R.C.S. Luxembourg B 63.274.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2008i>
Le lundi 14 janvier 2008, à 15.00 heures, les actionnaires de la société RESAN S.A. se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire à Luxembourg et ont pris les résolutions suivantes:
<i>Transfert du siège sociali>
Le siège social de la société est transféré de L-1320 Cessange, 90, rue de Cessange à L-2521 Luxembourg 26, rue
Demy Schlechter.
Luxembourg, le 14 janvier 2008.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Actionnairesi>
Référence de publication: 2008024824/3776/19.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03719. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
H2O FundCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 122.671.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société en date du 21 décembre 2007i>
Par résolutions prises en date du 21 décembre 2007, le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège
social de la Société au 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg avec effet au 21 décembre 2007.
Pour extrait
<i>H2O FundCo S.à r.l.
i>Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008024829/5499/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02724. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Distri Europe S.A, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 109.137.
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 janvier 2008 les décisions suivantes:
- Démission de l'administrateur Mme Katia Roti;
- Démission du commissaire aux comptes Monsieur Pascal Bonnet;
- Nomination d'un nouvel administrateur Mme Samira Ouadoudi, demeurant à F-75116 Paris, 27, avenue Kléber, pour
un mandat allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle tenue en 2011;
27817
- Nomination d'un nouveau commissaire, la société PKF ABAX AUDIT, société à responsabilité limitée, avec siège
social 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, pour un mandat allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle tenue
en 2011;
- Transfert du siège social au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2008.
<i>Pour la société
i>PKF WEBER ET BONTEMPS S.à r.l.
<i>Experts-comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprises
i>Signatures
Référence de publication: 2008024822/592/25.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2008, réf. LSO-CN00681. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080024398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Last Machine S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 90.744.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008024635/751/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2008, réf. LSO-CN03327. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Monarch Beach Capital (Max Bahr) No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 119.338.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2008.
<i>Pour MONARCH BEACH CAPITAL (MAX BAHR) NO. 1 S.à r.l.
i>PROSERVICES MANAGEMENT S.à r.l.
<i>Gérant
i>M. Bogers
<i>Géranti>
Référence de publication: 2008024768/1084/17.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2008, réf. LSO-CN02304. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080023932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Timbor International S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 103.607.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine Schaeffer, de résidence à Luxembourg, en date
du 20 décembre 2007, enregistré à Luxembourg A.C. le 28 décembre 2007, LAC/2007/43737, aux droits de douze euros
(12,- EUR), que la société TIMBOR INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau,
R.C.S. Luxembourg Numéro B 103.607, constituée par acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Jun-
27818
glinster, en date du 7 octobre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1320 du 27
décembre 2004.
a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation
auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Pour extrait conforme délivré aux fins de la radiation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2008.
M. Schaeffer
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008024742/5770/24.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN02027. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080024539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
S.E.C. Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 177, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 84.649.
L'affectation de résultat suivant bilan clos au 31 décembre 2006 a été déposée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008024627/1053/13.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2008, réf. LSO-CN03345. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
McCain Assets Inc. Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 131.969.
Il résulte d'une décision du conseil d'administration en date du 1
er
janvier 2008 que le siège social de la société a été
transféré avec effet au 1
er
janvier 2008 de
208, Val des Bons Malades à L-2121 Luxembourg
à
46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Luxembourg, le 9 janvier 2008.
<i>Pour McCain ASSETS INC., LUXEMBOURG BRANCH
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008024835/2270/18.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, réf. LSO-CM09237. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Moretta S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 35.814.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
27819
Luxembourg, le 13 février 2008.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2008024833/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2008, réf. LSO-CN01640. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080023957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Dlux Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 110.976.
In the year two thousand and seven, on the twenty-first day of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of DLUX HOLDCO S.à r.l. a société à responsabilité
limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of M
e
Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem,
(Grand-Duchy of Luxembourg), on 22 September 2005 published in the Mémorial C number 183 of 26 January 2006 and
entered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under the number 110.976. The articles
of incorporation have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary on 10 December 2007,
not yet published in the Mémorial C.
The extraordinary general meeting is declared open with M
e
Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, in the
chair,
who appointed as secretary Ms Rebecca Unverzagt, lawyer, residing in Luxembourg.
The extraordinary general meeting elected as scrutineer M
e
Michael Jonas, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested
the notary to state:
(i) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. To reduce the corporate capital of the Company by an amount of three hundred twenty seven thousand two hundred
seventy five euro (EUR 327,275.-) so as to reduce it from its current amount of two million five hundred thirty thousand
euro (EUR 2,530,000.-) to two million two hundred two thousand seven hundred twenty five euro (EUR 2,202,725.-) by
way of the cancellation of thirteen thousand ninety one (13,091) Class F Shares from its current number of sixteen
thousand (16,000) Class F Shares to two thousand nine hundred nine (2,909) Class F Shares and by way of the reim-
bursement of their nominal value on each cancelled share of an amount of twenty-five euro (EUR 25.-) together with an
aggregate share premium of thirty one million two hundred nine thousand five hundred ninety eight euro and fifty five
cents (EUR 31,209,598.55).
2. To set the amount of the Company's capital at two million two hundred two thousand seven hundred twenty five
euro (EUR 2,202,725.-) represented by twenty-one thousand three hundred (21,300) class B shares, twenty-one thousand
three hundred (21,300) class C shares, twenty-one thousand three hundred (21,300) class D shares, twenty-one thousand
three hundred (21,300) class E shares and two thousand nine hundred nine (2,909) class F shares, each with a nominal
value of twenty-five euro (EUR 25.-).
3. To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the capital
reduction hereinabove proposed.
4. To confer all and any powers to the board of managers in order to implement the capital reduction hereinabove
proposed.
5. Miscellaneous.
(ii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown
on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and
by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.
(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
(iv) The whole subscribed capital being represented at the present extraordinary general meeting and all the share-
holders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this
extraordinary general meeting, no convening notices were necessary.
27820
(v) The present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items
of the agenda.
The extraordinary general meeting resolves, after deliberation, unanimously to take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to reduce, with immediate effect, the corporate capital of the Company
by an amount of three hundred twenty seven thousand two hundred seventy five euro (EUR 327,275.-) so as to reduce
it from its current amount of two million five hundred thirty thousand euro (EUR 2,530,000.-) to two million two hundred
two thousand seven hundred twenty five (EUR 2,202,725.-) by way of the cancellation of thirteen thousand ninety one
(13,091) Class F Shares from its current number of sixteen thousand (16,000) Class F Shares to two thousand nine
hundred nine (2,909) Class F Shares and by way of the reimbursement of their nominal value on each cancelled share of
an amount of twenty-five euro (EUR 25.-) together with an aggregate share premium of thirty one million two hundred
nine thousand five hundred ninety eight euro and fifty five cents (EUR 31,209,598.55).
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to set, with immediate effect, the amount of the Company's corporate
capital at two million two hundred two thousand seven hundred twenty five (EUR 2,202,725.-) represented by twenty-
one thousand three hundred (21,300) class B shares, twenty-one thousand three hundred (21,300) class C shares, twenty-
one thousand three hundred (21,300) class D shares, twenty-one thousand three hundred (21,300) class E shares and
two thousand nine hundred nine (2,909) class F shares, each with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-).
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation
of the Company which shall forthwith read as follows:
« Art. 5. first paragraph. Subscribed Capital. The subscribed capital of the Company is set at two million two hundred
two thousand seven hundred twenty five (EUR 2,202,725.-) divided into twenty-one thousand three hundred (21,300)
class B shares (the «Class B Shares»), twenty-one thousand three hundred (21,300) class C shares (the «Class C Shares»),
twenty-one thousand three hundred (21,300) class D shares (the «Class D Shares»), twenty-one thousand three hundred
(21,300) class E shares (the «Class E Shares») and two thousand nine hundred nine (2,909) class F shares (the «Class F
Shares»), each with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-), all of which are fully paid up.»
<i>Fourth resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to confer all and any powers to the board of managers in order to im-
plement the above resolutions.
The board of managers is notably entitled and authorised to make the reimbursement of capital and of share premium
to the shareholders by payments in cash or in kind, to fix the date and other formalities of such payment and to do all
other things necessary and useful in relation to the above resolutions.
There being no other business, the extraordinary general meeting was thereupon closed.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société DLUX HOLDCO S.à r.l., une société à
responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec siège social à 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte de M
e
Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem
(Grand-Duché de Luxembourg), en date du 22 Septembre 2005, publié au Mémorial C numéro 183 du 26 janvier 2006
et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 110.976. Les statuts de
la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 10 décembre 2007, non
encore publié au Mémorial C.
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mme Rebecca Unverzagt, Rechtsanwältin, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Maître Michael Jonas, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
27821
(i) La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduire le capital de la Société d'un montant de trois cent vingt sept mille deux cent soixante quinze euros (EUR
327.275,-) afin de le porter de son présent montant de deux millions cinq cent trente mille euros (EUR 2.530.000,- ) à
deux millions deux cent deux mille sept cent vingt cinq euros (EUR 2.202.725,-) par l'annulation de treize mille quatre
vingt onze (13.091) Parts Sociales de Catégorie F afin de porter les présentes seize mille (16.000) Parts Sociales de
Catégorie F à deux mille neuf cent neuf (2.909) Parts Sociales de Catégorie F et par le remboursement de la valeur
nominale de chaque part sociale annulée d'un montant de vingt-cinq euros (EUR 25,-) ensemble avec une prime d'émission
totale de trente et un million deux cent neuf mille cinq cent quatre vingt dix huit euros et cinquante cinq cents (EUR
31.209.598,55).
2. Fixer le montant du capital de la Société à deux millions deux cent deux mille sept cent vingt cinq euros (EUR
2.202.725,-) représenté par vingt et un mille trois cents (21.300) Parts Sociales de Catégorie B, vingt et un mille trois
cents (21.300) Parts Sociales de Catégorie C, vingt et un mille trois cents (21.300) Parts Sociales de Catégorie D, vingt
et un mille trois cents (21.300) Parts Sociales de Catégorie E et deux mille neuf cent neuf (2.909) parts sociales de
Catégorie F avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
3. Modifier l'article 5, premier paragraphe, des statuts de la Société, afin de refléter la réduction de capital ci-dessus.
4. Conférer tous pouvoirs au conseil de gérance pour l'exécution de la réduction de capital proposé ci-dessus.
5. Divers.
(ii) Les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils dé-
tiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents,
les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
(iv) L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, il a pu
être fait abstraction des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués
et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
(v) La présente assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement,
telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale extraordinaire, après avoir délibéré, a alors pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des associés décide de réduire, avec effet immédiat, le capital de la Société d'un montant de trois
cent vingt sept mille deux cent soixante quinze euros (EUR 327.275,-) afin de le porter de son présent montant de deux
millions cinq cent trente mille euros (EUR 2.530.000,- ) à deux millions deux cent deux mille sept cent vingt cinq euros
(EUR 2.202.725,-) par l'annulation de treize mille quatre vingt onze (13.091) Parts Sociales de Catégorie F afin de porter
les présentes seize mille (16.000) Parts Sociales de Catégorie F à deux mille neuf cent neuf (2.909) Parts Sociales de
Catégorie F et par le remboursement de la valeur nominale de chaque part sociale annulée d'un montant de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) ensemble avec une prime d'émission totale de trente et un million deux cent neuf mille cinq cent quatre
vingt dix huit euros et cinquante cinq cents (EUR 31.209.598,55).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des associés décide de fixer, avec effet immédiat, le montant du capital de la Société à deux
millions deux cent deux mille sept cent vingt cinq euros (EUR 2.202.725,-) représenté par vingt et un mille trois cents
(21.300) Parts Sociales de Catégorie B, vingt et un mille trois cents (21.300) Parts Sociales de Catégorie C, vingt et un
mille trois cents (21.300) Parts Sociales de Catégorie D, vingt et un mille trois cents (21.300) Parts Sociales de Catégorie
E et deux mille neuf cent neuf (2.909) parts sociales de Catégorie F avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale des associés décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société qui
aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. premier alinéa. Capital social souscrit. Le capital social souscrit de la Société est fixé à deux millions deux
cent deux mille sept cent vingt cinq euros (EUR 2.202.725,-) divisé en vingt et un mille trois cents (21.300) Parts Sociales
de Catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), vingt et un mille trois cents (21.300) Parts Sociales de Catégorie C
(les «Parts Sociales de Catégorie C»), vingt et un mille trois cents (21.300) Parts Sociales de Catégorie D (les «Parts
Sociales de Catégorie D»), vingt et un mille trois cents (21.300) Parts Sociales de Catégorie E (les «Parts Sociales de
Catégorie E») et deux mille neuf cent neuf (2.909) parts sociales de Catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»),
avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.»
27822
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale des associés décide de conférer tous les pouvoirs au conseil de gérance pour mettre en œuvre
les résolutions prises ci-dessus.
Le conseil de gérance est notamment mandaté et autorisé à rembourser le capital et la prime d'émission aux associés
par paiement en espèces ou en nature, à fixer la date et toute autre modalité de ces paiements, et à prendre toute autre
mesure nécessaire et utile en relation avec les résolutions prises ci-dessus.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Loesch, R. Unverzagt, M. Jonas, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2008. Relation: EAC/2008/17. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 8 février 2008.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2008024616/239/179.
(080024254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 16.758.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2008.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008024704/1035/15.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2008, réf. LSO-CN02973. - Reçu 40 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080023923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Orangenburger S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 20.972.
Le bilan au 31 mai 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>ORANGENBURGER S.A.
i>B. Parmentier / C. François
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2008024776/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2008, réf. LSO-CN02420. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080023929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
27823
Invesco GT Continental European Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 21.109.
DISSOLUTION
In the year two thousand and seven, on the twenty seventh day of the month of December
Before me Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Appeared:
Me Manuèle Biancarelli, maître en droit, residing in Luxembourg (the «Proxy») acting as a special proxy of INVESCO
INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, a company organised under the laws of England, 30 Finsbury Square, London
EC2A 1AG, England (the «Principal»);
by virtue of a proxy under private seal given on 18th December 2007, which, after having been signed ne varietur by
the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.
The Proxy declared the following and requested the notary to act:
I. INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN MANAGEMENT S.A. (the «Company»), having its registered office at
69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section
B number 21.109, has been incorporated on 21st December 1983 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations on 26th March 1984;
II. The Principal is the owner of all one thousand four hundred (1,400) outstanding registered shares with a par value
per share of one hundred US Dollars (USD 100.-) representing the entire outstanding share capital of the Company;
III. The Principal approves the annual accounts for the year 2006 and declares that he has full knowledge of the financial
standing and position of the Company at the date of the present deed;
IV. The Principal as the sole shareholder makes an explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company
and assumes the function of liquidator;
V. The Principal declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive
all assets of the Company and acknowledges that the Principal will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the
Company after its dissolution;
VI. The Principal gives discharge to all directors and the statutory auditor of the Company in respect of their mandate
up to the date of the present deed;
VII. The shareholder's register and all the shares of the Company shall be cancelled; and
VIII. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the former registered
office of the Company at the offices of RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
After the document had been read, the aforementioned Proxy signed the present original deed with me, the under-
signed notary.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
Suit la traduction du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-septième jour du mois de décembre
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
M
e
Manuèle Biancarelli, maître en droit, demeurant à Luxembourg (le «Mandataire»);
agissant en sa qualité de mandataire spécial de INVESCO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, une société or-
ganisée sous droit anglais, 30 Finsbury Square, London EC2A 1AG, Angleterre (le «Mandant»);
en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 18 décembre 2007 laquelle, après avoir été signée
ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la
formalité de l'enregistrement.
Le Mandataire a déclaré et a requis le notaire d'acter:
I. Que INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN MANAGEMENT S.A. («la Société»), ayant son siège social à 69,
route d'Esch, L-1470 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le
numéro 21.109, a été constituée en date du 21 décembre 1983 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
le 26 mars 1984.
27824
II. Que le Mandant est le propriétaire de toutes les mille quatre cents (1.400) actions nominatives avec une valeur
nominale de cent Dollars US (USD 100,-) chacune, représentant l'entièreté du capital en émission de la Société.
III. Que le Mandant approuve les comptes pour l'année 2006 et déclare avoir parfaite connaissance de la situation
financière et de l'état financier de la susdite Société à la date du présent acte.
IV. Que le Mandant en tant qu'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société et
assume la fonction de liquidateur.
V. Que le Mandant déclare que le passif de la Société a été apuré et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société
et reconnaît qu'il sera tenu des obligations (s'il y en a) de la Société après sa dissolution.
VI. Que décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux administrateurs et au réviseur de la Société pour
l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date du présent acte.
VII. Qu'il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société.
VIII. Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à son ancien siège social dans les
bureaux de RBC DEXIA INVESTORS SERVICES BANK à 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg. Les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le Mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
A la demande du comparant, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais et sur décision
du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: M. Biancarelli, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008. Relation: LAC/2008/679. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2008.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2008024825/242/78.
(080023954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
HEPP III Luxembourg Master S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 959.850,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 108.984.
In the year two thousand and eight, on the tenth of January.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appears:
HEPP III MANAGEMENT COMPANY S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-8, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 106.142, acting in its own name and on behalf of HEITMAN EUROPEAN PROPERTY PARTNERS III, a mutual
investment fund (fonds commun de placement) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Mrs Rachel Uhl, jurist, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue
of a proxy established on January 9, 2008.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée»)
existing in Luxembourg under the name of HEPP III LUXEMBOURG MASTER S.à r.l. (the «Company») with registered
office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 108.984, which bylaws have been last amended by a deed of the undersigned notary, dated
December 21, 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. The Company's share capital is fixed at nine hundred forty-six thousand six hundred Euro (€ 946,600.-) represented
by thirty-seven thousand eight hundred sixty-four (37,864) shares with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each.
III. The sole shareholder resolves to increase the Company's corporate capital to the extent of thirteen thousand two
hundred fifty Euro (€ 13,250.-) to raise it from its present amount of nine hundred forty-six thousand six hundred Euro
(€ 946,600.-) to nine hundred fifty-nine thousand eight hundred fifty Euro (€ 959,850.-) by creation and issue of five
hundred thirty (530) new shares, with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each.
27825
<i>Subscription - Paymenti>
HEPP III MANAGEMENT COMPANY S.à r.l., prenamed, acting in its own name and on behalf of HEITMAN EURO-
PEAN PROPERTY PARTNERS III, declared to subscribe for all five hundred thirty (530) new shares and fully paid them
up in the nominal amount of thirteen thousand two hundred fifty Euro (€ 13,250.-) by contribution in cash in the same
amount.
The amount of thirteen thousand two hundred fifty Euro (€ 13,250.-) has been fully paid up in cash and is now available
to the Company, evidence thereof having been given to the notary.
IV. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company's articles of association is amended and shall
henceforth read as follows:
« Art. 6. The share capital is fixed at nine hundred fifty-nine thousand eight hundred fifty Euro (€ 959,850.-) represented
by thirty-eight thousand three hundred ninety-four (38,394) shares with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-)
each.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present shareholders' meeting are estimated at approximately two thousand Euro (€ 2,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by her
Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille huit, le dix janvier.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
HEPP III MANAGEMENT COMPANY S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant en vertu des
lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.142, agissant en son
nom et pour le compte d'HEITMAN EUROPEAN PROPERTY PARTNERS III, un fonds commun de placement constitué
en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ici représentée par Mme Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 9 janvier 2008.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
HEPP III LUXEMBOURG MASTER S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.984,
dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte du notaire soussigné, reçu en date du 21 décembre 2007,
pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. Le capital social de la Société est fixé à neuf cent quarante-six mille six cents Euro (€ 946.600,-) représenté par
trente-sept mille huit cent soixante-quatre (37.864) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-)
chacune.
III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de treize mille deux cent cinquante
Euro (€ 13.250,-) pour le porter de son montant actuel de neuf cent quarante-six mille six cents Euro (€ 946.600,-) à
neuf cent cinquante-neuf mille huit cent cinquante Euro (€ 959.850,-) par la création et l'émission de cinq cent trente
(530) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.
<i>Souscription - Libérationi>
HEPP III MANAGEMENT COMPANY S.à r.l., susnommée, agissant en son nom et pour le compte de HEITMAN
EUROPEAN PROPERTY PARTNERS III, déclare souscrire toutes les cinq cent trente (530) parts sociales et les libère
intégralement en valeur nominale au montant de treize mille deux cent cinquante Euro (€ 13.250,-) par apport en nu-
méraire du même montant.
Un montant de treize mille deux cent cinquante Euro (€ 13.250,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve
dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
27826
IV. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la
teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à neuf cent cinquante-neuf mille huit cent cinquante Euro (€ 959.850,-) représenté
par trente-huit mille trois cent quatre-vingt-quatorze (38.394) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€
25,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille Euro (€ 2.000,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom, état
et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, Relation: LAC/2008/1754. — Reçu 66,25 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2008.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2008024872/211/109.
(080024118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Supreme Entertainment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 116.232.
Constituée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date
du 26 avril 2006, acte publié au Mémorial C n
o
1338 du 11 juillet 2006. Les statuts ont été modifiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois par-devant le notaire pré-nommé en date du 16 mai 2007, non encore publié au
Mémorial.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SUPREME ENTERTAINMENT S.A.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2008024874/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2008, réf. LSO-CN02209. - Reçu 62 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Martek Power, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 101.039.
L'an deux mille huit, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARTEK POWER, ayant son
siège social au L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 101.039, constituée suivant acte reçu le 27 mai 2004 par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 774 du 28 juillet 2004.
L'assemblée est présidée par Monsieur Emmanuel Reveillaud, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg.
27827
Le président désigne comme secrétaire Madame Ludivine Peyrissaguet, avocat, résidant professionnellement à Lu-
xembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Esbelta De Freitas, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg.
Ces trois individus forment le bureau de l'assemblée.
Ayant été ainsi constitué, le bureau de l'assemblée dresse la liste de présence, qui, après avoir été signée par les
mandataires dûment autorisés des actionnaires et par les membres du bureau et le notaire restera attachée au présent
procès-verbal.
Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l'intégralité du montant du capital social de EUR
31.000,- (trente et un mille euros) sont présents ou valablement représentés à l'assemblée. L'assemblée peut dès lors
valablement délibérer et décider sur tous les sujets portés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu convocation préalable.
II.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Suppression des statuts de l'approbation du conseil d'administration préalable à toute cession d'action de la Société
2,- Suppression de l'article 3 alinéa 4 des statuts de la Société
3.- Divers
L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée
et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime la résolution unique suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée des actionnaires décide de supprimer l'obligation d'obtenir l'approbation du conseil d'administration pré-
alablement à toute cession d'action de la Société.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts en supprimant l'alinéa 4 du prédit article. L'article
3 des statuts prend donc la teneur suivante:
« Art. 3 . Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d'une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge, s'élève à environ cinq cents euros (500,- EUR.).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, le président lève la
séance.
Le notaire soussigné qui connaît la langue française constate que sur demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue française.
Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu en un langage connu des comparants, tous connus du notaire par leur prénoms, noms, état
civil et domicile, lesdits comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte en original.
Signe: E. Reveillaud, L.Peyrissaguet, E. De Freitas, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 21 janvier 2008, Relation: REM/2008/108. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 13 février 2008.
R. Arrensdorff.
Référence de publication: 2008024867/218/57.
(080024382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Rangiroa, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 111.904.
L'an deux mille sept, le vingt-quatre décembre
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
A comparu:
27828
La société anonyme VAVATE IMMOBILIER SA, avec siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités, inscrite au
Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 111.115
ici représentée par un de ses administrateurs la société SEREN Sàrl, avec siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc
d'activités, inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 110.588,
elle même représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue
G.-D. Charlotte propriétaire de la totalité des parts sociales de la société a responsabilité limitée RANGIROA Sàrl, avec
siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités, lequel comparant, a exposé au notaire:
- que la société RANGIROA Sàrl a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 28 octobre
2005, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, sous le numéro 358 du 17 février 2006
- inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 111.904,
- qu'elle a un capital de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100 ) parts sociales de cent vingt-
cinq euros (125,- EUR) chacune,
- que le comparant est le seul et unique associé représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée
RANGIROA Sàrl, avec siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités,
-que la société ne possède pas d'immeuble, ni de parts d'immeubles.
Ensuite le comparant a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
<i>Augmentation du Capital - Souscriptioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société par le biais de deux apports en nature faits par la Société
VAVATE IMMOBILER S.A.
1. Le premier apport est un immeuble évalué à un million six cent cinq mille euros (EUR 1.605.000,-), situé à 9-11-13,
boulevard Aimé Boissy, F-13004 Marseille en France,
Inscrit au cadastre comme suit:
Commune de Marseille, Quartier Chutes Lavie (204), section 817D.
Numéro 15, lieu-dit «9,11,13, boulevard Aimé Boissy», pour une contenance de 7 ares 16 centiares
Origine de propriété
L'immeuble appartient à la société VAVATE IMMOBILIER SA prédésignée pour l'avoir acquis aux termes d'un acte de
vente reçu le 9 janvier 2006 par le Notaire français Jacques Maube, de résidence à Marseille, transcrit.
2. Le second apport est composé de parts de la sicav DEXIA WRLD ALTERNATIF / ALPHAMAX-C/CAP (Code valeur
LU0132841213) dont le montant est évalué à un montant de cent quarante-cinq mille euros (EUR 145.000,-). Le capital
social de la société est ainsi augmenté d'un million sept cent cinquante mille euros (EUR 1.750.000,-). Quatorze mille
(14.000) parts sociales de cent vingt cinq euros (EUR 125,-) chacune sont émises. Ces nouvelles parts sociales sont
intégralement souscrites par la société VAVATE IMMOBILIER S.A. Ces évaluations sont reprises dans le rapport qui
conclut que
«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de
l'apport ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des actions de RANGIROA Sàrl à émettre en
contrepartie.»
Suite à cette augmentation de capital, l'article 5 alinéa 1
er
des statuts est remplacé par le texte suivant:
« Art. 5. alinéa 1
er
. Le capital social de la société est fixé à un million sept cent soixante deux mille cinq cents euros
(EUR 1.762.500,-) divisé en quatorze mille (14.000) parts sociales de cent vingt cinq euros (EUR 125,-) chacune.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à.
<i>Fraisi>
Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à
Dont acte, fait et passé à Mamer/Capellen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.
Signé: B. de Bien, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 3 janvier 2008, WIL/2008/2. — Reçu 17.500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Pletschette.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
27829
Wiltz, le 17 janvier 2008.
A. Holtz.
Référence de publication: 2008024887/2724/63.
(080024405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Um Gringert S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9151 Eschdorf, 1, Op der Heelt.
R.C.S. Luxembourg B 103.630.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Référence de publication: 2008024888/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 1
er
février 2008, réf. DSO-CN00005. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(080024019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Aperta Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 87.257.
Le bilan au 30 septembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2008.
<i>Pour APERTA SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK, Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2008024840/1126/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2008, réf. LSO-CN01482. - Reçu 58 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080023996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
SunlightLuxco-A S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 90.286.
DISSOLUTION
In the year two thousand and seven, on the twenty-seventh of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
Appeared:
Me Philippe Prussen, residing in Luxembourg,
acting as a special proxy of SUNLIGHT LUXCO S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg with
its registered office at 12, rue Léon Thyes and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg,
section B under number 90.285, in liquidation (the «Principal»),
by virtue of a proxy dated 24 December 2007 under private seal given which, after having been signed ne varietur by
the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this deed.
The proxy declared and requested the notary to record:
I. That the société à responsabilité limitée SunlightLuxco-A S.àr.l., having its registered office in 12, rue Thyes, L-2636
Luxembourg, registered in the registre de commerce et des sociétés in Luxembourg, section B number 90.286 (the
«Company»), has been incorporated by deed enacted on 26 November 2002, published in the Mémorial C, No 74, of 24
January 2003.
II. That the subscribed capital of the Company is presently of six hundred forty-six thousand six hundred and twenty-
five Euros (€ 646,625.-)
III. That the Principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the
Company.
27830
IV. That the Principal has acquired all shares of the Company and that as a sole shareholder declares explicitly to
proceed with the dissolution of the Company and assumes the function of liquidator of the Company.
V. That the Principal takes over all assets and assumes all the liabilities of the dissolved Company and that the liquidation
of the Company is completed without prejudice as it assumes all its liabilities.
VI. That the shareholder's register of the dissolved Company has been cancelled.
VII. That the Principal fully discharges the board of directors and statutory auditor for the due performance of their
duties up to this date.
VIII. That the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at the offices of the
dissolved Company.
The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing person,
the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surname, first name,
civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
M
e
Philippe Prussen, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de SUN-
LIGHT LUXCO S.à r.l., une société constituée sous le lois Du Luxembourg, avec siège social au 12, rue Léon Thyes,
L-2636 Luxembourg et enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, section B sous le numéro 90.285,
en liquidation (le «Mandant»),
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 24 décembre 2007, laquelle, après avoir été signée ne varietur
par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-
clarations et constatations:
I. Que la société à responsabilité limitée SunlightLuxco-A S.àr.l. ayant son siège social à 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 90.286 (la
«Société»), constituée suivant acte reçu le 26 novembre 2002, publié au Mémorial C numéro 74 du 24 janvier 2003.
II. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à six cent quarante-six mille six cent vingt-cinq euros (€
646.625,-).
III. Que son Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.
IV. Que son Mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la Société et qu'en tant qu'associé unique
il déclare expressément procéder à la dissolution de la Société et assume la fonction de liquidateur.
V. Que son Mandant déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société et que la liquidation
de la Société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI. Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associé de la Société dissoute.
VII. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs
de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
VIII. Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la Société
dissoute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence entre
le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a
signé avec le notaire instrumentant la présente minute.
Signé: P. Prussen, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, Relation: LAC/2008/677. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
27831
Luxembourg, le 11 février 2008.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2008024839/242/79.
(080023953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Cap Grisnez S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 38.969.
Le 25 janvier 2008, Maître Henon Christel a décidé de résilier le contrat de domiciliation du 7 juin 2001 conclu avec
la société CAP GRISNEZ SA, RCS numéro B 38.969, établie et ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel
Welter.
Fait à Luxembourg, le 25 janvier 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008024844/7430/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02785. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080024493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Audition International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 81.042.
DISSOLUTION
L'an deux mille sept, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société KYNA MYNA LIMITED, ayant son siège social à Road Town, 3175, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Madame Katia Roti, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 20 décembre 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualité qu'elle agit, a prié le notaire instrumentant de documenter les déclarations suivantes:
- La société anonyme AUDITION INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
fut constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 15 février 2001,
publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 875 du 12 octobre 2001, et dont les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 25 février 2005, publié
au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1429 du 21 décembre 2005.
- La société a actuellement un capital social de trente six mille euros (EUR 36.000,-), divisé en trois cent soixante (360)
actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.
- La comparante déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, savoir la société
KYNA MYNA LIMITED, prédésignée.
- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société AUDITION INTERNATIONAL S.A., prédésignée.
Il assume la fonction de liquidateur.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société AUDITION
INTERNATIONAL S.A.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l'actif ainsi que le cas échéant l'apurement du passif connu ou
inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'ac-
tionnaire unique.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société AUDITION INTERNATIONAL S.A., prédésignée.
Les livres et documents comptables de la société AUDITION INTERNATIONAL S.A., prédésignée demeureront
conservés pendant cinq ans à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et
demeure, la comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: K. Roti, H. Hellinckx.
27832
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, Relation: LAC/2008/921. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2008.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2008024848/242/45.
(080023950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Barclays Themis Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 128.477.
Les comptes annuels au 31 octobre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société BARCLAYS THEMIS INVESTMENTS S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2008024850/7902/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02781. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080023989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Partex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 111.183.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008024861/677/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2008, réf. LSO-CN01027. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080023979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Invesco GT Investment Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 7.445.
DISSOLUTION
In the year two thousand and seven, on the twenty seventh day of the month of December
Before me Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Appeared:
Me Manuèle Biancarelli, maître en droit, residing in Luxembourg (the «Proxy») acting as a special proxy of INVESCO
INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, a company organised under the laws of England, 30 Finsbury Square, London
EC2A 1AG, England (the «Principal»);
by virtue of a proxy under private seal given on 18th December 2007, which, after having been signed ne varietur by
the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.
The Proxy declared the following and requested the notary to act:
I. INVESCO GT INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A. (the «Company»), having its registered office at 69,
route d'Esch, L-1470 Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B
number 7.445, has been incorporated on 30th November 1966 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations on 6th December 1966;
II. The Principal is the owner of all four hundred and fifty (450) outstanding registered shares with a par value per share
of two hundred US Dollars (USD 200,-) representing the entire outstanding share capital of the Company;
III. The Principal approves the annual accounts for the year 2006 and declares that he has full knowledge of the financial
standing and position of the Company at the date of the present deed;
27833
IV. The Principal as the sole shareholder makes an explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company
and assumes the function of liquidator.
V. The Principal declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive
all assets of the Company and acknowledges that the Principal will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the
Company after its dissolution;
VI. The Principal gives discharge to all directors and the statutory auditor of the Company in respect of their mandate
up to the date of the present deed;
VII. The shareholder's register and all the shares of the Company shall be cancelled; and
VIII. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the former registered
office of the Company at the offices of RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
After the document had been read, the aforementioned Proxy signed the present original deed with me, the under-
signed notary.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
Suit la traduction du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-septième jour du mois de décembre
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
M
e
Manuèle Biancarelli, maître en droit, demeurant à Luxembourg (le «Mandataire»);
agissant en sa qualité de mandataire spécial de INVESCO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, une société or-
ganisée sous droit anglais, 30 Finsbury Square, London EC2A 1AG, Angleterre (le «Mandant»);
en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 18 décembre 2007 laquelle, après avoir été signée
ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la
formalité de l'enregistrement.
Le Mandataire a déclaré et a requis le notaire d'acter:
I. Que INVESCO GT INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A. («la Société»), ayant son siège social à 69, route
d'Esch, L-1470 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro
7.445, a été constituée en date du 30 novembre 1966 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations le 6
décembre 1966.
II. Que le Mandant est le propriétaire de toutes les quatre cent cinquante (450) actions nominatives avec une valeur
nominale de deux cents US Dollars (USD 200,-) chacune, représentant l'entièreté du capital en émission de la Société.
III. Que le Mandant approuve les comptes pour l'année 2006 et déclare avoir parfaite connaissance de la situation
financière et de l'état financier de la susdite Société à la date du présent acte.
IV. Que le Mandant en tant qu'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société et
assume la fonction de liquidateur.
V. Que le Mandant déclare que le passif de la Société a été apuré et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société
et reconnaît qu'il sera tenu des obligations (s'il y en a) de la Société après sa dissolution.
VI. Que décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux administrateurs et au réviseur de la Société pour
l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date du présent acte.
VII. Qu'il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société.
VIII. Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à son ancien siège social dans les
bureaux de RBC DEXIA INVESTORS SERVICES BANK à 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le Mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
A la demande du comparant, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais et sur décision
du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: M. Biancarelli, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, Relation: LAC/2008/682. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
27834
Luxembourg, le 11 février 2008.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2008024863/242/78.
(080023952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
INVESCO Maximum Income Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 28.885.
DISSOLUTION
In the year two thousand and seven, on the twenty-seventh day of the month of December
Before me Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Appeared:
Me Manuèle Biancarelli, maître en droit, residing in Luxembourg (the «Proxy») acting as a special proxy of INVESCO
UK LIMITED, a company organised under the laws of England, 30 Finsbury Square, London EC2A 1AG, England (the
«Principal»);
by virtue of a proxy under private seal given on 18th December 2007, which, after having been signed ne varietur by
the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.
The Proxy declared the following and requested the notary to act:
I. INVESCO MAXIMUM INCOME MANAGEMENT S.A. (the «Company»), having its registered office at 69, route
d'Esch, L-1470 Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number
28.885, has been incorporated on 9th September 1988 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
on 10th October 1988;
II. The Principal is the owner of all fifteen thousand (15,000) outstanding registered shares with a par value per share
of twenty US Dollars (USD 20.-) representing the entire outstanding share capital of the Company;
III. The Principal approves the annual accounts for the year 2006 and declares that he has full knowledge of the financial
standing and position of the Company at the date of the present deed;
IV. The Principal as the sole shareholder makes an explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company
and assumes the function of liquidator;
V. The Principal declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive
all assets of the Company and acknowledges that the Principal will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the
Company after its dissolution;
VI. The Principal gives discharge to all directors and the statutory auditor of the Company in respect of their mandate
up to the date of the present deed;
VII. The shareholder's register and all the shares of the Company shall be cancelled; and
VIII. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the former registered
office of the Company at the offices of RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
After the document had been read, the aforementioned Proxy signed the present original deed with me, the under-
signed notary.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
Suit la traduction du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-septième jour du mois de décembre
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
M
e
Manuèle Biancarelli, maître en droit, demeurant à Luxembourg (le «Mandataire»);
agissant en sa qualité de mandataire spécial de INVESCO UK LIMITED, une société organisée sous droit anglais, 30
Finsbury Square, London EC2A 1AG, Angleterre (le «Mandant»);
en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 18 décembre 2007 laquelle, après avoir été signée
ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la
formalité de l'enregistrement.
Le Mandataire a déclaré et a requis le notaire d'acter:
I. Que INVESCO MAXIMUM INCOME MANAGEMENT S.A. («la Société»), ayant son siège social à 69, route d'Esch,
L-1470 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 28.885,
27835
a été constituée en date du 9 septembre 1988 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations le 10 octobre
1988.
II. Que le Mandant est le propriétaire de toutes les quinze mille (15.000) actions nominatives actions avec une valeur
nominale de vingt Dollars US (USD 20,-) chacune, représentant l'entièreté du capital en émission de la Société.
III. Que le Mandant approuve les comptes pour l'année 2006 et déclare avoir parfaite connaissance de la situation
financière et de l'état financier de la susdite Société à la date du présent acte.
IV. Que le Mandant en tant qu'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société et
assume la fonction de liquidateur.
V. Que le Mandant déclare que le passif de la Société a été apuré et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société
et reconnaît qu'il sera tenu des obligations (s'il y en a) de la Société après sa dissolution.
VI. Que décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux administrateurs et au réviseur de la Société pour
l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date du présent acte.
VII. Qu'il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société.
VIII. Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à son ancien siège social dans les
bureaux de RBC DEXIA INVESTORS SERVICES BANK à 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le Mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
A la demande du comparant, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais et sur décision
du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: M. Biancarelli, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, Relation: LAC/2008/681. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2008.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2008024858/242/78.
(080023951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Barotek, Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 92.201.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de clôture de liquidation de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,
(Grand-Duché de Luxembourg), en date du 13 décembre 2007, enregistré à Grevenmacher, le 24 décembre 2007, Re-
lation: GRE/2007/5856:
I.- Que l'assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et qu'elle a constaté que la société responsabilité limitée
BAROTEK S.à R.L. en liquidation a cessé d'exister.
2.- Que l'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pour une
période de cinq années au siège social.
Pour extrait conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 30 janvier 2008.
J. Seckler
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008024859/231/20.
(080023981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Sebalea S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 87.776.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
27836
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008024865/677/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2008, réf. LSO-CN01022. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080023978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
A.E. Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 71.637.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008024868/677/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2008, réf. LSO-CN01020. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080023976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Manacor SA, Société Anonyme,
(anc. Laconi S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 106.542.
Le bilan et l'annexe au 30 juin 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MANACOR S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2008024871/45/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2008, réf. LSO-CN03066. - Reçu 34 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080023974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
H2O Land S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 64.766.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2008.
Signature.
Référence de publication: 2008024890/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN01775. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Moor Park Newday Netherlands Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 126.948.
In the year two thousand and seven, on the twentieth day of December.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
27837
The company MOOR PARK NEWDAY HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l. a company organized under the laws of
Luxembourg, with registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, registered with the Trade and Companies
Register of Luxembourg under the number B 125.758,
duly represented by Maître Julica Ortlinghaus, avocat, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de
la Pétrusse,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The prenamed company MOOR PARK NEWDAY HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l. is the sole member of the
private limited liability company (société à responsabilité limitée) MOOR PARK NEWDAY NETHERLANDS HOLDCO
S.à r.l., having its registered office at L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, registered with the Trade and Companies
Register of Luxembourg under number B 126.948, incorporated by a deed received by the undersigned notary, on March
30, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 1158 dated June 14, 2007 (the
«Company»), and the articles of association of the Company have been amended.
Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity of member of the Company has requested the
undersigned notary to state its following resolutions:
<i>First resolutioni>
The member resolves to change the accounting reference dates of the Company so that the current financial year that
started on the day of the incorporation shall now end on the thirty-first day of December 2007 and the subsequent
financial years of the Company shall begin on the first day of January of each year and end on the thirty-first day of
December of the following year.
<i>Second resolutioni>
The member resolves to amend Article 17 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the said
change as follows:
«The financial year of the Corporation shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the
thirty-first day of December of the following year.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Corporation, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately eight hundred and fifty Euros.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxy holder representing the appearing party, said proxy holder signed
together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
La société MOOR PARK NEWDAY HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l. une société constituée selon les lois de
Luxembourg, ayant son siège social à 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, enregistré avec le Registre de Commerce
et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 125.758,
dûment représentée par Maître Julica Ortlinghaus, avocate, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69,
boulevard de la Pétrusse,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signé ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant restera annexées
au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La société préqualifiée MOOR PARK NEWDAY HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l. est l'associé unique de la société
à responsabilité limitée MOOR PARK NEWDAY NETHERLANDS HOLDCO S.à r.l, avec siège social à L-1130 Luxem-
bourg, 37, rue d'Anvers, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 126.948,
constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 mars 2007, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 1158 du 14 juin 2007(ci-après la «Société») et les statuts de la Société n'ont
jamais été modifiés.
Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d'associée unique de la Société, a demandé
au notaire instrumentant d'acter ses résolutions suivantes:
27838
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de changer les dates de référence comptables de la Société de sorte que l'exercice social en
cours qui a commencé la date de la constitution se termine le 31 décembre 2007 et les exercices sociaux suivants
commenceront le premier janvier de chaque année et se termineront le trente et un décembre de l'année suivante.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société afin de refléter le dit changement comme
suit:
«L'année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de l'année
suivante.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la Société en raison des présentes est estimé sans préjudice
à la somme de huit cent cinquante euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, dûment repré-
sentée, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Ortlinghaus, J. Seckler.
Enregistré le Grevenmacher, le 31 décembre 2007, Relation GRE/2007/6056. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 février 2008
J. Seckler.
Référence de publication: 2008024893/231/87.
(080024417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Parndorf Bale S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-5367 Schuttrange, 80B, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 96.582.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Thomas Léon, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,
en date du 23 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1218 du 19 novembre
2003.
Les comptes annuels au 31 octobre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>PARNDORF BALE S.à r.l.
i>Signatures
Référence de publication: 2008024894/250/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02800. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Parndorf Bale S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-5367 Schuttrange, 80B, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 96.582.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Thomas Léon, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,
en date du 23 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1218 du 19 novembre 2003.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
27839
<i>PARNDORF BALE S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2008024898/250/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02807. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Eucon Finanz Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.
R.C.S. Luxembourg B 80.868.
Le bilan de clôture au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2008.
FISOGEST S.A.
Signature
Référence de publication: 2008024899/1218/14.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03596. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080024459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Transurb Finance S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 34.546.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte reçu par Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 28 janvier 2008, enregistré
à Mersch, le 30 janvier 2008, MER/2008/229, que les actionnaires ont à l'unanimité:
- prononcé la clôture de la liquidation de la société,
- décidé que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social
de la société à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 février 2008.
M. Lecuit
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008024855/243/18.
(080024067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Bisa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 129.497.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2008.
P. Frieders
<i>Notairei>
Référence de publication: 2008024579/212/12.
(080024428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
27840
A.E. Holding S.A.
Aire Investments S.à r.l.
Aperta Sicav
Audition International S.A.
Barclays Themis Investments S.à r.l.
Barotek
Bisa S.A.
Bizet S.A.
Cap Grisnez S.A.
Courcheval No. 1 S.à r.l.
Courcheval No. 1 S.à r.l.
Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.
Distri Europe S.A
Dlux Holdco S.à r.l.
Eucon Finanz Holding S.A.
Galluspark (Bridge) S.à r.l.
H2O FundCo S.à r.l.
H2O Land S.à r.l.
HEPP III Luxembourg Master S.à r.l.
Interneptune Holding
Invesco GT Continental European Management S.A.
Invesco GT Investment Management Company S.A.
INVESCO Maximum Income Management S.A.
Laconi S.A.
Last Machine S.A.
Last Machine S.A.
Manacor SA
Martek Power
McCain Assets Inc. Luxembourg Branch
Monarch Beach Capital (Max Bahr) No. 1 S.à r.l.
Moor Park Newday Netherlands Holdco S.à r.l.
Moretta S.A.
Orangenburger S.A.
Parndorf Bale S.à r.l.
Parndorf Bale S.à r.l.
Partex S.A.
Postma Holding B.V. / S.ar.l.
Rangiroa
Resan S.A.
Sebalea S.A.
S.E.C. Luxembourg S.A.
SIL Investments S.A.
SunlightLuxco-A S.àr.l.
Supreme Entertainment S.A.
Timbor International S.A.
Transurb Finance S.A.
Um Gringert S.A.
Valessore Holding S.A.