logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 443

21 février 2008

SOMMAIRE

Aderland Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21219

A.J.I.L. C. & P. S.A., Consultants-Courtiers

en Assurances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21262

Barclays Euro Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21223

Basinco Holdings S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . .

21220

Biscarosse S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21260

Blairnet S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21261

BPT Hansa Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21224

BPT Hansa Lux SICAV-SIF  . . . . . . . . . . . . .

21224

Co-Investment II Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . .

21262

Compagnie Industrielle et Financière des

Produits Amylacés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21219

Danor Media Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21262

Dexia Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21223

Domanial S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21218

Edinformatic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21255

ENEX Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21257

Falbala S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21224

Fiba S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21253

Fraco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21221

Gent's Properties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21255

Gestocapital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21253

Global Hotel Development Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21222

Inka A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21220

Intel Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21220

Inversiones Viso S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21221

Kismet Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

21264

Lago S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21222

Ligne XII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21252

Linéa Donna S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21251

L.M. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21261

Lux Cogeba S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21260

Manfred Ships Repairs  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21251

Marsan Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21222

M.G.C. Financière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

21218

Midilux Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21218

Mischabel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21262

MKL Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21254

Modern Funds Management Company S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21263

Nexo Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21254

Pacuare S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21263

Pictet Global Selection Fund  . . . . . . . . . . . .

21224

Pictet Global Selection Fund  . . . . . . . . . . . .

21251

Robeco Interest Plus Funds  . . . . . . . . . . . . .

21260

R. & T. Research and Technology S.A.  . . .

21253

SAGRAL (Société Agricole des Grands

Lacs) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21218

Société Européenne de Participations et

Investissements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21261

Société Internationale des Affaires Holding

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21252

Sofape S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21261

'SOMALUX' Société de Matériel Luxem-

bourgeoise S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21219

Somato S.A. Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21263

Station Shell Schengen S.A.  . . . . . . . . . . . . .

21259

Thurloe Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

21264

Thurloe Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

21264

Voyages Vandivinit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

21259

Waverley S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21255

21217

M.G.C. Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 70.481.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>12 mars 2008 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008016594/1017/15.

Midilux Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 6.749.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 1 <i>2 mars 2008 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Nouvelle fixation de la date de l'assemblée générale annuelle au 28 avril à 11.00 heures.
2. Refonte complète des statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions actuelles de la loi luxembourgeoise

du 10 août 1915 telle que modifiée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008021160/521/14.

SAGRAL (Société Agricole des Grands Lacs) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 42.973.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>11 mars 2008 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2007;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nominations des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008021699/10/19.

Domanial S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 41.966.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

21218

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 1 <i>2 mars 2008 à 16.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008021700/755/18.

C.I.P., Compagnie Industrielle et Financière des Produits Amylacés, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 4.367.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>11 mars 2008 à 14.00 heures, pour

délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 30 septembre 2007,

2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2007 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008021812/18.

'SOMALUX' Société de Matériel Luxembourgeoise S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 4.523.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>11 mars 2008 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Nomination statutaire du Commissaire aux Comptes,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008023587/795/16.

Aderland Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 27.556.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

21219

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 mars 2008 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008023589/795/15.

Intel Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 35.509.

Les actionnaires et porteurs de parts de fondateur sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 mars 2008 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 octobre 2007,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008023591/795/16.

Basinco Holdings S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 18.684.

Les actionnaires sont priés d'assister à:

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de la FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A., 4, rue Henri Schnadt, L-2530

Luxembourg le mardi <i>4 mars 2008 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'En-

treprises.

2. Présentation et approbation des comptes au 31 décembre 2007.
3. Affectation du Résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d'Entreprises.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008016679/503/19.

Inka A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 21.691.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:

21220

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement le <i>29 février 2008 à 15.00 heures avec l'ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes annuels au 31

décembre 2006.

2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006.
4. Décision conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dissolution

éventuelle de la société et proposition d'assainissement de la société.

5. Affectation du résultat.
6. Ratification du dépôt des comptes annuels au 31 décembre 2006, à titre conservatoire, en date du 21 décembre

2007.

7. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux comptes.
8. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes démissionnaire.
9. Nomination de nouveaux Administrateurs et d'un Commissaire aux comptes.

10. Transfert du siège social.
11. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008017692/26.

Inversiones Viso S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 50.558.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra lundi, le <i>3 mars 2008 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2006.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008018350/29/18.

Fraco S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 11.564.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 29 février 2008 à 10.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2007.

4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008019326/1023/16.

21221

Lago S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 30.125.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra lundi, le <i>3 mars 2008 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2007.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Reconduction de Monsieur Cornelius Martin Bechtel dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée

générale statutaire de 2009.

6. Reconduction de Madame Virginie Dohogne dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée gé-

nérale statutaire de 2009.

7. Reconduction de Madame Christine Schweitzer dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée

générale statutaire de 2009.

8. Reconduction de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. dans son mandat de commissaire aux

comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

9. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008018351/29/24.

Marsan Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 39.761.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra lundi, le <i>3 mars 2008 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2007.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Reconduction de Cornelius Martin Bechtel dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2009.

6. Reconduction de Madame Virginie Dohogne dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée gé-

nérale statutaire de 2009.

7. Reconduction de Madame Christine Schweitzer dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée

générale statutaire de 2009.

8. Reconduction de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. dans son mandat de commissaire aux

comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

9. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008018353/29/24.

Global Hotel Development Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 10.603.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

21222

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>29 février 2008 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2007.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008019327/1023/17.

Barclays Euro Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 66.581.

The Board of Directors of the above mentioned SICAV is pleased to invite the Shareholders of the SICAV to the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>February 28, 2008 at 10.30 a.m., at the Registered Office of the SICAV, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Nomination of the President of the Meeting.
2. Acknowledgement and approval of the reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor as at

October 31, 2007.

3. Acknowledgement and approval of the Balance Sheet and the Profit and Loss Accounts as at October 31, 2007.
4. Allocation of results.
5. Discharge to the Directors in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended on October

31, 2007.

6. Statutory elections.
7. Miscellaneous.

The resolutions on the agenda of the Annual General Meeting require no quorum and will be taken at a simple majority

of the votes cast.

Shareholders have to inform the Board of Directors of the Company by mail of their intention to attend the Meeting

at least two business days prior to the date of the Meeting.

Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed, dated and signed proxy

form no later than two business days prior to the date of the Meeting to Ms. Alexandra Schmitt, CACEIS BANK LU-
XEMBOURG, at 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (fax: 00352.47.67.33.45). Proxy forms can be obtained from the
Registered Office of the Company.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2008019328/755/28.

Dexia Global, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.727.

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires («l'Assemblée») de DEXIA GLOBAL aura lieu au siège social de la société le <i>29 février 2008 à 11.30

heures.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises au 30 septembre

2007,

2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 30 septembre

2007,

3. Affectation des résultats,

21223

4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé au 30 septembre 2007,
5. Election du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises,
6. Divers.

Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les

décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de

s'inscrire jusqu'au 27 février 2008 auprès de DEXIA GLOBAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, à l'attention de
Madame Mylène Castellani (Fax N° +352 / 2460-3331).

Pour être admis à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours

francs avant l'Assemblée aux guichets de Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470 Luxem-
bourg.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008019331/755/27.

Falbala S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 47.528.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>29 février 2008 à 12.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 novembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30

novembre 2007.

4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008019337/1023/16.

Pictet Global Selection Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion consolidé au 26 février 2008 du fonds commun de placement PICTET GLOBAL SELECTION

FUND, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PICTET GLOBAL SELECTION FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
SIgnatures

Référence de publication: 2008021113/52/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02837. - Reçu 172 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

BPT Hansa Lux SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé,

(anc. BPT Hansa Lux S.A.).

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 122.072.

In the year two thousand and seven, on the twenty-eighth day of December.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

was held an extraordinary general meeting of shareholders and bondholders of BPT HANSA LUX S.A. (the «Com-

pany»), a société anonyme with its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, incorporated
under Luxembourg law by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on 23 October 2006, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») of 26 January 2007. The articles of incorporation

21224

of the Company (the «Articles») have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx on
9 November 2007, published in the Mémorial on 15 December 2007.

The extraordinary general meeting was opened by M 

e

 Stéphanie Alexandrino, maître en droit, residing in Luxembourg,

in the chair.

The chairman appointed as secretary M 

e

 Eva Brauckmann, Volljuristin, professionally residing in Luxembourg.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer M 

e

 Patrick Reuter, maître en droit, residing in Luxembourg.

The shareholders and bondholders present or represented at the present extraordinary general meeting (the «Meet-

ing») and the number of shares / bonds held by each of them are shown on an attendance list. The said list and proxies
initialled ne varietur by the members of the bureau, the shareholders / bondholders present, the proxies of the repre-
sented shareholders and bondholders and the notary will be annexed to this document, to be registered with this deed.

The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record that:
I. The present Meeting was convened by notices containing the agenda of the meeting and sent to all holders of bonds

in the Company (the «Bondholders») by registered mail on 20 December 2007; the shareholders in the Company (the
«Shareholders») by proxy waived their right to receive a convening notice for the Meeting.

II. It appears from the attendance list that all the shares of the Company in issue at the date of the present Meeting

are present or represented at the present Meeting and that one hundred seventy-four thousand three hundred and
twenty-eight (174,328) out of two hundred and eighteen thousand one hundred and sixty-eight (218,168) bonds in the
Company in issue at the date of the present Meeting are present or represented at the present Meeting. As a result of
the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

III. The agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

For the vote of shareholders and bondholders
1. To approve the transformation of the Company into a specialised investment fund under the Luxembourg law of

13th February 2007 on specialised investment funds (the «Law of 2007») under the form of société d'investissement à
capital variable (SICAV) in accordance with the Law of 2007.

Only for the vote of shareholders
2. Change of the name of the Company from currently BPT HANSA LUX S.A. into BPT HANSA LUX SICAV-SIF.
3. Approval of the restated articles of incorporation so as to comply with the provisions of the Law of 2007.
4. Appointment of ERNST &amp; YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg as auditor of the Company.
5. Determination of the registered office of the Company to be located at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535

Luxembourg.

6. Appointment of Dr. Claus Löwe, Mr Lars Ohnemus, Mr Alain Heinz, Dr. Peter Schmidt zur Nedden and M 

e

 Patrick

Reuter as directors of the Company until the next annual general meeting.

7. Miscellaneous
After deliberation, the Meeting takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders and the Bondholders decide to approve the transformation the Company into a specialised invest-

ment fund under the Law of 2007 under the form of société d'investissement à capital variable (SICAV) in accordance
with the Law of 2007.

<i>Second resolution

The Shareholders decide to change the name of the Company from BPT HANSA LUX S.A. to BPT HANSA LUX

SICAV-SIF.

<i>Third resolution

The Shareholders decide to restate the Articles so as to comply with the provisions of the Law of 2007 and as to read

as follows:

Title I Name - registered office - duration - purpose

Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares

hereafter issued, a public limited company («société anonyme») qualifying as an investment company with variable share
capital-specialised investment fund («société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé») under
the name of BPT HANSA LUX SICAV-SIF (the «Company»).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the commune of Luxembourg by

resolution of the Board of Directors (the «Board»).

21225

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad (but

in no event in the United States of America, its territories or possessions) by a decision of the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent

which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation  of  these  abnormal  circumstances;  such  provisional  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the
Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment

by a resolution of the shareholders adopted by Qualified Majority, as prescribed in Article 22 hereof. Due to the specific
structure of the Company, the Board may submit, at the date of the annual general meeting to be held in 2022 a proposal
to the shareholders to restructure the Company. Any such proposal for restructuring the Company will require a Quali-
fied Majority. If such proposal is rejected, the Board shall, within the following 12 months and at the latest on the date
of  the  annual  general  meeting  to  be  held  in  2023,  submit  to  the  shareholders  a  proposal  to  put  the  Company  into
liquidation.

Art. 4. Purpose. The exclusive purpose of the Company is to invest, either directly or indirectly through its wholly

owned subsidiaries, the funds available to it in real estate, real estate related assets of all types and other permitted assets,
in accordance with the investment strategy referred to in Article 19, with the purpose of spreading investment risks and
affording its shareholders the results of the management of its assets. The Company may also invest the funds available
to it in cash, cash equivalents and any other assets permitted by law and consistent with such purpose.

The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and

development of its purpose to the fullest extent permitted under the law of 13th February 2007 on specialised investment
funds (the «Law of 2007»).

Title II Share capital - shares - net asset value

Art. 5. Share Capital - Classes of Shares. The capital of the Company shall be represented by fully paid up shares of

no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 11. The minimum
capital of the Company is one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000) and must be achieved within
twelve months after the date on which the Company has been authorised as a specialised investment fund under Lux-
embourg law.

The shares to be issued pursuant to Article 8 may, as the Board shall determine, be of one or more different classes

or series (each such class or series, a «Class»), the features, terms and conditions of which shall be established by the
Board. The proceeds from the issuance of shares of any Class shall be invested pursuant to the investment policy deter-
mined by the Board for the Company, subject to the investment restrictions determined by the Board. For the purpose
of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Class of shares shall, if not expressed in
Euro, be converted into Euro and the capital shall be the total of the net assets of all the Classes of shares.

For the avoidance of doubt, the Company shall in any event issue class BPT shares (the «Class BPT Shares»). Class

BPT Shares shall be issued to BALTIC PROPERTY TRUST ASSET MANAGEMENT A/S (BPTAM), its subsidiaries or any
company controlled by BPTAM (BPTAM Group).

Art. 6. Form of Shares. The shares of the Company shall be issued in registered form.
All issued shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by the Company

or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner
of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered shares held
by him and the amount paid up on each fractional share.

The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences his right of ownership of such

registered shares. The Company may issue confirmation of the shareholding by delivery of share certificates or otherwise.
In the absence of a request for registered shares to be issued with certificates, shareholders will be deemed to have
requested that their shares be issued without certificates.

Art. 7. Transfer of shares-restrictions. The shares of the Company are freely transferable, subject to the provisions

and limitations set forth hereafter. Every transfer of a share shall be entered in the register of shareholders upon payment
of such customary fee as shall have been approved by the Board for registering any other document relating to or affecting
the title to any Share.

Shareholders must give the Board 30 days' prior notice of all proposed transfers and all transfers are subject to the

transferee providing the Board with appropriate anti-money laundering documentation and, while the transferor has
outstanding Commitments, proof that the transferee has sufficient covenant strength to satisfy its obligations in relation
to the transferred Commitment.

The Board shall not unreasonably withhold its consent to a transfer of shares; provided however that the Board shall

be entitled to refuse the transfer of shares in the following circumstances:

(a)  if  the  Board  reasonably considers that  the  transfer  would result in a situation  or  event that  would cause  the

Company to be dissolved;

21226

(b) if the transfer would result in shares being held by any person not qualifying as an Well Informed Investor (as

defined in Article 10);

(c) if the transfer is to a US Person or a German Resident (as defined hereafter);
(d) if the Board considers that the transfer would violate any applicable law and in particular the Law of 2007, regulation

or any term of these Articles, and in particular Article 11 hereinafter;

(e) if the Board considers the transferee to be of inappropriate creditworthiness;
(f) if the transfer would result in the transferor or transferee holding shares representing a Commitment of less than

the minimum Commitment; for the avoidance of doubt this shall not apply to a transfer relating to all shares of the
transferor;

(g) if the Board considers that the transfer may adversely affect the Company's reputation or its situation towards

potential competitors;

(h) if a shareholder would hold more than 25% of all the shares in issue.
If the transfer is refused for a reason pursuant to (a) to (h) above the Board shall inform the transferor of such reason

and provide reasonable evidence thereof.

Any transfer of shares made otherwise than in accordance with the provisions of these Articles shall be void and shall

not be registered in the register of shareholders of the Company.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such

address will also be entered into the register of shareholders.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be

entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of
the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another
address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as
entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or
at such other address as may be set by the Company from time to time.

If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been lost, mutilated or

destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees as the
Company may determine. Upon the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate,
the original share certificate in replacement of which the new one has been issued shall become void.

Mutilated share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.
The Company may, at its election, charge the shareholders the costs of a duplicate or of a new share certificate and

all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issuance and registration thereof or in con-
nection with the annulment of the original share certificate.

The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership

of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent
such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to
such share(s).

Shares may, if the Board so decides, be issued in fractions up to three decimal places. Such fractional shares shall not

be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Class of shares on a
pro rata basis.

Art. 8. Issuance of Shares. The Board is authorised, during a period of 48 months starting at the date of the Initial

Closing, to issue without limitation an unlimited number of fully paid up shares at any time without reserving to existing
shareholders a preferential subscription right.

The Board may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued. The Board may, in particular,

decide that shares shall only be issued during one or more offering periods or at such other periodicity as provided for
in the Private Placement Memorandum (the «PPM») for the shares.

Furthermore, the Board may temporarily discontinue or finally suspend the issuance of shares without any prior notice

to shareholders, if the Board determines that this is in the best interest of the Company and the existing shareholders.

Investors wishing to subscribe for shares or existing shareholders wishing to subscribe for further shares following

the Initial Closing (a «Subsequent Closing») will be required to execute a subscription agreement and indicate therein
their total committed capital (the «Commitment» or «Commitments»); provided however that no shareholder of the
Company may hold at any time more than 25% of the total number of shares in issue. The minimum Commitment shall
be €125,000, unless the Board in its discretion accepts a lower amount. The Board may in its discretion accept or refuse
an offer to subscribe for shares made by an Investor. No subscription will be accepted more than 48 months after the
Initial Closing. Shares will not be offered for subscription to and may not be subscribed by investors resident in the Federal
Republic of Germany (a «German Resident»).

If a subscription is accepted by the Board, Commitments received from Investors may be drawn down by the Board,

in whole or in part, during a period of maximum 48 months after the Initial Closing (the «Commitment Period»).

21227

Commitments will cease to be available for draw-down after the expiry of 48 months period from the Initial Closing;

provided however that Commitments may be drawn down thereafter to the extent necessary (i) to pay fees, expenses
and liabilities of the Company, (ii) to complete any investments that have been committed to during the Commitment
Period such as the acquisition of a new property upon its completion or a refurbishment project or (iii) to make any
follow-on investments in existing transactions, in this latter case up to a maximum of 10% of Commitments. After the
expiry of 12 months following the end of the Commitment Period, Commitments will cease to be available for drawdowns
other than to satisfy any legal or contractual obligations of the Company, including without limitation in relation to their
position as a landlord of their existing real estate investments. Before drawing down Commitments pursuant to this
paragraph the Board shall examine other possible funding arrangements and select the most appropriate funding ar-
rangement.

The Board shall, subject to its knowledge, give the shareholders an estimate as to the likely extent of such obligations

at the end of the Commitment Period and again at the end of the additional 12 month period.

In no event will an Investor be required to make a capital contribution at any time in any amount in excess of its total

Commitment.

The price per share at which shares are issued at the Initial Closing shall be the initial subscription price of €1,000 and

thereafter the price per share at which the shares of each Class are issued shall be the Net Asset Value per share of the
relevant Class, as at the most recent Valuation Date determined in compliance with Article 11 as further adjusted on the
following basis:

(a) an adjustment shall be made for the difference between any deferred tax liability required to be provided for under

International Financial Reporting Standards as amended from time to time («IFRS») and the estimated future tax liabilities
as estimated by the Board.

(b) the Board shall be entitled to require an additional assessment of the Net Asset Value including a property valuation,

prior to determining the Net Asset Value for the purpose of any issue of any shares, where the Board considers that
there has been an intervening event since the last Valuation Day which would render the current valuation materially
misleading.

(c)  the  Board  shall  make  such  further  adjustment  to  the  calculation  of  the  price  per  share  as  they  may  consider

appropriate to ensure fairness between all shareholders.

The Board may rely on advice from its advisors in quantifying the likely amount of any estimated tax liabilities and take

such other advice as they consider appropriate before making a determination as to the appropriate adjustment to the
NAV calculation.

Each new shareholder shall also be required (to the extent not already included in the Net Asset Value pursuant to

Article 11) to pay on subscription its pro rata share (as determined by the Board) of the costs of establishment, organi-
sation and administration of the Company, property advisor fees, acquisition fees, disposal fees, financing fees and other
fixed fees recalculated from the Initial Closing date as if all shareholders had been admitted to the Company and had
subscribed for their Commitments at the time of the Initial Closing.

Where a new shareholder commits to subscribe for shares on a Subsequent Closing and Commitments are drawn

down by the Board, the Board shall draw down the entirety of the Commitments from the shareholders having made
their Commitments prior to the Subsequent Closing, until the proportion of their total Commitments have been fully
drawn down, before the Commitments of the new shareholders are drawn down.

The issue price, as determined by the Board and disclosed in the PPM of the shares subscribed shall be payable within

the time limit as determined from time to time by the Board which shall not be later than fifteen business days from the
relevant issue date or Valuation Day. The Board may delegate to any director, manager, officer or other duly authorised
agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver
them.

The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities or other assets which

could be acquired by the Company pursuant to its investment policy and restrictions, in compliance with the conditions
set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from the auditor of the Company.

Art. 9. Redemption of Shares. Shares may be tendered for redemption after a holding period of 10 years from the date

of issue.

Following such holding period, a shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the Company,

under the terms and procedures set forth by the Board in the PPM and within the limits provided by law and these
Articles. For avoidance of doubt, the aforesaid holding period will only apply to redemption of shares by the Company
and not to a transfer of shares.

In order to be accepted by the Company, any request for redemption of shares must be filed by the applying shareholder

in written form so as to arrive at the registered office of the Company in Luxembourg, at least ninety days prior to the
last bank business day of each quarter on which the shareholder wishes his redemption to be valued (the «Redemption
Valuation Day»), together with the certificate or certificates for such shares in proper form.

21228

There may be no redemption that would result in the redeeming shareholder holding shares representing a Commit-

ment of less than €125,000 unless the Board in its discretion agrees otherwise. For the avoidance of doubt, a redemption
of all of the shares of a redeeming shareholder does not require such Board approval.

The repurchase price shall be based on the Net Asset Value of shares as determined as at the applicable Redemption

Valuation Day in accordance with the provisions of Article 11 hereof. For the purposes of calculating the Net Asset Value
the Board may, in its absolute discretion, request the valuers to carry out a full property valuation in accordance with
Article 11(I)(9)(a). Any costs of the NAV valuation and such property valuation will be covered by the redeeming share-
holder. The repurchase price may be reduced by disposal costs and the breakage costs of financing, real or potential tax
liabilities, and an accrual of performance fees payable to any property advisor, as the Board may from time to time decide
and subject to a redemption fee calculated as follows:

Number of years since the

Redemption fee

Shares were subscribed for

as a percentage

of shareholder's

commitment

Up to 10 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5%

10 to 11 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4%

11 to 12 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3%

12 to 13 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2%

More than 13 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1%

Subject to the provisions below, the payment for the redemption of such shares will be made within thirty days from

the relevant Redemption Valuation Day.

The Board will only accept the relevant redemption requests, based on the Net Asset Value calculated on the Re-

demption Valuation Day, if sufficient liquid assets are available or have been made available. The Board may decide to
temporarily suspend the right to redeem shares if extraordinary circumstances occur which deem to make necessary
such suspension in the interest of the shareholders. In particular, the Board reserves the right to suspend the redemptions
of shares due to the lack of liquid assets if this seems necessary to protect the shareholders. If bank deposits and proceeds
from the sale of liquid assets are not sufficient for the payment of repurchase prices and proper conduction of business
of the Company, or if bank deposits and liquid assets are not available immediately at the time of a requested redemption,
then the Company is entitled to suspend the right to redemption for a period of three months as of the applicable
Redemption Valuation Day. If bank deposits and the proceeds from the sale of liquid assets are not sufficient after the
end of the aforementioned three-months-period, then the Board shall realise sufficient investments of the Company,
under due consideration of the interests of all the shareholders. The realisation of such investments will be made over a
period not exceeding one year from the Redemption Valuation Day on which the right to redemption was initially sus-
pended. The Company may suspend the right to redemptions until it is able to sell or encumber sufficient real property
on appropriate terms. The aforementioned one-year period may be extended by the Company for another year by giving
written notice to the shareholders. After the lifting of the suspension of the right to redeem shares, redemption requests
will be dealt with at the Net Asset Value determined for the shares on the next Redemption Valuation Day after the end
of such suspension. For the avoidance of doubt, in the event that the suspension is extended for the maximum two-year
period, the redemption will take place on the second anniversary of the original Redemption Valuation Date.

In addition to the foregoing, the Board may decide to temporarily suspend the redemption of shares if exceptional

circumstances as set forth in Article 12 «Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share» so warrant.

Any request for redemption shall be irrevocable except in the event of suspension of redemption pursuant to Article

12 hereof. In the event of any such suspension under Article 12 hereof, redemption will occur, as of the first business
day after the end of the suspension

If at any time a shareholder who has committed to subscribe for shares fails to honour its commitment through the

full payment of the subscription price within the timeframe decided by the Board (a «Defaulting Shareholder») and referred
to in the PPM, the Board has the authority, in addition to legal remedies, to charge interest on the resulting unpaid amount
at 4% per annum above European Central Bank's base rate from time to time. If the unpaid amount, plus interest thereon,
is not paid within 30 days, the Board shall have the right to:

a) impose damages corresponding to 10% of the amount committed by the investor; and
b) set off any distributions to the Defaulting Shareholder until any amounts owing to the Company have been paid in

full; and

c) redeem the shares of the Defaulting Shareholder as described in Article 10. below upon payment to such Defaulting

Shareholder of an amount equal to 85% of the NAV of its shareholding in the Company payable at the time of liquidation
of the Company;

d) reduce or terminate the Defaulting Shareholder's Commitment;
e) exercise any other remedy available under applicable law;

21229

f) offer the non-defaulting investor the right to purchase the defaulting investors interest in the Company at a price

equal to 85% of the Net Asset Value of the interest in the Company; or

g) admit new investors in order to replace the Defaulting Shareholder.
All redeemed shares shall be cancelled.

Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares and Compulsory Sale of Shares by the Board. The Board may restrict

or prevent the ownership of shares in the Company by any person, including a US Person or a German Resident, firm
or corporate body (a «Precluded Person»), if in the judgement of the Board such holding may be detrimental to the
Company or the majority of its shareholders; if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg
or foreign; if as a result thereof it may have adverse regulatory, tax or fiscal consequences, in particular if as a result
thereof the Company would become subject to laws other than those of the Grand Duchy of Luxembourg (including but
without limitation tax laws); or if a single shareholder would hold at any time more than 25% of the total number of
shares in issue. If the Board deems any such person to be a Precluded Person it shall inform such person of the reason
and provide reasonable evidence thereof.

Specifically, the Board shall restrict the issue of shares in the Company to well informed investors (a «Well Informed

Investor») as defined in article 2 of the Law of 2007. For such purposes the Board may:

A.- decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry

or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such shares by a Precluded Person or an investor
other than an Well Informed Investor; and

B.- at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares

in the register of shareholders, to furnish it with any information, which it may consider necessary for the purpose of
determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests in a Precluded Person or an investor
other than an Well Informed Investor, or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a
Precluded Person or an investor other than an Well Informed Investor; and

C.- decline to accept the vote of any Precluded Person or investor other than an Well Informed Investor at any meeting

of shareholders of the Company; and

D.- where it appears to the Board that any Precluded Person or an investor other than an Well Informed Investor

either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of shares, direct such shareholder to sell his
shares and to provide to the Company evidence of the sale within thirty (30) days of the notice. If such shareholder fails
to comply with the direction, the Company may undertake, on behalf of the relevant shareholder, a compulsory sale of
all the shares held by such shareholder in the manner described hereafter.

In the circumstances described in Article 9 and this Article 10, the Board may decide to undertake on behalf of the

relevant shareholder a compulsory sale of his shares. Upon the relevant shareholder having failed to comply with his
commitment (in case of Article 9) or the direction from the Board (in case of this Article 10) within 30 calendar days
from a correspondent notice (the «Notice of Transfer») from the Board, he shall be deemed to have given authority to
the  Board  to  sell  his  shares  to  a  person  permitted,  under  these  Articles  and  under  any  other  terms  which  may  be
determined by the Board, to acquire the shares (a «Permitted Transferee»), and for this purpose, he shall be deemed to
have granted authority to the Board to execute, on his behalf, a written declaration of transfer as referred to in Article
7 and to agree on a transfer price (the «Transfer Price») with the Permitted Transferee.

The Transfer Price shall be negotiated by the Board without the requirement for the Board to achieve any minimum

Transfer Price. During the period of 30 calendar days from the Notice of Transfer, the shareholder may notify to the
Board the name of a potential transferee. If such potential transferee meets all requirements normally imposed by the
Board on a Permitted Transferee, the Board shall not reasonably withhold its consent to such transfer. Upon a transfer
agreed by the Board, on behalf of the shareholder, to a Permitted Transferee after the period of 30 calendar days from
the Notice of Transfer, the Board and the Company shall have no other obligation towards the former shareholder than
to credit him with the Transfer Price agreed upon and paid by the Permitted Transferee, after deduction of any costs
incurred in relation with the transfer. In case the Board is not able to identify a Permitted Transferee who accepts to
acquire the shares within 90 calendar days from the Notice of Transfer, the relevant shares shall be forfeited and cancelled,
and the former holder thereof shall no longer be a shareholder of the Company.

The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any

case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any notice of sale, provided in such case the
said powers were exercised by the Company in good faith.

Whenever used in these Articles, «United States» or «U.S.» means the United States of America (including the States

and the District of Columbia) and any of its territories, possessions and other areas subject to its jurisdiction and «United
States Person» means a citizen or resident of the United States, or any corporation, partnership or other entity created
in or under the laws of the United States or any person falling within the definition of the term «U.S. Person» under
Regulation S promulgated under United States Securities Act of 1933.

21230

Art. 11. Calculation of Net Asset Value per Share. The net asset value of a share of the Company («Net Asset Value»)

shall be calculated by the Central Administration under the responsibility of the Board of Directors in accordance with
Luxembourg law and the IFRS, in accordance with the provisions of this Article.

The Net Asset Value per share of each Class of shares shall be expressed in Euro as a per share figure. The Company

will calculate a Net Asset Value in case where a shareholder requests redemption of part or all of his Shares or in the
case of a further issue of shares. The Net Asset Value per share of each class shall be determined on the last bank business
day of each quarter or more frequently as the Board may decide (each a «Valuation Day»), by dividing the net assets of
the Company, being the value of the portion of assets attributable to such Class less the portion of liabilities attributable
to such Class, calculated at such time as the Board shall have set for such purpose, by the total number of shares in the
Company then outstanding, in accordance with the valuation rules set forth below. The Net Asset Value per share may
be rounded up or down as the Board shall determine.

The Net Asset Value per share will be available not later than 20 Business Days after receipt of the Net Asset Value

valuation.

The valuation of the Net Asset Value of shares shall be made in the following manner; provided however that:
a) defaulted shares shall be disregarded for the purpose of calculation of the Net Asset Value other than in relation

to the determination of the compulsory redemption price as described in Article 10 hereabove; and

b) the unpaid portion of the committed capital in respect of any shares not already issued shall be disregarded in

calculating the Net Asset Value of such shares:

I. The assets of the Company shall include (without limitation):
1. property investments or property rights registered in the name of the Company or subsidiaries controlled by the

Company;

2. shareholdings in convertible and other debt securities of real estate companies;
3. all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
4. all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of properties, property rights, se-

curities or any other assets sold but not delivered);

5. all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, war-

rants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company
(provided that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (d) below with regard
to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);

6. all stock dividends, cash dividends and cash payments receivable by the Company to the extent information thereon

is reasonably available to the Company;

7. all rentals accrued on any property investments or interest accrued on any interest-bearing assets owned by the

Company except to the extent that the same is included or reflected in the value attributed to such asset;

8. the formation expenses of the Company, including Organisation Cost and the cost of issuing and distributing shares

of the Company, insofar as the same have not been written off; and

9. all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
The value of such assets shall be determined as follows:
(a) subject as prescribed below, real estate will be valued by an independent appraiser annually and on such other days

as  the  Board  may  determine.  Each  such  valuation  will  be  made  on  the  basis  of  the  gross  open  market  value  and  in
accordance with the methodology reflected in the Company's PPM;

(b) subject as specified below, the securities of real estate companies which are not listed on a stock exchange nor

dealt in on another regulated market will be valued on the basis of the probable net realisation value (excluding any
deferred taxation) estimated with prudence and in good faith with the Company using the value of real estate as deter-
mined in accordance with (a) above and as prescribed below;

(c) the value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash

dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof,
unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after
making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof;

(d) all other securities and other assets, including debt securities, restricted securities and securities for which no

market quotation is available, are valued on the basis of dealer-supplied quotations or by a pricing service approved by
the Board or, to the extent such prices are not deemed to be representative of market values, such securities and other
assets shall be valued at fair value as determined in good faith by the Board. Money market instruments held by the
Company with a remaining maturity of 90 days or less will be valued by the amortised cost method, which approximates
market value.

The appraisal of the value of (i) property investments and property rights registered in the name of the Company or

any of its directly or indirectly wholly-owned subsidiaries and (ii) direct or indirect shareholdings of the Company in real
estate companies referred to under (b) above in which the Company shall hold more than 50% of the outstanding voting
stock, shall be undertaken by the independent appraiser. Such valuation may be established at the accounting year end

21231

and used throughout the following year unless there is a change in the general economic situation or in the condition of
the relevant properties or property rights held by the Company or by any of the companies in which the Company has
a shareholding which requires new valuations to be carried out under the same conditions as the annual valuations.

The value of all assets and liabilities not expressed in Euro will be converted into Euro at the relevant rates of exchange

ruling on the relevant Valuation Day. If such quotations are not available, the rate of exchange will be determined in good
faith by the Board.

The Board may permit some other method of valuation to be used, if it considers that such valuation better reflects

the fair value of any asset of the Company.

II. The liabilities of the Company shall include (without limitation):
1) all loans, bills and accounts payable;
2) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
3) all accrued or payable expenses (including administrative expenses, management fees, incentive fees, custodian fees,

and corporate agents' fees);

4) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or

property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;

5) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from

time to time by the Company, and other reserves (if any) authorised and approved by the Board, as well as such amount
(if any) as the Board may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Company;

6) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with Luxembourg law

and IFRS. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the
Company which may comprise:

(a) all organisational expenses relating to the establishment of the Company, preparation of the placing documents

and related agreements including but not limited to legal, accounting and independent valuer's fees, securities filing fees,
postage and out of pocket expenses incurred excluding marketing expenses and travel expenses;

b) all operational expenses including, but not limited to fees and expenses payable to the Company's auditors and

accountants, custodian and its correspondents, domiciliary and corporate agent, registrar and transfer agent, any paying
agent, any permanent representatives in places of registration, as well as any other agent employed by the Company, the
remuneration (if any) of the directors and their reasonable out-of-pocket expenses, insurance coverage, fees and expenses
for legal and auditing services, any fees and expenses involved in registering and maintaining the registration of the Com-
pany  with  any  Governmental  agencies  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  and  in  any  other  country,  reporting  and
publishing expenses, including the cost of preparing, printing, and distributing periodical reports or registration statements,
and the costs of any reports to shareholders, all taxes, duties, governmental and similar charges, and all other operating
expenses, including the cost of identifying, buying, holding and selling assets, property agency fees, if applicable, interest,
bank charges and brokerage, postage, telephone and telex, hedging costs and borrowing costs and fees and expenses and
costs of third party services related to the transactions, assets, projects, asset owning companies in relation to both
completed and uncompleted transactions. The Company may accrue administrative and other expenses of a regular or
recurring nature based on an estimated amount rateably for yearly or other periods. Legal, accounting and independent
valuer's fees and organisational expenses connected with the establishing of the Company shall be paid or reimbursed by
the Company upon Initial Closing.

7) All financial liabilities of the Company shall be valued at their mark to market value and the net result in the figures

should be treated as an asset or a liability of the Company;

8) Any performance fees not ascertained at the relevant time shall be based on a bona fide estimate of the likely amount

of such fees.

Shareholders shall, on request, be given details of any of the fees and expenses referred to in this Article 11.
The value of the Company's liabilities are recorded at cost or amortised cost with the exception of any derivatives

which are recorded at fair value.

All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with Luxembourg law and

IFRS.

If there has been created one or more Classes, the allocation rules set forth above shall apply, as appropriate, to such

Classes.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value taken

by the Board or by any bank, company or other organisation which the Board may appoint for the purpose of calculating
the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders.

Art. 12. Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share. The determination of the Net Asset Value

per share of one or more Classes (if issued) may be suspended:

- during any period when one or more exchanges which provide the basis for valuing a substantial portion of the assets

of the Company are closed other than for, or during, holidays or if dealings are restricted or suspended or where trading
is restricted or suspended; or

21232

- during any period if, in the reasonable opinion of the Board, a fair valuation of the assets of the Company is not

practical for reasons of force majeure or act of nature beyond the control of the Board; or

- during the existence of any state of affairs as a result of which or valuation of assets of the Company would be

impracticable; or

- during any breakdown in excess of one week in the means of communication normally employed in determining the

value of the assets of the Company; or

-  when  the  central  administration  agent  advises  that  the  Net  Asset  Value  of  any  wholly  owned  subsidiary  of  the

Company may not be determined accurately; or

- on publication of a notice convening an extraordinary general meeting of shareholders for the purpose of resolving

the liquidation of the Company; or

- when for any reason the independent property valuer advises that the prices of any investments cannot be promptly

or accurately determined.

Any such suspension or lifting will be promptly notified to shareholders.

Title III Administration and supervision

Art. 13. Directors. The Company shall be managed by a board of directors (the «Board») composed of five members,

who need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term of a maximum of six years and shall hold
office until their successor is appointed. The shareholders of the Class BPT Shares, as described in Article 6 hereof, are
entitled to propose to the general meeting of shareholders a list containing the names of candidates for the position of
director of the Company.

The Class BPT shareholders (the «Class BPT Shareholders») shall propose a list of candidates to the general meeting

of shareholders out of which at least two directors must be appointed by the general meeting of shareholders to the
Board as Class BPT directors (the «Class BPT Directors»). The list of candidates submitted by the Class BPT Shareholders
shall indicate a number of candidates equal to at least twice the number of directors to be appointed as Class BPT
Directors. Shareholders may not express their votes for a number of candidates exceeding the number of directors to
be appointed as Class BPT Directors. The candidates of the list having received the highest number of votes will be
elected.

In addition, any shareholder who wants to propose a candidate for the position of directors of the Company to the

general meeting of shareholders, must present such candidate to the Company in writing at least three weeks prior to
the date of such general meeting. For the avoidance of doubt, the list of candidates of the Class BPT Shareholders must
also comply with such requirement.

Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general

meeting, provided however that if a Class BPT Director is removed, the remaining directors must call for an extraordinary
general meeting without delay in order for a new Class BPT Director to be appointed in his place and the new Class BPT
Director appointed by the general meeting of shareholders must be chosen from the candidate(s) on the list presented
by the Class BPT Shareholders.

In the event of a vacancy in the office of director, the remaining directors may temporarily fill such vacancy; the

shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting. For the avoidance of
doubt, a vacancy in the office of a Class BPT Director must be filled with a new Class BPT Director.

Art. 14. Board Meetings. All Board meetings will be held in Luxembourg or such other place abroad, as specified in

the convening notice. The Board shall choose from among the Class BPT Directors a chairman, and may choose from
among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall
write and keep the minutes of the meetings of the Board and of the shareholders. The Board shall meet upon call by the
chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at the meetings of the directors and of the shareholders. In his absence, the shareholders

or the Board members shall decide by a majority vote that another director, or in case of a shareholders' meeting, that
any other person shall be in the chair of such meetings.

The Board may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as well as any

other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such appointments
may be cancelled at any time by the Board. The officers need not be directors or shareholders of the Company. Unless
otherwise stipulated by these Articles of Association, the officers shall have the rights and duties conferred upon them
by the Board.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all directors at least twenty-four hours prior to the date

set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set
forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by email, telegram, telex, telefax or any
other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed
in a resolution adopted by the Board.

Any director may act at any meeting by appointing in writing, by email, telegram, telex or telefax or any other similar

means of communication a Luxembourg resident director as his proxy. A director may represent several of his colleagues.

21233

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call or similar means of communication equipment

whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall
constitute presence in person at such meeting. Such conference calls shall, to the extent this is practicable, be initiated
in Luxembourg. The majority of the directors participating will, to the extent this is practicable, be physically present in
Luxembourg at the time of the conference call.

The directors may only act at duly convened meetings of the Board provided however that resolutions of the Board

may also be passed in the form of a consent resolution in identical terms in the form of one or several documents in
writing, signed by all the Directors or by telex, telegram or telefax message, which shall together constitute appropriate
minutes evidencing such decision.

The directors may not bind the Company by their individual signatures, except if specifically authorised thereto by

resolution of the Board.

The Board can deliberate or act validly only if at least three directors, or any other number of directors that the Board

may determine, are present or represented.

Resolutions of the Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of extracts of

such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting
or any two directors.

Resolutions are taken by a majority vote of the directors present or represented and the chairman shall have a casting

vote.

Art. 15. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and

administration within the Company's purpose, in compliance with its investment policy.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the general meeting of share-

holders are in the competence of the Board.

Art. 16. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the signature of any two directors

acting jointly or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the Board.

Art. 17. Delegation of Power. The Board of the Company may delegate its powers to conduct the daily management

and affairs of the Company (including the right to act as authorised signatory for the Company) and its powers to carry
out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities,
which need not be members of the Board, who shall have the powers determined by the Board and who may, if the Board
so authorises, sub-delegate their powers.

The Board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.

Art. 18. Investment Manager. The Company shall enter into an investment management agreement with one or several

investment managers as further described in the PPM, who shall notably supply the Company with recommendations and
advice in connection with the management of the assets of the Company, in accordance with the investment objective
and strategy as described in the PPM. This(ese) investment manager(s) shall be part of the BPT Group. In the event that
an investment manager ceases to be a member of the BPT Group or a majority participation in the Company is held by
an entity not part of the BPT Group, the Company shall, on request by an BPT entity, change its name to another name
omitting the word «BPT» and not including any brand name of any company within the BPT Group.

Art. 19. Investment Policies and Restrictions. The Board has the power to determine the investment policies and

strategies of the Company, based upon the principle of risk spreading, and the course of conduct of the management and
business affairs of the Company, within the restrictions as shall be set forth by the Board in compliance with applicable
laws and regulations.

Investments of the Corporation may be made either directly or indirectly through subsidiaries, as the Board of Di-

rectors  may  from  time  to  time  decide.  Reference  in  these  Articles  to  «investments»  and  «assets»  shall  mean,  as
appropriate, either investments made and assets hold directly or investments made and assets hold indirectly through
the aforesaid subsidiaries.

Art. 20. Indemnification of Directors. The Company may indemnify any director or officer and her/his heirs, executors

and administrators, against expenses reasonably incurred by her/him in connection with any action, suit or proceeding
to which she/he may be made a party by reason of her/his being or having been a director or officer of the Company or,
at its request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which she/he is not
entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which she/he shall be finally adjudged in such action, suit
or proceeding to be liable for her/his wilful misconduct, bad faith, fraud, reckless disregard or gross negligence; in the
event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement
as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty.
The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 21. Auditors. The accounting information comprised in the annual report of the Company shall be audited by an

auditor  («réviseur  d'entreprises  agréé»)  appointed  by  the  general  meeting  of  shareholders  and  remunerated  by  the
Company.

21234

The auditor shall fulfil all duties prescribed by the Law of 2007.

Title IV General meetings - accounting year - distributions

Art. 22. General Meetings of Shareholders of the Company. The general meeting of shareholders of the Company

shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders
regardless of the Class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating
to the operations of the Company.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the Board. It may also be called upon the request of

shareholders representing at least one fifth (i.e. 20 %) of the share capital.

For the purposes of these Articles of Association:
(a) a «Qualified Majority» shall mean a decision taken by majority vote of 75 % of the shares present or represented

at a shareholder's meeting where a quorum of two-thirds of all the shares in issue, at the date of the meeting, has been
reached. If the quorum is not reached at the first meeting, the meeting shall be reconvened. Any reconvened meeting
having the same agenda will not be subject to the above quorum requirement and decisions are validly taken by majority
vote of 75 % of the shares present or represented at such reconvened meeting.

(b) subject to the requirements of Luxembourg law, any other reference to a shareholders vote shall mean a decision

taken by majority vote of the shares present or represented at a shareholder's meeting in which there shall be no quorum
requirements.

The annual meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, on the

fifteenth day of the month of June at 11 a.m.

If such day is not a business day the annual meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of

meeting.

Shareholders shall meet upon call by the Board pursuant to a notice setting forth the agenda, time and place of the

meeting, the applicable quorum and the majority requirements, sent at least eight days prior to the meeting to each
registered shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders. The giving of such notice to registered
shareholders need not be justified to the meeting. The agenda shall be prepared by the Board except in the instance
where the meeting is called on the written demand of the shareholders in which instance the Board may prepare a
supplementary agenda.

Such notice shall in addition be published, if provided by Luxembourg law, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations and in such other newspapers as the Board shall determine.

The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend any meeting

of shareholders.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda

(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

The shareholders of the Class or Classes (if any) issued, may hold, at any time, general meetings to decide on any

matters which relate exclusively to such Class or Classes.

Each whole share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles of Association. Share-

holders may act either in person or by giving a written proxy to another person who need not be a shareholder and may
be a director of the Company.

Art. 23. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin at the first day of January and shall terminate

on the last day of December of each year.

Art. 24. Distributions. To the extent permitted by law and having retained such amounts as are required for the proper

running of the Company and any identifiable liabilities or expenses of the Company as determined by the Board, the
profits of the Company may be distributed annually to the shareholders. If so decided, the Board shall declare and pay
to each shareholder a distribution within a time period of 20 business days after the due issuing of the annual report. The
Board may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by law.

If not reinvested pursuant to this article, net disposal proceeds and the proceeds of any refinancing after any deductions

required in relation to anticipated expenses or liabilities, as determined by the Board, shall be distributed to shareholders
within 60 business days.

No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
Net disposal proceeds received, if any, until the tenth anniversary of the Initial Closing may be re-invested rather than

distributed so long as 90% of the total Commitments have been permanently invested by the Company in investments.
Following the tenth anniversary of the Initial Closing such amounts may only be re-invested in follow-on investments in
existing investments.

Title V Final provisions

Art. 25. Custodian. As required by law, the Company shall enter into a custody agreement. The custodian shall fulfil

the duties and responsibilities as provided for by the Law of 2007.

21235

If the custodian desires to withdraw, the Board shall use its best efforts to find a successor custodian within two

months of the effectiveness of such withdrawal. The Board may terminate the appointment of the custodian but shall not
remove the custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed to act in the place thereof.

Art. 26. Dissolution of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting

of shareholders. Decision to dissolve the Company, except as provided in the following paragraphs, must be taken by
Qualified Majority.

Whenever the share capital falls below two-thirds of the minimum capital required by Luxembourg law, the question

of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting by the Board. The general meeting, for which
no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the votes of the shares represented at the meeting.

The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the share

capital falls below one-fourth of the minimum capital required by Luxembourg law; in such an event, the general meeting
shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one-fourth
of the votes of the shares represented at the meeting.

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets

of the Company have fallen below two-thirds or one-fourth of the legal minimum, as the case may be.

Art. 27. Liquidation. Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or

legal entities, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compen-
sation.

Art. 28. Amendments to the Articles of Association. These Articles of Association may be amended by a general

meeting of shareholders subject to a Qualified Majority vote of the shareholders.

Any change in the Articles of Association that affects the rights of shareholders of a Class must be approved by a

Qualified Majority vote of the shareholders of the Class concerned in addition to the Qualified Majority vote of the
shareholders referred to above.

Art. 29. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Association shall be determined in accordance

with the Law of 10 August 1915 on commercial companies and the Law of 2007.

<i>Fourth resolution

The Shareholders appoint ERNST &amp; YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg as auditor of the Company.

<i>Fifth resolution

The Shareholders fix the registered office of the Company at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Sixth resolution

The Shareholders appoint the following persons as directors:
- Dr. Claus Löwe, director, born on 23 October 1951 in Kiel, Germany, professionally residing at Große Friedberger

Straße 42, D-60313 Frankfurt am Main, Germany;

- Mr Lars Ohnemus, CEO, born on 11 June 1962 in Copenhagen, Denmark, professionally residing at Bredgade 23A,

DK-1260 Copenhagen K, Denmark;

- Mr Alain Heinz, director, born on 17 May 1968 in Forbach, France, professionally residing at 121, avenue de la

Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Dr. Schmidt zur Nedden, lawyer and notary, born on 2 September 1937 in Cologne, Germany, professionally residing

at Taunusanlage 11, D-60329 Frankfurt am Main, Germany; and

- M 

e

 Patrick Reuter, lawyer, born on 15 August 1963 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, professionally

residing at 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Their mandate shall lapse on the date of the annual general meeting of shareholders held in 2008.
There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the Meeting, the members of the bureau of the meeting, all of whom are known

to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present
original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausend und sieben, am achtundzwanzigsten Dezember.
Vor uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),

21236

wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre und Bondinhaber von BPT HANSA LUX S.A. (die

«Gesellschaft»), einer société anonyme mit eingetragenem Sitz in 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxemburg, ge-
gründet nach luxemburgischen Recht am 23. Oktober 2006 mit Urkunde von M 

e

 Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in

Luxemburg, die am 26. Januar 2007 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial») veröffentlicht
wurde. Die Satzung der Gesellschaft (die «Satzung») wurde zum letzten Mal mit Urkunde von M 

e

 Henri Hellinckx am 9.

November 2007, veröffentlicht im Mémorial am 15. Dezember 2007, geändert.

Die außerordentliche Generalversammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von M 

e

 Stéphanie Alexandrino, maître

en droit, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende bestimmte M 

e

 Eva Brauckmann, Volljuristin, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Protokollführer.

Die Generalversammlung bestimmte M 

e

 Patrick Reuter, maître en droit, in Luxemburg, zum Stimmenzähler.

Die  bei  der  vorliegenden  außerordentlichen  Generalversammlung  (die  «Generalversammlung»)  anwesenden  oder

vertretenen Aktionäre und Bondinhaber sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien / Bonds sind auf der Anwe-
senheitsliste  aufgeführt.  Diese  Liste  sowie  die  Vollmachten  wurden  ne  varietur  von  den  Mitgliedern  des  Büros,  den
anwesenden Aktionären / Bondinhabern, die Vollmachtnehmern der vertretenen Aktionäre und Bondinhaber sowie dem
unterzeichneten Notar paragraphiert und werden als Anhang der vorliegenden Urkunde mit dieser bei der Eintragungs-
behörde eingereicht.

Nachdem das Büro der Generalversammlung auf diese Weise gebildet wurde, erklärte der Vorsitzende und beauftragte

den Notar, folgendes festzustellen:

I. Die vorliegende Generalversammlung wurde durch Mitteilungen, die die Tagesordnung der Generalversammlung

enthielt und mittels eingeschriebenen Briefes am 20. Dezember 2007 an alle Inhaber von Bonds der Gesellschaft (die
«Bondinhaber») geschickt wurde, einberufen; the Aktionäre der Gesellschaft (die «Aktionäre») haben durch Vollmacht
auf ihr Recht auf eine Einberufungsmitteilung verzichtet.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle am Tag dieser Generalversammlung von der Gesellschaft ausge-

gebenen Aktien bei dieser Generalversammlung vertreten oder anwesend sind sowie dass einhundertvierundsiebzigtau-
send-dreihundertachtundzwanzig  (174.328)  von  insgesamt  zweihundertachtzehntausend-einhundertachtundsechzig
(218.168) von der Gesellschaft am Tag dieser Generalversammlung ausgegebenen Bonds bei dieser Generalversammlung
vertreten oder anwesend sind. Demzufolge ist die Generalversammlung rechtmäßig einberufen und kann rechtmäßig über
die Tagesordnungspunkte beraten.

III. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

Zur Abstimmung für Aktionäre und Bondinhaber
1. Genehmigung der Umwandlung der Gesellschaft in einen Spezialfonds nach dem luxemburgischen Gesetz vom 13.

Februar 2007 über Spezialfonds (das «Gesetz von 2007») in der Form einer société d'investissement à capital variable
(SICAV) in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 2007.

Nur zur Abstimmung für Aktionäre
2. Änderung des Namens der Gesellschaft von gegenwärtig BPT HANSA LUX S.A. in BPT HANSA LUX SICAV-SIF.
3. Genehmigung der neugefassten Satzung, um sie in Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 2007 zu bringen.
4. Ernennung von ERNST &amp; YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg zum Wirschaftprüfer der Gesell-

schaft.

5. Festlegung des Sitzes der Gesellschaft auf 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxemburg.
6. Ernennung von Dr. Claus Löwe, Herrn Lars Ohnemus, Herrn Alain Heinz, Dr. Peter Schmidt zur Nedden sowie M

e

 Patrick Reuter zu Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung.

7. Verschiedenes.
Nach Beratung fasst die Generalversammlung die folgenden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Aktionäre und Bondinhaber beschliessen, die Gesellschaft in einen Spezialfonds nach dem Gesetz von 2007 in der

Form einer société d'investissement à capital variable (SICAV) in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 2007 umzuwan-
deln.

<i>Zweiter Beschluss

Die Aktionäre beschliessen, den Namen der Gesellschaft von BPT HANSA LUX S.A. in BPT HANSA LUX SICAV-SIF

zu ändern.

<i>Dritter Beschluss

Die Aktionäre beschliessen, die Satzung der Gesellschaft neu zu fassen, damit sie im Einklang mit den Vorschriften des

Gesetzes von 2007 steht und wie folgt lautet:

21237

Titel I Name - Eingetragener Gesellschaftsitz - Dauer - Zweck

Art. 1. Name. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all jenen, die gegebenenfalls Eigentümer der nachfolgend

ausgegebenen Aktien werden, eine Aktiengesellschaft («société anonyme»), die als Investmentgesellschaft mit variablem
Stammkapital-Spezialfonds («société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé») einzustufen ist,
unter folgendem Namen errichtet: BPT HANSA LUX SICAV-SIF (die «Gesellschaft»).

Art. 2. Eingetragener Geschäftssitz. Als eingetragener Geschäftssitz der Gesellschaft wird Luxemburg, Großherzogtum

Luxemburg, festgelegt.

Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrats (der «Verwaltungsrat») an

jedweden anderen Ort in der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Zweigstellen, Tochterunternehmen oder sonstige Niederlassungen können auf Beschluss des Verwaltungsrats entwe-

der im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland (keinesfalls jedoch in den Vereinigten Staaten von Amerika, deren
Territorien oder Besitzungen) errichtet werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass außerordentliche politische oder militärische Ereignisse vorgefallen sind oder

unmittelbar drohen, die die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose
Kommunikation zwischen diesem Sitz und sich im Ausland aufhaltenden Personen beeinträchtigen, dann kann der einge-
tragene Sitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden;
derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbe-
schadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft kann jederzeit

durch einen Beschluss der Aktionäre aufgelöst werden, der mit Qualifizierter Mehrheit, wie in Artikel 22 beschrieben,
angenommen wurde. Aufgrund der besonderen Struktur der Gesellschaft, kann der Verwaltungsrat am Tag der im Jahr
2022 zu haltenden Generalversammlung den Vorschlag unterbreiten, die Gesellschaft zu restrukturieren. Jeder solche
Vorschlag, die Gesellschaft zu restrukturieren bedarf einer Qualifizierten Mehrheit. Wird ein solcher Vorschlag abgelehnt,
wird der Verwaltungsrat binnen der folgenden 12 Monate und spätestens am Tag der im Jahr 2023 abzuhaltenen Gene-
ralversammlung, den Aktionären den Vorschlag unterbreiten, die Gesellschaft aufzulösen.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die - direkt oder indirekt über 100%-

Tochtergesellschaften erfolgende - Investition der ihr zur Verfügung stehenden Finanzmittel in Immobilien, mit Immobilien
zusammenhängende Vermögensgüter aller Art und sonstige zulässigen Vermögenswerte, und zwar im Einklang mit der
in Artikel 19 beschriebenen Anlagestrategie, in der Absicht, die Anlagerisiken zu streuen und ihren Aktionären die Er-
gebnisse ihrer Vermögensverwaltung zuzuführen. Die Gesellschaft kann die ihr zur Verfügung stehenden Finanzmittel
auch in Bargeld, Barwerte und andere gesetzlich zulässige und mit diesem Zweck vereinbaren Anlagen investieren.

Die  Gesellschaft  kann  alle  Maßnahmen  setzen  und  jede  Transaktion  vornehmen,  die  sie  gegebenenfalls  als  für  die

Erfüllung und Entwicklung ihres Zwecks nützlich ansieht, und zwar im vollsten nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007
über Spezialfonds (das «Gesetz von 2007») zulässigen Ausmaß.

Titel II Stammkapital - Aktien - Nettovermögenswert

Art. 5. Stammkapital - Aktienklassen. Das Kapital der Gesellschaft wird durch zur Gänze einbezahlte Aktien ohne

Nennwert repräsentiert und entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Gesamtnettovermögen der Gesellschaft gemäß Artikel
11. Das Mindestkapital der Gesellschaft beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000 EUR) und muss
binnen zwölf Monaten nach dem Tag, an welchem die Gesellschaft als Spezialfonds nach Luxemburger Recht anerkannt
worden ist, erreicht werden.

Die gemäß Artikel 8 auszugebenden Aktien können je nach Entscheidung des Verwaltungsrats einer oder mehreren

Klassen beziehungsweise Serien angehören (jede solche Klasse beziehungsweise Serie wird als «Klasse» bezeichnet), deren
Merkmale, Bedingungen und Konditionen der Verwaltungsrat festlegt. Der Erlös aus der Ausgabe von Aktien jedweder
Klasse ist gemäß der vom Verwaltungsrat für die Gesellschaft festgelegten Anlagestrategie vorbehaltlich der vom Ver-
waltungsrat festgesetzten Anlagebeschränkungen zu investieren. Für die Festlegung des Kapitals der Gesellschaft sind die
jeder Aktienklasse zuzurechnenden Nettovermögenswerte in Euro umzurechnen, wenn sie nicht in Euro ausgedrückt
sind, und das Kapital entspricht der Gesamtsumme der Nettovermögenswerte aller Aktienklassen zusammen.

Um jeglichen Zweifel zu vermeiden wird festgehalten, dass die Gesellschaft in jedem Fall Aktien der Klasse BPT («Klasse

BPT-Aktien») ausgeben wird. Klasse BPT-Aktien werden an BALTIC PROPERTY TRUST ASSET MANAGEMENT A/S
(BPTAM), an deren Tochterunternehmen oder an von BPTAM kontrollierte Gesellschaften ausgegeben (BPTAM-Grup-
pe).

Art. 6. Form der Aktien. Die Aktien werden in Form registrierter Aktien ausgegeben.
Alle ausgegebenen Aktien der Gesellschaft sind im Register der Aktionäre einzutragen, welches von der Gesellschaft

oder von einer oder mehreren hierfür von der Gesellschaft bestimmten Personen zu führen ist, und in diesem Register
sind der Name jedes Eigentümers registrierter Aktien, sein Wohnsitz beziehungsweise Zustellungswohnsitz, so wie dieser
der Gesellschaft bekannt gegeben wurde, die Zahl der von ihm gehaltenen registrierten Aktien und der für jeden Bruch-
teilsanteil bezahlte Betrag zu vermerken.

21238

Die Eintragung des Namens des Aktionärs im Register der Aktionäre bildet den Nachweis seines Eigentumsrechts

hinsichtlich solcher registrierter Aktien. Die Gesellschaft kann eine Bestätigung der Beteiligung durch Ausstellung von
Aktienzertifikaten oder in anderer Weise herausgeben. Liegt kein Antrag auf Ausgabe registrierter Aktien mit Zertifikaten
vor, dann gilt das als Antrag der Aktionäre auf Ausgabe ihrer Aktien ohne entsprechende Zertifikate.

Art. 7. Übertragung von Aktien - Beschränkungen. Die Aktien der Gesellschaft sind, im Rahmen der hiernach festge-

legten Regelungen und Begrenzungen, frei übertragbar. Jede Übertragung einer Aktie wird nach Zahlung einer handels-
üblichen Gebühr, welche der Verwaltungsrat für die Registrierung jedes anderen Dokuments, das sich auf das Recht an
einer Aktie bezieht oder es betrifft, genehmigt hat in das Register der Aktionäre eingetragen. Aktionäre haben dem
Verwaltungsrat 30 Tage im Vorhinein alle beantragten Übertragungen anzuzeigen, und für alle Übertragungen gilt die
Vorbedingung, dass der Zedent dem Verwaltungsrat entsprechende Nachweise betreffend die Vorschriften zur Bekämp-
fung der Geldwäsche und - falls der Zedent noch ausstehende Einzahlungsverpflichtungen hat - einen Beweis dafür vorlegen
muss, dass der Zessionar verbindlich ausreichend Potential zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus der auf ihn übertra-
genen Einzahlungsverpflichtung besitzt.

Der Verwaltungsrat darf seine Zustimmung zu einer Aktienübertragung nicht ohne triftigen Grund verweigern; dies

gilt jedoch mit der Einschränkung, dass der Verwaltungsrat berechtigt ist, seine Zustimmung zu beantragten Übertragun-
gen in folgenden Fällen zu verweigern:

a) wenn der Verwaltungsrat in nachvollziehbarer Weise zu der Ansicht gelangt, dass sich aus der Übertragung eine

Situation oder ein Ereignis ergeben würde, die bzw. das zur Auflösung der Gesellschaft führen würde;

b) wenn sich aus der Übertragung ergeben würde, dass Aktien von einer Person gehalten werden, die nicht als Sach-

kundiger Anleger (wie in Artikel 10 definiert) qualifiziert;

c) wenn die Übertragung an eine US-Person oder an eine in Deutschland Ansässige Person (wie hiernach definiert)

erfolgen soll;

d) wenn der Verwaltungsrat zu der Ansicht gelangt, dass die Übertragung gegen irgendeine anwendbare Gesetzes-

vorschrift und insbesondere gegen das Gesetz von 2007, gegen eine Verordnung oder eine Bestimmung dieser Satzung
und insbesondere gegen den folgenden Artikel 11 verstoßen würde;

e) wenn der Verwaltungsrat zu der Ansicht gelangt, dass der geplante Übertragungsempfänger keine angemessene

Kreditwürdigkeit besitzt;

f) wenn die Übertragung dazu führen würde, dass Zedent oder Zessionar Aktien hielten, mit denen eine Einzahlungs-

verpflichtung, welche geringer als die Mindesteinzahlungsverpflichtung ist, verbunden wäre; um Zweifel auszuschließen
wird festgehalten, dass dies nicht für eine Übertragung gilt, die sämtliche Aktien des Zedenten betrifft;

g) wenn der Verwaltungsrat zu der Ansicht gelangt, dass die Übertragung das Ansehen der Gesellschaft oder ihre

Stellung gegenüber potenziellen Mitbewerbern nachteilig beeinflussen könnte;

h) wenn ein Aktionär mehr als 25% aller ausgegebenen Aktien halten würde.
Wird eine Übertragung wegen eines Grundes gemäß den obenstehenden litt. a) bis h) abgelehnt, dann hat der Ver-

waltungsrat dem Zedenten diesen Grund mitzuteilen und angemessene Nachweise für denselben zu liefern.

Jedwede Abtretung von Aktien, die anders als im Einklang mit den Bestimmungen dieser Satzung erfolgt, ist nichtig und

nicht im Register der Aktionäre der Gesellschaft einzutragen.

Die Aktionäre haben der Gesellschaft eine Adresse mitzuteilen, an die alle Mitteilungen und Ankündigungen gesandt

werden können. Eine solche Adresse ist auch in das Register der Aktionäre einzutragen.

Sollte ein Aktionär keine Adresse bekannt geben, dann kann die Gesellschaft eine diesbezügliche Anmerkung in das

Register der Aktionäre eintragen lassen, und als Adresse des Aktionärs gilt dann der eingetragene Sitz der Gesellschaft
oder jene andere Adresse, die jeweils von der Gesellschaft für diese Zwecke eingetragen werden sollte, bis der Gesell-
schaft von einem solchen Aktionär eine andere Adresse bekannt gegeben wird. Ein Aktionär kann jederzeit seine im
Register der Aktionäre eingetragene Adresse durch schriftliche Anzeige an die Gesellschaft, gerichtet an deren eingetra-
genen Sitz oder jene andere Adresse, die jeweils von der Gesellschaft für diese Zwecke festgesetzt werden sollte, ändern.

Kann ein Aktionär in für die Gesellschaft zufriedenstellender Weise den Nachweis dafür erbringen, dass sein Aktien-

zertifikat verloren gegangen ist, verstümmelt oder zerstört wurde, dann kann auf sein Ersuchen hin ein Zertifikatsdoppel
unter jenen Bedingungen und Garantien ausgestellt werden, die die Gesellschaft gegebenenfalls dafür festsetzt. Bei Ausgabe
des neuen Aktienzertifikats, auf welchem zu vermerken sein wird, dass es sich um ein Duplikat handelt, wird das ur-
sprüngliche Aktienzertifikat, an Stelle dessen das neue ausgegeben wird, ungültig.

Verstümmelte Aktienzertifikate können von der Gesellschaft ungültig gemacht und durch neue Zertifikate ersetzt

werden.

Die Gesellschaft kann nach eigener Wahl den Aktionären die Kosten für die Ausstellung eines Duplikats oder eines

neuen Aktienzertifikats und alle angemessenen Auslagen, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ausstellung und
Eintragung desselben oder im Zusammenhang mit der Annullierung des ursprünglichen Aktienzertifikats entstehen, in
Rechnung stellen.

Die Gesellschaft erkennt jeweils nur einen einzelnen Eigentümer pro Aktie an. Stehen ein oder mehrere Aktien in

einem gemeinsamen Eigentum oder ist das Eigentumsrecht an einer bzw. mehreren solchen Aktie(n) strittig, dann müssen

21239

alle einen Anspruch auf eine bzw. mehrere solcher Aktie(n) behauptenden Personen einen gemeinsamen Vertreter zur
Vertretung dieser Aktie(n) gegenüber der Gesellschaft bestellen. Erfolgt keine solche Bestellung eines Vertreters, dann
führt das zur Aussetzung aller mit einer bzw. mehreren solcher Aktie(n) verbundenen Rechte.

Aktien können, wenn der Verwaltungsrat es beschließt, in Bruchteilen bis auf drei Dezimalstellen ausgegeben werden.

Solche Bruchteils-Aktien verleihen kein Stimmrecht, wohl aber den Anspruch auf anteilsmäßige Beteiligung an dem der
entsprechenden Aktienklasse zurechenbaren Nettovermögen.

Art. 8. Ausgabe von Aktien. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, während eines Zeitraums von 48 Monaten nach dem

Ersten Closing, ohne Einschränkung zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine unbegrenzte Zahl von voll einbezahlten Aktien
auszugeben, ohne bestehenden Aktionären ein Vorzugsaktienbezugsrecht einzuräumen.

Der Verwaltungsrat kann Beschränkungen hinsichtlich der Häufigkeit der Ausgabe von Aktien verfügen. Insbesondere

kann der Verwaltungsrat bestimmen, dass Aktien nur während einer oder mehreren Angebotsperioden oder zu solchen
anderen periodischen Terminen ausgegeben werden dürfen, die im Privat Placement Memorandum (das «PPM») für die
Aktien angeführt sind.

Außerdem kann der Verwaltungsrat ohne jegliche Vorankündigung gegenüber den Aktionären die Ausgabe von Aktien

vorübergehend aussetzen oder endgültig einstellen, wenn der Verwaltungsrat beschließt, dass dies im besten Interesse
der Gesellschaft und der bestehenden Aktionäre liegt.

Anleger, die in der auf das Erste Closing folgenden Zeit (ein «Folge-Closing») Aktien zeichnen möchten, oder schon

beteiligte Aktionäre, die bei derselben Runde weitere Aktien erwerben möchten, sind verpflichtet, eine Zeichnungsver-
einbarung mit darin enthaltener Angabe des gesamten Einlagekapitals, zu dem sie sich verpflichten (die «Einzahlungsver-
pflichtung» bzw. die «Einzahlungsverpflichtungen»), abzuschließen; wobei allerdings vorausgesetzt wird, dass zu keiner
Zeit ein Aktionär der Gesellschaft mehr als 25% der Gesamtzahl der ausgegeben Aktien halten darf. Die Mindest-Ein-
zahlungsverpflichtung beträgt 125,000 Euro, es sei denn, der Verwaltungsrat würde nach seiner freien Entscheidung einen
niedrigeren Betrag akzeptieren. Der Verwaltungsrat kann nach seinem freien Ermessen einen Antrag auf Zeichnung von
Aktien durch einen Anleger annehmen oder ablehnen. Später als 48 Monate nach dem Ersten Closing wird keine Zeich-
nung akzeptiert. Aktien werden keinen in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Anlegern (eine «in Deutschland
Ansässige Person») zur Zeichnung angeboten und dürfen nicht von diesen gezeichnet werden.

Wird eine Zeichnung vom Verwaltungsrat akzeptiert, dann können von den Anlegern zugesagte Einzahlungsverpflich-

tungen vom Verwaltungsrat ganz oder teilweise während einer Periode von höchstens 48 Monaten nach dem Ersten
Closing (der «Einzahlungsverpflichtungsperiode») abgerufen werden.

Nach Ablauf einer Frist von 48 Monaten ab dem Ersten Closing sind Einzahlungsverpflichtungen nicht mehr für Abrufe

(Drawdowns) verfügbar, mit der Einschränkung, dass Einzahlungsverpflichtungen auch danach in dem (i) zur Zahlung von
Gebühren, Auslagen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft, (ii) zum Vollzug einer Anlage, die während der Einzahlungs-
verpflichtungsperiode eingegangen wurde wie den Erwerb einer neuen Immobilie nach deren Fertigstellung oder eines
Renovierungsprojekts  oder  auch  (iii)  zur  Tätigung  von  Folgeinvestitionen  im  Rahmen  bestehender  Transaktionen  (in
diesem letzteren Fall bis zu einem Höchstbetrag von 10% der Einzahlungsverpflichtungen) erforderlichen Ausmaß abge-
rufen werden können. Nach Ablauf von 12 Monaten nach Ende der Einzahlungsverpflichtungsperiode stehen Einzahlungs-
verpflichtungen nicht mehr für einen Abruf zur Verfügung, dies mit Ausnahme der Zwecke der Erfüllung bestehender
gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen der Gesellschaft, einschließlich - ohne jede Einschränkung - solcher hin-
sichtlich der Stellung als Vermieter bestehender Immobilienanlagen. Ehe er Einzahlungsverpflichtungen gemäß diesem
Absatz abruft, hat der Verwaltungsrat sonstige mögliche Möglichkeiten der Mittelbeschaffung zu prüfen und die ange-
messenste Möglichkeit der Finanzierung auszuwählen.

Der Verwaltungsrat hat nach seinem Wissensstand den Aktionären eine Schätzung betreffend des wahrscheinlichen

Ausmaßes solcher Verbindlichkeiten am Ende der Einzahlungsverpflichtungsperiode und dann erneut nach Ablauf einer
daran anschließenden 12-Monatsfrist vorzulegen.

Keinesfalls ist ein Anleger verpflichtet, zu irgendeinem Zeitpunkt eine Kapitaleinlage in einer Höhe zu leisten, die den

Betrag seiner gesamten Einzahlungsverpflichtung übersteigt.

Der Preis pro Aktie, zu dem Aktien beim Ersten Closing ausgegeben werden, ist der Anfangszeichnungspreis von 1.000

EUR, und danach entspricht der Preis pro Aktie, zu dem die Aktien jeder Aktienklasse ausgegeben werden, dem Netto-
vermögenswert pro Aktie der entsprechenden Klasse zum jüngsten Bewertungsstichtag, der im Einklang mit Artikel 11
in der Fassung späterer Abänderungen auf folgender Grundlage zu bestimmen ist:

(a) eine Anpassung ist für die Differenz zwischen einer latenten Steuerverbindlichkeit, für die nach den internationalen

Rechnungslegungsstandards (International Financial Reporting Standards), in der jeweils aktuellen Fassung («IFRS»), Rück-
stellungen  zu  bilden  sind,  und  den  geschätzten  zukünftigen  Steuerverbindlichkeiten  laut  der  Schätzung  durch  den
Verwaltungsrat vorzunehmen.

(b) Der Verwaltungsrat ist berechtigt, eine zusätzliche Bewertung des Nettovermögenswerts unter Einschluss einer

Liegenschaftsbewertung vor Ermittlung des Nettovermögenswerts zum Zweck irgendeiner Ausgabe irgendwelcher Ak-
tien  zu  verlangen,  wenn  der  Verwaltungsrat  der  Ansicht  ist,  dass  seit  dem  letzten  Bewertungsstichtag  ein  Ereignis
vorgefallen ist, durch das die aktuelle Schätzung in wesentlicher Weise irreführend geworden wäre.

21240

(c) Der Verwaltungsrat hat jene weiteren Anpassungen in der Berechnung des Preises pro Aktie vorzunehmen, die er

als angemessen erachtet, um eine faire Behandlung sämtlicher Aktionäre sicherzustellen.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, sich auf den Rat seiner Berater bei der Quantifizierung des wahrscheinlichen Be-

trages jedweder geschätzten Steuerverbindlichkeiten zu stützen und jeden anderen Rat einholen, den er für angemessen
erachtet,  ehe  er  eine  Bestimmung  hinsichtlich  der  angemessenen  Berichtigung  der  Nettovermögenswertberechnung
vornimmt.

Jeder neue Aktionär hat zudem (in dem Ausmaß, in dem das nicht bereits im Nettovermögenswert laut Artikel 11

enthalten ist) bei der Zeichnung den auf ihn (nach Festsetzung durch den Verwaltungsrat) entfallenden Anteil an den
Gründungs-, Organisations- und Verwaltungskosten der Gesellschaft, den Gebühren des Property Advisers, Erwerbungs-,
Veräußerungs- und Finanzierungsvergütungsbeträgen und sonstigen festgesetzten Gebühren zu bezahlen, die ab dem Tag
des Ersten Closings noch einmal so zu berechnen sind, als ob alle Anleger beim Ersten Closing zugelassen worden wären
und ihre Einzahlungsverpflichtungen zu diesem Zeitpunkt gezeichnet hätten.

Verpflichtet sich ein neuer Aktionär an einem Folge - Closing Aktien zu zeichnen und werden Einzahlungsverpflich-

tungen  vom  Verwaltungsrat  abgerufen,  wird  der  Verwaltungsrat  die  Gesamtheit  der  Einzahlungsverpflichtungen  der
Aktionäre, die ihre Einzahlungsverpflichten vor dem Folge - Closing eingegangen sind, bis zur Höhe ihrer gesamten Ein-
zahlungsverpflichtungen abrufen, bevor die Einzahlungsverpflichtungen der neuen Aktionäre abgerufen werden.

Der Ausgabepreis für die gezeichneten Aktien, so wie er vom Verwaltungsrat festgelegt und im PPM ausgewiesen wird,

ist binnen einer jeweils vom Verwaltungsrat festzusetzenden Frist zahlbar, die nicht mehr als fünfzehn Werktage ab dem
entsprechenden Ausgabetag beziehungsweise Bewertungsstichtag liegen darf. Der Verwaltungsrat kann die Vollmacht zur
Annahme von Zeichnungserklärungen, zur Entgegennahme der Zahlung des Preises der neuen auszugebenden Aktien
sowie zur Ausgabe derselben an jeden Direktor, Geschäftsführer, Funktionsträger oder sonstigen ordnungsgemäß be-
vollmächtigten Agenten delegieren.

Die Gesellschaft kann sich zur Ausgabe von Aktien als unbares Entgelt für Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte

verpflichten, die gegebenenfalls von der Gesellschaft gemäß ihrer Anlagestrategie und den Anlagebeschränkungen unter
Erfüllung der vom luxemburgischen Recht hierfür vorgesehenen Bedingungen, einschließlich der Verpflichtung zur Vorlage
eines Bewertungsberichts des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft, erworben werden könnten.

Art. 9. Rückkauf von Aktien. Aktien können nach einer Halteperiode von 10 Jahren ab Tag der Ausgabe zur Rücknahme

angeboten werden.

Nach der Halteperiode ist ein Aktionär berechtigt, den Rückkauf seiner Aktien zu beantragen, und zwar unter den

Bedingungen und Verfahrensvorschriften, die vom Verwaltungsrat im PPM für Aktien ausgeführt sind, und innerhalb der
von der Rechtsordnung und dieser Satzung vorgesehenen Begrenzungen. Um Zweifel zu vermeiden wird festgehalten,
dass die vorgenannte Halteperiode nur bei der Aktienrücknahme durch die Gesellschaft anwendbar ist und nicht bei der
Aktienübertragung.

Um von der Gesellschaft akzeptiert zu werden, muss jeder Antrag auf Rückkauf von Aktien von dem antragstellenden

Aktionär schriftlich so eingereicht werden, dass er bei dem eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg wenigstens
neunzig Tage vor dem letzten Bankwerktag jedes Quartals ankommt, für welchen der Aktionär eine Bewertung seines
Rückkaufsvolumens wünscht (der «Rückkaufsbewertungsstichtag»), zusammen mit dem bzw. den Zertifikaten für solche
Aktien in ordnungsgemäßer Form.

Ein Rückkauf, der dazu führen würde, dass der den Rückkauf betreibende Aktionär nunmehr Aktien hielte, die einer

Einzahlungsverpflichtung von weniger als 125.000 EUR entsprächen, findet nicht statt, es sei denn, der Verwaltungsrat
würde nach seinem freien Ermessen anders entscheiden. Um jeden Zweifel auszuschließen, erfordert ein Rückkauf sämt-
licher Aktien eines den Rückkauf betreibenden Aktionärs keine solche Zustimmung des Verwaltungsrats.

Der Rückkaufspreis beruht auf dem Nettovermögenswert der Aktien, wie er zum entsprechenden Rückkaufsbewer-

tungsstichtag gemäß den Bestimmungen von Artikel 11 dieser Satzung ermittelt worden ist. Der Verwaltungsrat kann,
nach seinem uneingeschränkten Ermessen, von Bewertungsgutachtern fordern, zur Berechnung des Nettovermögens-
werts eine vollständige Vermögensbewertung gemäß Artikel 11 (I) (9) (a) vorzunehmen. Jegliche Kosten einer Bewertung
des Nettovermögenswerts und einer solchen Liegenschaftsbewertung sind vom den Rückkauf betreibenden Aktionär zu
tragen. Vom Rückkaufspreis können der Veräußerungsaufwand sowie die «Breakage Costs» (Zinsauflösungskosten auf-
grund einer Refinanzierung, A.d.Ü.) der Finanzierung, tatsächliche oder potenzielle Steuerverbindlichkeiten, sowie der
Anfall der an den Property Adviser zu zahlenden Performance Fee abgezogen werden, je nach der jeweiligen Entscheidung
des Verwaltungsrats, und es kommt eine Rückkaufgebühr zur Anwendung, die wie folgt zu ermitteln ist:

Zahl der seit der Zeichnung

Rückkaufgebühr in Höhe des

der Aktien verstrichenen Jahre

Prozentsatzes der

Einzahlungsverpflichtung

des Anlegers

bis zu 10 Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5%

10 bis 11 Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4%

11 bis 12 Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3%

12 bis 13 Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2%

21241

mehr als 13 Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1%

Vorbehaltlich der untenstehenden Bestimmungen sind die entsprechenden Zahlungen für den Rückkauf binnen dreißig

Tagen ab dem entsprechenden Bewertungsstichtag des Rückkaufs zu leisten.

Der Verwaltungsrat wird die jeweiligen Rückkaufsforderungen, beruhend auf dem am Bewertungsstichtag des Rück-

kaufs errechneten Nettovermögenswert, nur akzeptieren, sofern ausreichende liquide Vermögensmittel verfügbar sind
bzw. verfügbar gemacht wurden. Der Verwaltungsrat kann eine vorübergehende Aussetzung des Rechts auf Rückkauf von
Aktien verfügen, wenn außerordentliche Umstände eintreten, die eine solche Aussetzung im Interesse der Aktionäre
notwendig erscheinen lassen. Insbesondere behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, den Rückkauf von Aktien man-
gels liquiden Vermögens auszusetzen, wenn dies erforderlich ist, um die Aktionäre zu schützen. Reichen die Bankguthaben
und die Erlöse aus dem Verkauf liquiden Vermögens nicht zur Bezahlung des Rückkaufspreises und zur ordnungsgemäßen
Geschäftsführung der Gesellschaft aus, oder sind Bankguthaben und liquide Vermögensgüter nicht unverzüglich im Au-
genblick eines beantragten Rückkaufs verfügbar, dann ist die Gesellschaft berechtigt, das Rückkaufsrecht für die Dauer
von drei Monaten ab dem betreffenden Rückkaufsbewertungsstichtag auszusetzen. Wenn nach Ablauf der vorgenannten
Dreimonatsfrist die Bankguthaben und die Erlöse aus dem Verkauf liquiden Vermögens nicht ausreichen, dann hat der
Verwaltungsrat Anlagen der Gesellschaft in ausreichendem Ausmaß unter ordnungsgemäßer Berücksichtigung der Inte-
ressen aller Aktionäre zu veräußern. Die Veräußerung solcher Anlagen hat während eines Zeitraums von höchstens einem
Jahr ab dem entsprechenden Bewertungsstichtag, zu dem das Rückkaufsrecht vorübergehend ausgesetzt wurde, zu er-
folgen. Die Gesellschaft ist berechtigt, das Rückkaufsrecht solange auszusetzen, bis sie imstande ist, genügend Immobilien
zu angemessenen Bedingungen zu verkaufen oder zu verpfänden. Die zuvor erwähnte Frist von einem Jahr kann durch
die Gesellschaft unter schriftlicher Benachrichtigung der Aktionäre um ein weiteres Jahr verlängert werden. Nach Auf-
hebung der Aussetzung des Rückkaufsrechts für Aktien werden Rückkaufsanträge zu dem Nettovermögenswert abge-
wickelt, der für Aktien zum nächsten Rückkaufsbewertungsstichtag nach Ende einer solchen Aussetzungsfrist ermittelt
wird.  Um  jeden  Zweifel  auszuschließen:  Sollte  die  Aussetzung  bis  zur  Höchstdauer  einer  Zweijahresfrist  ausgedehnt
werden, dann findet der Rückkauf am zweiten Jahrestag des ursprünglichen Rückkaufsbewertungsstichtags statt.

Zusätzlich zu dem Vorstehenden kann der Verwaltungsrat eine vorübergehende Aussetzung des Aktienrückkaufs ver-

fügen,  wenn  außerordentliche  Umstände,  wie  sie  in  Artikel  12  «Vorübergehende  Aussetzung  der  Berechnung  des
Nettovermögenswerts pro Aktie» ausgeführt sind, dies erfordern.

Jeder Antrag auf Rückkauf ist unwiderruflich, es sei denn im Fall einer Aussetzung des Rückkaufs nach Artikel 12 dieser

Satzung. Im Fall jeder solchen Aussetzung auf Grund des Artikels 12 dieser Satzung erfolgt der Rückkauf zum ersten
Werktag nach dem Ende der Aussetzung.

Kommt zu irgendeinem Zeitpunkt ein Aktionär, der sich zur Zeichnung von Aktien verpflichtet hat, seiner Einzah-

lungsverpflichtung nicht durch volle Einzahlung des Zeichnungspreises innerhalb der vom Verwaltungsrat festgesetzten
und im PPM angegebenen Frist nach (ein «Säumiger Aktionär»), dann ist der Verwaltungsrat berechtigt, zusätzlich zur
Ergreifung rechtlicher Mittel auf den sich ergebenden rückständigen Betrag Zinsen in Höhe von 4% per annum über dem
jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu erheben. Wird der rückständige Betrag zuzüglich darauf ent-
fallender Zinsen nicht binnen 30 Tagen entrichtet, dann stehen dem Verwaltungsrat folgende Rechte zu:

a) Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 10% der Einzahlungsverpflichtung; sowie
b) Aufrechnung mit jedweden Ausschüttungen an den Säumigen Aktionär, bis sämtliche der Gesellschaft geschuldeten

Beträge vollständig bezahlt sind; und

c) Rückkauf der Aktien des Säumigen Aktionärs wie in Artikel 10 beschrieben, gegen Auszahlung eines Betrages in

Höhe von 85% des Nettovermögenswerts seiner an der Gesellschaft gehaltenen Aktien, der zum Zeitpunkt der Abwick-
lung der Gesellschaft zahlbar wäre;

d) Herabsetzung oder Kündigung der Einzahlungsverpflichtung des Säumigen Aktionärs;
e) Geltendmachung jedes sonstigen unter der anwendbaren Rechtsordnung zustehenden Rechtsmittels;
f)  die  Möglichkeit,  den  nicht  säumigen  Aktionären  das  Recht  zum  Kauf  der  Aktie  des  Säumigen  Aktionärs  an  der

Gesellschaft zu einem Kaufpreis in Höhe von 85% des Nettovermögenswerts des Gesellschaftsanteils anzubieten; oder

g) Zulassung neuer Anleger als Ersatz für den Säumigen Aktionär.
Alle zurückgekauften Aktien werden für ungültig erklärt.

Art. 10. Beschränkungen des Eigentumsrechts an den Aktien und zwangsweiser Verkauf von Aktien durch den Ver-

waltungsrat. Der Verwaltungsrat kann das Eigentumsrecht an Aktien an der Gesellschaft für jede Person einschließlich
einer US Person oder einer in Deutschland Ansässigen Person, Firma oder Gesellschaft (eine «Ausgeschlossene Person»)
einschränken oder ausschließen, wenn nach Einschätzung des Verwaltungsrats eine solche Beteiligung für die Gesellschaft
oder die Mehrheit ihrer Aktionäre von Nachteil wäre; wenn sie zum Verstoß gegen ein Gesetz oder eine Rechtsvorschrift
der luxemburgischen oder einer ausländischen Rechtsordnung führen würde; wenn sie negative verwaltungsbehördliche,
steuerliche oder fiskalische Folgen auslösen könnte, insbesondere unter Einschluss des Falles, in dem als Ergebnis davon
die Gesellschaft einer anderen Rechtsordnung als jener des Großherzogtums Luxemburg unterworfen würde (einschließ-
lich unter anderem hinsichtlich der Steuergesetze); oder wenn ein einzelner Anleger mehr als 25% der Gesamtsumme
der ausgegebenen Aktien halten würde. Nimmt der Verwaltungsrat von irgendeiner Person an, dass sie die Eigenschaft

21242

einer Ausgeschlossenen Person besitzt, dann hat er dieser Person den Grund dafür mitzuteilen und angemessene Nach-
weise dafür vorzulegen.

Insbesondere hat der Verwaltungsrat die Ausgabe von Aktien an der Gesellschaft auf sachkundige Anleger zu be-

schränken (ein «Sachkundiger Anleger»), wie in Artikel 2 des Gesetzes von 2007 definiert. Zu diesen Zwecken ist der
Verwaltungsrat zu Folgendem berechtigt:

A. - die Ausgabe von jedweden Aktien und die Registrierung jeder Übertragung von Aktien abzulehnen, wenn es ihm

so erscheint, dass eine solche Registrierung beziehungsweise Übertragung zur Begründung eines rechtlichen oder wirt-
schaftlichen Eigentumsrechts an solchen Aktien durch eine Ausgeschlossene Person oder einen anderen Anleger als einen
Sachkundigen Anleger führen würde oder könnte; und

B. - jederzeit von jeder Person, deren Name in das Register der Aktionäre eingetragen wird oder jeder Person, die

eine Eintragung der Übertragung von Aktien in das Register der Aktionäre begehrt, die Vorlage jedweder Informationen
zu verlangen, die er als notwendig erachtet, um zu bestimmen, ob das Eigentumsrecht an solchen Aktien an eine Ausge-
schlossene  Person  oder  einen  anderen  Anleger  als  einen  Sachkundigen  Anleger  fallen  würde  oder  ob  eine  solche
Eintragung zur Begründung eines wirtschaftlichen Eigentums für eine Ausgeschlossene Person oder einen anderen Anleger
als einen Sachkundigen Anleger führen würde; und

C. - die Entgegennahme der Stimmabgabe jedweder Ausgeschlossenen Person oder jedwedes anderen Anlegers als

eines Sachkundigen Anlegers bei jeder Generalversammlung der Gesellschaft abzulehnen; sowie

D. - dort, wo es dem Verwaltungsrat so erscheint, dass irgendeine Ausgeschlossene Person oder ein anderer Anleger

als ein Sachkundiger Anleger entweder allein oder gemeinsam mit einer anderen Person wirtschaftlicher Eigentümer der
Aktien ist, diesen Aktionär anzuweisen, seine Aktien zu veräußern und der Gesellschaft binnen dreißig (30) Tagen ab einer
solchen Mitteilung Nachweise für den erfolgten Verkauf vorzulegen. Erfüllt ein solcher Aktionär diese Weisung nicht,
dann ist die Gesellschaft berechtigt, namens des entsprechenden Aktionärs einen Zwangsverkauf sämtlicher von ihm
gehaltenen Aktien in der nachstehend beschriebenen Weise vorzunehmen.

Unter den in Artikel 9 und diesem Artikel 10 beschriebenen Umständen kann der Verwaltungsrat beschließen, namens

des entsprechenden Aktionärs einen Zwangsverkauf der von ihm gehaltenen Aktien vorzunehmen. Hat der entsprechende
Aktionär seine Einzahlungsverpflichtung (im Fall von Artikel 9) oder die Anweisung des Verwaltungsrats (im Fall von
Artikel 10) binnen 30 Kalendertagen ab einer entsprechenden Mitteilung (der «Übertragungsmitteilung») durch den Ver-
waltungsrat nicht erfüllt, dann gilt dies als Erteilung der Vollmacht an den Verwaltungsrat zum Verkauf seiner Aktien an
eine zum Erwerb der Aktien auf Grund dieser Satzung und aller anderen gegebenenfalls vom Verwaltungsrat festgesetzten
Bedingungen zugelassene Person (der «Zulässige Übernehmer»), und als Erteilung einer Vollmacht an den Verwaltungsrat
zur Errichtung einer schriftlichen Übertragungserklärung in seinem Namen gemäß den Bestimmungen von Artikel 7 und
zum Abschluss einer Vereinbarung über den Kaufpreis (der «Kaufpreis») mit dem Zulässigen Übernehmer.

Der Kaufpreis wird durch den Verwaltungsrat ausgehandelt, ohne dass dieser verpflichtet wäre, irgendeinen Mindest-

Kaufpreis zu erzielen. Während der Frist von 30 Kalendertagen ab der Übertragungsmitteilung kann der Aktionär dem
Verwaltungsrat gegenüber einen potenziellen Erwerber namhaft machen. Wenn ein solcher potenzieller Erwerber alle
normalerweise vom Verwaltungsrat für einen Zulässigen Übernehmer geforderten Bedingungen erfüllt, darf der Verwal-
tungsrat seine Zustimmung zu einer solchen Übertragung nicht mutwillig verweigern. Bei einer durch den Verwaltungsrat
namens des Aktionärs ausgehandelten Übertragung an einen Zulässigen Übernehmer trifft den Verwaltungsrat und die
Gesellschaft keine andere Verpflichtung gegenüber dem früheren Aktionär als die, ihm den vereinbarten und vom Zuläs-
sigen Übernehmer bezahlten Kaufpreis nach Abzug jedweder im Zusammenhang mit der Übertragung angefallenen Kosten
gutzuschreiben. Ist der Verwaltungsrat binnen 90 Kalendertagen ab der Übertragungsmitteilung nicht imstande, einen
Zulässigen Übernehmer ausfindig zu machen, der den Erwerb der Aktien akzeptiert, dann verfallen die entsprechenden
Aktien und werden nichtig, und der frühere Inhaber derselben ist nicht länger Aktionär der Gesellschaft.

Die Ausübung der durch diesen Artikel übertragenen Vollmacht durch die Gesellschaft darf in keinem Fall mit der

Begründung, es hätte kein ausreichender Nachweis für das Eigentumsrecht an den Aktien durch eine bestimmte Person
vorgelegen oder die wahren Eigentumsverhältnisse an den Aktien wären anders, als sie der Gesellschaft zum Tag jedweder
Verkaufsmitteilung erschienen, in Frage gestellt oder aufgehoben werden, vorausgesetzt, die Ausübung dieser Vollmachten
durch die Gesellschaft ist in gutem Glauben erfolgt.

Überall, wo in dieser Satzung die Bezeichnung «Vereinigte Staaten» oder «U.S.» verwendet wird, sind damit die Ver-

einigten  Staaten  von  Amerika  (einschließlich  der  Bundesstaaten  und  des  District  of  Columbia)  sowie  jedwede  ihrer
Territorien, Besitzungen und sonstigen ihrer Gerichtsbarkeit unterworfenen Gebiete gemeint, und mit «United States
Person» ist ein Bürger oder eine Person mit Hauptwohnsitz in den Vereinigten Staaten gemeint, oder auch jedwede in
den Vereinigten Staaten oder nach der Rechtsordnung der Vereinigten Staaten errichtete Gesellschaft, Personengesell-
schaft oder sonstige Körperschaft oder jede Person, die unter die Definition einer «US Person» gemäß Regulation S des
United States Securities Act von 1933 fällt.

Art. 11. Ermittlung des Nettovermögenswerts pro Aktie. Der Nettovermögenswert einer Aktie der Gesellschaft (der

«Nettovermögenswert») ist von der Zentralverwaltung in Verantwortung des Verwaltungsrats gemäß dem luxemburgi-
schen Recht und den IFRS, im Einklang mit den Bestimmungen dieses Artikels zu berechnen.

Der Nettovermögenswert pro Aktie jeder Aktienklasse ist in Euro als Wert pro Aktie auszudrücken. Die Gesellschaft

nimmt eine Berechnung des Nettovermögenswerts pro Aktie vor, wenn ein Aktionär den Rückkauf eines Teils oder aller

21243

seiner Aktien begehrt oder im Fall einer weiteren Ausgabe von Aktien. Der Nettovermögenswert pro Aktie wird für
jede Klasse zum letzten Bankwerktag jedes Quartals oder auch noch häufiger, je nach Entscheidung des Verwaltungsrats
(jeweils ein «Bewertungsstichtag»), ermittelt, und zwar durch Division des Nettovermögens der Gesellschaft (entspricht
dem Wert der einer solchen Klasse zuzurechnenden Aktiva abzüglich des Werts der einer solchen Klasse zuzurechnenden
Passiva, berechnet zu dem Zeitpunkt, den der Verwaltungsrat für diesen Zweck bestimmt hat) durch die Gesamtzahl der
zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Aktien im Einklang mit den nachstehend ausgeführten Bewertungsregeln. Es erfolgt
ein Auf- oder Abrunden des Nettovermögenswerts pro Aktie je nach Entscheidung des Verwaltungsrats.

Der Nettovermögenswert pro Aktie ist spätestens 20 Werktage nach Erhalt der Nettovermögenswertbewertung

verfügbar.

Die Bewertung des Nettovermögenswerts der Aktien ist wie folgt vorzunehmen; jedoch mit folgenden Einschränkun-

gen:

(a) säumige Aktien werden zur Berechnung des Nettovermögenswerts nicht berücksichtigt, sofern sie nicht im Zu-

sammenhang mit der Bestimmung des Zwangsrückkaufpreises wie im oben stehenden Artikel 10 beschrieben, stehen;
und

(b) der nicht einbezahlte Teil der Einzahlungsverpflichtung ist hinsichtlich jedweder noch nicht ausgegebener Aktien

bei der Berechnung des Nettovermögenswerts solcher Aktien nicht zu berücksichtigen.

I. Die Aktiva der Gesellschaft umfassen (ohne Beschränkung):
1. Investitionen in Liegenschaften oder Liegenschaftsrechte, eingetragen auf den Namen der Gesellschaft oder auf

Tochtergesellschaften, die von der Gesellschaft kontrolliert werden;

2. Beteiligungen in konvertiblen und sonstigen Schuldverschreibungen von Immobiliengesellschaften;
3. jeglichen Bargeldbestand oder Kontoeinlagen einschließlich jedweder darauf angefallener Zinsen;
4. jegliche Wechsel und fällige Sichtpapiere sowie Kundenforderungen (einschließlich Erlöse aus Liegenschaftsverkäu-

fen, Verkäufen von Liegenschaftsrechten, Wertpapieren oder sonstigen verkauften, aber nicht gelieferten Vermögensgü-
tern);

5.  sämtliche  Bonds,  befristeten  Schuldscheine,  Depotscheine,  Anteile,  Aktien,  Schuldverschreibungen,  Debenture

Stocks (Obligationen mit Treuhandsicherung), Zeichnungsrechte, Optionsscheine, Optionen und sonstigen Wertpapiere,
Finanzinstrumente und ähnliche Vermögenswerte, die im Eigentum der Gesellschaft stehen oder für die die Gesellschaft
einen vertraglichen Anspruch erworben hat (mit der Einschränkung, dass die Gesellschaft in einer mit untenstehender lit.
(d) nicht unvereinbaren Weise Anpassungen betreffend die Schwankungen im Börsenwert von Wertpapieren, die durch
den Handel mit ex-Dividenden, ex-Bezugsrechten oder ähnliche Praktiken auftreten, vornehmen darf);

6. alle Kapitaldividenden, Bardividenden und Barzahlungen betreffende Forderungen der Gesellschaft in dem Ausmaß,

in dem der Gesellschaft darüber Informationen in angemessener Weise zur Verfügung stehen;

7. alle Mietansprüche, die hinsichtlich jeder Liegenschaftsinvestition angefallen sind oder Zinsansprüche, die bezüglich

jedweder zu verzinsender Vermögensgüter im Eigentum der Gesellschaft angefallen sind, mit Ausnahme des Ausmaßes,
in dem dieselben in dem diesem Vermögensgut zugemessenen Wert beinhaltet sind oder in demselben zum Ausdruck
kommen;

8. die Gründungskosten der Gesellschaft, einschließlich der Organisationskosten und der Kosten für die Ausgabe und

den Vertrieb der Aktien der Gesellschaft, soweit dieselben nicht abgeschrieben wurden; und

9. alle sonstigen Aktiva jedweder Art und Natur einschließlich der vorausbezahlten Aufwendungen.
Der Wert solcher Aktiva ist wie folgt zu bestimmen:
(a) vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen sind Immobilien jährlich und an jenen anderen Tagen, die der

Verwaltungsrat gegebenenfalls dafür festsetzt, durch einen unabhängigen Schätzgutachter zu bewerten. Jede solche Be-
wertung erfolgt auf der Grundlage des Bruttoverkehrswerts und gemäß der im PPM der Gesellschaft zum Ausdruck
kommenden Methode;

(b) vorbehaltlich der untenstehenden Spezifikationen sind die Wertpapiere von nicht an der Börse gelisteten oder auf

einem anderen geregelten Markt gehandelten Immobiliengesellschaften auf der Grundlage des wahrscheinlichen Netto-
Verkaufswerts (abzüglich jedweder latenter Steuern), der mit Sorgfalt und in gutem Glauben zu ermitteln ist, zu bewerten,
wobei die Gesellschaft den Wert der Immobilien zu verwenden hat, wie er im Einklang mit obiger lit. (a) ermittelt und
nachstehend vorgeschrieben wird;

(c) der Wert jeglichen Barbestandes oder von Bankeinlagen, Wechseln und Sichtpapieren sowie Kundenforderungen,

vorausbezahlten Aufwendungen, Bardividenden und angezeigter oder wie zuvor ausgeführt angefallener und noch nicht
bezogener Zinsbeträge wird als der volle Betrag dieser Posten angenommen, es sei denn, dass in einem Fall eine volle
Zahlung bzw. ein voller Eingang desselben unwahrscheinlich ist, wobei in diesem Fall der Wert desselben nach Abzug
jenes Betrages angesetzt wird, der in einem solchen Fall als zur Darstellung des tatsächlichen Wertes dieses Postens
angemessen erachtet wird;

(d) alle sonstigen Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte, einschließlich Darlehenssicherheiten, beschränkt han-

delbare Wertschriften und Wertpapiere, für die keine Börsennotierung verfügbar ist, werden auf der Grundlage von
Händlern gelieferter Notierungen oder durch einen vom Verwaltungsrat genehmigten Preisermittlungsdienst bewertet,
oder solche Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte sind, insoweit als solche Preise nicht als repräsentativ für die

21244

entsprechenden Marktwerte angesehen werden, zum gutgläubig vom Verwaltungsrat ermittelten Verkehrswert zu be-
werten. Von der Gesellschaft gehaltene Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von 90 Tagen oder weniger sind
nach der Restbuchwertmethode zu bewerten, was dem Marktwert nahe kommt.

Die Ermittlung des Werts von (i) Liegenschaftsinvestitionen und Liegenschaftsrechten, die auf den Namen der Gesell-

schaft  oder  einer  ihrer  direkten  oder  indirekten  100%-Tochterunternehmen  eingetragen  sind  und  (ii)  direkte  oder
indirekte Beteiligungen der Gesellschaft an Immobiliengesellschaften, auf die sich obige lit. (b) bezieht, an welchen die
Gesellschaft mehr als 50% des ausgegebenen stimmberechtigten Kapitals hält, hat durch unabhängige Schätzgutachter zu
erfolgen. Eine solche Bewertung kann zum Ende des Geschäftsjahres durchgeführt und während des Folgejahres verwen-
det werden, es sei denn, es hätte eine Veränderung in der allgemeinen wirtschaftlichen Situation oder in dem Zustand
der entsprechenden im Eigentum oder Eigentumsrecht der Gesellschaft oder einer der Beteiligungsgesellschaften der
Gesellschaft stehenden Liegenschaften beziehungsweise Liegenschaftsrechte gegeben, die die Vornahme neuer Bewer-
tungen unter denselben Bedingungen wie die jährlichen Bewertungen erforderlich machen würde.

Der Wert aller nicht in Euro ausgedrückten Aktiva und Passiva ist zu den entsprechenden Wechselkursen für den

jeweiligen Bewertungsstichtag in Euro umzurechnen. Sind solche Kurse nicht verfügbar, ist der Wechselkurs in gutem
Glauben durch den Verwaltungsrat festzusetzen.

Der Verwaltungsrat kann die Verwendung einer anderen Bewertungsmethode genehmigen, wenn er der Ansicht ist,

dass diese Bewertungsmethode den Verkehrswert eines Vermögensguts der Gesellschaft besser wiedergibt.

II. Die Passiva der Gesellschaft umfassen (ohne Einschränkung):
1) sämtliche Darlehen, Rechnungen und Lieferantenverbindlichkeiten;
2) sämtliche aufgelaufenen Zinsen auf Darlehen der Gesellschaft (einschließlich der angefallenen Gebühren für die

Bereitstellung solcher Darlehen);

3) alle angefallenen oder fälligen Auslagen (einschließlich Verwaltungsaufwand, Managementgebühren, Leistungsprämi-

en, Depotbankgebühren und Honorare der Vertreter der Gesellschaft);

4) alle bekannten gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten einschließlich aller fällig gewordenen vertraglichen

Verpflichtungen zur Zahlung in bar oder in Sachwerten, einschließlich des Betrags aller noch nicht bezahlter und von der
Gesellschaft erklärter Dividenden;

5) eine angemessene Rückstellung für künftige Steuern auf der Grundlage von Kapital und Ertrag zum Bewertungss-

tichtag  in  der  jeweils  von  der  Gesellschaft  festgestellten  Höhe,  sowie  gegebenenfalls  weitere  zugelassene  und  vom
Verwaltungsrat genehmigte Rücklagen, des Weiteren gegebenenfalls jener Betrag, den der Verwaltungsrat als angemes-
sene Rückstellung für jedwede ungewisse Verbindlichkeiten der Gesellschaft einstuft;

6) alle sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft, welcher Art und Rechtsnatur auch immer, angesetzt im Einklang

mit dem luxemburgischen Recht und den IFRS. Bei der Bestimmung des Betrages solcher Verbindlichkeiten hat die Ge-
sellschaft sämtliche von der Gesellschaft zu tragenden Auslagen zu berücksichtigen, die folgende Posten umfassen können:

(a) sämtlichen Organisationsaufwand im Zusammenhang mit der Gründung der Gesellschaft, der Erstellung der Anle-

gerunterlagen und damit zusammenhängenden Verträge, einschließlich unter anderem die Honorare der Rechtsberater,
Wirtschaftsprüfer und unabhängigen Bewertungsgutachter, der Gebühren für die Zulassung von Wertpapieren, der an-
gefallenen Postgebühren und Barauslagen, unter Ausschluss des Marketingaufwands und der Reisespesen;

(b) sämtlichen Organisationsaufwand einschließlich unter anderem die Honorare und Auslagenersatzbeträge, die an

die Wirtschaftsprüfer und Buchführer der Gesellschaft, an die Depotbank und deren Korrespondenten, an die Domizi-
lierungsstelle und Vertreterin der Gesellschaft (Domiciliary and Corporate Agent), an die Register- und Transferstelle,
an jede Zahlstelle, an alle permanenten Vertreter an Eintragungsorten und an alle sonstigen von der Gesellschaft be-
schäftigten Vertreter zu zahlen sind, die etwaigen Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder und deren angemessene
Barauslagen, Versicherungskosten, Honorare und Auslagenersatz für Rechtsberatung und Prüfungsleistungen, jedwede
Gebühren  und  Auslagen  im  Zusammenhang  mit  der  Eintragung  und  Fortführung  der  Eintragung  der  Gesellschaft  bei
jedweden Behörden im Großherzogtum Luxemburg und in jedem anderen Land, Berichts- und Veröffentlichungsaufwen-
dungen,  einschließlich  der  Kosten  für  die  Erstellung,  den  Druck  und  die  Verbreitung  periodischer  Berichte  oder
Eintragungsbestätigungen, sowie die Kosten jedweder Berichte an die Aktionäre, sämtliche Steuern, Abgaben, behördliche
und  sonstige  Gebühren,  und  sämtliche  sonstigen  Betriebsausgaben,  einschließlich  der  Kosten  für  die  Ermittlung,  den
Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Anlagen, gegebenenfalls Immobilienagenturhonorare, Zinsen, Bankspesen
und Maklergebühren, Post-, Telefon- und Telexgebühren, Hedgingkosten und Darlehensaufwand, Gebühren und Auslagen
sowie Kosten für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit den Transaktionen, den Vermögensgütern, Projekten
und den die Vermögensgüter haltenden Tochtergesellschaften sowohl hinsichtlich abgeschlossener als auch nicht abge-
schlossener Transaktionen. Die Gesellschaft kann Verwaltungs- und sonstige Aufwendungen regelmäßiger oder wieder-
kehrender Art auf der Grundlage ihrer geschätzten Höhe anteilsmäßig jährlich oder für sonstige Zeiträume verbuchen.
Die Honorare der Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer und unabhängigen Bewertungsgutachter sowie Organisationsauf-
wendungen im Zusammenhang mit der Gründung der Gesellschaft sind von der Gesellschaft beim Ersten Closing zu zahlen
oder zu erstatten;

7) sämtliche finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft sind bei deren Auftreten zum Marktwert zu bewerten, und

der Nettosaldo in den Ansätzen ist als Posten der Aktiva oder Passiva der Gesellschaft zu behandeln;

21245

8) jedwede nicht zum entsprechenden Zeitpunkt festgestellten Performance Fees sind auf der Grundlage eines gut-

gläubig ermittelten Schätzwerts des wahrscheinlichen Betrags solcher Gebühren anzusetzen.

Den Aktionären sind auf Antrag Detailangaben jedweder solcher Gebühren und Auslagen zur Verfügung zu stellen, auf

die in diesem Artikel 11 Bezug genommen wird.

Der Wert der Passiva der Gesellschaft ist zu den Gestehungskosten oder zum Restbuchwert anzusetzen, mit Aus-

nahme jedweder Derivativposten, die zum Marktwert anzusetzen sind.

Sämtliche Bewertungsregelungen und Bestimmungen sind im Einklang mit luxemburgischem Recht und den IFRS aus-

zulegen beziehungsweise vorzunehmen.

Wurden eine oder mehrere Klassen eingerichtet, dann sind die zuvor festgelegten Buchungsregeln entsprechend auf

solche Klassen anzuwenden.

Sofern nicht Bösgläubigkeit, schwere Fahrlässigkeit oder ein offensichtlicher Irrtum vorliegt, ist jede Entscheidung im

Rahmen der Berechnung des Nettovermögenswerts, die vom Verwaltungsrat oder von jedweder Bank, Gesellschaft oder
sonstigen Institution, die vom Verwaltungsrat zum Zweck der Berechnung des Nettovermögenswerts beauftragt wird,
getroffen wird, endgültig und bindend für die Gesellschaft und die gegenwärtigen, früheren oder zukünftigen Aktionäre.

Art. 12. Vorübergehendes Aussetzen der Ermittlung des Nettovermögenswerts pro Aktie. Die Ermittlung des Net-

tovermögenswerts pro Aktie für eine oder mehrere Klassen (falls solche ausgegeben wurden) kann in folgenden Fällen
ausgesetzt werden:

- während einer Zeitspanne, während der eine oder mehrere Börsen, die die Grundlage für die Bewertung eines

wesentlichen Teils des Gesellschaftsvermögens bilden, aus anderen Gründen als wegen eines Feiertages oder während
der Ferien geschlossen sind, oder wenn Transaktionen beschränkt oder ausgesetzt sind oder der Handel beschränkt oder
ausgesetzt ist; oder

- während jedweder Phase, in der auf Grund nachvollziehbarer Beurteilung durch den Verwaltungsrat eine angemes-

sene Bewertung der Aktiva der Gesellschaft auf Grund von Ereignissen Höherer Gewalt oder von Naturkatastrophen,
die sich der Kontrolle durch den Verwaltungsrat entziehen, nicht tunlich ist; oder

- während des Bestehens einer Situation, auf Grund der eine Bewertung der Aktiva der Gesellschaft unmöglich wäre;

oder

- während eines über eine Woche hinaus andauernden Ausfalls der Kommunikationsmedien, die normalerweise zur

Bestimmung des Wertes der Aktiva der Gesellschaft herangezogen werden; oder

- wenn dem Rat der Zentralverwaltung zufolge der Nettovermögenswert einer 100%-Tochtergesellschaft der Gesell-

schaft gegebenenfalls nicht genau bestimmt werden kann; oder

- bei der Veröffentlichung einer Mitteilung, mit der eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre zwecks

Beschlussfassung über die Abwicklung der Gesellschaft einberufen wird; oder

- wenn aus irgendeinem Grund der unabhängige Liegenschafts-Bewertungsgutachter die Stellungnahme abgibt, dass die

Preise irgendwelcher Anlagen nicht sofort oder nicht genau bestimmt werden können.

Jedes solche Aussetzen beziehungsweise jede Aufhebung desselben ist den Aktionären unverzüglich anzuzeigen.

Titel III Geschäftsführung und Aufsichtsorgan

Art. 13. Verwaltungsratsmitglieder. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen Verwaltungsrat (der

«Verwaltungsrat»), bestehend aus fünf Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Sie werden für eine
Amtszeit von höchstens sechs Jahren gewählt und bleiben bis zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt. Die Aktionäre
der in Artikel 6 beschriebenen Klasse BPT-Aktien sind berechtigt, der Generalversammlung eine Liste mit Namen von
Kandidaten für die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds der Gesellschaft vorzuschlagen.

Die Klasse-BPT-Aktionäre (die «Klasse-BPT-Aktionäre») werden der Generalversammlung der Aktionäre eine Kan-

didatenliste vorschlagen, aus der von der Generalversammlung mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder als Klasse-
BPT-Verwaltungsratsmitglieder  (die  «Klasse-BPT-Direktoren»)  ernannt  werden  müssen.  Die  von  den  Klasse-BPT-
Aktionären  vorgelegte  Kandidatenliste  muss  mindestens  doppelt  so  viele  Kandidaten  enthalten,  wie  Klasse-BPT-
Direktoren zu wählen sind. Die Aktionäre dürfen bei der Wahl keine höhere Zahl an Kandidaten wählen als Klasse-BPT-
Direktoren zu ernennen sind. Gewählt sind die jeweiligen Kandidaten der Liste, welche die meisten Stimmen erhalten
haben.

Hinzu kommt, dass jeder Aktionär, der der Generalversammlung der Aktionäre einen Kandidaten für die Stelle eines

Verwaltungsratsmitglieds vorzuschlagen wünscht, diesen Kandidaten der Gesellschaft mindestens drei Wochen vor dem
Tag dieser Generalversammlung schriftlich vorstellen muss. Um Zweifel zu vermeiden wird festgehalten, dass auch die
Liste der Kandidaten der Klasse-BPT-Aktionäre dieser Anforderung genügen muss.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung mit oder ohne Grund abbe-

rufen  oder  ersetzt  werden,  dies  gilt  jedoch  mit  der  Einschränkung,  dass  im  Falle  der  Abberufung  eines  Klasse-BPT-
Direktors die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung
einberufen, um an seiner Stelle einen neuen Klasse-BPT-Direktor zu wählen, wobei dieser von der Generalversammlung
aus den Kandidaten von der Liste der Klasse-BPT-Aktionäre ausgewählt werden muss.

21246

Bei einer Vakanz auf einem Verwaltungsratsposten können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder vorüberge-

hend  für  eine  Besetzung  der  vakanten  Stelle  Sorge  tragen;  die  Gesellschafter  treffen  dann  in  der  nächstfolgenden
Generalversammlung eine endgültige Entscheidung über eine solche Ernennung. Um Zweifel zu vermeiden wird festge-
halten, dass ein vakantes Amt eines Klasse-BPT-Direktors mit einem neuen Klasse-BPT-Direktor besetzt werden muss.

Art. 14. Verwaltungsratssitzungen. Sämtliche Verwaltungsratssitzungen finden in Luxemburg oder an jedem anderen

Ort im Ausland, der in der Einberufungsmitteilung festgelegt ist statt. Der Verwaltungsrat wählt aus den Klasse-BPT-
Direktoren einen Vorsitzenden und kann aus seiner Mitte einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende wählen. Er
kann darüber hinaus einen Schriftführer wählen - der nicht selbst Verwaltungsratsmitglied sein muss -, der das Protokoll
der Verwaltungsratssitzungen und Generalversammlungen aufnimmt und führt. Der Verwaltungsrat tritt auf Grund einer
Einberufung durch den Vorsitzenden oder beliebige zwei Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einberufung angege-
benen Ort zu Sitzungen zusammen.

Der Vorsitzende führt bei Verwaltungsratssitzungen und in der Generalversammlung den Vorsitz. In seiner Abwesen-

heit  entscheiden  die  Aktionäre  beziehungsweise  die  Verwaltungsratsmitglieder  mit  Mehrheit  der  Stimmen,  dass  ein
anderes Verwaltungsratsmitglied, beziehungsweise im Fall der Generalversammlung eine andere Person, den Vorsitz bei
derartigen Sitzungen übernehmen soll.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, jedwede Funktionsträger einschließlich eines Generaldirektors und jedweder Vi-

zegeneraldirektoren sowie andere Organe zu bestellen, welche die Gesellschaft für ihren Betrieb und ihre Geschäftsfüh-
rung  für  notwendig  erachtet.  Solche  Bestellungen  können  vom  Verwaltungsrat  jederzeit  widerrufen  werden.  Die
Funktionsträger müssen nicht Verwaltungsratsmitglieder oder Aktionäre der Gesellschaft sein. Wenn in dieser Satzung
nichts anderes bestimmt ist, dann haben die Funktionsträger jene Rechte und Pflichten, die ihnen vom Verwaltungsrat
übertragen werden.

Eine schriftliche Einberufung zu jeder Verwaltungsratssitzung hat sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern wenigstens

vierundzwanzig Stunden vor dem für eine solche Sitzung geplanten Termin zuzugehen, ausgenommen in Notfällen, in
denen die Art der diese begründenden Umstände in der Einberufung zur Sitzung anzugeben ist. Die Pflicht zur vorherigen
Einberufungsmitteilung kann durch schriftlich, per E-Mail, Telegramm, Fernschreiben, Telefax oder andere ähnliche Kom-
munikationsmittel bekundetes Einverständnis abbedungen werden. Eine gesonderte Einberufung für Sitzungen, die an
Orten und zu Terminen stattfinden, die in einem Verwaltungsratsbeschluss festgelegt wurden, ist nicht erforderlich.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann in jeder Sitzung handeln, indem er schriftlich, per E-Mail, Telegramm, Fernschrei-

ben, Telefax oder andere ähnliche Kommunikationsmittel ein anderes in Luxemburg ansässiges Verwaltungsratsmitglied
zu seinem Vertreter bestimmt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Verwaltungsratssitzung mittels Telefonkonferenzschaltung oder ähnlicher

Kommunikationsmittel teilnehmen, durch welche sämtliche an der Sitzung teilnehmenden Personen einander hören kön-
nen, und die Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel entspricht der persönlichen Anwesenheit
bei dieser Sitzung. Derartige Konferenzschaltungen haben, soweit durchführbar, von Luxemburg aus eingeleitet zu wer-
den. Die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder wird in dem möglichen Ausmaß zum Zeitpunkt der Konferenzschaltung
in Luxemburg physisch anwesend sein.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind lediglich zum Handeln in den ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssit-

zungen  befugt,  wobei  Entscheidungen  des  Verwaltungsrats  allerdings  auch  im  Wege  einstimmiger  Beschlüsse  gefasst
werden können, indem ein oder mehrere wörtlich übereinstimmende Schriftstücke von allen Mitgliedern des Verwal-
tungsrats unterzeichnet oder mittels Telex, Telegramm oder Telefaxschreiben übermittelt werden, die gemeinsam ein
angemessenes die Entscheidung beweisendes Protokoll darstellen.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind nicht berechtigt, die Gesellschaft durch Einzelzeichnung zu verpflichten, es sei denn,

sie hätten dazu spezifisch eine Vollmacht durch einen Verwaltungsratsbeschluss erhalten.

Der Verwaltungsrat kann nur dann gültig beschließen oder handeln, wenn wenigstens drei Verwaltungsratsmitglieder

oder jene andere Zahl von Verwaltungsratsmitgliedern, welche der Verwaltungsrat gegebenenfalls hierfür festsetzt, an-
wesend oder vertreten sind.

Beschlüsse des Verwaltungsrats sind im von dem Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnenden Protokoll festzuhalten.

Kopien der Auszüge aus solchen Protokollen, die in Gerichtsverfahren oder anderswo vorgelegt werden sollen, sind gültig
durch den Vorsitzenden der Sitzung oder jedwede zwei Verwaltungsratsmitglieder zu unterzeichnen.

Die Beschlussfassung erfolgt durch Stimmenmehrheit der teilnehmenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder,

und der Vorsitzende hat bei Stimmengleichstand die entscheidende Stimme.

Art. 15. Befugnisse des Verwaltungsrats. Dem Verwaltungsrat werden die weitest gehenden Vollmachten zur Vor-

nahme jedweder Verfügungs- und Geschäftsführungsakte im Rahmen des Zwecks der Gesellschaft unter Einhaltung ihrer
Anlagestrategie übertragen.

Sämtliche nicht ausdrücklich von der Rechtsordnung oder der vorliegenden Satzung der Generalversammlung vorbe-

haltenen Befugnisse gehören zum Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Art. 16. Zeichnungsbefugnis für die Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft gültig durch die Zeichnung

jedweder zweier Verwaltungsratsmitglieder, die gemeinsam vorgehen, oder durch die gemeinsame oder Einzelzeichnung
jeder Person(en) verpflichtet, denen entsprechende Vollmacht vom Verwaltungsrat erteilt wurde.

21247

Art. 17. Übertragung von Vollmachten. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann seine Befugnisse zur Führung der

täglichen Geschäfte und Belange der Gesellschaft (einschließlich des Rechts, als Zeichnungsbevollmächtigter für die Ge-
sellschaft zu handeln) und seine Befugnisse zur Vornahme von Handlungen im Rahmen der Verfolgung der Gesellschafts-
strategie und des Gesellschaftszwecks an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen delegieren, die nicht
Verwaltungsratsmitglieder sein müssen, wobei denselben die vom Verwaltungsrat bestimmten Befugnisse zukommen, und
sie, falls der Verwaltungsrat sie dazu ermächtigt, befugt sind, ihre Vollmachten weiter zu delegieren.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvertretungsbefugnisse durch notarielle oder einfache Vollmachtsurkunden er-

teilen.

Art. 18. Investment Manager. Die Gesellschaft soll einen Investment Management Vertrag mit einem oder mehreren

Investment Managern, wie sie näher im PPM beschrieben sind, abschließen, welche der Gesellschaft insbesondere Emp-
fehlungen  und  Beratungsleistungen  in  Bezug  auf  die  Vermögenswerte  der  Gesellschaft  in  Übereinstimmung  mit  dem
Anlageziel und der Anlagestrategie, wie sie im PPM beschrieben sind, liefern. Dieser beziehungsweise diese Investment
Manager sollen zur BPT-Gruppe gehören. Wenn ein Investment Manager aus der BPT-Gruppe ausscheidet oder die
Mehrheit der Gesellschaft von einer nicht zur BPT-Gruppe gehörenden Gesellschaft gehalten wird, wird die Gesellschaft
auf einen Antrag aus der BPT-Gruppe ihren Namen in einen solchen Namen ändern, der nicht das Wort «BPT» und auch
keinen Markennamen irgendeiner Gesellschaft der BPT-Gruppe enthält.

Art. 19. Anlagestrategie und Anlagebeschränkungen Der Verwaltungsrat hat die Befugnis zur Festsetzung der Anlage-

strategie und -politik der Gesellschaft auf der Grundlage der Risikostreuung, sowie der großen Linien der Geschäftsfüh-
rung und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft innerhalb der Beschränkungen, die vom Verwaltungsrat unter Beachtung der
anwendbaren Gesetze und Verordnungen festgesetzt werden.

Anlagen der Gesellschaft können unmittelbar oder mittelbar über Tochterunternehmen erfolgen, worüber der Ver-

waltungsrat jeweils zu entscheiden hat. Unter «Anlagen» und «Vermögenswerten» im Sinne dieser Bestimmungen sind,
je nach Verwendung, entweder unmittelbar getätigte Anlagen und gehaltene Vermögenswerte oder mittelbar über Toch-
terunternehmen getätigte Anlagen und gehaltene Vermögenswerte zu verstehen.

Art. 20. Schadloshaltung von Verwaltungsratsmitgliedern. Die Gesellschaft kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder

jeden sonstigen Funktionsträger und deren Erben, Vollstrecker und Verwalter hinsichtlich irgendwelcher in angemessener
Weise denselben im Zusammenhang mit Klagen, Prozessen oder Verfahren, bei welchen dieselben auf Grund der Tat-
sache, dass sie ein Verwaltungsratsmitglied oder ein Funktionsträger der Gesellschaft oder - auf deren Wunsch - jeder
anderen Gesellschaft gewesen sind, der gegenüber die Gesellschaft die Stellung eines Aktionärs oder Gläubigers hat, und
von der keine Entschädigung zu erwarten ist, entstandenen Auslagen schadlos halten, jedoch mit der Einschränkung, dass
dies nicht für irgendeine Angelegenheit gilt, hinsichtlich derer die entsprechende Person im Rahmen einer solchen Klage,
eines solchen Prozesses oder Verfahrens rechtskräftig eines vorsätzlichen Fehlverhaltens, bösgläubigen Handelns, Arglist,
sorgfaltloser Unachtsamkeit oder grober Fahrlässigkeit überführt wird; im Fall eines Vergleichs ist Entschädigung nur im
Zusammenhang mit jenen von dem Vergleich erfassten Angelegenheiten zu gewähren, hinsichtlich derer die Gesellschaft
von ihrem Rechtsberater die Rechtsansicht erhält, dass die zu entschädigende Person keine solche Pflichtverletzung zu
verschulden hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt keine anderen der Person gegebenenfalls zustehenden
Rechte aus.

Art. 21. Wirtschaftsprüfer. Die im Jahresbericht der Gesellschaft enthaltenen buchhalterischen Informationen sind

durch einen Wirtschaftsprüfer («réviseur d'entreprises agrée») zu prüfen, der von der Generalversammlung bestellt und
von der Gesellschaft bezahlt wird.

Der Wirtschaftsprüfer hat alle im Gesetz von 2007 festgelegten Pflichten zu erfüllen.

Titel IV. Generalversammlungen - Geschäftsjahr - Ausschüttungen

Art. 22. Generalversammlungen der Gesellschaft. Die Generalversammlung der Gesellschaft repräsentiert die Ge-

samtheit der Aktionäre derselben. Ihre Beschlüsse sind für alle Aktionäre bindend, gleichgültig welche Klasse von Aktien
sie innehaben. Die Generalversammlung hat die weitest gehenden Befugnisse zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizie-
rung von Akten im Zusammenhang mit den Transaktionen der Gesellschaft.

Die Generalversammlung tritt auf Grund einer Einberufung durch den Verwaltungsrat zusammen. Sie kann auch auf

Wunsch von Aktionären einberufen werden, die wenigstens ein Fünftel (d.h. 20%) des Stammkapitals repräsentieren.

Für Zwecke dieser Satzung gelten folgende Definitionen:
(a) Unter «Qualifizierte Mehrheit» ist eine Entscheidung zu verstehen, die mit Zustimmung einer Mehrheit von 75%

der bei einer durch ein entsprechendes Anwesenheits-Quorum von zwei Dritteln aller zum Tag der Versammlung aus-
gegebenen Aktien beschlussfähigen Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst worden ist. Wird das
Quorum bei der ersten Einberufung nicht erreicht, findet eine weitere Einberufung der Versammlung statt. Jede Ver-
sammlung in zweiter Einberufung hat dieselbe Tagesordnung, unterliegt aber nicht den Anforderungen an das Quorum
für die Beschlussfähigkeit, und Beschlüsse können gültig mit Zustimmung einer Mehrheit von 75% der bei einer solchen
Versammlung in zweiter Einberufung anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst werden.

21248

(b) vorbehaltlich der Erfordernisse der luxemburgischen Rechtsordnung bezeichnet jede sonstige Bezugnahme auf eine

Abstimmung  der  Aktionäre  einen  Beschluss,  der mit  Zustimmung einer Mehrheit der  bei einer ohne Anwesenheits-
Quorum beschlussfähigen Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst worden ist.

Die jährliche Generalversammlung hat gemäß luxemburgischem Recht am eingetragenen Sitz der Gesellschaft jeweils

am fünfzehnten Tag des Monats Juni um 11 Uhr stattzufinden.

Sollte dieser Tag kein Werktag sein, dann ist die jährliche Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag abzu-

halten.

Sonstige Generalversammlungen können an jenen Orten und zu jenen Zeitpunkten stattfinden, die in den entsprech-

enden Einberufungsmitteilungen angegeben sind.

Die Aktionäre treten auf Einberufung durch den Verwaltungsrat auf Grund einer Einladung zusammen, in der die

Tagesordnung, Zeit und Ort der Versammlung, die geltenden Anwesenheits-Quoren und die Mehrheitserfordernisse
angegeben sind, und die wenigstens acht Tage vor dem Termin der Versammlung an jeden eingetragenen Aktionär an die
im Aktionärsregister eingetragene Adresse desselben zu senden ist. Die Übermittlung einer solchen Einladung an einge-
tragene Aktionäre muss gegenüber der Versammlung nicht begründet werden. Die Tagesordnung wird vom Verwal-
tungsrat erstellt, es sei denn, die Versammlung wurde auf schriftlichen Antrag von Aktionären einberufen, wobei in diesem
Fall der Verwaltungsrat eine zusätzliche Tagesordnung erstellen kann.

Eine solche Einberufung ist zusätzlich, falls dies das luxemburgische Recht so vorsieht, im Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations und jenen anderen Druckschriften zu veröffentlichen, die der Verwaltungsrat hierfür bestimmt.

Der Verwaltungsrat kann alle sonstigen Bedingungen festlegen, die von den Aktionären für eine Teilnahme an jedweder

Versammlung der Aktionäre erfüllt werden müssen.

Die bei jeder Versammlung der Aktionäre verhandelten Angelegenheiten beschränken sich auf die in der Tagesordnung

(die alle gesetzlich vorgeschriebenen Angelegenheiten zu enthalten hat) enthaltenen Punkte und die zu solchen Bereichen
gehörenden Geschäfte.

Die Aktionäre der ausgegebenen Klasse beziehungsweise gegebenenfalls der Klassen von Aktien können jederzeit

Generalversammlungen zur Erörterung von Angelegenheiten abhalten, die sich ausschließlich auf eine solche Klasse bzw.
solche Klassen beziehen.

Jede volle Aktie gibt das Anrecht auf eine Stimme im Einklang mit der luxemburgischen Rechtsordnung und dieser

Satzung. Die Aktionäre können entweder persönlich tätig werden oder einer anderen Person schriftliche Vertretungs-
vollmacht erteilen, wobei diese Person kein Aktionär sein muss und ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sein
kann.

Art. 23. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Dezembertag

eines jeden Jahres.

Art. 24. Ausschüttungen. In dem gesetzlich zulässigen Ausmaß und nach Einbehaltung jener Beträge, die für die ord-

nungsgemäße Geschäftsführung der Gesellschaft und alle erkennbaren Verpflichtungen beziehungsweise Auslagen der
Gesellschaft in vom Verwaltungsrat bestimmter Höhe erforderlich sind, können die Gewinne der Gesellschaft jährlich an
die Aktionäre ausgeschüttet werden. Der Verwaltungsrat hat binnen einer Frist von 20 Werktagen ab der ordnungsge-
mäßen  Herausgabe  des  Jahresberichts  jeden  Aktionär  von  einer  Ausschüttung  zu  verständigen  und  sie  an  denselben
auszuzahlen. Der Verwaltungsrat kann beschließen, im Einklang mit den gesetzlich festgesetzten Bedingungen Zwischen-
dividenden auszuschütten

Findet keine Wiederveranlagung statt, dann sind die Nettoveräußerungserträge und die Erträge aus jedweder Refi-

nanzierung  nach  jedweden  für  antizipierte  Auslagen  oder  Verbindlichkeiten  nach  Festsetzung  des  Verwaltungsrats
vorgenommenen Abzügen binnen 60 Geschäftstagen an die Aktionäre auszuschütten

Für eine von der Gesellschaft erklärte und von ihr zur Verfügung des Anspruchsberechtigten gehaltene Dividende sind

keine Zinsen zu bezahlen.

Die bis zum zehnten Jahrestag des Ersten Closings eingenommenen Nettoveräußerungserträge, sofern vorhanden,

können solange wiederveranlagt werden, bis 90% der Einlageverpflichtungen durch die Gesellschaft auf Dauer in Anlagen
investiert wurden. Nach dem zehnten Jahrestag des Ersten Closings kann eine Wiederveranlagung von Beträgen aus-
schließlich als Folgeinvestitionen in bereits bestehende Anlagen erfolgen.

Titel V. Schlussbestimmungen

Art. 25. Depotbank. Wie vom Gesetz gefordert, wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag abschließen. Die De-

potbank hat die Pflichten und Verantwortungen zu übernehmen, die im Gesetz von 2007 festgelegt sind.

Möchte die Depotbank das Verhältnis lösen, dann hat der Verwaltungsrat sich nach besten Kräften zu bemühen, eine

Nachfolge-Depotbank binnen zwei Monaten ab Rechtswirksamkeit einer solchen Vertragslösung zu finden. Der Verwal-
tungsrat kann das Auftragsverhältnis kündigen, er darf die Depotbank jedoch nicht aus ihrer Stellung entlassen, bis eine
Nachfolge-Depotbank zum Tätigwerden an ihrer Stelle bestellt wurde.

Art. 26. Auflösung der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Generalversammlung

aufgelöst werden. Ein Auflösungsbeschluss muss - mit Ausnahme der Bestimmungen der nachstehenden Absätze - mit
Qualifizierter Mehrheit gefasst werden.

21249

Fällt das Stammkapital der Gesellschaft zu irgendeinem Zeitpunkt unter zwei Drittel des nach luxemburgischem Recht

erforderlichen Mindestkapitals, dann muss der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Frage einer etwaigen Auflö-
sung der Gesellschaft vorlegen. Diese Generalversammlung, für die kein Quorum als Beschlussfähigkeitserfordernis gilt,
entscheidet mit einfacher Mehrheit der Stimmen der bei der Versammlung vertretenen Aktien.

Des Weiteren ist die Frage einer etwaigen Auflösung der Gesellschaft der Generalversammlung vorzulegen, wenn zu

irgendeinem Zeitpunkt das Stammkapital unter ein Viertel des jeweils nach luxemburgischem Recht erforderlichen Min-
destkapitals fällt; in einem solchen Fall findet die Generalversammlung ohne jegliche Quorumerfordernisse statt, und ein
Auflösungsbeschluss kann durch die Aktionäre, die ein Viertel der bei dieser Versammlung vertretenen Aktien halten,
gefasst werden.

Die Generalversammlung ist so einzuberufen, dass sie binnen einer Frist von vierzig Tagen ab der Feststellung, dass

das Nettovermögen der Gesellschaft unter zwei Drittel beziehungsweise unter ein Viertel des rechtlichen Mindestwerts
gefallen ist, abgehalten wird.

Art. 27. Abwicklung. Die Abwicklung ist durch einen oder mehrere Abwickler durchzuführen, die natürliche oder

juristische Personen sein können, und die von der Generalversammlung der Aktionäre bestellt werden, welche auch ihre
Befugnisse und ihre Vergütung festsetzt.

Art. 28. Satzungsänderungen. Diese Satzung kann durch eine Generalversammlung der Aktionäre mit Qualifizierter

Mehrheit abgeändert werden.

Jede Änderung der Satzung, von der die Rechte der Aktionäre einer Klasse betroffen sind, bedarf der Zustimmung

einer Qualifizierten Mehrheit der Aktionäre dieser Klasse zusätzlich zu der oben erwähnten Qualifizierten Mehrheit der
Aktionäre insgesamt.

Art. 29. Anwendbare Rechtsordnung. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten kommen die Be-

stimmungen  des  Gesetzes  über  Handelsgesellschaften  vom  10.  August  1915  und  jene  des  Gesetzes  von  2007  zur
Anwendung.

<i>Vierter Beschluss

Die Aktionäre ernennen ERNST &amp; YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, zum Wirtschaftsprüfer der

Gesellschaft.

<i>Fünfter Beschluss

Die Aktionäre legen 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Sitz der

Gesellschaft fest.

<i>Sechster Beschluss

Die Aktionäre ernennen die folgenden Personen zu Mitgliedern des Verwaltungsrats:
- Dr. Claus Löwe, Geschäftsführer, geboren am 23. Oktober 1951 in Kiel, Deutschland, geschaftsansässig in Große

Friedberger Landstraße 42, D-60313 Frankfurt am Main, Deutschland;

- Herrn Lars Ohnemus, CEO, geboren am 11. Juni 1962 in Kopenhagen, Dänemark, geschäftsansässig in Bredgade 23A,

DK-1260 Kopenhagen K, Dänemark;

- Herrn Alain Heinz, Direktor, geboren am 17. Mai 1968 in Forbach, Frankreich, geschäftsansässig in 121, avenue de

la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg;

-  Dr.Peter  Schmidt  zur  Nedden,  Rechtsanwalt  und  Notar,  geboren  am  2.  September  1937  in  Köln,  Deutschland,

geschäftsansässig in Taunusanlage 11, D-60329 Frankfurt am Main, Deutschland; und

- M 

e

 Patrick Reuter, Rechtsanwalt, geboren am 15. August 1963 in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, ge-

schäftsansässig in 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ihre Ernennung endet am Tag der jährlichen Generalversammlung die im Jahr 2008 gehalten wird.
Da keine weiteren Angelegenheiten auf der Tagesordnung der Generalversammlung stehen, wurde diese daraufhin

geschlossen.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-

kunde auf Wunsch der erschienenen Personen in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst
wurde. Auf Antrag der erschienenen Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, soll die englische Version maßgeblich sein.

Dem Vorgennanten entsprechend wurde die vorliegenden Urkunde in Luxemburg am zu Beginn dieses Dokumentes

gennanten Datum erstellt.

Nachdem die Urkunde der Generalversammlung, den Mitgliedern des Büros der Versammlung, die dem Notar alle

dem Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnsitz nach bekannt sind, verlesen wurde, wurde sie gemeinsam mit dem
unterzeichneten Notar unterschrieben.

Gezeichnet: S. Alexandrino, E. Brauckmann, P. Reuter, H. Hellinckx.

21250

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, Relation: LAC/2008/891. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für Gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt.

Luxemburg, den 25. Januar 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008020514/242/1508.
(080019093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2008.

Linéa Donna S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 90, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 43.977.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 11 février 2008, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, Dix-huitième

Chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société à responsabilité limitée LINEA DONNA S.à r.l., avec siège social à L-2146 Luxembourg, 90, rue de Merl,

de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Claudine De La Hamette, premier juge au Tribunal d'Arron-

dissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Vincent Bolard, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 3 mars 2008 au greffe de la Dix-huitième

Chambre du Tribunal de Commerce de Luxembourg.

Pour mentions aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
V. Bolard.
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008021694/8664/23.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04018. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2008.

Pictet Global Selection Fund, Fonds Commun de Placement.

L'Amendement au règlement de gestion consolidé au 26 février 2008 du fonds commun de placement PICTET GLOBAL

SELECTION FUND a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PICTET GLOBAL SELECTION FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008021114/52/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02835. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080023990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

M S R S.à r.l., Manfred Ships Repairs, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 77.381.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 11 février 2008, le tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième cham-

bre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société à responsabilité limitée MANFRED SHIPS REPAIRS S.à r.l., avec siège social à L-1635 Luxembourg, 4, allée

Léopold Goebel, de fait inconnue à cette adresse,

21251

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Claudine De La Hamette, premier juge au tribunal d'arron-

dissement  de  et  à  Luxembourg,  et  liquidateur  Maître  Vincent  Bolard,  avocat,  demeurant  à  la  Cour,  demeurant  à
Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 3 mars 2008 au greffe du tribunal de

commerce de Luxembourg.

Pour mentions aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
V. Bolard.
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008021677/8664/24.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04014B. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080024772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2008.

Société Internationale des Affaires Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 41.315.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 11 février 2008, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, Dix-huitième

Chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme SOCIETE INTERNATIONALE DES AFFAIRES HOLDING S.A., dont le siège social à L-1931

Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, a été dénoncé en date du 11 novembre 2004.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Claudine De La Hamette, premier juge au Tribunal d'Arron-

dissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Vincent Bolard, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 3 mars 2008 au greffe de la Dix-huitième

Chambre du Tribunal de Commerce de Luxembourg.

Pour mentions aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
V. Bolard.
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008021678/8664/22.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04009. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2008.

Ligne XII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 90.426.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 11 février 2008, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, Dix-huitième

Chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société à responsabilité limitée LIGNE XII S.à r.l., avec son siège social à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe, de

fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Claudine De La Hamette, premier juge au Tribunal d'Arron-

dissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Vincent Bolard, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 3 mars 2008 au greffe de la Dix-huitième

Chambre du Tribunal de Commerce de Luxembourg.

Pour mentions aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

21252

Pour extrait conforme
V. Bolard.
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008021697/8664/23.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04020. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2008.

Fiba S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 27.648.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 24 janvier 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société à responsabilité limitée FIBA S.à r.l., avec siège social à L-1425 Luxembourg, 2, rue du Fort Dumoulin.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, et liquidateur Maître Sandra Alves Roussado, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 février 2008 au greffe du tribunal de

commerce de Luxembourg.

Pour extrait conforme
S. Alves Roussado
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008021814/5419/21.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN03999. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2008.

R. &amp; T. Research and Technology S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 22.079.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 11 février 2008, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième

chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme R. &amp; T. RESEARCH AND TECHNOLOGY S.A., dont le siège social à L-1931 Luxembourg, 25,

avenue de la Liberté, a été dénoncé en date du 13 octobre 2004.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Claudine De La Hamette, premier juge au Tribunal d'Arron-

dissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Vincent Bolard, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 3 mars 2008 au greffe du tribunal de

commerce de Luxembourg.

Pour mentions aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
V. Bolard.
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008021698/8664/22.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04011. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2008.

Gestocapital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 16.494.

21253

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 24 janvier 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme GESTOCAPITAL S.A., avec siège social à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, et liquidateur Maître Sandra Alves Roussado, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 février 2008 au greffe du tribunal de

commerce de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
S. Alves Roussado
Le liquidateur

Référence de publication: 2008021813/5419/22.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN03996. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080024765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2008.

MKL Immobilière S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 45.879.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 24 janvier 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme MKL IMMOBILIERE S.A., ayant eu son siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gille Mathay, juge au tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, et liquidateur Maître Sandra Alves Roussado, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 février 2008 au greffe du tribunal de

commerce de Luxembourg.

Pour mentions aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
S. Alves Roussado
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008021815/5419/21.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04003. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2008.

Nexo Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 17, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 22.429.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 24 janvier 2008, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme NEXO HOLDING S.A., avec siège social à L-1116 Luxembourg, 17, rue Adolphe, de fait inconnnue

à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, et liquidateur Maître Sandra Alves Roussado, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 février 2008 au greffe du tribunal de

commerce de Luxembourg.

Pour mentions aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

21254

Pour extrait conforme
S. Alves Roussado
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008021816/5419/23.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2008, réf. LSO-CN04001. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2008.

Waverley S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 127.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 109.030.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008018969/6341/13.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, réf. LSO-CM09204. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080016402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Edinformatic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 86.305.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008018973/6341/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, réf. LSO-CM09195. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080016389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Gent's Properties, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3462 Dudelange, 3, rue Edison.

R.C.S. Luxembourg B 135.652.

STATUTS

L'an deux mille sept, le onze décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Manuele Gentilotti, employé public, et son épouse
2.- Madame Romana Mikolajczak, coiffeuse,
demeurant ensemble à L-3462 Dudelange, 3, rue Edison
Lesquels comparants, présents comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire de dresser acte d'une société à res-

ponsabilité limitée familiale, qu'ils déclarent constituer entre eux et entre tous ceux qui en deviendront associés par la
suite et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GENT'S PRO-

PERTIES.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Ville de Dudelange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune, par simple décision des associés.

Art. 3. L'objet de la société est la mise en valeur et la gestion d'immeubles pour compte propre.

21255

D'une façon générale elle peut faire toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rattachant directement

ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. La société pourra se porter garante des enga-
gements des associés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner dans les six (6) premiers

mois de l'exercice avec effet au 31 décembre par lettre recommandée à la poste à ses coassociés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu'à la fin de l'exercice sur le rachat des parts de l'associé sortant.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à trois cent trente cinq mille euros (335.000,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales

sans valeur nominale réparties comme suit:

Parts sociales

1.- Monsieur Manuele Gentilotti, quatre-vingt-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

2.- Madame Romana Mikolajczak, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés, elles ne peuvent être cédées entre vifs ni transmises pour

cause de mort à des non associés que moyennant l'agrément unanime des autres associés. En cas de refus d'agrément,
les parts sociales seront reprises à leur valeur résultant du dernier bilan approuvé.

Art. 8. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l'assemblée générale des associés

qui désignent leurs pouvoirs.

Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 10. L'exercice social de la société correspond à l'année civile.
Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté,

déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 11. Le décès ou l'incapacité de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société.

Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation la première année sociale commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève à approximativement 3.500,- €.

<i>Souscription et Paiement

Le capital social d'un montant total de trois cent trente-cinq mille euros (335.000,- EUR) a été souscrit par apport en

nature du terrain sis à Burmerange, um Schotz inscrit au cadastre comme suit:

Commune de Burmerange, section B de Burmerange
- numéro 3215/5541, lieu dit «Um Schotz», place, contenant 7,83 ares, évaluée à 335.000,- EUR

<i>Assemblée générale

Et ensuite les associés présents, représentant l'intégralité du capital social se considérant toutes comme valablement

convoqués se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- Est nommée gérante pour une durée indéterminée Madame Romana Mikolajczak, prénommée,
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante, y compris le pouvoir

de constituer hypothèque ou de donner mainlevée.

- Le siège social est établi à L-3462 Dudelange, 3, rue Edison

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: M. Gentilotti, R. Mikolajczak, P. Decker.

21256

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2007, Relation: LAC/2007/40487. — Reçu 1.675 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 29 janvier 2008.

P. Decker.

Référence de publication: 2008018773/206/77.
(080016743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

ENEX Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 135.653.

STATUTS

L'an deux mille sept, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich,

A comparu:

Monsieur Arthur Lundrigan Trueman Davis, de nationalité canadienne, demeurant à Genève
ici représentée par Monsieur Patrick Römer, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg-Strassen, 7, rue

Thomas Edison.

en vertu de d'une procuration donnée sous seing privé, en date du 27 décembre 2007
laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumen-

tant, restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle

va constituer entre elle et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite:

Dénomination - siège - durée - objet - capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ENEX GROUP S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg
Lorsque des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces,
l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et
au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise
au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre dès
obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,

le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Elle pourra
généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Du-
ché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet
social..

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions d'une

valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

21257

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence

de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par tous moyens de communications, étant admis. En cas d'urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

Art. 10. Vis-à-vis de tiers la société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par

la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit, le 1 

er

 mardi du mois de juin à 16.00 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout ou il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

huit.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille neuf.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, l'actionnaire unique, préqualifiée, déclare souscrire toutes les cinq mille

(5.000) actions et déclare entièrement les libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 50.000,-
EUR (cinquante mille euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire
soussigné.

21258

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur

les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à la somme de EUR 1.800,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, l'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social,

représentée comme dit ci-avant et se considérant comme dûment convoquée a pris les décisions suivantes:

1) Le siège social de la société est fixé à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirlant en 2013:
a) Monsieur Romain Bontemps, expert-comptable et fiscal, réviseur d'entreprises,
b) Monsieur Ronald Weber, expert-comptable et fiscal, réviseur d'entreprises,
c) Monsieur Carlo Reding, expert-comptable et fiscal, réviseur d'entreprises,
tous domiciliés professionnellement à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirera en 2013 la société PKF ABAX AUDIT,

ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy (RCS Luxembourg N 

o

 B 27.761)

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l'étude de notaire, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu par le notaire instrumentant

par son nom prénom, état et demeure celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Römer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2008. Relation: LAC/2007/328. - Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur Pr. (signé): R. Jungers.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 25 janvier 2008.

P. Decker.

Référence de publication: 2008018772/206/127.
(080016774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Station Shell Schengen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 100, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 98.440.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008018987/508/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01533. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080016683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Voyages Vandivinit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5683 Dahleim, 17, Kiischtestrooss.

R.C.S. Luxembourg B 37.860.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008018988/525/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01590. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080016682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

21259

Lux Cogeba S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 9, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 85.819.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008018989/508/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2007, réf. LSO-CL04984. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080016678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Robeco Interest Plus Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 40.490.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 29 novembre 2007 a décidé:
- de prendre note de la démission de Messieurs Frank Alexander De Boer et Stéfan F.A. Richter avec effet au 29

novembre 2007,

- de nommer en tant qu'administrateurs Monsieur Francesco Baici, Vice-President, Robeco Schweiz, Uraniastrasse 12,

P.O. Box 2068, CH-8001 Zürich, ainsi que Monsieur Ali Ould Rouis, Robeco France, 21 boulevard de la Madeleine,
F-75039 Paris Cedex 01, et ce pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2008,

-  de  renouveler  le  mandat  de  Madame  Edith  J.  Siermann,  Executive  Vice  President,  ROBECO  GROEP  N.V.,  120,

Coolsingel, NL - 3011 AG Rotterdam en sa qualité d'administrateur pour une période d'un an prenant fin lors de la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008,

de sorte que le conseil d'administration se compose dès lors comme suit:
Monsieur Francesco Baici, Vice-President, Robeco Schweiz, Uraniastrasse 12, P.O. Box 2068, CH-8001 Zürich,
Monsieur Ali Ould Rouis, Robeco France, 21, boulevard de la Madeleine, F-75039 Parix Cedex 01,
Madame Edith J. Siermann, Executive Vice President, ROBECO GROEP N.V., 120, Coolsingel, NL - 3011 AG Rotter-

dam.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a également décidé de renouveler le mandat de Pricewaterhouse-

Coopers S. à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, RCS B 65.477, en sa qualité de Réviseur d'Entreprises pour une
période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

<i>Pour ROBECO INTEREST PLUS FUNDS
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008017810/1126/30.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07779. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080015197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2008.

Biscarosse S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5680 Dalheim, 6, Wenkelhiel.

R.C.S. Luxembourg B 98.972.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008018983/508/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2007, réf. LSO-CL04986. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080016698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

21260

Blairnet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 24, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 103.543.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008018984/508/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2007, réf. LSO-CL04993. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080016697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

L.M. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 38, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 84.768.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008018985/508/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01550. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080016691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Société Européenne de Participations et Investissements, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 37.082.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 5 décembre 2007 que:
1. La révocation de Monsieur Olivier Dorier en sa qualité de liquidateur est acceptée.
2. Est nommé en remplacement du Liquidateur révoqué, la société FGS CONSULTING LLC, ayant son siège social au

520 S. 7th. Street, Suite C, Las Vegas, NV-89101 (Etats-Unis).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008019016/6312/18.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, réf. LSO-CM09422. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080016488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Sofape S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.520.000,00.

Siège social: L-4084 Esch-sur-Alzette, 11, rue François Donven.

R.C.S. Luxembourg B 109.752.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008019010/534/13.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM01985. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080017006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

21261

Co-Investment II Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 100.643.

Le bilan de liquidation au 5 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FAIRLAND PROPERTY LIMITED
Liquidateur
B. Zech
<i>Directeur

Référence de publication: 2008018995/724/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, réf. LSO-CM08188. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080016933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Danor Media Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 12.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 82.388.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R.P. Pels.

Référence de publication: 2008018996/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, réf. LSO-CM08190. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080016929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

A.J.I.L. C. &amp; P. S.A., Consultants-Courtiers en Assurances, Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 21, Stawelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 68.314.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008018993/768/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2007, réf. LSO-CL04677. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080016949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Mischabel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 77.331.

Annule et remplace la publication enregistrée le 22 octobre 2007 sous la référence LSO-CI07377 et déposée le 24

octobre 2007 sous la référence L070145515.04

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

21262

MISCHABEL S.A.
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008018997/45/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01536. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080016955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Somato S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R.C.S. Luxembourg B 77.756.

Le bilan et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2007.

P. Rochas
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008019000/636/15.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2008, réf. LSO-CM02407. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080016973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Pacuare S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 67.924.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 décembre 2007

- L'Assemblée ratifie la cooptation au poste d'administrateur de LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à.r.l., ayant son

siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée qui se tiendra en
2010.

- L'Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, du commissaire aux comptes ORANGEFIELD TRUST (LU-

XEMBOURG) S.A. (anciennement ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.), ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg.

- L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire CO-VENTURES S.A., ayant son

siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 27 décembre 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008017935/655/23.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2008, réf. LSO-CM04680. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080014731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2008.

Modern Funds Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 46.846.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration

Il résulte du procès-verbal des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société que le projet de fusion

entre la Société et BANQUE INVIK ASSET MANAGEMENT S.A, ayant son siège social au 7, avenue Pescatore à L-2324
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 106.131, a été publié en
date du 16 novembre 2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 2620 et qu'en l'absence (i) d'une

21263

convocation d'une assemblée générale de la Société et (ii) d'un refus du projet de fusion par une assemblée générale
extraordinaire, la fusion est devenue effective le 16 décembre 2007, soit un mois à partir de la première publication.

Pour extrait
<i>MODERN FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008017917/5499/20.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, réf. LSO-CM07018. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080014951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2008.

Kismet Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 237.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 111.397.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008018968/6341/13.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, réf. LSO-CM09207. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080016404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Thurloe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 251.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 109.035.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008018970/6341/13.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, réf. LSO-CM09202. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080016397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Thurloe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 251.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 109.035.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008018971/6341/13.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, réf. LSO-CM09198. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080016394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

21264


Document Outline

Aderland Holding S.A.

A.J.I.L. C. &amp; P. S.A., Consultants-Courtiers en Assurances

Barclays Euro Funds

Basinco Holdings S.A.H.

Biscarosse S.A.

Blairnet S.à r.l.

BPT Hansa Lux S.A.

BPT Hansa Lux SICAV-SIF

Co-Investment II Luxco S.à r.l.

Compagnie Industrielle et Financière des Produits Amylacés

Danor Media Sàrl

Dexia Global

Domanial S.A.

Edinformatic S.A.

ENEX Group S.A.

Falbala S.A.

Fiba S.à r.l.

Fraco S.A.

Gent's Properties

Gestocapital S.A.

Global Hotel Development Holding S.A.

Inka A.G.

Intel Holding S.A.

Inversiones Viso S.A.

Kismet Properties S.à r.l.

Lago S.A.

Ligne XII S.à r.l.

Linéa Donna S.à r.l.

L.M. S.à r.l.

Lux Cogeba S.A.

Manfred Ships Repairs

Marsan Holding S.A.

M.G.C. Financière S.A.

Midilux Holdings S.A.

Mischabel S.A.

MKL Immobilière S.A.

Modern Funds Management Company S.A.

Nexo Holding S.A.

Pacuare S.A.

Pictet Global Selection Fund

Pictet Global Selection Fund

Robeco Interest Plus Funds

R. &amp; T. Research and Technology S.A.

SAGRAL (Société Agricole des Grands Lacs) S.A.

Société Européenne de Participations et Investissements

Société Internationale des Affaires Holding S.A.

Sofape S.à r.l.

'SOMALUX' Société de Matériel Luxembourgeoise S.A.

Somato S.A. Holding

Station Shell Schengen S.A.

Thurloe Holdings S.à r.l.

Thurloe Holdings S.à r.l.

Voyages Vandivinit S.à r.l.

Waverley S.à r.l.