logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 435

20 février 2008

SOMMAIRE

Apimmo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20876

Avencor Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20868

B.H.I. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20877

BVLUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20875

BVLUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20840

Chiltern Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . .

20878

Club d'Epargne "Eng voll Kees Nothum"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20871

Coiffure Cap'Act S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

20877

ColBiSpazio Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

20854

Comont S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20870

Dematic Holding S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

20877

Endurance Asset S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20876

Endurance Hospitality Asset S.à r.l.  . . . . . .

20873

Esculape S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20854

Eurazeo Entertainment Lux S.à r.l.  . . . . . .

20870

FinSole S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20879

Gallaher Finance Luxembourg S.à r.l.  . . . .

20847

Gallaher Finance Luxembourg S.à r.l.  . . . .

20851

Gallaher Investments Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20841

Gallaher Investments Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20844

Gallaher Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

20834

Gallaher Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

20837

GEBPF Finance (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

20879

IEE Holding 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20854

Immobilier Caraïbique S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

20880

Immobilier Caraïbique S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

20880

ISPC II LLC Cie. SCS ("société en com-

mandite simple") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20879

Kamea International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

20880

Lukas LuxCo 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20878

MCR SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20875

Michael SCHORN S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

20869

MMI Trust Holding s.a.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

20875

Multitel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20878

Orco Croatia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20876

Orco Germany S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20869

Renaissance Cruises S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

20870

Satin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20880

Swan Investment Company  . . . . . . . . . . . . .

20840

Tanna Holding S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

20868

Tiger Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20875

Til S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20869

Tong International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

20876

Tysama International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

20868

Value Entertainment S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

20869

20833

Gallaher Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 10.651.950,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 84.801.

In the year two thousand and seven, on the twenty-third of February,
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholder of GALLAHER LUXEMBOURG S.à r.l., a company estab-

lished and existing in Luxembourg under the form of a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under section B, number 84.801, incorporated pursuant to a deed of Notary Joseph Elvinger,
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the 26 November 2001, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (Mémorial C), number 470 of 25 March 2002 as amended (hereafter the «Company»).

The articles of incorporation of the Company have been lastly amended by notarial deed enacted on 10 June 2003,

published in the Mémorial C, number 793 of 29 July 2003.

The meeting was presided by Mr Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg,
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs Flora Gibert, jurist, residing in Lux-

embourg,

The chairman requested the notary to certify that:
I.- The shareholder was present or duly represented and the number of shares held by each of them were shown on

an attendance list. That list and proxy, initialed ne varietur and signed by the appearing persons and the notary, would
remain annexed to the minutes to be registered with them.

II.- As shown in the attendance list, the 426,078 (four hundred twenty-six thousand seventy-eight) shares, with a

nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, representing the whole capital of the Company, were represented
and  accordingly  the  meeting  could  validly  decide  on  all  the  items  of  the  agenda  of  which  the  shareholder  had  been
beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting was as follows:

<i>Agenda:

1. Waiving of the notice right;
2. Approval of the change of the nationality of the Company and of the migration from the Grand Duchy of Luxembourg

to Guernsey and appointment of proxy-holders of the Company in relation to the Luxembourg migration formalities;

3. Amendment of the articles of association of the Company and adoption of a memorandum of association in order

to comply with The Companies (Guernsey) Law, 1994 to be effective upon fulfillment of the condition precedent to the
migration of the Company to Guernsey, i.e. the registration of the Company on the Guernsey Register of Companies;

4. Approval of the resignation of Mr Gérard Becquer and Mrs Charlotte Bastin as managers of the Company and the

appointment of new managers of the Company subject to the condition precedent to the migration of the Company to
Guernsey being fulfilled; and

5. Miscellaneous.
IV.- The meeting was provided with a copy of the current articles of association of the Company;
After the foregoing was approved by the shareholder, the following resolutions were taken:

<i>First resolution

It was unanimously resolved that the shareholder waives its right to notice of the extraordinary general meeting which

should have been sent to them prior to this meeting; the shareholder acknowledges to be sufficiently informed of the
agenda and consider the meeting to be validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of
the agenda. It was resolved further that all the documentation produced to the meeting had been put at the disposal of
the shareholder within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

<i>Second resolution

It was unanimously resolved to migrate the Company from Luxembourg to Guernsey, that the Company take the

Guernsey nationality, and that the Company close its place of business in Luxembourg (the «Migration»).

It was reported that the legal personality of the Company would survive the Migration and hence the Company will

be and remain the sole and full owner of all its assets and fully liable for all its debts and liabilities following the Migration.
It was reported further that, following the Migration, the Company would take the form of a company limited by shares
under Guernsey law.

The conditions and formalities to be complied with under both Luxembourg and Guernsey laws in order to proceed

with the Migration were then described to the shareholder and the latter resolved that the Migration be subject to the

20834

condition precedent that the Company be registered on the Guernsey Register of Companies (the «Condition Prece-
dent»).

It was resolved that provided that the Condition Precedent was fulfilled, the Migration would only be effective on and

from the date of fulfillment of the Condition Precedent. The Company would be deregistered in Luxembourg following
its registration in Guernsey so as fully to become a Guernsey Company, governed only by the laws of Guernsey. It was
highlighted further that, as from the date of its registration on the Guernsey Register of Companies (i) the Company
would no longer be registered as a Luxembourg Company and hence (ii) no longer governed by Luxembourg laws.

It was resolved to appoint Ms Soledad Pascual and Mr Torsten Schmitt of Noble and Scheidecker, with professional

address at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, and Mr Régis Galiotto of Etude Notaire Elvinger, with professional
address at 15, côte d'Eich, L-1450, Luxembourg, acting with full power of substitution, acting individually in the name and
on behalf of the Company, to deregister the Company from the Luxembourg Register of Commerce and Companies.

In addition, it was resolved that further to the completion of the Migration, the registered office of the Company will

be located at Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 3BG. For the avoidance of doubt, such a change
in the place of the registered office of the Company shall not be effective unless and until the Condition Precedent is
fulfilled.

<i>Third resolution

Further to the second resolution, it was unanimously resolved to amend the articles of association of the Company

and to adopt a memorandum of association in order to comply with The Companies (Guernsey) Law, 1994 (the «Amend-
ments»).  It  was  noted  that  further  to  the  Amendments  the  Company  shall  be  named  GALLAHER  LUXEMBOURG
LIMITED. It was resolved further that the Amendments would however not be effective until and unless the Condition
Precedent was fulfilled. For the avoidance of doubt, should the Condition Precedent be fulfilled, the Amendments would
then be effective on and from the date of fulfilment of the Condition Precedent. It was resolved that, following the
Amendments, the articles of association of the Company and the memorandum of association would be drafted in ac-
cordance with the attached schedule.

<i>Fourth resolution

It was noted that further to a letter dated 22 February 2007, Mr Gérard Becquer and Mrs Charlotte Bastin, both

residing at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg have tender their resignation from
their function of managers of the Company to be effective on and from the Condition Precedent being fulfilled (the
«Resignations»). It was unanimously resolved to approve the Resignations with effect on and from the Condition Prec-
edent being fulfilled and to grant Mr Gérard Becquer and Mrs Charlotte Bastin discharge for the performance of their
duties as from the date of their appointment as managers of the Company until the date the Condition Precedent is
fulfilled, unless any faults in the execution of their duty are identified on the basis on the financial statement corresponding
to the current financial year.

It was unanimously resolved to appoint Mr Michael John Seymour Eades and Mr Andrew Boyce, both residing at 7

New Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 4BZ as new manager(s) of the Company, to be effective on and from the
Condition Precedent being fulfilled. It was noted that by letter dated 22 February 2007, Mr Michael John Seymour Eades
and Mr Andrew Boyce have consented to act as a manager of the Company on and from the Condition Precedent being
fulfilled.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would

be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about EUR 2,000.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mil sept, le vingt-trois février,
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de GALLAHER LUXEMBOURG S.à r.l., une

société établie et existant au Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 84.801, constituée conformément à l'acte du notaire Joseph
Elvinger, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 26 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (Memorial C), numéro 470 en date du 25 mars 2003, tel que modifié (ci-après la «Société»).

20835

Les statuts de la Société ont été dernièrement modifiés par acte notarié en date du 10 juin 2003, publié au Mémorial

C, numéro 793 en date du 29 juillet 2003.

L'assemblée a été présidée par M. Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Le président a désigné comme secrétaire et l'assemblée a choisi comme scrutateur Madame Flora Gibert, juriste,

demeurant à Luxembourg,

Le président a prié le notaire d'acter que:
I.- L' associé unique était présent ou dûment représenté et que le nombre de parts sociales qu'ils détient a été reporté

sur une liste de présence. Cette liste de présence et la procuration, paraphées ne varietur et signées par le comparant
et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 426.078 (quatre cent vingt-six mille soixante-dix-huit) parts sociales,d'une

valeur nominale de 25,- EUR (vinght-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, étaient
représentées, de sorte que l'assemblée pouvait valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, et
dont l' associé unique avait été préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation du changement de nationalité de la Société et du transfert du Grand-Duché de Luxembourg vers

Guernesey, et nomination de mandataires de la Société pour l'exécution des formalités luxembourgeoises de transfert;

3. Modification des statuts de la Société et adoption d'un memorandum of association afin de mettre les documents

statutaires en conformité avec «The Companies (Guernesey) Law, 1994» applicable dès lors que la condition suspensive
pour le transfert sera remplie, c'est à dire dès l'enregistrement de la Société au Registre des Sociétés de Guernesey;

4. Approbation de la démission de M. Gérard Becquer et Mme Charlotte bastin comme gérants de la Société et

nomination de nouveaux gérants de la Société, sous condition suspensive de la migration effective de la Société à Guer-
nesey; et

5. Divers.
IV.- Une copie des statuts en vigueur de la Société a été communiquée à l'assemblée.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l' associé unique présent, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé que l'associé unique renonce aux délais de convocation de l'assemblée générale extraordinaire qui devait

lui être envoyée antérieurement à cette assemblée; l'associé unique reconnaît être suffisamment informé de l'ordre du
jour et considère être valablement convoqué à la présente assemblée et vote sur tous les points portés à l'ordre du jour.
De plus, il est décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition de l'associé
unique pendant un laps de temps suffisant pour lui permettre d'examiner avec attention chaque document.

<i>Deuxième résolution

Il a été décidé de migrer la Société du Luxembourg vers Guernesey, que la Société adopte la nationalité de Guernesey

et que la Société cesse toute activité à Luxembourg (le «Transfert»).

Il est rappelé que la personne morale de la Société survivra au Transfert et que, par voie de conséquence, la Société

sera et demeurera le seul propriétaire de tous ses actifs et sera pleinement responsable de ses dettes suite au Transfert.
De plus, il est rappelé que, suite au Transfert, la Société adoptera la forme d'une société à responsabilité limitée régie
par les lois de Guernesey.

Les conditions et les formalités à accomplir au regard des lois luxembourgeoise et de Guernesey, permettant d'opérer

le Transfert, ont été présentées à l'associé unique et ce dernier a décidé que le Transfert sera soumis à la réalisation de
la condition suspensive que la Société soit immatriculée au Registre des Sociétés de Guernesey (la «Condition Suspen-
sive»).

Il a été décidé, sous réserve que la Condition Suspensive soit remplie, que le Transfert sera effectif uniquement au

jour de réalisation de la Condition Suspensive. Suite à l'immatriculation de la Société à Guernesey, cette dernière sera
radiée du registre à Luxembourg, afin de devenir pleinement une société de Guernesey, régie exclusivement par les lois
de Guernesey. Il est de plus souligné que la Société (i) cessera d'être enregistrée comme une société de droit luxem-
bourgeois à la date de son immatriculation au Registre des Sociétés de Guernesey et par voie de conséquence, qu'elle
(ii) cessera d'être régie par les lois luxembourgeoises au jour de son immatriculation au Registre des Sociétés de Guer-
nesey.

Il est décidé de nommer Mme Soledad Pascual et M. Torsten Schmitt de Noble &amp; Scheidecker, avec adresse profes-

sionnelle au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et M. Régis Galiotto de l'étude de
notaire  Elvinger,  avec  adresse  professionnelle  au  15,  côte  d'Eich  L-1450Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,
investis des pleins pouvoirs de substitution, agissant au nom et pour le compte de la Société, de demander la radiation
de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

20836

De plus, il a été décidé que suite à l'accomplissement de la Migration, le siège social de la Société sera situé à Dorey

Court, Admiral Park, St Peter Port, GY1 3BG, Guernesey. Afin d'éviter tout doute, le changement de siège social de la
Société ne sera pas effectif tant que la Condition suspensive ne sera pas remplie.

<i>Troisième résolution

Consécutivement à l'adoption de la deuxième résolution, il a été décidé de modifier les statuts de la Société et d'adopter

un  mémorandum  of  association  afin  de  se  mettre  en  conformité  avec  «The  Companies  (Guernsey)  Law,  1994»  (les
«Modifications»). Il est également noté qu'en vertu des Modifications la Société se dénommera GALLAHER LUXEM-
BOURG  LIMITED.  De  plus,  il  a  été  unanimement  décidé  que  les  Modifications  ne  seront  pas  effectives  tant  que  la
Condition Suspensive ne sera pas remplie. Pour éviter tout doute, si la Condition Suspensive se réalise, les Modifications
deviendront effectives dès la date de réalisation de la Condition Suspensive. Il est décidé que, suite aux Modifications, les
Statuts de la Société et les modifications des Statuts seront rédigés en accord avec les annexes ci-jointes.

<i>Quatrième résolution

Il est rapporté que conformément à une lettre datée du 22 février 2007, M. Gérard Becquer et Mme Charlotte Bastin,

tous deux résidants au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ont proposé leur
démission de leurs fonctions de gérant de la Société avec effet dès la date de réalisation de la Condition Suspensive (les
«Démissions»). Il est également unanimement décidé d'approuver les Démissions avec effet dès la date de réalisation de
la Condition Suspensive et d'accorder décharge à M. Gérard Becquer et Mme Charlotte Bastin pour l'exercice de leur
mandat à compter de la date de leur nomination comme gérant de la Société jusqu'à la date de réalisation de la Condition
Suspensive, à moins que les états comptables annuels de l'exercice social en cours ne mettent en évidence des fautes de
gestion.

Il est unanimement décidé de nommer M. Michael John Seymour Eades et M. Andrew Boyce, résidants au 7, New

Street, St Peter Port, Guernesey, GY1 4BZ comme nouveau gérant de la Société à compter de la date de réalisation de
la Condition Suspensive. Il est noté que M. Michael John Seymour Eades et M. Andrew Boyce ont, par lettre datée du 22
février 2007, accepté le mandat de gérant de la Société à compter de la date de réalisation de la Condition Suspensive.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ 2.000,- euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite du présent acte original au comparant, ce dernier a signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Galiotto, F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, Relation LAC/2007/807. - Reçu 12 euros.

<i>Le receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme à l'original, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008018240/211/209.
(080015988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Gallaher Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 10.651.950,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 84.801.

In the year two thousand and seven, on the twelfth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of GALLAHER LUXEMBOURG S.à r.l., a company es-

tablished and existing in Luxembourg under the form of a «société à responsabilité limitée», having its registered office
at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under section B number 84.801, incorporated pursuant to a deed of Notary Joseph Elvinger, residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the 26 November 2001, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (Mémorial C), number 470 of 25 March 2002 as amended (hereafter the «Company»).

The articles of association of the Company have been lastly amended by notarial deed enacted on 12 April 2007,

published in the Memorial C, number 1666 of 7 August 2007.

20837

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders of the Company, namely (i) GALLAHER BENELUX LIMITED, a company incorporated under the

laws of England and Wales, having its registered office at Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 OQU,
England and (ii) GALLAHER LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered
office at Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey, KT13 OQU, England, are both respectively duly represented
by Mr Régis Galiotto from the notary office of Mr Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, pursuant to powers of attorney dated 6th, and 7th, December 2007. The number of shares held by the
shareholders is shown on an attendance list. That list and the powers of attorney, signed by the appearing persons and
the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As it appears from the attendance list, the 426,078 (four hundred twenty-six thousand seventy-eight) shares with

a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, representing the entire share capital of EUR 10,651,950.- (ten million
six hundred fifty-one thousand nine hundred fifty Euro) of the Company, are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda of which the shareholders state having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Waiving of the notice right;
2. Approval of the decision to revoke the decision of 23 February 2007 regarding the migration of the Company to

Guernsey; and

3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It was unanimously resolved that the shareholders waive their right to the prior notice of the current extraordinary

general meeting, which should have been sent to them prior to this meeting; the shareholders acknowledge being suffi-
ciently informed on the agenda and consider the meeting being validly convened and therefore agree to deliberate and
vote upon all the items of the agenda. It was unanimously resolved further that all the documentation produced to the
meeting had been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to
examine carefully each document.

<i>Second resolution

It was noted that, in an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on 23 February 2007

in front of the undersigned notary, the following decisions were taken: (i) approval of the change of the nationality of the
Company and of the migration from the Grand Duchy of Luxembourg to Guernsey and appointment of proxy-holders
of the Company in relation to the Luxembourg migration formalities, (ii) consequently amendment of the articles of
association of the Company and adoption of a memorandum of association in order to comply with The Companies
(Guernsey) Law, 1994 and (iii) approval of the resignation of Mr Gérard Becquer and Ms Charlotte Bastin as managers
of the Company and the appointment of new managers of the Company (the «Migration Decisions»).

It was further noted that the effectiveness of the decisions described above were subject to the fulfilment of the

condition precedent of the registration of the Company at the Guernsey Register of Companies (the «Condition Prec-
edent»).

It was reported that to date, the Condition Precedent has not been fulfilled and that the Company is not any more

interested in proceeding to the migration.

After due and careful consideration, it was unanimously resolved that the Migration Decisions be revoked and that

therefore the Company shall remain and continue its business in Luxembourg as if no Migration Decisions had ever been
taken.

In addition, it was unanimously resolved to grant to any manager of the Company the power to execute any docu-

mentation in the name and on behalf of the Company and to do all such acts and execute all such documents, certificates
and notices that may be expedient for the implementation of the decision here-above adopted.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would

be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about 1,500.- Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

20838

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le douze décembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de GALLAHER LUXEMBOURG S.à r.l., une société

établie et existant au Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 84.801, constituée conformément à l'acte du notaire Joseph Elvinger,
demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 26 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations (Mémorial C), numéro 470 en date du 25 mars 2002, tel que modifié ci-après (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été dernièrement modifiés par acte notarié en date du 12 avril 2007, publié au Mémorial

C numéro 1666 en date du 7 août 2007.

L'assemblée a été présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire et l'assemblée a choisi comme scrutateur Flora Gibert, juriste, demeurant à

Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés de la Société, à savoir (i) GALLAHER BENELUX LIMITED, une société constituée sous les lois du

Royaume Uni, ayant son siège social à Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 OQU, Angleterre et
(ii) GALLAHER LIMITED, une société constituée sous les lois du Royaume Uni, ayant son siège social à Members Hill,
Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 OQU, Angleterre, sont dûment et respectivement représentés par M. Régis
Galiotto de l'étude notariale de M. Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
suivant procurations en date des 6 et 7 décembre 2007. Le nombre de parts sociales qu'ils détiennent a été reporté sur
une liste de présence. Cette liste de présence et les procurations, signées par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 426.078 (quatre cent vingt-six mille soixante dix-huit) parts sociales, d'une

valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société d'un
montant de 10.651.950,- EUR (dix millions six cent cinquante et un mille neuf cent cinquante euros), étaient représentées,
de sorte que l'assemblée pouvait valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, et dont les associés
avaient été préalablement dûment informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la décision d'annuler la décision du 23 février 2007 relative à la migration de la Société à Guernesey;

et

3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par les associés, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est unanimement décidé que les associés renoncent à leur droit de convocation préalable à la présente assemblé

générale extraordinaire, laquelle convocation aurait dû leurs être adressée préalablement à la tenue de cette assemblée;
les associés reconnaissent être suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent être valablement convoqués à la
présente assemblée et en conséquence acceptent de délibérer et voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De
plus, il est unanimement décidé que toute la documentation présentée lors de l'assemblée a été mise à la disposition des
associés pendant un laps de temps suffisant pour leur permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution

Il est noté que, lors d'une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue le 23 février 2007 devant

le notaire instrumentant, les décisions suivantes ont été prises: (i) approbation du changement de nationalité de la Société
et de la migration du Grand-Duché de Luxembourg à Guernesey et nomination de mandataires de la Société pour l'ac-
complissement des formalités requises au Luxembourg pour la migration, (ii) la modification subséquente des statuts de
la Société et l'adoption d'un memorandum of association afin de se conformer à la Loi de Guernesey sur les Sociétés de
1994 et (iii) approbation de la démission de M. Gérard Becquer et Mme Charlotte Bastin de leurs fonctions de gérants
de la Société et de la nomination de nouveaux gérants de la Société (les «Décisions de Migration»).

Il est ensuite noté que l'effectivité des décisions ci-dessus décrites était subordonnée à l'accomplissement de la con-

dition préalable d'enregistrement de la Société au Registre des Sociétés de Guernesey (la «Condition Préalable»).

20839

Il est reporté qu'à ce jour, la Condition Préalable n'a pas été remplie et que la Société n'a plus intérêt à poursuivre la

migration.

Après pleine et attentive considération, il est unanimement décidé que les Décisions de Migration doivent être annulées

et que la Société doit donc rester et poursuivre son activité à Luxembourg comme si les Décisions de Migration n'avaient
jamais été prises.

De plus, il est unanimement décidé d'accorder à tout gérant de la Société le pouvoir d'exécuter toute documentation

au nom et pour le compte de la Société et de faire tous actes et exécuter tous documents, certificats et préavis qui
pourraient être appropriés pour la réalisation de la décision ci-dessus adoptée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ 1.500,- euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite du présent acte original au comparant, ce dernier a signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui maîtrise la langue anglaise, constate que, sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Galiotto, F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2007, Relation LAC/2007/40896. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008018241/211/150.
(080015990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Swan Investment Company, Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.

R.C.S. Luxembourg B 74.884.

La société PLAZA LUXEMBOURG S.A., avec siège social au 156, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg, inscrite au

RCS de Luxembourg sous le numéro B 74.882, nommée administrateur de la société SWAN INVESTMENT COMPANY
S.A., en date du 28 septembre 2000, a désigné Monsieur Jan Van Holsbeeck, né le 10 novembre 1965 à Alost (Belgique),
employé privé, demeurant 156, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg comme représentant permanent pour la durée
de son mandat, qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2007.

<i>SWAN INVESTMENT COMPANY S.A.
T. Meganck
<i>Administrateur Délégué

Référence de publication: 2008017924/795/19.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, réf. LSO-CM08312. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080014818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2008.

BVLUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5533 Remich, 47, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 49.059.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2008.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2008018180/5770/12.
(080016037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

20840

Gallaher Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.042.342.800,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 84.799.

In the year two thousand and seven, on the twenty-third of February,
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholder of GALLAHER INVESTMENTS LUXEMBOURG S.à r.l., a

company established and existing in Luxembourg under the form of a société à responsabilité limitée, having its registered
office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under section B, number 84.799, incorporated pursuant to a deed of Notary
Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the 26 November 2001, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), number 470 of 25 March 2003 as amended (hereafter
the «Company»).

The articles of incorporation of the Company have been lastly amended by notarial deed enacted on 24 March 2005,

published in the Mémorial C, number 1027 of 12 October 2005.

The meeting was presided by Mr Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg,
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs Flora Gibert, jurist, residing profes-

sionally in Luxembourg,

The chairman requested the notary to certify that:
I.- The shareholder was present or duly represented and the number of shares held by each of them were shown on

an attendance list. That list and proxy, initialed ne varietur and signed by the appearing persons and the notary, would
remain annexed to the minutes to be registered with them.

II.- As shown in the attendance list, the 41,693,712 (forty-one million six hundred ninety-three thousand seven hundred

twelve) shares, with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, representing the whole capital of the Company,
were represented and accordingly the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the shareholder
had been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting was as follows:

<i>Agenda:

1. Waiving of the notice right;
2. Approval of the change of the nationality of the Company and of the migration from the Grand Duchy of Luxembourg

to Guernsey and appointment of proxyholders of the Company in relation to the Luxembourg migration formalities;

3. Amendment of the articles of association of the Company and adoption of a memorandum of association in order

to comply with The Companies (Guernsey) Law, 1994 to be effective upon fulfillment of the condition precedent to the
migration of the Company to Guernsey, i.e. the registration of the Company on the Guernsey Register of Companies;

4. Approval of the resignation of Mr Gérard Becquer and Mrs Charlotte Bastin as managers of the Company and the

appointment of new managers of the Company subject to the condition precedent to the migration of the Company to
Guernsey being fulfilled; and

5. Miscellaneous.
IV.- The meeting was provided with a copy of the current articles of association of the Company;
After the foregoing was approved by the shareholder, the following resolutions were taken:

<i>First resolution

It was unanimously resolved that the shareholder waives its right to notice of the extraordinary general meeting which

should have been sent to them prior to this meeting; the shareholder acknowledges to be sufficiently informed of the
agenda and consider the meeting to be validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of
the agenda. It was resolved further that all the documentation produced to the meeting had been put at the disposal of
the shareholder within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

<i>Second resolution

It was unanimously resolved to migrate the Company from Luxembourg to Guernsey, that the Company take the

Guernsey nationality, and that the Company close its place of business in Luxembourg (the «Migration»).

It was reported that the legal personality of the Company would survive the Migration and hence the Company will

be and remain the sole and full owner of all its assets and fully liable for all its debts and liabilities following the Migration.
It was reported further that, following the Migration, the Company would take the form of a company limited by shares
under Guernsey law.

20841

The conditions and formalities to be complied with under both Luxembourg and Guernsey laws in order to proceed

with the Migration were then described to the shareholder and the latter resolved that the Migration be subject to the
condition precedent that the Company be registered on the Guernsey Register of Companies (the «Condition Prece-
dent»).

It was resolved that provided that the Condition Precedent was fulfilled, the Migration would only be effective on and

from the date of fulfillment of the Condition Precedent. The Company would be deregistered in Luxembourg following
its registration in Guernsey so as fully to become a Guernsey Company, governed only by the laws of Guernsey. It was
highlighted further that, as from the date of its registration on the Guernsey Register of Companies (i) the Company
would no longer be registered as a Luxembourg Company and hence (ii) no longer governed by Luxembourg laws.

It was resolved to appoint Ms Soledad Pascual and Mr Torsten Schmitt of Noble and Scheidecker, with professional

address at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, and Mr Régis Galiotto of Etude Notaire Elvinger, with professional
address at 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, acting with full power of substitution, acting individually in the name and
on behalf of the Company, to deregister the Company from the Luxembourg Register of Commerce and Companies.

In addition, it was resolved that further to the completion of the Migration, the registered office of the Company will

be located at Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 3BG. For the avoidance of doubt, such a change
in the place of the registered office of the Company shall not be effective unless and until the Condition Precedent is
fulfilled.

<i>Third resolution

Further to the second resolution, it was unanimously resolved to amend the articles of association of the Company

and to adopt a memorandum of association in order to comply with The Companies (Guernsey) Law, 1994 (the «Amend-
ments»).  It  was  noted  that  further  to  the  Amendments  the  Company  shall  be  named  GALLAHER  INVESTMENTS
LUXEMBOURG LIMITED. It was resolved further that the Amendments would however not be effective until and unless
the  Condition  Precedent  was  fulfilled.  For  the  avoidance  of  doubt,  should  the  Condition  Precedent  be  fulfilled,  the
Amendments would then be effective on and from the date of fulfilment of the Condition Precedent. It was resolved that,
following the Amendments, the articles of association of the Company and the memorandum of association would be
drafted in accordance with the attached schedule.

<i>Fourth resolution

It was noted that further to a letter dated 22 February 2007, Mr Gérard Becquer and Mrs Charlotte Bastin, both

residing at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg have tender their resignation from
their function of managers of the Company to be effective on and from the Condition Precedent being fulfilled (the
«Resignations»). It was unanimously resolved to approve the Resignations with effect on and from the Condition Prec-
edent being fulfilled and to grant Mr Gérard Becquer and Mrs Charlotte Bastin discharge for the performance of their
duties as from the date of their appointment as managers of the Company until the date the Condition Precedent is
fulfilled, unless any faults in the execution of their duty are identified on the basis of the financial statement corresponding
to the current financial year.

It was unanimously resolved to appoint Mr Michael John Seymour Eades and Mr Andrew Boyce, both residing at 7

New Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 4BZ as new manager(s) of the Company, to be effective on and from the
Condition Precedent being fulfilled. It was noted that by letter dated 22 February 2007, Mr Michael John Seymour Eades
and Mr Andrew Boyce have consented to act as a manager of the Company on and from the Condition Precedent being
fulfilled.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would

be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about EUR 2,500.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille sept, le vingt-trois février,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de GALLAHER INVESTMENTS LUXEMBOURG

S.à r.l., une société établie et existant au Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée, ayant son siège
social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Com-

20842

merce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 84.799, constituée conformément à l'acte du notaire
Joseph Elvinger, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 26 novembre 2001, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (Memorial C), numéro 470 en date du 25 mars 2003, tel que modifié (ci-après la
«Société»).

Les statuts de la Société ont été dernièrement modifiés par acte notarié en date du 24 mars 2005, publié au Mémorial

C, numéro 1027 en date du 12 octobre 2005.

L'assemblée a été présidée par M. Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Le président a désigné comme secrétaire et l'assemblée a choisi comme scrutateur Flora Gibert, juriste, demeurant

professionnellement à Luxembourg,

Le président a prié le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique était présent ou dûment représenté et que le nombre de parts sociales qu'il détient a été reporté

sur une liste de présence. Cette liste de présence et la procuration, paraphées ne varietur et signées par les comparants
et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 41.693.712 (quarante et un millions six cent quatre vingt-treize mille sept

cent douze) parts sociales, d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du
capital social de la Société, étaient représentées, de sorte que l'assemblée pouvait valablement se prononcer sur tous les
points portés à l'ordre du jour, et dont l' associé unique avait été préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation du changement de nationalité de la Société et du transfert du Grand-Duché de Luxembourg vers

Guernesey, et nomination de mandataires de la Société pour l'exécution des formalités luxembourgeoises de transfert;

3. Modification consécutive des statuts de la Société et adoption d'un memorandum of association afin de mettre les

documents statutaires en conformité avec «The Companies (Guernesey) Law, 1994» applicable dès lors que la condition
suspensive pour le transfert sera remplie, c'est à dire dès l'enregistrement de la Société au Registre des Sociétés de
Guernesey;

4. Approbation de la démission de M. Gérard Becquer et Mme Charlotte Bastin comme gérants de la Société et

nomination de nouveaux gérants de la Société, sous condition suspensive de la migration effective de la Société à Guer-
nesey; et

5. Divers.
IV.- Une copie des statuts en vigueur de la Société a été communiquée à l'assemblée.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé que l'associé unique renonce aux délais de convocation de l'assemblée générale extraordinaire qui devait

lui être envoyée antérieurement à cette assemblée; l'associé unique reconnaît être suffisamment informé de l'ordre du
jour et considère être valablement convoqué à la présente assemblée générale extraordinaire et vote sur tous les points
portés à l'ordre du jour. De plus, il est décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise à la
disposition de l'associé unique dans un laps de temps suffisant pour lui permettre d'examiner avec attention chaque
document.

<i>Deuxième résolution

Il a été décidé de migrer la Société du Luxembourg vers Guernesey, que la Société adopte la nationalité de Guernesey

et que la Société cesse toute activité à Luxembourg (le «Transfert»).

Il est rappelé que la personne morale de la Société survivra au Transfert et que, par voie de conséquence, la Société

sera et demeurera le seul propriétaire de tous ses actifs et sera pleinement responsable de ses dettes suite au Transfert.
De plus, il est rappelé que, suite au Transfert, la Société adoptera la forme d'une société à responsabilité limitée régie
par les lois de Guernesey.

Les conditions et les formalités à accomplir au regard des lois luxembourgeoise et de Guernesey, permettant d'opérer

le Transfert, ont été présentées à l'associé unique et ces dernier a décidé que le Transfert sera soumis à la réalisation de
la condition suspensive que la Société soit immatriculée au Registre des Sociétés de Guernesey (la «Condition Suspen-
sive»).

Il a été décidé, sous réserve que la Condition Suspensive soit remplie, que le Transfert sera effectif uniquement au

jour de réalisation de la Condition Suspensive. Suite à l'immatriculation de la Société à Guernesey, cette dernière sera
radiée du registre à Luxembourg, afin de devenir pleinement une société de Guernesey, régie exclusivement par les lois
de Guernesey. Il est de plus souligné que la Société (i) cessera d'être enregistrée comme une société de droit luxem-
bourgeois à la date de son immatriculation au Registre des Sociétés de Guernesey et par voie de conséquence, qu'elle
(ii) cessera d'être régie par les lois luxembourgeoises au jour de son immatriculation au Registre des Sociétés de Guer-
nesey.

20843

Il est décidé de nommer Mme Soledad Pascual et M. Torsten Schmitt de Noble &amp; Scheidecker, avec adresse profes-

sionnelle au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et M. Régis Galiotto de l'étude de
notaire Elvinger, avec adresse professionnelle au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
investis des pleins pouvoirs de substitution, agissant au nom et pour le compte de la Société, de demander la radiation
de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

De plus, il a été décidé que suite à l'accomplissement de la Migration, le siège social de la Société sera situé à Dorey

Court, Admiral Park, St Peter Port, GY1 3BG, Guernesey. Afin d'éviter tout doute, le changement de siège social de la
Société ne sera pas effectif tant que la Condition suspensive ne sera pas remplie.

<i>Troisième résolution

Consécutivement à l'adoption de la deuxième résolution, il a été unanimement décidé de modifier les statuts de la

Société et d'adopter un mémorandum of association afin de se mettre en conformité avec «The Companies (Guernsey)
Law, 1994» (les «Modifications»). Il est également noté qu'en vertu des Modifications la Société se dénommera GALLA-
HER INVESTMENTS LUXEMBOURG LIMITED. De plus, il a été décidé que les Modifications ne seront pas effectives
tant que la Condition Suspensive ne sera pas remplie. Pour éviter tout doute, si la Condition Suspensive se réalise, les
Modifications deviendront effectives dès la date de réalisation de la Condition Suspensive. Il est décidé que, suite aux
Modifications, les Statuts de la Société et les modifications des Statuts seront rédigés en accord avec les annexes ci-jointes.

<i>Quatrième résolution

Il est rapporté que conformément à une lettre datée du 6 février 2007, M. Gérard Becquer et Mme Charlotte Bastin,

tous deux résidants au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg, ont proposé leur
démission de leurs fonctions de gérant de la Société avec effet dès la date de réalisation de la Condition Suspensive (les
«Démissions»). Il est également unanimement décidé d'approuver les Démissions avec effet dès la date de réalisation de
la Condition Suspensive et d'accorder décharge à M. Gérard Becquer et Mme Charlotte Bastin pour l'exercice de leur
mandat à compter de la date de leur nomination comme gérant de la Société jusqu'à la date de réalisation de la Condition
Suspensive, à moins que les états comptables annuels de l'exercice social en cours ne mettent en évidence des fautes de
gestion.

Il est unanimement décidé de nommer M. Michael John Seymour Eades et M. Andrew Boyce, résidants au 7, New

Street, St Peter Port, Guernesey, GY1 4BZ comme nouveau gérant de la Société à compter de la date de réalisation de
la Condition Suspensive. Il est noté que M. Michael John Seymour Eades et M. Andrew Boyce ont, par lettre datée du 22
février 2007, accepté le mandat de gérant de la Société à compter de la date de réalisation de la Condition Suspensive.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ 2.500,- Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite du présent acte original aux membres du bureau, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Galiotto, F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, Relation LAC/2007/808. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme à l'original, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008018238/211/213.
(080016002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Gallaher Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.042.342.800,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 84.799.

In the year two thousand and seven, on the twelfth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of GALLAHER INVESTMENTS LUXEMBOURG S.à r.l.,

a company established and existing in Luxembourg under the form of a «société à responsabilité limitée», having its
registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Lux-

20844

embourg Trade and Companies Register under section B number 84.799, incorporated pursuant to a deed of Notary
Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the 26 November 2001, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), number 470 of 25 March 2002 as amended (hereafter
the «Company»).

The articles of association of the Company have been lastly amended by notarial deed enacted on 12 April 2007,

published in the Memorial C, number 1760 of 21 August 2007.

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders of the Company, namely (i) GALLAHER BENELUX LIMITED, a company incorporated under the

laws of England and Wales, having its registered office at Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 OQU,
England and (ii) GALLAHER LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered
office at Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey, KT13 OQU, England, are both respectively duly represented
by Mr Régis Galiotto from the notary office of Mr Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, pursuant to powers of attorney dated 6th, and 7th, December 2007. The number of shares held by the
shareholders is shown on an attendance list. That list and the powers of attorney, signed by the appearing persons and
the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As it appears from the attendance list, the 41,693,712 (forty-one million six hundred ninety-three thousand seven

hundred twelve) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, representing the entire share capital
of EUR 1,042,342,800.- (one billion forty-two million three hundred forty-two thousand eight hundred Euro) of the
Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders
state having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Waiving of the notice right;
2. Approval of the decision to revoke the decision of 23 February 2007 regarding the migration of the Company to

Guernsey; and

3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It was unanimously resolved that the shareholders waive their right to the prior notice of the current extraordinary

general meeting, which should have been sent to them prior to this meeting; the shareholders acknowledge being suffi-
ciently informed on the agenda and consider the meeting being validly convened and therefore agree to deliberate and
vote upon all the items of the agenda. It was unanimously resolved further that all the documentation produced to the
meeting had been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to
examine carefully each document.

<i>Second resolution

It was noted that, in an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on 23 February 2007

in front of the undersigned notary, the following decisions were taken: (i) approval of the change of the nationality of the
Company and of the migration from the Grand Duchy of Luxembourg to Guernsey and appointment of proxy-holders
of the Company in relation to the Luxembourg migration formalities, (ii) consequently amendment of the articles of
association of the Company and adoption of a memorandum of association in order to comply with The Companies
(Guernsey) Law, 1994 and (iii) approval of the resignation of Mr Gérard Becquer and Ms Charlotte Bastin as managers
of the Company and the appointment of new managers of the Company (the «Migration Decisions»).

It was further noted that the effectiveness of the decisions described above were subject to the fulfilment of the

condition precedent of the registration of the Company at the Guernsey Register of Companies (the «Condition Prec-
edent»).

It was reported that to date, the Condition Precedent has not been fulfilled and that the Company is not any more

interested in proceeding to the migration.

After due and careful consideration, it was unanimously resolved that the Migration Decisions be revoked and that

therefore the Company shall remain and continue its business in Luxembourg as if no Migration Decisions had ever been
taken.

In addition, it was unanimously resolved to grant to any manager of the Company the power to execute any docu-

mentation in the name and on behalf of the Company and to do all such acts and execute all such documents, certificates
and notices that may be expedient for the implementation of the decision here-above adopted.

20845

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would

be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about 1,500.- Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le douze décembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de GALLAHER INVESTMENTS LUXEMBOURG S.à

r.l., une société établie et existant au Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée, ayant son siège
social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 84.799, constituée conformément à l'acte du notaire
Joseph Elvinger, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 26 novembre 2001, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), numéro 470 en date du 25 mars 2002, tel que modifié ci-après (la
«Société»).

Les statuts de la Société ont été dernièrement modifiés par acte notarié en date du 12 avril 2007, publié au Mémorial

C numéro 1760 en date du 21 août 2007.

L'assemblée a été présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Le président a désigné comme secrétaire et l'assemblée a choisi comme scrutateur Flora Gibert, juriste, demeurant à

Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés de la Société, à savoir (i) GALLAHER BENELUX LIMITED, une société constituée sous les lois du

Royaume Uni, ayant son siège social à Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 OQU, Angleterre et
(ii) GALLAHER LIMITED, une société constituée sous les lois du Royaume Uni, ayant son siège social à Members Hill,
Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 OQU, Angleterre, sont dûment et respectivement représentés par M. Régis
Galiotto de l'étude notariale de M. Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
suivant procurations en date des 6 et 7 décembre 2007. Le nombre de parts sociales qu'ils détiennent a été reporté sur
une liste de présence. Cette liste de présence et les procurations, signées par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 41.693.712 (quarante et un millions six cent quatre-vingt-treize mille sept

cent douze) parts sociales, d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du
capital social de la Société d'un montant de 1.042.342.800,- EUR (un milliard quarante-deux millions trois cent quarante-
deux mille huit cents euros), étaient représentées, de sorte que l'assemblée pouvait valablement se prononcer sur tous
les points portés à l'ordre du jour, et dont les associés avaient été préalablement dûment informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la décision d'annuler la décision du 23 février 2007 relative à la migration de la Société à Guernesey;

et

3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par les associés, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est unanimement décidé que les associés renoncent à leur droit de convocation préalable à la présente assemblé

générale extraordinaire, laquelle convocation aurait dû leurs être adressée préalablement à la tenue de cette assemblée;
les associés reconnaissent être suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent être valablement convoqués à la
présente assemblée et en conséquence acceptent de délibérer et voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De
plus, il est unanimement décidé que toute la documentation présentée lors de l'assemblée a été mise à la disposition des
associés pendant un laps de temps suffisant pour leur permettre un examen attentif de chaque document.

20846

<i>Deuxième résolution

Il est noté que, lors d'une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue le 23 février 2007 devant

le notaire instrumentant, les décisions suivantes ont été prises: (i) approbation du changement de nationalité de la Société
et de la migration du Grand-Duché de Luxembourg à Guernesey et nomination de mandataires de la Société pour l'ac-
complissement des formalités requises au Luxembourg pour la migration, (ii) la modification subséquente des statuts de
la Société et l'adoption d'un memorandum of association afin de se conformer à la Loi de Guernesey sur les Sociétés de
1994 et (iii) approbation de la démission de M. Gérard Becquer et Mme Charlotte Bastin de leurs fonctions de gérants
de la Société et de la nomination de nouveaux gérants de la Société (les «Décisions de Migration»).

Il est ensuite noté que l'effectivité des décisions ci-dessus décrites était subordonnée à l'accomplissement de la con-

dition préalable d'enregistrement de la Société au Registre des Sociétés de Guernesey (la «Condition Préalable»).

Il est reporté qu'à ce jour, la Condition Préalable n'a pas été remplie et que la Société n'a plus intérêt à poursuivre la

migration.

Après pleine et attentive considération, il est unanimement décidé que les Décisions de Migration doivent être annulées

et que la Société doit donc rester et poursuivre son activité à Luxembourg comme si les Décisions de Migration n'avaient
jamais été prises.

De plus, il est unanimement décidé d'accorder à tout gérant de la Société le pouvoir d'exécuter toute documentation

au nom et pour le compte de la Société et de faire tous actes et exécuter tous documents, certificats et préavis qui
pourraient être appropriés pour la réalisation de la décision ci-dessus adoptée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ 1.500,- euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite du présent acte original au comparant, ce dernier a signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui maîtrise la langue anglaise, constate que, sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Galiotto, F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2007, Relation LAC/2007/40872. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008018239/211/153.
(080016004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Gallaher Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 60.964.275,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 84.800.

In the year two thousand and seven, on the twenty-third of February,
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is  held  an  extraordinary  general  meeting  of  the  shareholder  of  GALLAHER  FINANCE  LUXEMBOURG  S.à  r.l.,  a

company established and existing in Luxembourg under the form of a société à responsabilité limitée, having its registered
office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under section B, number 84.800, incorporated pursuant to a deed of Notary
Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the 26 November 2001, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), number 469 of 25 March 2003 as amended (hereafter
the «Company»).

The articles of incorporation of the Company have been lastly amended by notarial deed enacted on 24 March 2005,

published in the Mémorial C, number 989 of 5 October 2005.

The meeting was presided by Mr Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg,
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs Flora Gibert, jurist, residing in Lux-

embourg,

The chairman requested the notary to certify that:

20847

I.- The shareholder was present or duly represented and the number of shares held by each of them were shown on

an attendance list. That list and proxy, initialed ne varietur and signed by the appearing persons and the notary, would
remain annexed to the minutes to be registered with them.

II.- As shown in the attendance list, the 2,438,571 (two million four hundred thirty-eight thousand five hundred seventy-

one) shares, with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, representing the whole capital of the Company,
were represented and accordingly the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the shareholder
had been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting was as follows:

<i>Agenda:

1. Waiving of the notice right;
2. Approval of the change of the nationality of the Company and of the migration from the Grand Duchy of Luxembourg

to Guernsey and appointment of proxyholders of the Company in relation to the Luxembourg migration formalities;

3. Amendment of the articles of association of the Company and adoption of a memorandum of association in order

to comply with The Companies (Guernsey) Law, 1994 to be effective upon fulfillment of the condition precedent to the
migration of the Company to Guernsey, i.e. the registration of the Company on the Guernsey Register of Companies;

4. Approval of the resignation of Mr Gérard Becquer and Mrs Charlotte Bastin as managers of the Company and the

appointment of new managers of the Company subject to the condition precedent to the migration of the Company to
Guernsey being fulfilled; and

5. Miscellaneous.
IV.- The meeting was provided with a copy of the current articles of association of the Company;
After the foregoing was approved by the shareholder, the following resolutions were taken:

<i>First resolution

It was resolved that the shareholder waives its right to notice of the extraordinary general meeting which should have

been sent to them prior to this meeting; the shareholder acknowledges to be sufficiently informed of the agenda and
consider the meeting to be validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda.
It was resolved further that all the documentation produced to the meeting had been put at the disposal of the shareholder
within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

<i>Second resolution

It was resolved to migrate the Company from Luxembourg to Guernsey, that the Company take the Guernsey na-

tionality, and that the Company close its place of business in Luxembourg (the «Migration»).

It was reported that the legal personality of the Company would survive the Migration and hence the Company will

be and remain the sole and full owner of all its assets and fully liable for all its debts and liabilities following the Migration.
It was reported further that, following the Migration, the Company would take the form of a company limited by shares
under Guernsey law.

The conditions and formalities to be complied with under both Luxembourg and Guernsey laws in order to proceed

with the Migration were then described to the shareholder and the latter resolved that the Migration be subject to the
condition precedent that the Company be registered on the Guernsey Register of Companies (the «Condition Prece-
dent»).

It was resolved that provided that the Condition Precedent was fulfilled, the Migration would only be effective on and

from the date of fulfillment of the Condition Precedent. The Company would be deregistered in Luxembourg following
its registration in Guernsey so as fully to become a Guernsey Company, governed only by the laws of Guernsey. It was
highlighted further that, as from the date of its registration on the Guernsey Register of Companies (i) the Company
would no longer be registered as a Luxembourg Company and hence (ii) no longer governed by Luxembourg laws.

It was resolved to appoint Ms Soledad Pascual and Mr Torsten Schmitt of Noble and Scheidecker, with professional

address at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, and Mr Régis Galiotto of Etude Notaire Elvinger, with professional
address at 15, côte d'Eich, L-1450, acting with full power of substitution, acting individually in the name and on behalf of
the Company, to deregister the Company from the Luxembourg Register of Commerce and Companies.

In addition, it was resolved that further to the completion of the Migration, the registered office of the Company will

be located at Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 3BG, Guernsey. For the avoidance of doubt,
such a change in the place of the registered office of the Company shall not be effective unless and until the Condition
Precedent is fulfilled.

<i>Third resolution

Further to the second resolution, it was resolved to amend the articles of association of the Company and to adopt

a memorandum of association in order to comply with The Companies (Guernsey) Law, 1994 (the «Amendments»). It
was noted that further to the Amendments the Company shall be named GALLAHER HOLDINGS LUXEMBOURG
LIMITED. It was resolved further that the Amendments would however not be effective until and unless the Condition
Precedent was fulfilled. For the avoidance of doubt, should the Condition Precedent be fulfilled, the Amendments would

20848

then be effective on and from the date of fulfilment of the Condition Precedent. It was resolved that, following the
Amendments, the articles of association of the Company and the memorandum of association would be drafted in ac-
cordance with the attached schedule.

<i>Fourth resolution

It was noted that further to a letter dated 22 February 2007, Mr Gérard Becquer and Mrs Charlotte Bastin, both

residing at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, have tender their resignation from
their function of managers of the Company to be effective on and from the Condition Precedent being fulfilled (the
«Resignations»). It was resolved to approve the Resignations with effect on and from the Condition Precedent being
fulfilled and to grant Mr Gérard Becquer and Mrs Charlotte Bastin discharge for the performance of their duties as from
the date of their appointment as managers of the Company until the date the Condition Precedent is fulfilled, unless any
faults in the execution of their duty are identified on the basis of the financial statement corresponding to the current
financial year.

It was unanimously resolved to appoint Mr Michael John Seymour Eades and Mr Andrew Boyce, both residing at 7

New Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 4BZ as new manager(s) of the Company, to be effective on and from the
Condition Precedent being fulfilled. It was noted that by letter dated 22 February 2007, Mr Michael John Seymour Eades
and Mr Andrew Boyce have consented to act as a manager of the Company on and from the Condition Precedent being
fulfilled.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would

be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about EUR 2,500.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille sept, le vingt-trois février,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG S.à

r.l., une société établie et existant au Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée, ayant son siège
social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 84.800, constituée conformément à l'acte du notaire
Joseph Elvinger, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 26 novembre 2001, publié au Mémorial C,
recueil des Sociétés et Associations (Memorial C), numéro 469 en date du 25 mars 2003, tel que modifié (ci-après la
«Société»).

Les statuts de la Société ont été dernièrement modifiés par acte notarié en date du 24 mars 2005, publié au Mémorial

C, numéro 989 en date du 5 octobre 2005.

L'assemblée a été présidée par M. Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Le président a désigné comme secrétaire et l'assemblée a choisi comme scrutateur Flora Gibert, juriste, demeurant à

Luxembourg.

Le président a prié le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique était présent ou dûment représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient a été reporté sur

une liste de présence. Cette liste de présence et la procuration, paraphées ne varietur et signées par les comparants et
le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.438.571 (deux millions quatre cent trente-huit mille cinq cent soixante

et onze) parts sociales, d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital
social de la Société, étaient représentées, de sorte que l'assemblée pouvait valablement se prononcer sur tous les points
portés à l'ordre du jour, et dont l' associé unique avait été préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation du changement de nationalité de la Société et du transfert du Grand-Duché de Luxembourg vers

Guernesey, et nomination de mandataires de la Société pour l'exécution des formalités luxembourgeoises de transfert;

20849

3. Modification des statuts de la Société et adoption d'un memorandum of association afin de mettre les documents

statutaires en conformité avec «The Companies (Guernesey) Law, 1994» applicable dès lors que la condition suspensive
pour le transfert sera remplie, c'est à dire dès l'enregistrement de la Société au Registre des Sociétés de Guernesey;

4. Approbation de la démission de M. Gérard Becquer et Mme Charlotte Bastin comme gérants de la Société et

nomination de nouveaux gérants de la Société, sous condition suspensive de la migration effective de la Société à Guer-
nesey; et

5. Divers.
IV.- Une copie des statuts en vigueur de la Société a été communiquée à l'assemblée.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique présent, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé que l'associé unique renonce aux délais de convocation de l'assemblée générale extraordinaire qui devait

lui être envoyée antérieurement à cette assemblée; l'associé unique reconnaît être suffisamment informé de l'ordre du
jour et considère être valablement convoqué à la présente assemblée et vote sur tous les points portés à l'ordre du jour.
De plus, il est décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition de l'associé
unique dans un laps de temps suffisant pour lui permettre d'examiner avec attention chaque document.

<i>Deuxième résolution

Il a été décidé de migrer la Société du Luxembourg vers Guernesey, que la Société adopte la nationalité de Guernesey

et que la Société cesse toute activité à Luxembourg (le «Transfert»).

Il est rappelé que la personne morale de la Société survivra au Transfert et que, par voie de conséquence, la Société

sera et demeurera le seul propriétaire de tous ses actifs et sera pleinement responsable de ses dettes suite au Transfert.
De plus, il est rappelé que, suite au Transfert, la Société adoptera la forme d'une société à responsabilité limitée régie
par les lois de Guernesey.

Les conditions et les formalités à accomplir au regard des lois luxembourgeoise et de Guernesey, permettant d'opérer

le Transfert, ont été présentées à l'associé unique et ce dernier a décidé que le Transfert sera soumis à la réalisation de
la condition suspensive que la Société soit immatriculée au Registre des Sociétés de Guernesey (la «Condition Suspen-
sive»).

Il a été décidé, sous réserve que la Condition Suspensive soit remplie, que le Transfert sera effectif uniquement au

jour de réalisation de la Condition Suspensive. Suite à l'immatriculation de la Société à Guernesey, cette dernière sera
radiée du registre à Luxembourg, afin de devenir pleinement une société de Guernesey, régie exclusivement par les lois
de Guernesey. Il est de plus souligné que la Société (i) cessera d'être enregistrée comme une société de droit luxem-
bourgeois à la date de son immatriculation au Registre des Sociétés de Guernesey et par voie de conséquence, qu'elle
(ii) cessera d'être régie par les lois luxembourgeoises au jour de son immatriculation au Registre des Sociétés de Guer-
nesey.

Il est décidé de nommer Mme Soledad Pascual et M. Torsten Schmitt de Noble &amp; Scheidecker, avec adresse profes-

sionnelle au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et M. Régis Galiotto de l'étude de
notaire Elvinger, avec adresse professionnelle au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
investis des pleins pouvoirs de substitution, agissant au nom et pour le compte de la Société, de demander la radiation
de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

De plus, il a été décidé que suite à l'accomplissement du transfert, le siège social de la Société sera situé à Dorey Court,

Admiral Park, St Peter Port, GY1 3BG, Guernesey. Afin d'éviter tout doute, le changement de siège social de la Société
ne sera pas effectif tant que la Condition suspensive ne sera pas remplie.

<i>Troisième résolution

Consécutivement à l'adoption de la deuxième résolution, il a été décidé de modifier les statuts de la Société et d'adopter

un  mémorandum  of  association  afin  de  se  mettre  en  conformité  avec  «The  Companies  (Guernsey)  Law,  1994»  (les
«Modifications»). Il est également noté qu'en vertu des Modifications la Société se dénommera GALLAHER HOLDINGS
LUXEMBOURG LIMITED. De plus, il a été décidé que les Modifications ne seront pas effectives tant que la Condition
Suspensive ne sera pas remplie. Pour éviter tout doute, si la Condition Suspensive se réalise, les Modifications deviendront
effectives dès la date de réalisation de la Condition Suspensive. Il est décidé que, suite aux Modifications, les Statuts de
la Société et les modifications des statuts seront rédigés en accord avec les annexes ci-jointes.

<i>Quatrième résolution

Il est rapporté que conformément à une lettre datée du vingt-deux février 2007, M. Gérard Becquer et Mme Charlotte

Bastin, tous deux résidants au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ont proposé
leur démission de leurs fonctions de gérant de la Société avec effet dès la date de réalisation de la Condition Suspensive
(les «Démissions»). Il est également unanimement décidé d'approuver la Démission avec effet dès la date de réalisation
de la Condition Suspensive et d'accorder décharge à M. Gérard Becquer et Mme Charlotte Bastin pour l'exercice de leur
mandat à compter de la date de leur nomination comme gérant de la Société jusqu'à la date de réalisation de la Condition
Suspensive, à moins que les états comptables annuels de l'exercice social en cours ne mettent en évidence des fautes de
gestion.

20850

Il est unanimement décidé de nommer M. Michael John Seymour Eades et M. Andrew Boyce, résidants au 7, New

Street, St Peter Port, Guernesey, GY1 4BZ comme nouveau gérant de la Société à compter de la date de réalisation de
la Condition Suspensive. Il est noté que M. Michael John Seymour Eades et M. Andrew Boyce ont, par lettre datée du 22
février 2007, accepté le mandat de gérant de la Société à compter de la date de réalisation de la Condition Suspensive.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ 2.500,- euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite du présent acte original aux membres du bureau, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Galiotto, F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, Relation LAC/2007/810. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour copie conforme à l'original, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008018243/211/211.
(080016007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Gallaher Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 60.964.275,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 84.800.

In the year two thousand and seven, on the twelfth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG S.à r.l., a

company established and existing in Luxembourg under the form of a «société à responsabilité limitée», having its regis-
tered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under section B number 84.800, incorporated pursuant to a deed of Notary Joseph
Elvinger, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the 26 November 2001, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), number 469 of 25 March 2002 as amended (hereafter the «Com-
pany»).

The articles of association of the Company have been lastly amended by notarial deed enacted on 12 April 2007,

published in the Memorial C, number 1714 of 13 August 2007.

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders of the Company, namely (i) GALLAHER BENELUX LIMITED, a company incorporated under the

laws of England and Wales, having its registered office at Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 OQU,
England and (ii) GALLAHER LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered
office at Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey, KT13 OQU, England, are both respectively duly represented
by Mr Régis Galiotto from the notary office of Mr Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, pursuant to powers of attorney dated 6th, and 7th, December 2007. The number of shares held by the
shareholders is shown on an attendance list. That list and the powers of attorney, signed by the appearing persons and
the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As it appears from the attendance list, the 2,438,571 (two million four hundred thirty-eight thousand five hundred

seventy-one) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, representing the entire share capital of
EUR 60,964,275.- (sixty million nine hundred sixty-four thousand two hundred seventy-five Euro) of the Company, are
represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders state having
been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

20851

<i>Agenda:

1. Waiving of the notice right;
2. Approval of the decision to revoke the decision of 23 February 2007 regarding the migration of the Company to

Guernsey; and

3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It was unanimously resolved that the shareholders waive their right to the prior notice of the current extraordinary

general meeting, which should have been sent to them prior to this meeting; the shareholders acknowledge being suffi-
ciently informed on the agenda and consider the meeting being validly convened and therefore agree to deliberate and
vote upon all the items of the agenda. It was unanimously resolved further that all the documentation produced to the
meeting had been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to
examine carefully each document.

<i>Second resolution

It was noted that, in an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on 23 February 2007

in front of the undersigned notary, the following decisions were taken: (i) approval of the change of the nationality of the
Company and of the migration from the Grand Duchy of Luxembourg to Guernsey and appointment of proxy-holders
of the Company in relation to the Luxembourg migration formalities, (ii) consequently amendment of the articles of
association of the Company and adoption of a memorandum of association in order to comply with The Companies
(Guernsey) Law, 1994 and (iii) approval of the resignation of Mr. Gérard Becquer and Ms Charlotte Bastin as managers
of the Company and the appointment of new managers of the Company (the «Migration Decisions»).

It was further noted that the effectiveness of the decisions described above were subject to the fulfilment of the

condition precedent of the registration of the Company at the Guernsey Register of Companies (the «Condition Prec-
edent»).

It was reported that to date, the Condition Precedent has not been fulfilled and that the Company is not any more

interested in proceeding to the migration.

After due and careful consideration, it was unanimously resolved that the Migration Decisions be revoked and that

therefore the Company shall remain and continue its business in Luxembourg as if no Migration Decisions had ever been
taken.

In addition, it was unanimously resolved to grant to any manager of the Company the power to execute any docu-

mentation in the name and on behalf of the Company and to do all such acts and execute all such documents, certificates
and notices that may be expedient for the implementation of the decision here-above adopted.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would

be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about 1,500.- Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le douze décembre,
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG S.à r.l., une

société établie et existant au Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 84.800, constituée conformément à l'acte du notaire Joseph
Elvinger, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 26 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (Mémorial C), numéro 469 en date du 25 mars 2002, tel que modifié ci-après (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été dernièrement modifiés par acte notarié en date du 12 avril 2007, publié au Mémorial

C numéro 1714 en date du 13 août 2007.

L'assemblée a été présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

20852

Le président a désigné comme secrétaire et l'assemblée a choisi comme scrutateur Flora Gibert, juriste, demeurant à

Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés de la Société, à savoir (i) GALLAHER BENELUX LIMITED, une société constituée sous les lois du

Royaume Uni, ayant son siège social à Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 OQU, Angleterre et
(ii) GALLAHER LIMITED, une société constituée sous les lois du Royaume Uni, ayant son siège social à Members Hill,
Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 OQU, Angleterre, sont dûment et respectivement représentés par M. Régis
Galiotto de l'étude notariale de M. Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
suivant procurations en date des 6 et 7 décembre 2007. Le nombre de parts sociales qu'ils détiennent a été reporté sur
une liste de présence. Cette liste de présence et les procurations, signées par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.438.571 (deux millions quatre cent trente-huit mille cinq cent soixante

et onze) parts sociales, d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital
social  de  la  Société  d'un  montant  de  60.964.275,-  EUR  (soixante  millions  neuf  cent  soixante-quatre  mille  deux  cent
soixante-quinze euros), étaient représentées, de sorte que l'assemblée pouvait valablement se prononcer sur tous les
points portés à l'ordre du jour, et dont les associés avaient été préalablement dûment informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la décision d'annuler la décision du 23 février 2007 relative à la migration de la Société à Guernesey;

et

3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par les associés, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est unanimement décidé que les associés renoncent à leur droit de convocation préalable à la présente assemblé

générale extraordinaire, laquelle convocation aurait dû leurs être adressée préalablement à la tenue de cette assemblée;
les associés reconnaissent être suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent être valablement convoqués à la
présente assemblée et en conséquence acceptent de délibérer et voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De
plus, il est unanimement décidé que toute la documentation présentée lors de l'assemblée a été mise à la disposition des
associés pendant un laps de temps suffisant pour leur permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution

Il est noté que, lors d'une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue le 23 février 2007 devant

le notaire instrumentant, les décisions suivantes ont été prises: (i) approbation du changement de nationalité de la Société
et de la migration du Grand-Duché de Luxembourg à Guernesey et nomination de mandataires de la Société pour l'ac-
complissement des formalités requises au Luxembourg pour la migration, (ii) la modification subséquente des statuts de
la Société et l'adoption d'un memorandum of association afin de se conformer à la Loi de Guernesey sur les Sociétés de
1994 et (iii) approbation de la démission de M. Gérard Becquer et Mme Charlotte Bastin de leurs fonctions de gérants
de la Société et de la nomination de nouveaux gérants de la Société (les «Décisions de Migration»).

Il est ensuite noté que l'effectivité des décisions ci-dessus décrites était subordonnée à l'accomplissement de la con-

dition préalable d'enregistrement de la Société au Registre des Sociétés de Guernesey (la «Condition Préalable»).

Il est reporté qu'à ce jour, la Condition Préalable n'a pas été remplie et que la Société n'a plus intérêt à poursuivre la

migration.

Après pleine et attentive considération, il est unanimement décidé que les Décisions de Migration doivent être annulées

et que la Société doit donc rester et poursuivre son activité à Luxembourg comme si les Décisions de Migration n'avaient
jamais été prises.

De plus, il est unanimement décidé d'accorder à tout gérant de la Société le pouvoir d'exécuter toute documentation

au nom et pour le compte de la Société et de faire tous actes et exécuter tous documents, certificats et préavis qui
pourraient être appropriés pour la réalisation de la décision ci-dessus adoptée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ 1.500,- euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite du présent acte original au comparant, ce dernier a signé avec le notaire le présent acte.

20853

Le notaire soussigné qui maîtrise la langue anglaise, constate que, sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Galiotto, F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2007, Relation LAC/2007/40900. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008018244/211/152.
(080016008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

ColBiSpazio Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.900,00.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 115.564.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

V. Réveilliez
<i>Responsable Juridique
Habilitée par la Gérance

Référence de publication: 2008013525/4025/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04124. - Reçu 42 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

Esculape S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Am Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 67.296.

Constituée par-devant M 

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 novembre 1998, acte publié

au Mémorial C n° 83 du 10 février 1999.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ESCULAPE S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Référence de publication: 2008008073/1261/18.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07698. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080003433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

IEE Holding 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 134.858.

In the year two thousand eight, on the sixteenth day of January.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the société anonyme IEE HOLDING 2 S.A., a

company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Zone Industrielle,
L-6468 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 14
December 2007, not yet published in the Mémorial C and registered with the Luxembourg Register of Commerce and

20854

Companies under number B 134.858 (the «Company»). The articles of incorporation of the Company have not yet been
amended.

The meeting is declared open at 08.10 a.m. with Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Ms Jennifer Ferrand, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Eric Cadilhac, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1 To hear and to approve a report of the sole director of the Company and a report of the independent auditor on

the contribution in kind for the proposed capital increase.

2 To increase the corporate capital by an amount of five hundred twenty-six thousand eight hundred seventy Euro

(EUR 526,870.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to five hundred
fifty-seven thousand eight hundred seventy Euro (EUR 557,870.-).

3 To issue two hundred sixty-three thousand four hundred thirty-five (263,435) new shares with a nominal value of

two Euro (EUR 2.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

4 To accept the subscription for the new shares by CAPTOR S.A., CAPTOLIA, AUDIOCOM S.A., BIP VENTURE

PARTNERS S.A., SICAR, ING BELGIUM S.A., HUTTON COLLINS MEZZANINE PARTNERS L.P., CAPZANINE FCPR
and WestLB AG, London Branch respectively and to accept payment in full for such new shares, including the payment
of a share premium in an aggregate amount of eighty-one million two hundred forty-eight thousand six hundred twenty-
two Euro and seventy cents (EUR 81,248,622.70), by a contribution in cash or in kind consisting of their shares in IEE
INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A.

5 To restate the authorised capital so as to set it at one million two hundred sixty-five thousand five hundred Euro

(EUR 1,265,500.-) divided into six hundred thirty-two thousand fifty (632,750) shares and to set the conditions for the
use of such authorised share capital with the right to cancel or limit any preferential subscription right.

6 To amend article 5 of the articles of incorporation in order to reflect the capital increase.
7 To amend article 7 of the articles of incorporation in order to reflect the restatement of the authorised capital.
8 Statutory elections.
9 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of represented shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxyholders
of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at
the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the proxyholders and by the board of

the meeting will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being represented at the present meeting and all the shareholders present or

represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

(v) That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the

agenda.

Then the general meeting of shareholders adopted unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolved to hear and to approve the report of the sole director of the Company

dated 15 January 2008 for the proposed capital increase and a report of the independent auditor on the contribution in
kind for the proposed capital increase drawn up by Mr Jean-Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, 67, rue Michel Welter,
L-2730 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Independent Auditor»), on 16 January 2008 wherein the shares
of IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A. so contributed are described and valued (the «Con-
tribution in kind Report»).

The conclusions of the Contribution in kind Report read as follows:
«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe

that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 263,431 shares
of nominal value of EUR 2.- each, to be issued with a total related share premium of EUR 81,247,389.02, representing a
total consideration amounting to EUR 81,774,251.02.»

The Contribution in kind Report, signed ne varietur by the attorney-in-fact and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

20855

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolved to increase the corporate capital by an amount of five hundred twenty-

six thousand eight hundred seventy Euro (EUR 526,870.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand
Euro (EUR 31,000.-) to five hundred fifty-seven thousand eight hundred seventy Euro (EUR 557,870.-).

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolved to issue two hundred sixty-three thousand four hundred thirty-five

(263,435) new shares with a nominal value of two Euro (EUR 2.-) per share, having the same rights and privileges as the
existing shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon has appeared CAPTOR S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

with registered office at Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101.668 (the «First Subscriber»),

represented by Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of the proxy given on 15 January

2008,

and has declared to subscribe for one hundred sixty-nine thousand two hundred sixty-six (169,266) new shares with

a nominal value of two Euro (EUR 2.-) and to make payment in full for such new shares, together with an aggregate share
premium on all shares taken together in an amount of fifty-two million two hundred five thousand nineteen Euro and
seventy-two cents (EUR 52,205,019.72), by a contribution in kind consisting of ninety-six thousand nine hundred forty-
nine (96,949) shares in IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A., a société anonyme governed by
the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand Duchy
of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101.661
(the «First Contribution»).

The First Contribution represents consequently a value in an aggregate amount of fifty-two million five hundred forty-

three thousand five hundred fifty-one Euro and seventy-two cents (EUR 52,543,551.72).

The First Subscriber, acting trough its duly appointed attorney in fact, declared that there subsist no impediments to

the free transferability of this First Contribution to the Company and that valid instructions have been given to undertake
all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the First Contribution to the
Company.

Proof of the ownership by the First Subscriber of the First Contribution has been given to the undersigned notary.
Thereupon, the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the First

Contribution and to allot the one hundred sixty-nine thousand two hundred sixty-six (169,266) new shares to the First
Subscriber.

<i>Subscription - Payment

Thereupon has appeared CAPTOLIA, a société civile governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having

its registered office at Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Lux-
embourg Register of Commerce and Companies under number E 396 (the «Second Subscriber»),

represented by Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of the proxy given on 15 January

2008,

and has declared to subscribe for thirty thousand (30,000) new shares with a nominal value of two Euro (EUR 2.-) and

to make payment in full for such new shares, together with an aggregate share premium on all shares taken together in
an amount of nine million two hundred fifty-two thousand six hundred Euro (EUR 9,252,600.-), by a contribution in kind
consisting of seventeen thousand one hundred eighty-three (17,183) shares in IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp;
ENGINEERING S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office
at Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 101.661 (the «Second Contribution»).

The Second Contribution represents consequently a value in an aggregate amount of nine million three hundred twelve

thousand six hundred Euro (EUR 9,312,600.-).

The Second Subscriber, acting trough its duly appointed attorney in fact, declared that there subsist no impediments

to the free transferability of this Second Contribution to the Company and that valid instructions have been given to
undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Second Con-
tribution to the Company.

Proof of the ownership by the Second Subscriber of the Second Contribution has been given to the undersigned notary.
Thereupon, the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the Second

Contribution and to allot the thirty thousand (30,000) new shares to the Second Subscriber.

20856

<i>Subscription - Payment

Thereupon has appeared AUDIOCOM S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-

bourg, having its registered office at 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 51.390 (the «Third Subscriber»),

represented by Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of the proxy given on 15 January

2008,

and has declared to subscribe for twenty-five thousand three hundred sixty-seven (25,367) new shares with a nominal

value of two Euro (EUR 2.-) and to make payment in full for such new shares, together with an aggregate share premium
on all shares taken together in an amount of seven million eight hundred twenty-three thousand six hundred ninety Euro
and fourteen cents (EUR 7,823,690.14), as follows:

1) as to one (1) newly subscribed share, by a contribution in cash in an aggregate amount of three hundred ten Euro

and forty-two cents (EUR 310.42) (the «Third Cash Contribution»), and

2) as to the remainder of the newly subscribed shares, by a contribution in kind consisting of fourteen thousand five

hundred twenty-nine (14,529) shares in IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A., a société ano-
nyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at Zone Industrielle, L-6468
Echternach, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 101.661, which represent a value in an aggregate amount of seven million eight hundred seventy-four
thousand one hundred thirteen Euro and seventy-two cents (EUR 7,874,113.72) (the «Third In Kind Contribution», the
Third Cash Contribution and the Third In Kind Contribution being referred to as the «Third Contribution»).

The Third Contribution represents consequently a value in an aggregate amount of seven million eight hundred seventy-

four thousand four hundred twenty-four Euro and fourteen cents (EUR 7,874,424.14).

The Third Subscriber, acting trough its duly appointed attorney in fact, declared that there subsist no impediments to

the free transferability of this Third In Kind Contribution to the Company and that valid instructions have been given to
undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer thereof to the Company.

Proof of the ownership by the Third Subscriber of the Third In Kind Contribution has been given to the undersigned

notary.

Proof that the Company has the Third In Cash Contribution at its disposal was given to the undersigned notary who

expressly recorded this statement.

Thereupon, the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the Third

Contribution and to allot the twenty-five thousand three hundred sixty-seven (25,367) new shares to the Third Subscriber.

<i>Subscription - Payment

Thereupon has appeared BIP VENTURE PARTNERS S.A., SICAR, a société anonyme governed by the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 1, rue des Coquelicots, L-1356 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 114.029 (the
«Fourth Subscriber»),

represented by Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of the proxy given on 15 January

2008,

and has declared to subscribe for twenty-five thousand three hundred sixty-seven (25,367) new shares with a nominal

value of two Euro (EUR 2.-) and to make payment in full for such new shares, together with an aggregate share premium
on all shares taken together in an amount of seven million eight hundred twenty-three thousand six hundred ninety Euro
and fourteen cents (EUR 7,823,690.14), as follows:

1) as to one (1) newly subscribed share, by a contribution in cash in an aggregate amount of three hundred ten Euro

and forty-two cents (EUR 310.42) (the «Fourth Cash Contribution»), and

2) as to the remainder of the newly subscribed shares, by a contribution in kind consisting of fourteen thousand five

hundred twenty-nine (14,529) shares in IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A., a société ano-
nyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at Zone Industrielle, L-6468
Echternach, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 101.661, which represent a value in an aggregate amount of seven million eight hundred seventy-four
thousand one hundred thirteen Euro and seventy-two cents (EUR 7,874,113.72) (the «Fourth In Kind Contribution», the
Fourth Cash Contribution and the Fourth In Kind Contribution being referred to as the «Fourth Contribution»).

The Fourth Contribution represents consequently a value in an aggregate amount of seven million eight hundred

seventy-four thousand four hundred twenty-four Euro and fourteen cents (EUR 7,874,424.14).

The Fourth Subscriber, acting trough its duly appointed attorney in fact, declared that there subsist no impediments

to the free transferability of this Fourth In Kind Contribution to the Company and that valid instructions have been given
to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer thereof to the
Company.

Proof of the ownership by the Fourth Subscriber of the Fourth Contribution has been given to the undersigned notary.

20857

Proof that the Company has the Fourth In Cash Contribution at its disposal was given to the undersigned notary who

expressly recorded this statement.

Thereupon, the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the Fourth

Contribution and to allot the twenty-five thousand three hundred sixty-seven (25,367) new shares to the Fourth Sub-
scriber.

<i>Subscription - Payment

Thereupon has appeared CAPZANINE FCPR, a fonds commun de placements à risques managed by ATALANTE SAS,

a company incorporated under French law, registered with the Register of Commerce and Companies of Paris under
number 478 003 403 and with its registered office at 242, rue de Rivoli, 75001 Paris, France (the «Fifth Subscriber»),

represented by Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of the proxy given on 15 January

2008,

and has declared to subscribe for one thousand two hundred thirty-seven (1,237) new shares with a nominal value of

two Euro (EUR 2.-) and to make payment in full for such new shares, together with an aggregate share premium on all
shares taken together in an amount of three hundred eighty-one thousand five hundred fifteen Euro and fifty-four cents
(EUR 381,515.54), by a contribution in kind consisting of seven hundred nine (709) shares in IEE INTERNATIONAL
ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
with registered office at Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101.661 (the «Fifth Contribution»).

The Fifth Contribution represents consequently a value in an aggregate amount of three hundred eighty-three thousand

nine hundred eighty-nine Euro and fifty-four cents (EUR 383,989.54).

The Fifth Subscriber, acting trough its duly appointed attorney in fact, declared that there subsist no impediments to

the free transferability of this Fifth Contribution to the Company and that valid instructions have been given to undertake
all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Fifth Contribution to the
Company.

Proof of the ownership by the Fifth Subscriber of the Fifth Contribution has been given to the undersigned notary.
Thereupon, the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the Fifth

Contribution and to allot the one thousand two hundred thirty-seven (1,237) new shares to the Fifth Subscriber.

<i>Subscription - Payment

Thereupon  has  appeared  HUTTON  COLLINS  MEZZANINE  PARTNERS  L.P.,  a  limited  partnership  incorporated

under the laws of England and Wales, with its registered office at Kingsbury House, 15-17 King Street, London SW1Y
6Q, United Kingdom (the «Sixth Subscriber»),

represented by Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of the proxy given on 15 January

2008,

and has declared to subscribe for ten thousand nine hundred ninety-nine (10,999) new shares with a nominal value of

two Euro (EUR 2.-) and to make payment in full for such new shares, together with an aggregate share premium on all
shares taken together in an amount of three million three hundred ninety-two thousand three hundred eleven Euro and
fifty-eight cents (EUR 3,392,311.58), by a contribution in kind consisting of six thousand three hundred (6,300) shares in
IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office at Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101.661 (the «Sixth Contribu-
tion»).

The Sixth Contribution represents consequently a value in an aggregate amount of three million four hundred fourteen

thousand three hundred nine Euro and fifty-eight cents (EUR 3,414,309.58).

The Sixth Subscriber, acting trough its duly appointed attorney in fact, declared that there subsist no impediments to

the free transferability of this Sixth Contribution to the Company and that valid instructions have been given to undertake
all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Sixth Contribution to the
Company.

Proof of the ownership by the Sixth Subscriber of the Sixth Contribution has been given to the undersigned notary.
Thereupon, the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the Sixth

Contribution and to allot the ten thousand nine hundred ninety-nine (10,999) new shares to the Sixth Subscriber.

<i>Subscription - Payment

Thereupon has appeared ING BELGIUM S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Belgium and with

registered  office  at  24,  avenue  Marnix,  B-1000  Brussels,  Belgium  and  registered  in  Brussels  under  the  number
0403.200.393. (the «Seventh Subscriber»),

represented by Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of the proxy given on 15 January

2008,

20858

and has declared to subscribe for three hundred sixty-nine (369) new shares with a nominal value of two Euro (EUR

2.-) and to make payment in full for such new shares, together with an aggregate share premium on all shares taken
together in an amount of one hundred thirteen thousand eight hundred six Euro and ninety-eight (EUR 113,806.98), as
follows:

1) as to one (1) newly subscribed share, by a contribution in cash in an aggregate amount of three hundred ten Euro

and forty-two cents (EUR 310.42) (the «Seventh Cash Contribution»), and

2) as to the remainder of the newly subscribed shares, by a contribution in kind consisting of two hundred eleven

(211) shares in IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A., a société anonyme governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand Duchy of
Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101.661, which
represent a value in an aggregate amount of one hundred fourteen thousand two hundred thirty-four Euro and fifty-six
cents (EUR 114,234.56) (the «Seventh In Kind Contribution», the Seventh Cash Contribution and the Seventh In Kind
Contribution being referred to as the «Seventh Contribution»).

The Seventh Contribution represents consequently a value in an aggregate amount of one hundred fourteen thousand

five hundred forty-four Euro and ninety-eight cents (EUR 114,544.98).

The Seventh Subscriber, acting trough its duly appointed attorney in fact, declared that there subsist no impediments

to the free transferability of this Seventh In Kind Contribution to the Company and that valid instructions have been given
to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer thereof to the
Company.

Proof of the ownership by the Seventh Subscriber of the Seventh Contribution has been given to the undersigned

notary.

Proof that the Company has the Seventh In Cash Contribution at its disposal was given to the undersigned notary who

expressly recorded this statement.

Thereupon, the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the Seventh

Contribution and to allot the three hundred sixty-nine (369) new shares to the Seventh Subscriber.

<i>Subscription - Payment

Thereupon has appeared WestLB AG, London Branch, a company organised and existing under the laws of Germany,

acting through its London branch, registered in England under number FC 007772 and with registered office at Woolgate
Exchange, 25 Basinghall Street, London EC2V 5HA, United Kingdom (the «Eighth Subscriber»),

represented by Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of the proxy given on 15 January

2008,

and has declared to subscribe for eight hundred thirty (830) new shares with a nominal value of two Euro (EUR 2.-)

and to make payment in full for such new shares, together with an aggregate share premium on all shares taken together
in an amount of two hundred fifty-five thousand nine hundred eighty-eight Euro and sixty cents (EUR 255,988.60), as
follows:

1) as to one (1) newly subscribed share, by a contribution in cash in an aggregate amount of three hundred ten Euro

forty-two cents (EUR 310.42) (the «Eighth Cash Contribution»), and

2) as to the remainder of the newly subscribed shares, by a contribution in kind consisting of four hundred seventy-

five (475) shares in IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A., a société anonyme governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand Duchy
of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101.661,
which represent a value in an aggregate amount of two hundred fifty-seven thousand three hundred thirty-eight Euro and
eighteen cents (EUR 257,338.18) (the «Eighth In Kind Contribution», the Eighth Cash Contribution and the Eighth In Kind
Contribution being referred to as the «Eighth Contribution»).

The Eighth Contribution represents consequently a value in an aggregate amount of two hundred fifty-seven thousand

six hundred forty-eight Euro and sixty cents (EUR 257,648.60).

The Eighth Subscriber, acting trough its duly appointed attorney in fact, declared that there subsist no impediments

to the free transferability of this Eighth In Kind Contribution to the Company and that valid instructions have been given
to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer thereof to the
Company.

Proof of the ownership by the Eighth Subscriber of the Eighth Contribution has been given to the undersigned notary.
Proof that the Company has the Eighth In Cash Contribution at its disposal was given to the undersigned notary who

expressly recorded this statement.

Thereupon, the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the Eighth

Contribution and to allot the eight hundred thirty (830) new shares to the Eighth Subscriber.

20859

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolved to restate the authorised capital so as to set it at one million two hundred

sixty-five thousand five hundred Euro (EUR 1,265,500.-) divided into six hundred thirty-two thousand fifty (632,750)
shares and to set the conditions for the use of such authorised share capital as follows:

«The Board of Directors is authorised and empowered within the limits of the authorised capital to (i) realise any

increase of the issued capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of the
subscription and/or conversion rights granted by the Board of Directors within the limits of the authorised capital under
the terms and conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments),
convertible bonds, notes or similar instruments issued from time to time by the Company, by the issuing of new shares,
with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any
other manner; (ii) determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and
conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription
right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash. This authorisation is valid during a period
ending 16 January 2013 and it may be renewed by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in com-
pliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for
any amendment of these Articles of Association.

The Board of Directors may delegate, to any duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving

payment for shares representing part or all of the issue of new shares under the authorised capital.

Following each increase of the issued capital within the limits of the authorised capital, realized and duly stated in the

form provided for by the Laws, these Articles of Association will be modified so as to reflect the actual increase. Such
modification will be recorded in a notarial deed upon the instructions of the Board of Directors or of any person duly
authorised and empowered by the Board of Directors for this purpose.

7.2. The issued and/or authorised capital of the Company may further be increased or reduced one or several times

by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by
these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the general meeting of shareholders, voting in compliance with the quorum and majority

rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of
Association may limit or withdraw the preferential subscription right.»

<i>Fifth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of

article 5 of the articles of incorporation, which will from now on read as follows:

« Art. 5. Corporate capital. The issued capital of the Company is set at five hundred fifty-seven thousand eight hundred

seventy Euro (EUR 557,870.-) divided into two hundred seventy-eight thousand nine hundred thirty-five (278,935) shares
with a nominal value of two Euro (EUR 2,-) each, all of which are fully paid up.»

<i>Sixth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting of shareholders resolved to amend article 7 of the articles

of incorporation, which will from now on read as follows:

« Art. 7. Authorised Capital, Increase and Reduction of Capital.
7.1. The authorised capital of the Company is set at one million two hundred sixty-five thousand five hundred Euro

(EUR 1,265,500.-) divided into six hundred thirty-two thousand fifty (632,750) shares. Each authorised share shall have a
nominal value of two Euro (EUR 2.-) each.

The Board of Directors is authorised and empowered within the limits of the authorised capital to (i) realise any

increase of the issued capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of the
subscription and/or conversion rights granted by the Board of Directors within the limits of the authorised capital under
the terms and conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments),
convertible bonds, notes or similar instruments issued from time to time by the Company, by the issuing of new shares,
with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any
other manner; (ii) determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and
conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription
right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash. This authorisation is valid during a period
ending 16 January 2013 and it may be renewed by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in com-
pliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for
any amendment of these Articles of Association.

The Board of Directors may delegate, to any duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving

payment for shares representing part or all of the issue of new shares under the authorised capital.

20860

Following each increase of the issued capital within the limits of the authorised capital, realized and duly stated in the

form provided for by the Laws, these Articles of Association will be modified so as to reflect the actual increase. Such
modification will be recorded in a notarial deed upon the instructions of the Board of Directors or of any person duly
authorised and empowered by the Board of Directors for this purpose.

7.2. The issued and/or authorised capital of the Company may further be increased or reduced one or several times

by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by
these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the general meeting of shareholders, voting in compliance with the quorum and majority

rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of
Association may limit or withdraw the preferential subscription right.»

<i>Seventh resolution

The general meeting of shareholders resolved to set at four (4) the number of members of the Board of Directors

and further resolved to elect the following for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held
on 2014:

- Mr Bertrand Pivin, employee, residing at 38, rue Ernest André, F-78110 Le Vésinet, France.
- Mr Hubert Jacobs van Merlen, employee, residing at 3, rue Belair, L-5318 Contern, Grand Duchy of Luxembourg.
- Mr Michel Witte, employee, residing at 129, avenue Gaston Diederich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

- Mr Rodney Holmes, private employee, residing at 2655, Kentmoor Road, USA-MI48304 Bloomfield Hills, United

States of America.

For the sake of clarity, the general meeting of shareholders further confirmed that the first financial year of the Com-

pany will end on 30 September 2008.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

are estimated at eight thousand euro.

As following the contemplated contribution in kind of the shares issued by IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp;

ENGINEERING S.A., the Company holds more than 65% of the issued share capital of IEE INTERNATIONAL ELEC-
TRONICS &amp; ENGINEERING S.A., a company having its place effective management and business and statutory seat in a
Member State of the European Union, and as the contributions in kind have been made exclusively in exchange for newly
issued shares in the capital of the Company, which has its effective place of business and statutory seat in a Member State
of the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law of December 29, 1971, which provides for capital
duty exemption in this case as regards the contributions in kind.

The contributions in kind represent an aggregate amount of eighty-one million seven hundred seventy-four thousand

two hundred fifty-one Euro and two cents (EUR 81,774,251.02).

The contributions in cash represent an aggregate amount of one thousand two hundred forty one point sixty eight

Euro (EUR 1,241.68) and remain subject to capital duty.

There being no other business, the meeting was closed at 08.40 a.m.
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil status

and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le seize janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IEE HOLDING 2 S.A., une

société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social dans la Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand-
Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 14 décembre 2007, non encore publié
au Mémorial C et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.858 (la
«Société»). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés.

L'assemblée est déclarée ouverte à 8.10 heures sous la présidence de M 

e

 Laurent Schummer, avocat, demeurant à

Luxembourg,

20861

qui désigne comme secrétaire, M 

e

 Jennifer Ferrand, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur M 

e

 Eric Cadilhac, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1 Prise de connaissance et approbation d'un rapport de l'administrateur unique de la Société et d'un rapport du réviseur

d'entreprises sur l'apport en nature relatif à l'augmentation de capital proposée.

2 Augmentation du capital social à concurrence de cinq cent vingt-six mille huit cent soixante-dix euro (EUR 526.870,-)

pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euro (EUR 31.000,-) à cinq cent cinquante-sept mille huit cent
soixante-dix euro (EUR 557.870,-).

3 Emission de deux cent soixante-trois mille quatre cent trente-cinq (263.435) actions nouvelles d'une valeur nominale

de deux euro (EUR 2,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

4 Acceptation de la souscription des actions nouvelles par CAPTOR S.A., CAPTOLIA, AUDIOCOM S.A., BIP VEN-

TURE PARTNERS S.A., SICAR, ING BELGIUM S.A., HUTTON COLLINS MEZZANINE PARTNERS L.P., CAPZANINE
FCPR and WestLB AG, London Branch et acceptation de la libération intégrale de chacune de ces nouvelles actions, avec
une prime d'émission d'un montant total de quatre-vingt-un million deux cent quarante-huit mille six cent vingt-deux euro
et  soixante-dix  cents  (EUR  81.248.622,70),  par  un  apport  en  numéraire  ou  en  nature  consistant  aux  actions  de  IEE
INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A.

5 Modification du capital autorisé afin de le fixer à un million deux cent soixante-cinq mille cinq cents euro (EUR

1.265.500,-) représenté par six cent trente-deux mille sept cent cinquante (632.750) actions et de fixer les conditions
pour l'utilisation de ce capital autorisé comprenant le droit de supprimer ou limiter tout droit préférentiel de souscription.

6 Modification de l'article 5 des statuts afin de refléter l'augmentation de capital.
7 Modification de l'article 7 des statuts afin de refléter la refonte du capital autorisé.
8 Elections statutaires.
9 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions représentées, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les mandataires et

le conseil de l'assemblée resteront pareillement annexées aux présentes.

(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents

ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage.

(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous

les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale des actionnaires a adopté, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de prendre connaissance et d'approuver le rapport de l'administrateur

unique daté du 15 janvier 2008 pour le projet d'augmentation du capital et le rapport du réviseur d'entreprises sur l'apport
en nature pour le projet d'augmentation de capital établi par M. Jean-Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, 67, rue
Michel Welter, L-2730 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le «Réviseur d'Entreprises»), en date du 16 janvier
2008 dans lequel les actions de IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A. sont décrites et évaluées
(le «Rapport sur l'Apport en nature»).

Les conclusions du Rapport sur l'Apport en nature sont les suivantes:
«Sur base du travail effectué, tel que décrit ci-dessus, rien n'a été porté à notre attention qui pourrait nous laisser faire

croire que la valeur de l'apport en nature ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 263.431
actions d'une valeur nominale de EUR 2,- chacune, à être émises avec une prime d'émission totale de EUR 81.247.389,02,
représentant une contrepartie totale s'élevant à EUR 81.774.251,02.»

Ce rapport, signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être

soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent vingt-six mille

huit cent soixante-dix euro (EUR 526.870,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euro (EUR
31.000,-) à cinq cent cinquante-sept mille huit cent soixante-dix euro (EUR 557.870,-).

20862

<i>Troisième résolution

L'assemblée  générale  des  actionnaires  a  décidé  d'émettre  deux  cent  soixante-trois  mille  quatre  cent  trente-cinq

(263.435) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux euro (EUR 2,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges
que les actions existantes.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite, CAPTOR S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social dans la Zone

Industrielle, L-6468 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 101.668 (le «Premier Souscripteur»),

représentée par M. Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15

janvier 2008,

a déclaré souscrire cent soixante-neuf mille deux cent soixante-six (169.266) actions nouvelles d'une valeur nominale

de deux euro (EUR 2,-) et libérer intégralement ces actions nouvelles, avec une prime d'émission d'un montant total de
cinquante-deux million deux cent cinq mille dix-neuf euro et soixante-douze cents (EUR 52.205.019,72), par un apport
en  nature  consistant  en  quatre-vingt-seize  mille  neuf  cent  quarante-neuf  (96.949)  actions  de  IEE  INTERNATIONAL
ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social
dans la Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 101.661 (le «Premier Apport»).

Le Premier Apport représente par conséquent une valeur d'un montant total de cinquante-deux million cinq cent

quarante-trois mille cinq cent cinquante et un euro et soixante-douze cents (EUR 52.543.551,72).

Le Premier Souscripteur, agissant par le biais de son mandataire dûment nommé, a déclaré qu'il n'y a aucun obstacle

au libre transfert de ce Premier Apport à la Société et que des instructions valides ont été données pour réaliser toutes
les notifications, formalités d'enregistrement et autres nécessaires au transfert du Premier Apport à la Société.

Le notaire instrumentant a reçu la preuve que le Premier Apport appartient au Premier Souscripteur.
Ensuite, l'assemblée générale des associés a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement, d'attribuer les cent

soixante-neuf mille deux cent soixante-six (169.266) actions nouvelles au Premier Souscripteur.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite, CAPTOLIA, une société civile régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social dans la Zone Indus-

trielle, L-6468 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro E 396 (le «Second Souscripteur»),

représentée par M. Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15

janvier 2008,

a déclaré souscrire trente mille (30.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux euro (EUR 2,-) et libérer

intégralement ces actions nouvelles, avec une prime d'émission d'un montant total de neuf million deux cent cinquante-
deux mille six cents euro (EUR 9.252.600,-), par un apport en nature consistant en dix-sept mille cent quatre-vingt-trois
(17.183) actions de IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A., une société anonyme régie par le
droit luxembourgeois, ayant son siège social dans la Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 101.661 (le «Second Apport»).

Le Second Apport représente par conséquent une valeur d'un montant total de neuf million trois cent douze mille six

cents euro (EUR 9.312.600,-).

Le Second Souscripteur, agissant par le biais de son mandataire dûment nommé, a déclaré qu'il n'y a aucun obstacle

au libre transfert de ce Second Apport à la Société et que des instructions valides ont été données pour réaliser toutes
les notifications, formalités d'enregistrement et autres nécessaires au transfert du Second Apport à la Société.

Le notaire instrumentant a reçu la preuve que le Second Apport appartient au Second Souscripteur.
Ensuite, l'assemblée générale des associés a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement, d'attribuer les

trente mille (30.000) actions nouvelles au Second Souscripteur.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite, AUDIOCOM S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue

Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 51.390 (le «Troisième Souscripteur»),

représentée par M. Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15

janvier 2008,

a déclaré souscrire vingt-cinq mille trois cent soixante-sept (25.367) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux

euro (EUR 2,-) et libérer intégralement ces actions nouvelles, avec une prime d'émission d'un montant total de sept million
huit cent vingt-trois mille six cent quatre-vingt-dix euro et quatorze cents (EUR 7.823.690,14), comme suit:

1) pour une (1) action nouvellement souscrite, par un apport en numéraire d'un montant total de trois cent dix euro

et quarante-deux cents (EUR 310,42) (la «Troisième Apport En Numéraire»), et

20863

2) pour le restant des actions nouvellement souscrites, par un apport en nature consistant en quatorze mille cinq cent

vingt-neuf (14.529) actions de IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A., une société anonyme régie
par le droit luxembourgeois, ayant son siège social dans la Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand-Duché de Lu-
xembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 101.661, qui représente une
valeur totale de sept million huit cent soixante-quatorze mille cent treize euro et soixante-douze cents (EUR 7.874.113,72)
(le «Troisième Apport En Nature», le Troisième Apport En Numéraire et le Troisième Apport En Nature étant définis
comme le «Troisième Apport»).

Le Troisième Apport représente par conséquent une valeur d'un montant total de sept million huit cent soixante-

quatorze mille quatre cent vingt-quatre euro et quatorze cents (EUR 7.874.424,14).

Le Troisième Souscripteur, agissant par le biais de son mandataire dûment nommé, a déclaré qu'il n'y a aucun obstacle

au libre transfert de ce Troisième Apport En Nature à la Société et que des instructions valides ont été données pour
réaliser toutes les notifications, formalités d'enregistrement et autres nécessaires au transfert de celui-ci à la Société.

Le notaire instrumentant a reçu la preuve que le Troisième Apport En Nature appartient au Troisième Souscripteur.
Le notaire instrumentant a reçu la preuve que le Troisième Apport En Numéraire est à la disposition de la Société,

lequel fait une mention expresse dans l'acte.

Ensuite, l'assemblée générale des associés a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement, d'attribuer les vingt-

cinq mille trois cent soixante-sept (25.367) actions nouvelles au Troisième Souscripteur.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite, BIP VENTURE PARTNERS S.A., SICAR, une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 1, rue des Coquelicots, L-1356 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.029 (le «Quatrième Souscripteur»),

représentée par M. Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15

janvier 2008,

a déclaré souscrire vingt-cinq mille trois cent soixante-sept (25.367) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux

euro (EUR 2,-) et libérer intégralement ces actions nouvelles, avec une prime d'émission d'un montant total de sept million
huit cent vingt-trois mille six cent quatre-vingt-dix euro et quatorze cents (EUR 7.823.690,14), comme suit:

1) pour une (1) action nouvellement souscrite, par un apport en numéraire d'un montant total de trois cent dix euro

et quarante-deux cents (EUR 310,42) (le «Quatrième Apport En Numéraire»), et

2) pour le restant des actions nouvellement souscrites, par un apport en nature consistant en quatorze mille cinq cent

vingt-neuf (14.529) actions de IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A., une société anonyme régie
par le droit luxembourgeois, ayant son siège social dans la Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand-Duché de Lu-
xembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 101.661, qui représente une
valeur totale de sept million huit cent soixante-quatorze mille cent treize euro et soixante-douze cents (EUR 7.874.113,72)
(le «Quatrième Apport En Nature», le Quatrième Apport En Numéraire et le Quatrième Apport En Nature étant définis
comme le «Quatrième Apport»).

Le Quatrième Apport représente par conséquent une valeur d'un montant total de sept million huit cent soixante-

quatorze mille quatre cent vingt-quatre euro et quatorze cents (EUR 7.874.424,14).

Le Quatrième Souscripteur, agissant par le biais de son mandataire dûment nommé, a déclaré qu'il n'y a aucun obstacle

au libre transfert de ce Quatrième Apport En Nature à la Société et que des instructions valides ont été données pour
réaliser toutes les notifications, formalités d'enregistrement et autres nécessaires au transfert de celui-ci à la Société.

Le notaire instrumentant a reçu la preuve que le Quatrième Apport En Nature appartient au Quatrième Souscripteur.
Le notaire instrumentant a reçu la preuve que le Quatrième Apport En Numéraire est à la disposition de la Société,

lequel fait une mention expresse dans l'acte.

Ensuite, l'assemblée générale des associés a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement, d'attribuer les vingt-

cinq mille trois cent soixante-sept (25.367) actions nouvelles au Quatrième Souscripteur.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite, CAPZANINE FCPR, un fonds commun de placement à risques géré par ATALANTE SAS, une société con-

stituée sous le droit français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 478 003
403 et ayant son siège social au 242, rue de Rivoli, 75001 Paris, France (le «Cinquième Souscripteur»),

représentée par M. Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15

janvier 2008,

a déclaré souscrire mille deux cent trente-sept (1.237) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux euro (EUR

2,-) et libérer intégralement ces actions nouvelles, avec une prime d'émission d'un montant total de trois cent quatre-
vingt-un mille cinq cent quinze euro et cinquante-quatre cents (EUR 381.515,54), par un apport en nature consistant en
sept cent neuf (709) actions de IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A., une société anonyme
régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social dans la Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand-Duché de
Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 101.661 (le «Cinquième Ap-
port»).

20864

Le Cinquième Apport représente par conséquent une valeur d'un montant total de trois cent quatre-vingt-trois mille

neuf cent quatre-vingt-neuf euro et cinquante-quatre cents (EUR 383.989,54).

Le Cinquième Souscripteur, agissant par le biais de son mandataire dûment nommé, a déclaré qu'il n'y a aucun obstacle

au libre transfert de ce Cinquième Apport à la Société et que des instructions valides ont été données pour réaliser toutes
les notifications, formalités d'enregistrement et autres nécessaires au transfert du Cinquième Apport à la Société.

Le notaire instrumentant a reçu la preuve que le Cinquième Apport appartient au Cinquième Souscripteur.
Ensuite, l'assemblée générale des associés a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement, d'attribuer les mille

deux cent trente-sept (1.237) actions nouvelles au Cinquième Souscripteur.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite, HUTTON COLLINS MEZZANINE PARTNERS L.P., un limited partnership constitué sous le droit anglais,

ayant son siège social au Kingsbury House, 15-17 King Street, London SW1Y 6Q, United Kingdom (le «Sixième Souscri-
pteur»),

représentée par M. Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15

janvier 2008,

a déclaré souscrire dix mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (10.999) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux

euro (EUR 2,-) et libérer intégralement ces actions nouvelles, avec une prime d'émission d'un montant total de trois
million trois cent quatre-vingt-douze mille trois cent onze euro et cinquante-huit cents (EUR 3.392.311,58), par un apport
en nature consistant en six mille trois cents (6.300) actions de IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING
S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social dans la Zone Industrielle, L-6468
Echternach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B
101.661 (le «Sixième Apport»).

Le Sixième Apport représente par conséquent une valeur d'un montant total de trois million quatre cent quatorze

mille trois cent neuf euro et cinquante-huit cents (EUR 3.414.309,58).

Le Sixième Souscripteur, agissant par le biais de son mandataire dûment nommé, a déclaré qu'il n'y a aucun obstacle

au libre transfert de ce Sixième Apport à la Société et que des instructions valides ont été données pour réaliser toutes
les notifications, formalités d'enregistrement et autres nécessaires au transfert du Sixième Apport à la Société.

Le notaire instrumentant a reçu la preuve que le Sixième Apport appartient au Sixième Souscripteur.
Ensuite, l'assemblée générale des associés a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement, d'attribuer les dix

mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (10.999) actions nouvelles au Sixième Souscripteur.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite, ING BELGIUM S.A., une société anonyme constituée sous le droit belge, ayant son siège social au 24, avenue

Marnix, B-1000 Bruxelles, Belgique et immatriculée au registre de Bruxelles sous le numéro 0403.200.393 (le «Septième
Souscripteur»),

représentée par M. Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15

janvier 2008,

a déclaré souscrire trois cent soixante-neuf (369) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux euro (EUR 2,-) et

libérer intégralement ces actions nouvelles, avec une prime d'émission d'un montant total de cent treize mille huit cent
six euro et quatre-vingt-dix-huit cents (EUR 113.806,98), comme suit:

1) pour une (1) action nouvellement souscrite, par un apport en numéraire d'un montant total de trois cent dix euro

et quarante-deux cents (EUR 310.42) (le «Cinquième Apport En Numéraire»), et

2) pour le restant des actions nouvellement souscrites, par un apport en nature consistant en deux cent onze (211)

actions de IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A., une société anonyme régie par le droit lu-
xembourgeois, ayant son siège social dans la Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 101.661, qui représente une valeur totale de
cent quatorze mille deux cent trente-quatre euro et cinquante-six cents (EUR 114,234,56) (le «Septième Apport En
Nature», le Septième Apport En Numéraire et le Septième Apport En Nature étant définis comme le «Septième Apport»).

Le Septième Apport représente par conséquent une valeur d'un montant total de cent quatorze mille cinq cent qua-

rante-quatre euro et quatre-vingt-dix-huit cents (EUR 114.144,98).

Le Septième Souscripteur, agissant par le biais de son mandataire dûment nommé, a déclaré qu'il n'y a aucun obstacle

au libre transfert de ce Septième Apport En Nature à la Société et que des instructions valides ont été données pour
réaliser toutes les notifications, formalités d'enregistrement et autres nécessaires au transfert de celui-ci à la Société. Le
notaire instrumentant a reçu la preuve que le Septième Apport appartient au Septième Souscripteur.

Le notaire instrumentant a reçu la preuve que le Septième Apport En Numéraire est à la disposition de la Société,

lequel fait une mention expresse dans l'acte.

Ensuite, l'assemblée générale des associés a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement, d'attribuer les trois

cent soixante-neuf (369) actions nouvelles au Septième Souscripteur.

20865

<i>Souscription - Paiement

Ensuite, WestLB AG, London Branch, une société organisée et existante sous le droit allemand, agissant par les biais

de sa succursale londonienne immatriculée en Angleterre sous le numéro FC 007772 et ayant son siège social au Woolgate
Exchange, 25 Basinghall Street, Londres EC2V 5HA, Grande-Bretagne (le «Huitième Souscripteur»),

représentée par M. Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15

janvier 2008,

a déclaré souscrire huit cent trente (830) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux euro (EUR 2,-) et libérer

intégralement ces actions nouvelles, avec une prime d'émission d'un montant total de deux cent cinquante-cinq mille neuf
cent quatre-vingt-huit euro et soixante cents (EUR 255.988,60), comme suit:

1) pour une (1) action nouvellement souscrite, par un apport en numéraire d'un montant total de trois cent dix euro

et quarante-deux cents (EUR 310.42) (le «Cinquième Apport En Numéraire»), et

2) pour le restant des actions nouvellement souscrites, par un apport en nature consistant en quatre cent soixante-

quinze (475) actions de IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A., une société anonyme régie par
le droit luxembourgeois, ayant son siège social dans la Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 101.661, qui représente une valeur totale
de deux cent cinquante-sept mille trois cent trente-huit euro et dix-huit cents (EUR 257.338,18) (le «Huitième Apport
En Nature», le Huitième Apport En Numéraire et le Huitième Apport En Nature étant définis comme le «Huitième
Apport»).

Le Huitième Apport représente par conséquent une valeur d'un montant total de deux cent cinquante-sept mille six

cent quarante-huit euro et soixante cents (EUR 257.648,60).

Le Huitième Souscripteur, agissant par le biais de son mandataire dûment nommé, a déclaré qu'il n'y a aucun obstacle

au libre transfert de ce Huitième Apport En Nature à la Société et que des instructions valides ont été données pour
réaliser toutes les notifications, formalités d'enregistrement et autres nécessaires au transfert de celui-ci à la Société.

Le notaire instrumentant a reçu la preuve que le Huitième Apport appartient au Huitième Souscripteur.
Le notaire instrumentant a reçu la preuve que le Huitième Apport En Numéraire est à la disposition de la Société,

lequel fait une mention expresse dans l'acte.

Ensuite, l'assemblée générale des associés a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement, d'attribuer les huit

cent trente (830) actions nouvelles au Huitième Souscripteur.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier la capital autorisé afin de le fixer à un million deux cent

soixante-cinq mille cinq cents euro (EUR 1.265.500,-) représenté par six cent trente-deux mille sept cent cinquante
(632.750) actions et de fixer les conditions pour l'utilisation de ce capital autorisé comprenant le droit de supprimer ou
limiter tout droit préférentiel de souscription comme suit:

«Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté, jusqu'à concurrence du montant du capital autorisé, à (i) réaliser

toute augmentation de capital émis en une ou plusieurs fois, le cas échéant, à la suite de l'exercice de droits de souscription
et/ou aux droits de conversion accordés par le Conseil d'Administration à concurrence du capital autorisé conformément
aux conditions de bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets ou instru-
ments similaires), d'obligations convertibles ou instruments similaires émis de temps à autre par la Société, en émettant
de nouvelles actions, avec ou sans prime d'émission, contre des apports en numéraire ou en nature, par conversion de
créances de la Société, ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives,
les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles; et (iii) supprimer ou limiter le droit préférentiel
de souscription des actionnaires dans le cas d'une émission d'actions contre apport en numéraire. Cette autorisation est
valable pendant une période se terminant le 16 janvier 2013 après la publication de l'acte de constitution au Mémorial et
peut être renouvelée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et
de majorité exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts.

Le Conseil d'Administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d'accepter des souscriptions

et de recevoir payement pour des actions représentant tout ou partie de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre du
capital autorisé.

A la suite de chaque augmentation du capital social dans le cadre du capital autorisé, qui a été réalisée et constatée

dans les formes prévues par les Lois, les Statuts seront modifiés afin de refléter l'augmentation du capital. Une telle
modification sera constatée sous forme notariée après instructions par le Conseil d'Administration ou par toute personne
dûment autorisée à cet effet par le Conseil d'Administration.

7.2 Le capital émis et/ou autorisé de la Société peut être en outre augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois,

par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées
par les présents Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants

proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Conseil d'Administration fixera le délai pendant lequel le
droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours.

20866

Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de

quorum et de majorité que celles exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification
des Statuts, peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription.»

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier le

premier paragraphe de l'article 5 des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

« Art. 5. Capital social. Le capital émis de la société est fixé à cinq cent cinquante-sept mille huit cent soixante-dix euro

EUR 557.870,-) divisé en deux cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq (278.935) actions, ayant une valeur
nominale de deux euro (EUR 2,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.»

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier l'article

7 des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

« Art. 7. Capital Autorisé, Augmentation et Réduction du Capital Social.
7.1 Le capital autorisé de la Société est fixé à un million deux cent soixante-cinq mille cinq cents euro (EUR 1.265.500,-)

divisé en  six cent  trente-deux  mille  sept  cent  cinquante  (632.750) actions. Chaque  action autorisée aura  une  valeur
nominale de deux euro (EUR 2,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté, jusqu'à concurrence du montant du capital autorisé, à (i) réaliser

toute augmentation de capital émis en une ou plusieurs fois, le cas échéant, à la suite de l'exercice de droits de souscription
et/ou aux droits de conversion accordés par le Conseil d'Administration à concurrence du capital autorisé conformément
aux conditions de bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets ou instru-
ments similaires), d'obligations convertibles ou instruments similaires émis de temps à autre par la Société, en émettant
de nouvelles actions, avec ou sans prime d'émission, contre des apports en numéraire ou en nature, par conversion de
créances de la Société, ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives,
les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles; et (iii) supprimer ou limiter le droit préférentiel
de souscription des actionnaires dans le cas d'une émission d'actions contre apport en numéraire. Cette autorisation est
valable pendant une période se terminant le 16 janvier 2013 après la publication de l'acte de constitution au Mémorial et
peut être renouvelée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et
de majorité exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts.

Le Conseil d'Administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d'accepter des souscriptions

et de recevoir payement pour des actions représentant tout ou partie de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre du
capital autorisé.

A la suite de chaque augmentation du capital social dans le cadre du capital autorisé, qui a été réalisée et constatée

dans les formes prévues par les Lois, les Statuts seront modifiés afin de refléter l'augmentation du capital. Une telle
modification sera constatée sous forme notariée après instructions par le Conseil d'Administration ou par toute personne
dûment autorisée à cet effet par le Conseil d'Administration.

7.2 Le capital émis et/ou autorisé de la Société peut être en outre augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois,

par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées
par les présents Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants

proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Conseil d'Administration fixera le délai pendant lequel le
droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours.

Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de

quorum et de majorité que celles exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification
des Statuts, peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription.»

<i>Septième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de fixer à quatre (4) le nombre des membres du Conseil d'Adminis-

tration et a décidé ensuite d'élire pour une période se terminant à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra
en 2014 les personnes suivantes:

- M. Bertrand Pivin, employé privé, résident à 38, rue Ernest André, F-78110 Le Vésinet, France.
- M. Hubert Jacobs van Merlen, employé privé, résident à 3, rue Belair, L-5318 Contern, Grand-Duché de Luxembourg.
- M. Michel Witte, employé privé, résident à 129, avenue Gaston Diederich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

- M. Rodney Holmes, employé privé, résident à 2655, Kentmoor Road, USA-MI48304 Bloomfield Hills, Etats-Unis

d'Amérique.

En outre, l'assemblée générale des actionnaires a confirmé que le premier exercice se clôture le 30 septembre 2008.

20867

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de cette augmentation

de capital sont estimés à huit mille euros.

Suite à l'apport en nature de l'ensemble des actions de IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A.,

la Société détient plus de 65% du capital social émis de IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A.,
une société ayant son siège réel et statutaire dans un Etat membre de l'Union Européenne, et dans la mesure où ces
apports en nature ont été effectués exclusivement en échange d'actions nouvelles de la Société, ayant son siège réel et
statutaire dans un Etat membre de l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971,
qui prévoit l'exonération du droit d'apport dans un tel cas en ce qui concerne les apports en nature.

Les apports en nature représentent un montant total de quatre-vingt-un million sept cent soixante-quatorze mille deux

cent cinquante et un euro et deux cents (EUR 81.774.251,02).

Les apports en numéraire représentent un montant total de mille deux cent quarante et un euro et soixante-huit cents

(EUR 1.241,68) et restent soumis au droit d'apport.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 8.40 heures.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande des même comparants et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Schummer, J. Ferrand, E. Cadilhac, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 2008. Relation: EAC/2008/952. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 25 janvier 2008.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2008018258/239/766.
(080015392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Tanna Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 17.352,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.216.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2008.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2008014689/5770/13.
(080011125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2008.

Tysama International S.A., Société Anonyme,

(anc. Avencor Holding S.A.).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 73.985.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 18 janvier 2008.

H. Beck
<i>Notaire

Référence de publication: 2008017518/201/13.
(080014972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2008.

20868

Til S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Am Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 29.755.

Constituée par-devant M 

e

 Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date

du 22 décembre 1988, acte publié au Mémorial C n° 94 du 11 avril 1989

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour TIL S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Référence de publication: 2008008075/1261/18.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07693. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080003432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Value Entertainment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 118.312.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 14. Januar 2008.

<i>Für die Gesellschaft
Pour Maître J. Seckler
<i>Notar
M. Goeres

Référence de publication: 2008011144/231/14.
(080006809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Michael SCHORN S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 6, rue Pierre Risch.

R.C.S. Luxembourg B 116.090.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 18 janvier 2008.

H. Beck
<i>Notaire

Référence de publication: 2008017516/201/12.
(080014964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2008.

Orco Germany S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 40, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 102.254.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008017575/242/10.
(080014625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2008.

20869

Eurazeo Entertainment Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 149.138,75.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 129.566.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2008017529/242/13.
(080014659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2008.

Comont S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 57.552.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2008.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2008017561/242/12.
(080014607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2008.

Renaissance Cruises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 70.919.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue de manière ordinaire le 17 octobre 2007

Il résulte du procès-verbal de ladite assemblée générale des actionnaires qu'à l'unanimité des voix, l'assemblée a pris

les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a accepté la démission de Monsieur Bart Van Der Haegen, demeurant professionnellement à 63-65,

rue de Merl, L-2146 Luxembourg au 1 

er

 juillet 2007, en sa qualité d'administrateur,

2. L'assemblée prend note de la nomination de Monsieur Marian Murzynski demeurant professionnellement à 63-65,

rue de Merl, L-2146 Luxembourg en lieu et place de Monsieur Bart Van Der Haegen, administrateur démissionnaire, mais
ne ratifie pas sa nomination;

3. L'assemblée accepte la démission de Monsieur Marian Murzynski, précité, ainsi que la démission de Monsieur Van

Herck en qualité d'administrateur-délégué, Monsieur Van Herck gardant sa qualité d'administrateur de la société, et
nomme en leur remplacement comme administrateur et administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle
Monsieur Arno Reitsma demeurant professionnellement à Uferstrasse 90, CH-4019 Basel; son mandat prendra fin lors
de la prochaine assemblée qui se tiendra en 2009;

4. L'Assemblée a accepté la démission du commissaire aux comptes Monsieur Jules Roebben demeurant au 63-65, rue

de Merl, L-2146 Luxembourg, au 7 mai 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>RENAISSANCE CRUISES S.A.
Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2008018393/1066/29.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2008, réf. LSO-CM09117. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080015834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

20870

Club d'Epargne "Eng voll Kees Nothum", Association sans but lucratif.

Siège social: L-9678 Nothum, 19, Beiwenerstrooss.

R.C.S. Luxembourg F 7.496.

STATUTEN

Am 7. Mai 2007 haben folgende Unterzeichnende:

Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Beruf
Schroeder-Defays Dorothée, L-9647 Doncols, 65, Duerfstrooss, 15. Juli 1969, fonctionnaire d'Etat
Winandy Jean-Claude, L-9678 Nothum, 2, Duerfstrooss, L-9678 Nothum, 1, 9. August 1965, ouvrier d'Etat
Feiten Carlo, Kaunereferstrooss, L-9678 Nothum, 1, 30. Januar 1953, employé privé
Felten-Theis Maggy, Kaunereferstrooss, 8. April 1956, sans état
Schoeder Robert, L-9678 Nothum, 23, Um Knupp, 10. März 1954, employé privé
Michels Marcel, L-9678 Nothum, 2, Beiwenerstrooss, 24. März 1954, cultivateur
Berna Guy, L-9678 Nothum, 21, Duerfstrooss, 14. Juli 1953, employé privé

beschlossen eine Vereinigung ohne Gewinnzweck mit dem Namen CLUB D'EPARGNE «ENG VOLL KEES NOTHUM»

a.s.b.l. mit nachstehenden Statuten zu gründen.

CLUB D'EPARGNE «ENG VOLL KEES NOTHUM» a.s.b.l.

Art. 1. Am 7. Mai 2007 wurde der Sparverain CLUB D'EPARGNE «ENG VOLL KEES NOTHUM» a.s.b.l. ins Leben

gerufen.

Der Sitz der Vereinigung befindet sich in L-9678 Nothum, 19, Beiwenerstrooss.
Der Sitz der Vereinigung kann durch Mitgliederbeschluss umgeändert werden. Hierzu genügt die einfache Stimmen-

mehrheit der anwesenden Mitglieder. Das Einberufungsschreiben zu dieser Mitgliederversammlung muss den Gegenstand
der Änderung erwähnen.

Art. 2. Zweck der Vereinigung ist es seine Mitglieder zum Sparen anzuhalten, durch Veranstaltungen geselliger Art

freundschaftlich zusammenzubringen und das Gesellschaftsleben zu fördern. Die Aktivität der Vereinigung ist absolut
unabhängig von jeder politischen und religiösen Bewegung.

Art. 3. Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt.

Art. 4. Die Vereinigung setzt sich zusammen aus aktiven Mitgliedern und Ehrenmitgliedern. Die Mindestzahl der aktiven

Mitglieder beträgt 5, die Höchstzahl 48. Die Zahl der Ehrenmitglieder ist unbegrenzt.

Art. 5. Gründungsmitglied ist dasjenige, welches bei der Gründung der Vereinigung eine Anmeldegebühr von 80,- EUR

entrichtet hatte.

Art. 6. Jede weitere Aufnahme in die Vereinigung obliegt dem Votum der Vereinigungsmitglieder. Der Kandidat bedarf

der einfachen Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Mindestalter des beitretenden Mitglieds ist das vollendete
16. Lebensjahr. Das neue Mitglied muss die Statuten anerkennen und den Aufnahmebeitrag entrichten.

Art. 7. Der Aufnahmebeitrag wird jährlich von der Generalversammlung festgesetzt.

Art. 8. Jedes Mitglied darf aus dem Verein ausscheiden, indem es bei den Vorstandsmitgliedern schriftlich um seine

Entlassung bittet.

Der Ausschluss eines Mitglieds erfolgt durch Beschluss des Vorstandes oder Generalversammlung mit 2/3 Stimmen-

mehrheit. Motiv: Nicht-Einhalten der Statuten, nach dreimaligem Nicht-Entrichten des monatlichen Mindestsparbeitrages,
Schulden gegenüber der Vereinigung, Nicht-Einhalten der Beschlüsse des Vorstandes und der Generalversammlung.

Das austretende oder ausgeschlossene Mitglied hat nur Anrecht auf die eingezahlten Spargelder, abzüglich der Ord-

nungsstrafen und den Beträgen zu dem Lotto-Zusatzzahl-Spiel. Es kann keinen Anspruch auf den Geschäftsfonds und die
Rückzahlung seiner entrichteten Beiträge geltend machen.

Art. 9. Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Generalversammlung eine Mindestgeldreserve festsetzen.
Diese finanzielle Reserve darf nur auf Beschluss des Vorstandes verwendet werden, mindestens 2/3 der Vorstands-

mitglieder müssen bei dieser Entscheidung anwesend sein.

Art. 10. Die Generalversammlung setzt jährlich den monatlichen Pflichtbetrag fest, welcher der Vereinskasse zufliesst.

Art. 11. Der Mindestsparbeitrag pro Monat wird ebenfalls jährlich von der Generalversammlung festgesetzt.

Art. 12. Die Sparkiste wird monatlich einmal entleert. Der Tag und die Uhrzeit der monatlichen Entleerung werden

von der Generalversammlung festgesetzt.

20871

Art. 13. Bei Nichteinwurf des Beitrages wird eine Ordnungsstrafe erhoben, deren Betrag jährlich von der General-

versammlung festgesetzt wird.

Art. 14. Einwerfen auf eine falsche Nummer wird nicht zur Kenntnis genommen.

Art. 15. Ab jedem ersten Montag im Monat liegen die persönlichen Sparkonten während einer Woche zur Unterschrift

auf. Mit seiner Unterschrift bestätigt jedes Mitglied die Richtigkeit der Eintragungen auf seinem Sparkonto. Die Unterschrift
ist jeweils nur für den vorherigen Monat zu leisten. Bei Nichteinhaltung wird eine Ordnungsstrafe, deren Höhe jährlich
von der Generalversammlung festgesetzt wird, erhoben.

Art. 16. Die Spareinlagen werden wenigstens einmal im Monat vom Kassierer auf ein dem Verein gehörendes Konto

bei einem Bankinstitut zinsbringend angelegt. Die Zinsen verfallen der Vereinskasse.

Art. 17. Der Vorstand bevollmächtigt den Kassierer über die entsprechenden Konten bei den Bankinstituten zu ver-

fügen. Der Vorstand behält sich ein periodisches Kontrollrecht vor.

Art. 18. Prinzipiell werden die Spargelder jährlich und zwar gelegentlich der ordentlichen Generalversammlung zurück

bezahlt. Die Mitglieder können eine spätere Rückzahlung genehmigen. Hierzu genügt die Stimmenmehrheit der anwe-
senden Mitglieder. In Härtefällen kann der Vorstand eine vorzeitige Rückzahlung erlauben.

Schulden gegenüber der Vereinigung können von der Rückzahlung der geschuldeten Spargelder abgezogen werden.

Art. 19. Der Kassierer muss ein Kassenbuch führen, in welches er alle Einnahmen und Ausgaben einträgt. Monatlich

nimmt er die Eintragungen in die persönlichen Sparkonten und in das Sparkontenkontrollblatt vor. Bei diesen monatlichen
Eintragungen hilft dem Kassierer ein(e) beigeordnete(r) Kassierer(in).

Art. 20. Die Vereinigung wird durch die Generalversammlung und den Vorstand verwaltet.

Art. 21. Die Generalversammlung vereinigt alle Mitglieder.
Jedes Mitglied hat das gleiche Wahlrecht.
Die Generalversammlung kann unabhängig der Zahl der anwesenden Mitglieder entscheiden, dies unter Berücksichti-

gung der Bestimmungen von Artikel 8 des Gesetzes vom 21. April 1928.

Die Generalversammlung ist zuständig für:
a. die Wahl des Vorstandes;
b. die Ernennung von zwei Kassenrevisoren;
c. die Annahme des Aktivitätsberichtes und der Bilanzen;
d. die Änderung der Statuten und die Auflösung der Vereinigung;
e. das Ernennen von einem oder mehreren Liquidatoren;
f. das Festsetzen einer finanziellen Reserve, auf Vorschlag des Vorstandes.
Die Einberufung der Mitglieder zu den Generalversammlungen erfolgt mindestens 14 Tage im Voraus per Brief, Fax

oder E-Mail. Die Tagesordnung muss der Einberufung anhängen.

Alle Beschlüsse der Generalversammlung, der Mitgliederversammlung und des Vorstandes werden mit einfacher Stim-

menmehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten.

Die Generalversammlung nimmt die Stellungnahmen des Vorstandes zur Kenntnis.
Die Generalversammlung bezeichnet zwei Kassenrevisore, welche nicht Mitglied des Vorstandes sind. Funktion der

beiden Kassenrevisore ist eine jährliche Prüfung der Kasse und das Erstellen eines Berichtes, welcher der ordentlichen
Generalversammlung zur Genehmigung unterbreitet wird.

Das Mandat der Kassenrevisore erstreckt sich auf die Dauer von zwei Jahren, kann jedoch erneuert werden.

Art. 22. Der Schriftenführer verfasst von jeder General-, Mitglieder-, und Vorstandsversammlung einen schriftlichen

Bericht. Derselbe wird in der jeweiligen folgenden Sitzung zur Genehmigung vorgelegt.

Art. 23. Jedes Jahr im Monat Januar findet eine ordentliche Generalversammlung statt.

Art. 24. Der Vorstand kann eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen, er muss es tun auf Antrag zweier

Drittel der Mitglieder. Die Beschlüsse erfolgen nach Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder.

Art. 25. Statutenänderungen können nur von der Generalversammlung vorgenommen werden. Die Generalversamm-

lung beschliesst nur dann rechtsgültig, wenn das Einberufungsschreiben den Gegenstand dieser Änderung eigens erwähnt,
und wenn zwei Drittel der Mitglieder in der Versammlung zugegen sind. Ohne zwei Drittel Stimmenmehrheit dürfen
Abänderungen nicht vorgenommen werden.

Sind in der ersten Versammlung zwei Drittel der Mitglieder nicht anwesend, so kann eine zweite Versammlung ein-

berufen werden, diese ist beschlussfähig, welches auch die Zahl der anwesenden Mitglieder ist.

Art. 26. Die Leitung der Vereinigung obliegt einem Vorstand von mindestens 5 und maximal 7 Mitgliedern: einem

Präsidenten, einem Vizepräsidenten, einem Sekretär, einem Kassierer und einem bis drei Beisitzenden. Die Kandidaturen
für  die  Vorstandsposten  müssen  schriftlich  an  den  Präsidenten  gerichtet  werden.  Die  Kandidaten  mit  der  höchsten

20872

Stimmzahl, welche von der Generalversammlung gewählt wurden, bilden den Vorstand. Die Aufteilung der oben er-
wähnten Funktionen erfolgt durch den Vorstand.

Kein Vorstandsmitglied darf Angestellter der Vereinigung sein.
Der Vorstand führt die Geschäfte der Vereinigung. Alles was der Generalversammlung nicht ausdrücklich vorbehalten

ist, wird vom Vorstand geregelt.

Urkunden,  Geschäftsabschlüsse,  Verträge  und  Briefe  werden  vom  Präsidenten  oder  seinem  Stellvertreter  unters-

chrieben.

Der Vorstand tritt zusammen wenn dies nötig ist, jedoch mindestens zwei mal im Jahr. Der Vorstand ist beschlussfähig,

egal wieviele Mitglieder anwesend sind, darunter muss jedoch mindestens der Präsident oder der Vizepräsident sein. Bei
Stimmengleichheit entscheidet der Präsident oder sein Stellvertreter. Alle Sitzungen mit den Beschlüssen werden in einem
Sitzungsbericht festgehalten. Gefasste Beschlüsse können nur durch den Vorstand geändert oder aufgehoben werden.

Die Mitglieder des Vorstandes arbeiten ehrenamtlich. Ihnen werden nur die entstandenen Auslagen rückerstattet.

Art. 27. Die Finanzen werden vom Kassierer verwaltet. Der Kassierer wird vom Vorstand bevollmächtigt alle Banko-

perationen durchzuführen.

Art. 28. Der Präsident vertritt den Vorstand und die Vereinigung.
Der Präsident führt den Vorsitz während der Vorstandssitzungen und der Generalversammlung.

Art. 29. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.
Das erste Geschäftsjahr läuft ausnahmsweise vom 7. Mai 2007 bis zum 31. Dezember 2007.

Art. 30. Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung der Statuten entscheidet der Vorstand.

Art. 31. Die Auflösung der Vereinigung kann nur dich eine eigens zu diesem Zweck einberufene Generalversammlung

erfolgen. Bei der Auflösung der Vereinigung wird das Vereinigungsguthaben, nach Abzug der Spargelder der Mitglieder
und nach Abzug aller Verbindlichkeiten, einer Wohltätigkeitsorganisation überwiesen.

Unterschriften.

Référence de publication: 2008018542/801049/131.
Enregistré à Diekirch, le 29 janvier 2008, réf. DSO-CM00392. - Reçu 474 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080015946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Endurance Hospitality Asset S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 124.540.

In the year two thousand and seven, on the eighteenth of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

Appeared:

1) ENDURANCE REAL ESTATE MANAGEMENT COMPANY S.A., a company incorporated and existing under the

laws of Luxembourg having its registered office at L-8308 Capellen, 38-40, rue Pafebruch PA Hirebusch, registered with
the Companies and Trade Register of Luxembourg, under the number B 105.344,

represented by Mr Alexander Semik, employee, with professional address in Capellen, by virtue of a proxy given under

private seal.

2) ENDURANCE HOSPITALITY FINANCE S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg

having its registered office at Luxembourg, registered with the Companies and Trade Register of Luxembourg, under the
number B 124.539,

represented by Mr Alexander Semik, employee, with professional address in Capellen, by virtue of a proxy given under

private seal.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, acting as sole members of ENDURANCE HOSPITALITY ASSET S. à r.l. having its registered

office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, on the 19th of January, 2007, published in the
Mémorial, Recueil C, number 717 of April 26, 2007, have requested the undersigned notary to to state the following
resolutions:

<i>First resolution

The shareholders resolve to amend the first paragraph of Article 2 of the Articles of incorporation so as to read

henceforth as follows:

20873

«The registered office of the Company is established in Capellen.»

<i>Second resolution

The shareholders resolve to transfer the registered office of the company from L-1330 Luxembourg, 48, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, to L-8308 Capellen, 38, rue Pafebruch PA Hirebusch.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ENDURANCE REAL ESTATE MANAGEMENT COMPANY S.A., une société de droit luxembourgeois sous forme

de société anonyme, ayant son siège social au L-8308 Capellen, 38-40, rue Pafebruch PA Hirebusch, inscrite au registre
de commerce et des sociétés sous le numéro B 105.344,

représentée par Monsieur Alexander Semik, employé privé, avec adresse professionnelle à Capellen, en vertu d'une

procuration sous seing privé.

2) ENDURANCE HOSPITALITY FINANCE S.à r.l., une société de droit luxembourgeois sous forme de société à

responsabilité limitée, ayant son siège social au L-8308 Capellen, 38, rue Pafebruch PA Hirebusch, inscrite au registre de
commerce et des sociétés sous le numéro B 124.539,

représentée par Monsieur Alexander Semik, employé privé, avec adresse professionnelle à Capellen, en vertu d'une

procuration sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire

instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée ENDURANCE

HOSPITALITY ASSET S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 19 janvier 2007, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 717 du 26 avril 2007, ont requis le notaire instrumentant
de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier le premier alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner désormais la teneur

suivante:

«Le siège social est établi à Capellen.»

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

à L-8308 Capellen, 38, rue Pafebruch PA Hirebusch.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: A. Semik, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2007. Relation: LAC/2007/42963. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008018255/242/78.
(080015549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

20874

MMI Trust Holding s.a., Société Anonyme.

Siège social: L-6760 Grevenmacher, 28, rue de Muenschecker.

R.C.S. Luxembourg B 104.298.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008018303/2323/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, réf. LSO-CM06918. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080016003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

MCR SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 100, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 93.924.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008018304/2323/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04309. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080015963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

BVLUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5533 Remich, 47, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 49.059.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2008.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2008018175/5770/12.
(080016029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Tiger Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.

R.C.S. Luxembourg B 57.009.

La société PLAZA LUXEMBOURG S.A., avec siège social au 156, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg, inscrite au

RCS de Luxembourg sous le numéro B 74.882, nommée administrateur de la société TIGER INVESTMENT S.A., en date
du 28 septembre 2000, a désigné Monsieur Jan Van Holsbeeck, né le 10 novembre 1965 à Alost (Belgique), employé privé,
demeurant 156, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg comme représentant permanent pour la durée de son mandat,
qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2007.

<i>TIGER INVESTMENT S.A.
T. Meganck
<i>Administrateur Délégué

Référence de publication: 2008017929/795/19.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, réf. LSO-CM08302. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080014796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2008.

20875

Endurance Asset S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 110.782.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008018167/242/11.
(080015922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Tong International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.

R.C.S. Luxembourg B 29.630.

La société PLAZA LUXEMBOURG S.A., avec siège social au 156, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg, inscrite au

RCS de Luxembourg sous le numéro B 74.882, nommée administrateur de la société TONG INTERNATIONAL S.A., en
date du 28 septembre 2000, a désigné Monsieur Jan Van Holsbeeck, né le 10 novembre 1965 à Alost (Belgique), employé
privé, demeurant 156, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg comme représentant permanent pour la durée de son
mandat, qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 avril 2007.

<i>TONG INTERNATIONAL S.A.
T. Meganck
<i>Administrateur Délégué

Référence de publication: 2008017926/795/19.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, réf. LSO-CM08306. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080014807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2008.

Apimmo S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 28.782.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2008.

G. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2008018168/220/12.
(080015980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Orco Croatia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 40, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 108.667.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2007.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2008017571/242/12.
(080014614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2008.

20876

B.H.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 16.740.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 20 décembre 2007, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- B.H.I. S.A.(B 16.740), avec siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling, de fait inconnue à cette adresse.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au Tribunal d'Arrondissement de et

à Luxembourg, et liquidateur Maître Marguerite Ries, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leur créance avant le 9 janvier 2008 au greffe du Tribunal de

Commerce de et à Luxembourg.

Pour extrait conforme

e

 M. Ries

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008018562/2630/21.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM02856. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080015887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Dematic Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 10.000.000,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 112.618.

<i>Extrait des décisions des associés prises en date du 10 janvier 2008

Monsieur Brian Mc Mahon, employé privé, né le 4 novembre 1968 à Dublin (Irlande) et Madame Zohra Souid, employée

privée, née le 15 janvier 1974 à Thionville (France), résidant professionnellement à L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe
II, ont été nommés gérants B pour une période illimitée (en remplacement de Messieurs Russell Perchard et Pascal Leclerc,
démissionnaires).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DEMATIC HOLDING S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008018389/1649/19.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2008, réf. LSO-CM08788. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080015765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Coiffure Cap'Act S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4574 Differdange, 6, rue du Parc de Gerlache.

R.C.S. Luxembourg B 88.206.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 29 janvier 2008.

COIFFURE CAP'ACT S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008018369/1136/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07429. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080015416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

20877

Lukas LuxCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 121.148.

<i>Extrait des décisions des associés prises en date du 10 janvier 2008

Monsieur Brian Mc Mahon, employé privé, né le 4 novembre 1968 à Dublin (Irlande) et Madame Zohra Souid, employée

privée, née le 15 janvier 1974 à Thionville (France), résidant professionnellement à L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe
II, ont été nommés gérants B pour une période illimitée (en remplacement de Messieurs Russell Perchard et Pascal Leclerc,
démissionnaires).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LUKAS LUXCO 2 S.à.r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008018390/1649/19.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2008, réf. LSO-CM08787. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080015776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Multitel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-5365 Münsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 82.483.

Il résulte de la décision du Conseil de Gérance du 9 janvier 2007 que les Gérants ont pris la décision suivante:
Transfert du siège social de la Société du 22, Parc d'Activité Syrdall au 9, Parc d'Activité Syrdall à L-5365 Münsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MULTITEL S.à r.l.
EQUITY TRUST CO. (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008018539/683/17.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2008, réf. LSO-CM08860. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080015414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Chiltern Participations S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 102.986.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte des résolutions prises du liquidateur de la société nommé le 14 décembre 2007, tenues le 21 décembre 2007,

au siège social que:

1. Le liquidateur décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pour une période de 5

ans à l'adresse suivante: 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

2. Le liquidateur décide que les créances non réclamées des créditeurs ou des actionnaires de la société seront dé-

posées et conservées à la Caisse de Consignation.

3. Le liquidateur prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a cessé d'exister.

20878

Luxembourg, le 31 décembre 2007.

<i>Pour CHILTERN PARTICIPATIONS S.A.
Pour le compte de DAMSOR LIMITED
P. Venn
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008018565/759/23.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, réf. LSO-CM07357. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080016038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

GEBPF Finance (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 94.401.

<i>Extrait des résolutions du Conseil de Gérance prises en date du 12 décembre 2007

1. Le siège social de le Société a été transféré du 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg vers le 6, rue

Philippe II, L-2340 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 février 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008018563/6981/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02340. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080015905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

FinSole S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 85.437.

<i>Convention de Domiciliation

La Convention de Domiciliation conclue en date du 18 décembre 2001 entre la Société Anonyme FinSole S.A. (an-

ciennement S.A.R.S. S.A.), avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE
EUROPEENNE DE BANQUE S.A., avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Lu-
xembourg B 13.859, a été dénoncée avec effet immédiat en date du 20 décembre 2007.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008018567/24/16.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, réf. LSO-CM09134. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080016154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

ISPC II LLC Cie. SCS ("société en commandite simple"), Société en Commandite simple.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 95.909.

<i>Extrait des décisions des gérants du 31 août 2007

Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

20879

Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008018568/534/15.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2008, réf. LSO-CM06709. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080015531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Kamea International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 97.440.

Le bilan au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008018337/802/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, réf. LSO-CM09211. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080015730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Immobilier Caraïbique S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 99.958.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008015913/6566/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05685. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080012887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Immobilier Caraïbique S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 99.958.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008015914/6566/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05687. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080012890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Satin S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 57.536.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2008.

G. Lecuit
<i>Notaire

Référence de publication: 2008018170/220/12.
(080016011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

20880


Document Outline

Apimmo S.A.

Avencor Holding S.A.

B.H.I. S.A.

BVLUX

BVLUX

Chiltern Participations S.A.

Club d'Epargne "Eng voll Kees Nothum"

Coiffure Cap'Act S.à r.l.

ColBiSpazio Lux S.à r.l.

Comont S.A.

Dematic Holding S.à.r.l.

Endurance Asset S.à r.l.

Endurance Hospitality Asset S.à r.l.

Esculape S.A.

Eurazeo Entertainment Lux S.à r.l.

FinSole S.A.

Gallaher Finance Luxembourg S.à r.l.

Gallaher Finance Luxembourg S.à r.l.

Gallaher Investments Luxembourg S.à r.l.

Gallaher Investments Luxembourg S.à r.l.

Gallaher Luxembourg S.à r.l.

Gallaher Luxembourg S.à r.l.

GEBPF Finance (Lux) S.à r.l.

IEE Holding 2 S.A.

Immobilier Caraïbique S.à r.l.

Immobilier Caraïbique S.à r.l.

ISPC II LLC Cie. SCS ("société en commandite simple")

Kamea International S.A.

Lukas LuxCo 2 S.à r.l.

MCR SA

Michael SCHORN S.à r.l.

MMI Trust Holding s.a.

Multitel S.à r.l.

Orco Croatia S.A.

Orco Germany S.A.

Renaissance Cruises S.A.

Satin S.A.

Swan Investment Company

Tanna Holding S. à r. l.

Tiger Investment S.A.

Til S.A.

Tong International S.A.

Tysama International S.A.

Value Entertainment S.A.