logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 392

15 février 2008

SOMMAIRE

3 R S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18806

Afimo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18816

Agaka S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18772

A & K - AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18802

Alias Mustang International  . . . . . . . . . . . . .

18781

Allianz European Pension Investments  . . .

18797

Allianz European Pension Investments  . . .

18808

Allianz Global Investors Fund  . . . . . . . . . . .

18803

Allianz Global Investors Fund  . . . . . . . . . . .

18808

Amas Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18775

Amber International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

18802

Asian Food International S.A.  . . . . . . . . . . .

18798

Asian Food International S.A.  . . . . . . . . . . .

18804

Aurea Finance Company . . . . . . . . . . . . . . . .

18779

Bairlinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18771

Beka-Lux 2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18797

Berbo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18815

BEVING Joseph S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18802

Blatteus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18774

Bluegreen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18773

Bonny S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18816

Bourne Park Capital (Lux) S.A. . . . . . . . . . .

18777

Business-Immo International, s. à r.l.  . . . .

18802

Business Management Group Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18775

Chimato-Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18796

Comitalu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18811

Compagnie Financière Montchoisi S.A.  . .

18773

Continental Pacific & Atlantic Holding AG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18802

Dailkan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18771

DB FCS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18809

Defibresil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18775

Deka-CorporateBond High Yield Euro  . . .

18781

Deka-GlobalConvergenceRenten  . . . . . . . .

18797

Deka-WorldTopGarant 1  . . . . . . . . . . . . . . .

18798

Demmer-Vermögensverwaltungs-Fonds

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18782

DWS Best Global FX Selection Plus  . . . . .

18809

DWS DifferenzChance2013  . . . . . . . . . . . . .

18806

DWS Flex Aktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18809

DWS Performance Select 2014  . . . . . . . . .

18809

Eco Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18810

E&G Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18801

Elite Coiffure S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18813

Eurocash-Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18777

Fëlsberg Promotions S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . .

18814

F.I.B.M. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18774

Fincimec Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18771

Finesse Holding S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

18812

Five Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18813

FT EuroCorporates  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18804

FT Europazins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18803

Gabbiano S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18813

Galli S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18776

Gemini Logistics S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18813

GREIFF America OP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18782

Guliver Sicherheit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18801

Haspa PB Ertrag Plus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18800

Heck, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18814

Inland Navigation Luxembourg S.A.  . . . . .

18772

Jonathan Finance Holding S.A.  . . . . . . . . . .

18776

Kensington S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18772

Kordy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18780

La Brin Dille s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18805

Lebanese African Finance and Trading Co

(Holding) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18807

LF Open Waters OP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18778

Locatrans S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18811

Lombard Odier Darier Hentsch Invest  . . .

18779

L & P, Lange and Partner S.à r.l. . . . . . . . . .

18814

Mahevia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18814

Manzoni International S.A. . . . . . . . . . . . . . .

18774

18769

Mecconti S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18815

Moventum S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18804

Multi Opportunities II  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18807

Multi Opportunities II  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18809

Niko-International GmbH  . . . . . . . . . . . . . .

18807

Nova Editior S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18781

N.S.D. Nouvelle Société de Développe-

ment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18812

N.S.D. Nouvelle Société de Développe-

ment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18812

Pagan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18806

RIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18802

RIA Allocation I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18801

RP Rendite Plus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18808

RP Rendite Plus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18801

SaarGummi technologies S.à r.l. . . . . . . . . .

18782

Select Commerce S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

18815

Serrano S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18778

Siamstores S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18811

Solar Capital Luxembourg I  . . . . . . . . . . . . .

18810

Star Group Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

18776

Strapeg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18810

T-Comalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18812

TriGlobal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18802

UBP Money Market Fund Sicav . . . . . . . . . .

18773

Unicum SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18815

Weberbank Special Mandate Fund  . . . . . .

18800

18770

Dailkan S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 52.759.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>21 mars 2008 à 9.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008015380/755/18.

Bairlinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 94.272.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>20 mars 2008 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008015381/755/19.

Fincimec Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 35.223.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 mars 2008 à 10.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes aux 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007,
3. Affectation des résultats,
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
5. Réélections statutaires,
6. Divers.

18771

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008019015/322/17.

Inland Navigation Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.

R.C.S. Luxembourg B 78.719.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Aktionäre von INLAND NAVIGATION LUXEMBOURG S.A., welche am <i>29. Februar 2008 um 11.00 Uhr am

Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

<i>Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars;
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2004, 31. Dezember

2005 und 31 Dezember 2006;

3. Beschlussfassung über die Gewinn- und Verlustwendungen;
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars;
5. Mandatsverlängerungen;
6. Verschiedenes.

<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2008016127/19.

Kensington S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 21.859.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>10 mars 2008 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008018874/755/19.

Agaka S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 127.350.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>3 mars 2008 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2007.

4. Divers.

18772

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008020880/1023/16.

Bluegreen S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 64.425.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>3 mars 2008 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
- Délibération et décision à prendre quant à la poursuite éventuelle de l'activité de la société conformément à l'article

100 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008018878/755/21.

Compagnie Financière Montchoisi S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 24.944.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE

des actionnaires qui se tiendra au siège social, 15, boulevard Roosevelt à L-2450 Luxembourg, le mercredi <i>12 mars

<i>2008 à 10.00 heures.

<i>Ordre du jour:

- Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de se conformer à l'article 10 des statuts.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008019011/687/14.

UBP Money Market Fund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 74.045.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par la présente à

l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

des actionnaires de la société qui aura lieu le jeudi <i>6 mars 2008 à 11.00 heures au siège social de la société avec l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration.
2. Lecture du rapport du Réviseur d'Entreprises.
3. Lecture et approbation du rapport annuel au 31 décembre 2007.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge aux administrateurs pour l'année écoulée.
6. Nominations statutaires.
7. Tantièmes aux Administrateurs.

18773

8. Divers.

Les décisions concernant les points à l'ordre du jour ne requièrent pas de quorum. Les décisions seront prises à la

majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout dé-
tenteur d'actions nominatives peut se faire représenter à l'Assemblée en renvoyant le formulaire de procuration qui leur
a été adressé (dont une copie peut être obtenue au siège social). Le formulaire de procuration doit être dûment daté,
signé et renvoyé par fax ou par courrier avant la fermeture des activités le 5 mars 2008 à 17.00 heures. Les détenteurs
d'actions au porteur désirant participer ou voter à l'Assemblée, devront déposer leurs actions pour le 5 mars 2008 à
17.00 heures au plus tard au siège de la Sicav ou à l'adresse suivante: UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.,
18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008020876/755/28.

F.I.B.M. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 40.615.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>6 mars 2008 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008019517/755/18.

Manzoni International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 71.820.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le <i>6 mars 2008 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008020877/534/17.

Blatteus S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 36.120.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

18774

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>4 mars 2008 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2007.

4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008020882/1023/16.

Business Management Group Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 59.384.

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of the company, which will be held at the headoffice, on <i>March 3, 2008 at 13.15 o'clock.

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2007 an allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending December 31, 2007.

4. Statutory Elections.
5. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2008020884/1023/17.

Defibresil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 125.382.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>3 mars 2008 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2007.

4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008020886/1023/16.

Amas Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 52.605.

Les Actionnaires sont invités à assister à

18775

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>4 mars 2008 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises Agréé,
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2007 et de l'affectation des résultats,
3. Décharge aux Administrateurs,
4. Nominations Statutaires,
5. Divers.

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles

au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 3 mars 2008

au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008020891/755/20.

Galli S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 40.111.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>3 mars 2008 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2007.

4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 sur la législation des sociétés.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008020887/1023/17.

Star Group Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 63.756.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>3 mars 2008 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2007.

4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008020889/1023/16.

Jonathan Finance Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 42.591.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

18776

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>3 mars 2008 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et et du rapport du commissaire aux comptes,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007,
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008020890/506/16.

Bourne Park Capital (Lux) S.A., Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.403.

The Board of Directors convenes the Shareholders of BOURNE PARK CAPITAL (LUX) S.A. to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the SICAV-SIF on <i>March 5th, 2008 at 11.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

Amendment of article 1 of the Articles of Incorporation in order to read BOURNE PARK CAPITAL (LUX) S.A.,
SICAV - SIF.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before

the meeting at the registered office of the Company or at one of the offices of BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme in Luxembourg.

In order for the meeting to deliberate validly on the items of the agenda, a quorum of 50% of the shares outstanding

is required, and the passing of each resolution requires the consent of two thirds of the votes expressed, abstentions,
invalid or blank votes and non represented votes not included.

The draft restated articles of association are available, free of charge, upon request, at the registered office of the

company.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2008020892/755/22.

Eurocash-Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 45.631.

Gemäß Art. 22 ff. der Statuten laden wir die Aktionäre zur

ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

ein, die am <i>12. März 2008 um 16.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers über das am 31. Dezember 2007 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Genehmigung der Bilanz zum 31. Dezember 2007 samt GuV und Anhang sowie Beschlussfassung über die Ge-

winnverwendung.

3. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.
5. Verlängerung des Mandats des Wirtschaftsprüfers.
6. Neuwahl des Verwaltungsrats.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung sowie zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Ak-

tionäre berechtigt, die bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der
Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, daß die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten
werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Die

18777

Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Hinsichtlich
der Anwesenheit einer Mindestanzahl von Aktionären gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Luxemburg, im Februar 2008.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008020895/1999/26.

LF Open Waters OP, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 122.218.

Gemäß Art. 11 ff. der Statuten laden wir die Aktionäre zur

ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

ein, die am <i>11. März 2008 um 16:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 4, rue Jean Monnet, stattfinden wird.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrats und Wirtschaftsprüfers über das Geschäftsjahr vom 30. November 2006 bis zum 30.

September 2007.

2. Genehmigung der Bilanz zum 30. September 2007 samt GuV und Anhang sowie Beschlussfassung über die Ge-

winnverwendung.

3. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.
5. Verlängerung des Mandats des Wirtschaftsprüfers.
6. Wahl einzelner Verwaltungsratsmitglieder.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung sowie zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Ak-

tionäre berechtigt, die bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der
Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, daß die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung hinterlegt wor-
den sind. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Die
Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Hinsichtlich
der Anwesenheit einer Mindestanzahl von Aktionären gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Aktionäre treffen ihre
Entscheidungen durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre.

Luxemburg, im Februar 2008.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008020893/1999/28.

Serrano S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 43.094.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 février 200 8 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2007;
4. Vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008013636/10/18.

18778

Aurea Finance Company, Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 47.028.

L'assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 28 janvier n'ayant pu délibérer sur l'ordre du jour faute de

quorum, les actionnaires d'AUREA FINANCE COMPANY sont priés de bien vouloir assister à une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>3 mars 2008 à 10.00 heures au siège de la société, 50, rue Basse à Steinsel, Grand-Duché de

Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification des alinéas premier et deuxième de l'objet social de la société, suite à l'autorisation n° 63/07 du

gouvernement - Ministère de finances conformément à la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments
financiers, et conformément aux articles 14 et 15 de ladite loi modifiée du 5 avril 1993, afin de leur donner la teneur
suivante:
«Article 2,
La société a pour objet principal les opérations d'une entreprise d'investissement exerçant les fonctions de distri-
buteur de parts d'OPC pouvant accepter ou faire des paiements, de professionnel intervenant pour compte propre,
gérant de fortunes, commissionnaire, courtier en instruments financiers, conseiller en investissement telles que
décrites par les articles 24, 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 24-7, 25, 29-1 et 29-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative
au secteur financier, ainsi que les autres fonctions autorisées dans le cadre des fonctions énumérées ci-dessus dans
le sens le plus large autorisé par la loi.
Elle peut notamment:
- recevoir et transmettre des ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;
- exécuter des ordres pour le compte de clients;
- négocier pour compte propre;
- gérer des portefeuilles;
- fournir des conseils en investissement;
et plus généralement:...»

2. Compléter l'alinéa 8 de l'objet social, afin de lui donner la teneur suivante:

«- faire toutes opérations de placement, d'investissement, de prise de participation;
- faire toutes opérations en relation avec la domiciliation des sociétés».
Les actionnaires ayant l'intention d'assister à cette assemblée sont priés de bien vouloir en aviser la société par
lettre, télécopie ou téléphone au moins une heure avant l'ouverture de ladite assemblée.

Référence de publication: 2008011973/1593/35.

Lombard Odier Darier Hentsch Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 25.301.

Le Conseil d'Administration de la SICAV susmentionnée a le plaisir de convier ses actionnaires à

l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra le <i>28 février 200 8 à 11.00 heures au siège social de la SICAV et dont l'ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2007
3. Distribution des résultats après ratification du paiement des dividendes suivants pour l'exercice clos le 30 septembre

2007 :
Nom des compartiments et Dividendes
LODH Invest - The Defender Fund (EUR) P - D, EUR 0.13
LODH Invest - The Dynamic Plus Portfolio Fund (GBP) P - D, GBP 0.111
LODH Invest - The Alto RI Global Equity Fund P - D, EUR 0.06
LODH Invest - The Europe Fund P - D, EUR 0.08
LODH Invest - The Alto Europe Equity Fund P - D, EUR 0.16
LODH Invest - The European Small and Mid Caps Fund P - D, EUR 0.22
LODH Invest - The Continental European Small and Mid Caps Fund I - D, EUR 0.17
LODH Invest - The Greater China Fund P - D, USD 0.75
LODH Invest - The Pacific Rim Fund P - D, USD 0.06

18779

LODH Invest - The Asian Small Caps Fund P - D, USD 0.64
LODH Invest - The Global Asia Pacific Fund P - D, USD 0.33
LODH Invest - The European Bond Fund P - D, EUR 0.13
LODH Invest - The Optimum Dollar Bond Fund P - D, USD 0.31
LODH Invest - The Dollar Bloc Bond Fund P - D, USD 0.26
LODH Invest - The Optimum Euro Bond Fund P - D, EUR 0.25
LODH Invest - The Euro Corporate Bond Fund P - D, EUR 0.30
LODH Invest - The European Short Term Fund P - D, EUR 0.26
LODH Invest - The Swiss Franc Credit Bond Fund P - D, CHF 0.14
LODH Invest - The Optimum Treasury Bond Fund (CHF) P - D, CHF 0.20
LODH Invest - The Emerging Market Bond Fund P - D, USD 0.53
LODH Invest - The EU Convergence Bond Fund P - D, EUR 0.32
LODH Invest - The Eonia Plus Fund (EUR) P - D, EUR 2.52

4. Rémunération des Administrateurs
5. Décharge des Administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clos le 30 septembre 2007
6. Election/démission des Administrateurs:

* Acceptation de la démission de M. Hubert Keller avec effet au 27 février 2008;
* Ratification de la cooptation de M. Alexandre Meyer en tant qu'Administrateur de la SICAV à compter du 27
février 2008, en remplacement de M. Hubert Keller;
* Réélection de M. Patrick Odier, M. Peter E.F. Newbald, M. Jean-Claude Ramel, M 

me

 Francine Keiser, M. Yvar

Mentha, M. Stefan Bichsel, M. Patrick Zurstrassen et M. Alexandre Meyer en tant qu'Administrateurs de la SICAV
jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009.

7. Réélection de PricewaterhouseCoopers Sàrl en tant que Réviseur d'entreprises de la SICAV jusqu'à l'Assemblée

générale annuelle en 2009.

8. Divers

Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour délibérer sur les points à l'ordre du jour et que les

décisions seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à
une voix. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée en signant une procuration en faveur d'un représentant.

Le prospectus complet et les prospectus simplifiés de la SICAV, ses Statuts et les rapports annuel et semestriel ainsi

qu'un modèle de procuration sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la SICAV.

Si vous souhaitez participer à cette Assemblée, nous vous serions reconnaissants de nous en informer au moins deux

jours avant la date de l'Assemblée.

Si vous ne pouvez pas assister à cette Assemblée, nous vous serions reconnaissants de nous retourner une procuration

dûment signée, d'abord par fax au (352) 47 67 75 08 puis par courrier à l'attention de M 

me

 Céline Parmentier, CACEIS

BANK LUXEMBOURG, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, d'ici au 26 février 2008.

<i>Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2008014251/755/60.

Kordy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 79.938.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société KORDY S.A. qui se réunira le lundi <i>25 février 2008 à 15.00 heures, au siège social pour délibérer sur

l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Discussion concernant l'établissement des comptes annuels aux 31 décembre 2004, 31 décembre 2005, 31 dé-

cembre 2006 et 31 décembre 2007;

2. Divers.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées par la majorité des actions présentes ou représentées.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008014903/587/17.

18780

Nova Editior S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 89.509.

Le Conseil d'Administration convoque

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

par devant Notaire, au siège social, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, le <i>25 février 2008 à 15.00 heures avec

l'ordre du jour ci-après:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social
2. Modification de l'article 3 des statuts de façon à refléter l'augmentation de capital proposé.
3. Divers

Luxembourg, le 4 février 2008.
Référence de publication: 2008014904/744/15.

Alias Mustang International, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 95.884.

Le conseil d'administration prie les actionnaires de la société anonyme ALIAS MUSTANG INTERNATIONAL d'assister

à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>25 février 2008 à 11.00 heures à Luxembourg au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg ,

afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation spéciale au droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une augmentation de capital.
2. Autorisation de l'émission de Bons Autonomes de Souscription d'Actions et renonciation spéciale au droit préfé-

rentiel de souscription.

Les actionnaires sont informés que cette Assemblée a besoin d'un quorum d'actionnaires présents ou représentés de

plus de 50% du nombre total d'actions pour délibérer valablement sur l'ordre du jour. Les résolutions, pour être valables,
doivent réunir la majorité de deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à ladite Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur devront présenter leurs certificats d'ac-

tions ou un certificat de blocage bancaire.

Référence de publication: 2008016513/755/20.

Deka-CorporateBond High Yield Euro, Fonds Commun de Placement.

Die DEKA INTERNATIONAL S.A., RC Luxembourg B 28.599, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für

gemeinsame Anlagen DEKA-CorporateBond HIGH YIELD EURO, der den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom
20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der Depotbank des Fonds
DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., zum 8. Februar 2008, das Sonderreglement geändert.

Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschafts-

register) hinterlegt.

Luxemburg, den 7. Januar 2008.

DEKA INTERNATIONAL S.A. / DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / <i>Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften

Référence de publication: 2008009124/1208/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM06237. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

18781

GREIFF America OP, Fonds Commun de Placement.

La partie spécifique du règlement de gestion du fonds commun de placement GREIFF AMERICA OP a été déposée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2008011674/1999/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, réf. LSO-CM07990. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080012742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Demmer-Vermögensverwaltungs-Fonds, Fonds Commun de Placement.

Die INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., RC Luxembourg B 8.558, hat als Verwaltungsgesellschaft den

Organismus für gemeinsame Anlagen DEMMER-VERMÖGENSVERWALTUNGS-FONDS, der den Bestimmungen des
Gesetzes vom 13. Februar 2007 über die Spezialfonds unterliegt, mit Zustimmung der Depotbank des Fonds DekaBank
DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., am 6. November 2007, gegründet.

Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschafts-

register) hinterlegt.

Luxemburg, den 6. November 2007.

INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A. / DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / <i>Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften

Référence de publication: 2008009125/1207/17.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05599. - Reçu 48 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

SaarGummi technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 67.820.750,00.

Siège social: L-5445 Schengen, 97, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 108.936.

Gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtswohsitz in Sanem, am 20.

Juni 2005, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 1127, vom 31. Oktober 2005,

abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Paul Bettingen, mit Amtswohsitz in Niederanven, am 27.

April 2006, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 1642, 30. August 2006.

Chapter I. Form, Corporate name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate name. There is hereby established by the single founding member a company (the «Company»)

in the form of a private limited company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg (the «Laws») and by the present articles of association (the «Articles of Association»).

The Company is initially composed of one single member, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several members, but not exceeding forty (40) members, notably as a result of the transfer of shares
or the issue of new shares.

The Company will exist under the corporate name of SaarGummi TECHNOLOGIES, S.à r.l.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of Schengen.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Schengen by a resolution of the

Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

In the event that, in the view of the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, extraordinary political,

economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad,
the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal

18782

circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding
the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures
will be taken and notified to any interested parties by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

Art. 3. Object. The object of the Company is (i) the acquisition and holding of debt and/or equity interests in any kind

or form in Luxembourg and/or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such
interests as well as (iii) the direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation
or which are members of its group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued
by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial
instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which it holds a
participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guarantees in
any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever; (iv) make
loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry out any
transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables, which are
directly or indirectly connected with its object.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

divided into five hundred (500) shares. Each issued share has a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) and is fully
paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Association or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may repurchase from its members, to offset any net realised losses, to make
distributions to the members in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. The single member may freely transfer its shares.
The shares may be transferred freely amongst members when the Company is composed of several members. Save

as otherwise provided by the Laws, the shares may be transferred to non-members only with the authorisation of mem-
bers representing at least three quarters of the issued capital, given at a general meeting of members.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in accordance
with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Association and the resolutions adopted by the

single member or the general meeting of members.

Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the Laws.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or

several times by a resolution of the single member or, as the case may be, of the general meeting of members adopted
in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws
for any amendment of these Articles of Association.

The Company may acquire its own shares in view of and subject to their immediate cancellation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a member. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar

event affecting the single member or any of the members does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Managers, Statutory Auditor

Art. 9. Management. The Company shall be managed by one or two managers, acting jointly, who need not be members

(the «Manager(s)») or by a board of Managers, composed of not less than three members, who need not be members
(the «Board of Managers»).

The Manager(s) or, as the case may be, the members of the Board of Managers, will be elected by the single member

or, as the case may be, by the general meeting of members, who will determine their number and the term of their office.
He(they) will hold office until their successors are elected. He(they) are re-eligible and he(they) may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution adopted by the single member or, as the case may be, by the general meeting
of members.

18783

The Board of Managers (if any) will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint

a secretary, who need not be a member of the Board of Managers, who will be responsible for keeping the minutes of
the meetings of the Board of Managers (the «Secretary»).

The Board of Managers (if any) will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers(if any) must

be convened if any two of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers(if any), except that in his absence the Board of

Managers(if any) may appoint another member of the Board of Managers(if any) as chairman pro tempore by vote of the
majority present at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's notice of Board

of Managers meetings (if any) shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the
transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and
the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, transmitted by any means
of communication allowing for the transmission of a written text, of each member of the Board of Managers (if any). No
separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Managers (if any).

Every Board of Managers meeting (if any) shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers

(if any) may from time to time determine. Any member of the Board of Managers (if any) may act at any meeting of the
Board of Managers (if any) by appointing in writing another member of the Board of Managers (if any) as his proxy.

A quorum of the Board of Managers (if any) shall be the presence or the representation of a majority of the members

of the Board of Managers (if any) holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the
Board of Managers (if any) present or represented at such meeting.

One or more members of the Board of Managers (if any) may participate in a meeting by means of a conference call

or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously commu-
nicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Board of Managers (if any), is proper and valid

as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers (if any) which was duly convened and held. Such a
decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of
them signed by one or several members of the Board of Managers (if any).

The members shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Management. The Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers, is(are) vested with

the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not
expressly reserved by the Articles of Association or by the Laws to the single member or, as the case may be, the general
meeting of members are in the competence of the Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers.

Art. 11. Management Fees and Expenses. The Manager(s) or as the case may be, the members of the Board of Managers,

may receive a management fee in respect of the carrying out of his(their) management of the Company and shall in addition
be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation with such management of the
Company or the pursuit of the Company's corporate object.

Art. 12. Managers' Liability. No Manager or, as the case may be, no member of the Board of Managers commits itself,

by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.
Any such Manager or member of the Board of Managers is only liable for the performance of its duties.

Art. 13. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) or as the case may be, the Board of

Managers may delegate special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary functions to persons
or committees of its choice.

The Company will be bound towards third parties by the single signature of any Manager or by the joint signature of

any two members of the Board of Managers.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any persons to

whom special signatory power has been delegated by the Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers, within
the limits of such special power.

Art. 14. Conflicts of interest - Indemnity. No contract or other transaction between the Company and any other

company or firm shall be affected or invalidated by the fact that a member of the Board of Managers, the Manager(s),
officers or employees of the Company have a personal interest in, or is a shareholder, director, manager, officer or
employee of such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the
Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason solely of such affiliation with such other
company or firm, be prevented from considering, voting or otherwise acting upon any matters with respect to such
contract or business.

Notwithstanding the above, in the event that any member of the Board of Managers or any Manager (in case there are

two) has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such member of the Board of Managers

18784

or such Manager shall make known such personal interest to the Board of Managers or the other Manager and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such interest of the member of the Board of Managers
or of any Manager therein shall be reported to the next general meeting of members.

The Company shall indemnify the members of the Board of Managers, the Manager(s), officers or employees of the

Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages to be paid and expenses
reasonably incurred by them in connection with any action, suit or proceeding to which they may be made a party by
reason of them being or having been members of the Board of Managers, Managers, officers or employees of the Company,
or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by
which they are not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which they shall be finally adjudged in
such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification
shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised
by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right
of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the present Articles
of Association may be entitled.

Art. 15. Records of Manager Resolutions. The resolutions of the Manager(s) (if any) shall be recorded in writing. Copies

or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by any one Manager.

The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will

remain attached thereto. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise
will be signed by the Chairman and by the Secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 16. Auditors. The business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and

and accounts, may and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more auditors, who need not be members.

The auditor(s) will be elected by the single member or, as the case may be, by the general meeting of members, who

will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are
elected. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by
the single member of, as the case may be, by the general meeting of members.

Chapter IV. General Meeting of Members

Art. 17. Powers of the Meeting of Members. Any regularly constituted meeting of members of the Company represents

the entire body of members.

The general meeting of members shall have such powers as are vested with the general meeting of members pursuant

to these Articles of Association and the Laws.

If the Company is composed of one single member, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of members. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting of members, to be held only if the Company has more

than twenty-five (25) members, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be
specified in the notice convening the meeting, on the last day of May at 11.00 a.m.

If such day is a public holiday, a Saturday or a Sunday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 19. Other General Meetings. If the Company is composed of no more than twenty five (25) members, the decisions

of the members may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the
Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers to the members in writing and transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text. In this latter case, the members are under the obligation
to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote
and send it to the Company by any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum
and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of members shall mutatis
mutandis apply to the adoption of written resolutions.

Unless there is only one single member, the members may meet in a general meeting of members upon issuance of a

convening notice in compliance with these Articles of Association or the Laws, by the Manager(s) or, as the case may be,
the Board of Managers, subsidiary, by the statutory auditor (if any) or, more subsidiary, by members representing half
the corporate capital. The convening notice sent to the members will specify the time and place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of members. The agenda
for an extraordinary general meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of
Association and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company. If all the
members are present or represented at a general meeting of members and if they state that they have been informed of
the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Members' meetings, including the annual general meeting of members (if any), may be held abroad if, in the judgement

of the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Attendance - Representation at a Meeting of Members. All members are entitled to attend and speak at any

general meeting of members.

18785

A member may act at any general meeting of members by appointing in writing, to be transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a member himself. The
Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, may determine the form of proxy and may request that the
proxies be deposited at the place indicated by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers at least five
days prior to the date set for the meeting. Any legal entity, being a member, may execute a form of proxy under the hand
of a duly authorised officer, or may authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any general meeting
of members, subject to the production of such evidence of authority as the Manager(s) or, as the case may be, the Board
of Managers, may require. The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers may determine any other
conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of members.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners

of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at any general
meeting of members.

Art. 21. Proceedings at a Meeting of Members. Any general meeting of members shall be presided by the Chairman

or by a person designated by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

The chairman of the general meeting of members shall appoint a secretary.
The general meeting of members shall elect one scrutineer to be chosen from the members present or represented.
The chairman, the secretary and the scrutineer thus appointed together form the board of the general meeting.

Art. 22. Vote at a Meeting of Members. An attendance list indicating the name of the members and the number of

shares for which they vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of
the general meeting of members.

The general meeting of members may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of members resolves to adopt

another voting procedure.

At any general meeting of members other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amending

the Company's Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority
requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions shall be adopted by a majority of members
present or represented, representing at least half of the issued capital.

At any extraordinary general meeting of members, convened in accordance with these Articles of Association or the

Laws, for the purpose of amending the Company's Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is
subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions are validly
adopted only by a majority of members representing at least three quarters of the issued capital.

Art. 23. Minutes of member(s)' resolutions. The minutes of the general meeting of members shall be signed by the

chairman of the meeting, the secretary of the meeting and the scrutineer of the meeting and may be signed by any members
or proxies of members, who so request.

The resolutions adopted by the single member shall be documented in writing and signed by the single member.
Copies or extracts of the resolutions adopted by the single member, of the minutes of the general meeting of members

as well as the written members resolutions to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
Chairman or any Manager.

Chapter V. Financial Year, Distribution of earnings

Art. 24. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January in each year and ends on the

thirty-first day of December in the same year.

Art. 25. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Manager(s)

or, as the case may be, the Board of Managers draw(s) up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the
profit and loss account, in accordance with the Laws and Luxembourg accounting practice.

The annual accounts are submitted to the single member or, as the case may be, to the general meeting of members,

who shall consider and, if thought fit, adopt these annual accounts.

Prior to such approval, each member or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered

office of the Company. If the Company is composed of more than 25 members, such right may only be exercised within
a time period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of members.

Art. 26. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company at least five per cent (5%) shall each

year be allocated to the reserve required by law (the «Legal Reserve»). That allocation to the Legal Reserve will cease
to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the
Company.

After the allocations to the Legal Reserve, the single member or, as the case may be, the general meeting of members

shall determine how the remainder of the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the
remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, together

18786

with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the members, each share entitling to the same
proportion in such distributions.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) or, as the

case may be, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends to the members. The Manager(s) or,
as the case may be, the Board of Managers fixe(s) the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 27. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved prior to the term provided in article 4 of the present

Articles of Association, by a resolution of the single member, or, as the case may be, by the general meeting of members
adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be,
by the Laws for any amendment of these Articles of Association.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or, as the case may be, the

Board of Managers or such other person (who may be physical persons or legal entities) appointed by the single member
or, as the case may be, by the general meeting of members, who will determine their powers and their compensation.

After payment of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the members in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same economic result as the distribution rules set our for dividend distributions.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 28. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accordance

with the Laws, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Kapitel I. Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form, Name. Durch den Alleingesellschafter ist hiermit eine Gesellschaft (die «Gesellschaft») in Form einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet worden, die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (die «Ge-
setze») und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die «Satzung») unterliegt.

Die Gesellschaft besteht ursprünglich aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist. Die

Gesellschaft kann jedoch zu jeder Zeit insbesondere nach einer Übertragung oder einer Neuausgabe von Gesellschafts-
anteilen aus mehreren Gesellschaftern bestehen, deren Zahl, vierzig (40) nicht übersteigen darf.

Die Gesellschaft existiert unter dem Namen SaarGummi TECHNOLOGIES, S.à r.l.

Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Schengen.
Der Gesellschaftssitz kann aufgrund eines Beschlusses des/der Geschäftsführer(s) oder des Geschäftsführungsrates an

jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Schengen verlegt werden.

Zweigniederlassungen oder andere Büros der Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland können

durch einen Beschluss des/der Geschäftsführer(s) oder des Geschäftsführungsrates errichtet werden.

Sollte(n) der/die Geschäftsführer(s) oder der Geschäftsführungsrat der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereig-

nisse  politischer,  wirtschaftlicher  oder  sozialer  Art  aufgetreten  sind  oder  unmittelbar  bevorstehen,  die  die  normale
Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz beziehungsweise
zwischen dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorü-
bergehend, bis zur völligen Beilegung der außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vorüberge-
hende Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf das Statut der Gesellschaft, welche unbeschadet der provisorischen
Verlegung ihres Sitzes weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unterliegt. Diese vorübergehende Maßnahme ist von
dem/den Geschäftsführer(n) oder dem Geschäftsführungsrate zu beschließen und den hiervon betroffenen Dritten mit-
zuteilen.

Art. 3. Ziel. Der Zweck der Gesellschaft ist (i) der Kauf und das Halten von Darlehens- und/oder Kapitalbeteiligungen

in jeder Art oder Form in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, (ii) die Verwaltung, Entwicklung und
Betreuung solcher Instrumente sowie (iii) die mittelbare und/oder unmittelbare finanzielle Unterstützung der Unterneh-
men in denen sie Anteile hält oder welche der Gesellschaftsgruppe angehören.

Die Gesellschaft kann insbesondere (i) mittels Zeichnung, Ankauf, Tausch oder auf jede andere Weise, Aktien, Anteile

und andere Wertpapiere, Anleihen, Schuldverschreibungen, Hinterlegungsscheine und andere Schuldtitel oder mehr all-
gemein  jegliche  Wert-  und  Handelspapiere  die  Eigentumsrechte,  Forderungen  oder  von  öffentlichen  oder  privaten
Emittenten ausgestellte übertragbare Wertpapiere verkörpern erwerben; (ii) alle Rechte ausüben, die diesen Wert- und
Handelspapieren anhängen; (iii) den Unternehmen, in denen sie Anteile hält oder welche der Gesellschaftsgruppe ange-
hören, mittelbare und/oder unmittelbare finanzielle Unterstützung gewähren, insbesondere mittels der Gewährung von
Darlehen, Kreditlinien und Sicherheiten in jeglicher Form und für jegliche Dauer, und ihnen Rat und Betreuung in jeder
Form gewähren; (iv) Darlehen in jeglicher Form aufnehmen und/oder, ohne öffentliches Angebot, Schuldtitel in jeglicher
Form auflegen und (v) jegliche Geschäfte durchziehen, ob wirtschaftlicher, industrieller oder finanzieller Natur, mit Bezug
auf bewegliche und unbewegliche Güter die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gesellschaftsgegenstand verbunden sind.

18787

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Kapitel II. Kapital, Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünf-hundert Euro (EUR

12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile. Jedes Anteil hat einen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-)
und ist vollständig eingezahlt.

Jedes Anteil ist vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes oder der vorliegenden Satzung mit denselben

Rechten und Pflichten ausgestattet.

Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgelder,

die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses Aufgeld-
kontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zum Ausgleich von
realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter in Form von Dividenden oder zur Bereitstellung der
gesetzlichen Rückstellungen genutzt werden.

Art. 6. Anteile. Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. An Nichtge-

sellschafter, und falls nicht anders verfügt durch gesetzliche Bestimmungen, dürfen die Anteile nur mit dem bei einer
Hauptversammlung erklärten Einverständnis der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des ausgegebenen Kapitals
darstellen, übertragen werden.

Die Übertragung von Anteilen muss durch eine notarielle Urkunde oder durch einen privatschriftlichen Vertrag belegt

werden. Solange eine solche Übertragung der Gesellschaft nicht ordnungsgemäß angezeigt oder von ihr angenommen
worden ist gemäss den in Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Luxemburgs über die Forderungsübertragung fest-
gelegten Regeln, ist jene Übertragung der Gesellschaft und Dritten gegenüber nicht bindend.

Das Eigentum an einem Anteil beinhaltet zugleich implizit das Einverständnis mit der Satzung und den von dem Allein-

gesellschafter oder denen von der Hauptversammlung angenommenen Beschlüssen.

Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme, vorbehaltlich der durch die Gesetze auferlegten Beschränkungen.

Art. 7. Erhöhung oder Herabsetzung des Kapitals. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehr-

fach durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, wo dies der Fall ist, der Hauptversammlung, der in Überein-
stimmung mit den, nach dieser Satzung oder den zur Änderung dieser Satzung ergangenen Gesetzen, erforderlichen
Quorum und Mehrheiten, angenommen wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Die Gesellschaft darf ihre eigenen Anteile nur unter Berücksichtigung ihrer unverzüglichen Annullierung erwerben.

Art. 8. Handlungsunfähigkeit oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die Handlungsunfähigkeit oder Insolvenz oder ein

vergleichbarer, den Alleingesellschafter oder einen anderen Gesellschafter betreffenden Umstand führt die Gesellschaft
nicht zur Auflösung.

Kapitel III. Geschäftsführer, Revisoren

Art. 9. Verwaltung. Die Gesellschaft wird durch einen oder zwei Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen,

(die «Geschäftsführer») gemeinschaftlich oder durch ein Gremium von Geschäftsführern geleitet, das aus nicht weniger
als drei Mitgliedern besteht, die nicht Gesellschafter sein müssen (der «Geschäftsführungsrat»), verwaltet.

Der/die Geschäftsführer oder, je nachdem, die Mitglieder des Geschäftsführungsrates werden von dem Alleingesell-

schafter oder, wo dies der Fall ist, von der Hauptversammlung gewählt, die ihre Anzahl und ihre Amtsdauer festlegen. Sie
verbleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Sie sind erneut wählbar und können jederzeit, mit oder ohne Angabe
von Gründen, durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, wo dies der Fall ist, der Hauptversammlung abberufen
werden.

Der Geschäftsführungsrat (falls es einen solchen gibt) ernennt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden (der «Vor-

sitzende»). Der Geschäftsführungsrat (falls es einen solchen gibt) kann ebenso einen Schriftführer ernennen, der nicht
Mitglied des Geschäftsführungsrates sein muss und der für die Protokollführung während der Sitzungen des Geschäfts-
führungsrates verantwortlich ist (der «Schriftführer»).

Der Geschäftsführungsrat (falls es einen solchen gibt) tritt nach Einberufung durch den Vorsitzenden zusammen. Eine

Sitzung des Geschäftsführungsrats (falls es einen solchen gibt) muss ferner auf Wunsch zweier seiner Mitglieder einberufen
werden.

Der Vorsitzende steht allen Sitzungen des Geschäftsführungsrats (falls es einen solchen gibt) vor, es sei denn, dass der

Geschäftsführungsrat  (falls  es  einen  solchen  gibt)  wegen  der  Abwesenheit  des  Vorsitzenden  ein  anderes  Mitglied  als
Vorsitzenden auf Zeit durch Mehrheitswahl in dieser Sitzung ernannt hat.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei einer vorher erteilten Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die

Sitzungen des Geschäftsführungsrats (falls es einen solchen gibt) eine Woche vor ihrem Termin schriftlich durch ein, die
Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium einberufen. Jedes dieser Einberufungsschreiben soll Ort und
Zeit der Sitzung sowie die Tagesordnung und die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Jedes Mitglied
des  Geschäftsführungsrats  (falls  es  einen  solchen  gibt)  kann  schriftlich  durch  ein,  die  Schriftlichkeit  gewährleistendes
Kommunikationsmedium auf die Benachrichtigung verzichten. Für Sitzungen, deren Veranstaltungsort und Zeit in einem

18788

zuvor angenommenen Beschluss des Geschäftsführungsrats (falls es einen solchen gibt) festgelegt worden sind, ist keine
gesonderte Benachrichtigung erforderlich.

Jede Geschäftsführungsratssitzung findet in Luxemburg oder an jedem anderen Ort, den der Geschäftsführungsrat (falls

es einen solchen gibt) hierfür bestimmt hat, statt. Jedes Geschäftsführungsratsmitglied kann sich bei den Geschäftsfüh-
rungsratssitzungen durch ein anderes Geschäftsführungs-ratsmitglied vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich
bevollmächtigt.

Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrats (falls es einen solchen gibt) erfordert die Anwesenheit einer Mehrheit

von  Mitglieder.  Entschlüsse  werden  per  Mehrheitsentscheid  aller  bei  der  Sitzung  anwesenden  oder  vertretenen  Ge-
schäftsführungsratsmitglieder gefasst.

Ein oder mehrere Geschäftsführungsratsmitglieder können an einer Sitzung durch eine Telefonkonferenzschaltung

oder durch ähnliche, gleichzeitige und gegenseitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellende Mittel
teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit in einer Sitzung gleich gestellt.

In Dringlichkeitsfällen steht eine von allen Geschäftsführungsratsmitgliedern unterzeichnete Entscheidung einem Be-

schluss gleich, der in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsratssitzung gefasst worden
wäre. Ein solcher Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben
Inhalts und jeweils von einem oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet festgehalten sein.

Die Gesellschafter sollen weder an der Geschäftsführung der Gesellschaft teilnehmen noch sich in diese einmischen.

Art. 10. Befugnisse des/der Geschäftsführer(s). Der/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, der Geschäftsführungsrat

haben die weitest gehenden Befugnisse, um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen
Handlungen  vorzunehmen.  Sämtliche  Befugnisse,  die  die  Satzung  oder  die  Gesetze  nicht  ausdrücklich  der  Hauptver-
sammlung übertragen haben, fallen in die Zuständigkeit des/der Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, des Geschäftsfüh-
rungsrates.

Art. 11. Kosten der Geschäftsführung und Ausgaben. Der/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, die Mitglieder des

Geschäftsführungsrates dürfen zur Ausführung der Verwaltung eine Vergütung erhalten und ferner einen Ersatz aller
Aufwendungen, die sie hierbei oder bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks gemacht haben, erhalten.

Art. 12. Haftung der Geschäftsführung. Einen Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, kein Mitglied des Geschäftsfüh-

rungsrates trifft keine persönliche Haftung hinsichtlich der aufgrund seiner Funktion für die Gesellschaft eingegangen
Verpflichtungen. Jeder Geschäftsführer oder jedes Mitglied des Geschäftsführungsrates ist nur für die Ausführung seiner
Aufgaben verantwortlich.

Art. 13. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Der/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls,

der Geschäftsführungsrat können einer oder mehreren Personen oder Ausschüsse seiner/ihrer Wahl besondere Befug-
nisse oder Vollmachten übertragen oder letztere mit dauernden oder zeitweisen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers oder die ge-

meinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführungsrates vertreten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber ferner durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift

derjenigen Person(en) vertreten, denen die besondere Zeichnungsbefugnis von dem/den Geschäftsführer(n) oder, gege-
benenfalls, dem Geschäftsführungsrat übertragen wurde, aber immer nur im Rahmen dieser besonderen Zeichnungsvoll-
macht.

Art. 14. Interessenkonflikte-Freistellung. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und

einer anderen Gesellschaft oder einer anderen Firma werden in ihrer Wirksamkeit dadurch beeinflusst werden, dass ein
oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates, ein Geschäftsführer, einer oder mehrere der Angestellten oder
Arbeitnehmer der Gesellschaft ein persönliches Interesse bezüglich der anderen Gesellschaft oder Firma haben oder ein
Anteilsinhaber, Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer, Angestellter oder Arbeitnehmer der anderen Gesellschaft oder
Firma sind. Jede Person, die in der zuvor beschriebenen Weise mit einer Gesellschaft oder einer Firma verbunden ist und
mit denen die Gesellschaft vertraglich oder in anderer Weise in Geschäftsbeziehungen treten wird, soll nicht alleine wegen
dieser Verbindung, an der Abstimmung oder der Vornahme anderer Handlungen in Bezug auf einen solchen Vertrag oder
sonstigen Geschäftstätigkeit gehindert sein.

Ungeachtet des Vorstehenden soll jedes Mitglieder des Geschäftsführungsrates oder jeder Geschäftsführer (sollte es

zwei geben) im Falle eines persönlichen Interesses an einer Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, dies dem Geschäftsfüh-
rungsrates oder jeweils anderen Geschäftsführer bekannt machen und nicht über diese Geschäftstätigkeit der Gesellschaft
mit beraten oder abstimmen. Diese Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und das persönliche Interesse des Mitglieds des
Geschäftsführungsrates oder des Geschäftsführers ist der nächsten Hauptversammlung zu berichten.

Die Gesellschaft wird die Mitglieder des Geschäftsführungsrates oder die Geschäftsführer Verwaltungsratsmitglieder

oder die Angestellten oder Arbeitnehmer, und, wo dies der Fall ist, deren Nachkommen, Erben, Erbvollstrecker und
Verwalter für sämtlichen Schadensersatz und vernünftige Auslagen, die sie in ihrer Eigenschaft als Partei im Zusammenhang
mit einer Handlung, einer Klage oder einem Verfahren in ihrer Eigenschaft als Anteilsinhaber, Geschäftsführungsratsmit-
glied,  Geschäftsführer,  Angestellter  oder  Arbeitnehmer  der  Gesellschaft,  oder,  auf  Verlangen  der  Gesellschaft,  jeder
anderen Gesellschaft, deren Anteilsinhaber oder Gläubiger die Gesellschaft ist, zahlen mussten und für die sie keine

18789

anderweitige Entschädigung bekommen, entschädigen. Diese Entschädigung spielt nur mit Ausnahme der Angelegenheiten,
derentwegen die vorgenannten Personen in besagter Handlung, Klage oder Verfahren wegen grober Fahrlässigkeit oder
Misswirtschaft verurteilt wurden. Im Falle einer Einigung bezieht sich die Entschädigung nur auf jene Punkte der Einigung,
zu denen der Gesellschaft von ihrem Rechtsberater dargelegt wurde, dass die zu entschädigende Person sich keiner groben
Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft schuldig gemacht hat. Das vorgenannte Recht auf Entschädigung schließt keine anderen
Entschädigungsansprüche, zu welchen die Satzung berechtigt, aus.

Art. 15. Aufzeichnung der Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse des/der Geschäftsführer, soweit vorhan-

den, sollen schriftlich festgehalten werden. Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, die in rechtlichen Verfahren oder
anderweitig übermittelt werden, unterzeichnen einer der Geschäftsführer.

Die Protokolle der Geschäftsführungsratssitzung werden von dem Vorsitzenden unterzeichnet. Jede erteilte Vollmacht

bleibt dem Protokoll beigefügt.

Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, unter-

zeichnen der Vorsitzende und, soweit vorhanden, der Schriftführer oder zwei andere Mitglieder des Geschäftsführungs-
rates.

Art. 16. Wirtschaftsprüfer. Die Geschäfte der Gesellschaft und ihre finanzielle Situation, einschliesslich der Bücher und

Konten, werden und müssen, in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, von einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern,
die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, durchgesehen.

Die Wirtschaftsprüfer werden von dem Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, vom Geschäftsführungsrat, die deren

Anzahl festlegen, für einen Zeitraum gewählt, der sechs Jahre nicht überschreiten darf, und sie bleiben im Amt, bis ihre
Nachfolger gewählt sind. Sie sind wieder wählbar, können jedoch jederzeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss
des Geschäftsführers oder, gegebenenfalls, des Geschäftsführungsrats abberufen werden.

Kapitel IV. Hauptversammlung

Art. 17. Befugnisse der Hauptversammlung. Jede ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung vertritt die Gesamt-

heit der Gesellschafter (die «Hauptversammlung»).

Sie besitzt die ihr nach dieser Satzung und nach den Gesetzen zukommenden Befugnisse.
Besteht die Gesellschaft nur aus einem Alleingesellschafter, übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der Haupt-

versammlung übertragen hat. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10.
August 1915 sind hierauf nicht anwendbar.

Art. 18. Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung der Gesellschafter, die lediglich abzuhalten ist, wenn

die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter hat, wird am Sitz der Gesellschaft oder an jedem anderen, in der
Hinweisbekanntmachung spezifizierten Platz am letzten Tag des Monats Mai um 11 Uhr abgehalten.

Fällt dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag, auf einen Samstag oder einen Sonntag, wird die Versammlung am

nächstfolgenden Geschäftstag abgehalten.

Art. 19. Weitere Generalversammlungen. Besteht die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig Gesellschaftern,

können die Gesellschafter über den Text der anzunehmenden Beschlüsse, der ihnen von dem/den Geschäftsführern oder,
gegebenenfalls, vom Geschäftsführungsrat schriftlich durch ein die Schriftlichkeit des Textes gewährleistendes Medium
übermittelt wird, in schriftlicher Abstimmung entscheiden. Im letzteren Fall sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb
einer Frist von fünfzehn Tagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen
und sie der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistende Medium zukommen zu lassen. Die zur Beschluss-
fassung erforderlichen Quorum und Mehrheiten bei Beschlüssen der Hauptversammlung sind mutatis mutandis auf die
Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.

Außer in Fällen eines Alleingesellschafters, können die Gesellschafter auf Einberufungsschreiben, ausgegeben in Über-

einstimmung mit dieser Satzung und den Gesetzen, durch den/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, den Geschäfts-
führungsrat, in zweiter Linie durch die Revisoren und nachrangig nach diesen, durch die Gesellschafter, die die Hälfte des
Gesellschaftskapitals vertreten, zusammentreten. Das an die Gesellschafter versandte Einberufungsschreiben gibt den Ort
und die Zeit sowie die Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftspunkte der jeweiligen Hauptversammlung
an. Die Tagesordnung einer außerordentliche Hauptversammlung muss, insofern angebracht, die vorzunehmenden Än-
derungen in der Satzung beschreiben und, soweit erforderlich, den Wortlaut der Änderungen ausführen, die Auswir-
kungen auf Gesellschaftszweck und -form der Gesellschaft haben.

Sind alle Gesellschafter bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, über die Tagesordnung

der Versammlung unterrichtet zu sein, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Hauptversammlungen sowie die Jahreshauptversammlung können außer Landes abgehalten werden, wenn dies nach

dem endgültigen Urteil des/der Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, des Geschäftsführungsrates durch die Umstände
höherer Gewalt angebracht ist.

Art. 20. Teilnahme - Vertretung bei den Gesellschafterversammlungen. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Haupt-

versammlung ein Teilnahme- und ein Rederecht.

18790

Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit wahrende Übertra-

gungsweise übermittelt wurde, bei jeder Hauptversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst Gesellschafter
sein muss, vertreten lassen. Der/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, der Geschäftsführungsrat können die Form
der Vertretungserklärung sowie deren Hinterlegung mindestens fünf Tage vor Sitzungsbeginn festlegen. Jede juristische
Person, die Gesellschafter ist, kann ihre Vertretungserklärung durch einen ordnungsgemäß ernannten Vertreter erstellen
oder eine ihr geeignet erscheinende Person zur Vertretung bei einer Hauptversammlung ernennen, jedoch unter der
Bedingung des Ermächtigungsnachweises auf Verlangen des/der Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, des Geschäftsfüh-
rungsrates. Der/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, der Geschäftsführungsrat kann/können weitere Bedingungen,
die zur Teilnahme an einer Hauptversammlung erfüllt sein müssen aufstellen.

In Bezug auf die Gesellschaft ist jeder Anteil unteilbar. Die Miteigentumsinhaber, die Nießbraucher und die bloßen

Eigentümer von Anteilen, sowie die Pfandgläubiger und die Pfandschuldner von Anteilen müssen einen einzigen Vertreter
zu ihrer Vertretung bei der Hauptversammlung bestimmen.

Art. 21. Verfahren bei den Gesellschafterversammlungen. Der Vorsitzende oder eine von dem/den Geschäftsführer

(n) oder, gegebenenfalls, dem Geschäftsführungsrat bestimmte Person steht jeder Hauptversammlung vor.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung wird einen Schriftführer ernennen.
Die Hauptversammlung wird aus den anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern einen Stimmenzähler wählen.
Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler bilden zusammen den Vorstand der Hauptversammlung.

Art. 22. Abstimmung bei der Gesellschafterversammlung. Eine Anwesenheitsliste, die die Namen der Gesellschafter

und die Anzahl ihrer zur Abstimmung berechtigenden Anteile angibt, wird von den Gesellschaftern oder von ihren Ver-
tretern vor der Eröffnung der Hauptversammlung unterzeichnet.

Die Hauptversammlung darf nur über solche Punkte beraten und abstimmen, die auf der Tagesordnung aufgeführt sind.
Die Abstimmungen finden per Handzeichen oder durch Namensaufruf statt, falls nicht die Hauptversammlung be-

schlossen hat ein anderes Abstimmungsverfahren anzunehmen.

Bei jeder Hauptversammlung, mit Ausnahme der außerordentlichen, die zum Zwecke der Abänderung der Satzung

oder zur Abstimmung über Beschlüsse, deren Annahme den Quorum- oder Mehrheitserfordernissen einer Abänderung
der Satzung unterliegt, werden die Beschlüsse von einer Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern, die
die Hälfte des ausgegebenen Kapitalsvertreten, angenommen.

Bei jeder Hauptversammlung, die zum Zwecke der Abänderung der Satzung oder zur Abstimmung über Beschlüsse,

deren Annahme den Quorum- oder Mehrheitserfordernissen einer Abänderung der Satzung unterliegt, einberufen wurde,
werden Beschlüsse gültig durch eine Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des ausgegebenen Kapital-
svertreten, angenommen.

Art. 23. Protokoll.  Das  Sitzungsprotokoll  der  Hauptversammlung  wird  vom  Vorsitzenden  der  Versammlung,  dem

Schriftführer und dem Stimmenzähler der Versammlung unterzeichnet. Es kann auf Verlangen von jedem Gesellschafter
oder Vertreter eines Aktionärs unterzeichnet werden.

Die von dem Alleingesellschafter angenommenen Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleinge-

sellschafter unterzeichnet.

Kopien oder Auszüge der von dem Alleingesellschafter angenommenen Beschlüsse, des Sitzungsprotokolls der Ge-

sellschafterversammlung  sowie  die  schriftlichen  Beschlüsse  der  Gesellschafter,  die  in  gerichtlichen  Verfahren  oder
anderweitig übermittelt werden, sollen von dem Vorsitzenden oder einem der Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Ausschüttung und Verteilung von gewinnen

Art. 24. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31.

Dezember des selben Jahres.

Art. 25. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Finanzjahres werden die Konten geschlossen und der

Geschäftsführungsrat oder der/die Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen
und den luxemburgischen Buchhaltungsvorschriften ein Verzeichnis der Vermögensanlagen und Verpflichtungen, die Bilanz
und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Dieser Jahresabschluss wird dem Alleingesellschafter oder, wo dies der Fall ist, der Hauptversammlung unterbreitet,

die hierüber beraten und, im Falle der Zustimmung, diesen annehmen wird.

Vor dieser Annahme, kann jeder Gesellschafter oder sein Berater die finanztechnischen Unterlagen am Gesellschafts-

sitz durchlesen. Besteht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während
einer Zeitspanne von fünfzehn Tagen vor dem Datum der Jahreshauptversammlung ausgeübt werden.

Art. 28. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens 5% der gesetzlich

vorgesehenen Rückstellungen (die «gesetzliche Rückstellung») zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt, sobald die ge-
setzliche Rückstellung die Höhe von 10% des ausgegebenen Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Nach der Bereitstellung der gesetzlichen Rückstellung wird der Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, die Haupt-

versammlung festlegen, wie der verbleibende Überschuss an Reingewinn verteilt werden soll; ob durch vollständige oder

18791

teilweise Bildung einer Rückstellung oder als Zuweisung zu einer Provisionszahlung; durch Übernahme bis in das nächste
Geschäftsjahr oder durch Ausschüttung, gemeinsam mit den übernommenen Gewinnen, den ausschüttungsfähigen Rück-
stellungen oder den Ausgabenprämien, an die Gesellschafter, wobei jeder Anteil zu einer gleich großen Berücksichtigung
bei der Ausschüttung berechtigt.

Vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestim-

mungen,  kann  der  Geschäftsführungsrat  oder  der/die  Geschäftsführer  eine  Abschlagsdividende  an  die  Gesellschafter
auszahlen. Der Geschäftsführungsrat oder der/die Geschäftsführer legen die Summe und das Datum einer solchen Ab-
schlagszahlung fest.

Kapitel VI. Auflösung, Abwicklung

Art. 29. Auflösung, Abwicklung. Die Gesellschaft kann zu einem früheren als dem in Artikel 4 dieser Satzung vorge-

sehenen Zeitpunkt durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, wo dies der Fall ist, der Hauptversammlung, der
in Übereinstimmung mit den nach dieser Satzung oder den zur Änderung dieser Satzung ergangenen Gesetzen, erfor-
derlichen Quorum und Mehrheiten gefasst worden ist, aufgelöst werden.

Wird die Gesellschaft aufgelöst, soll ihre Abwicklung von dem Geschäftsführungsrat oder dem/den Geschäftsführern

oder jeder anderen (natürlichen oder juristischen) Person ausgeführt werden, deren Befugnisse und deren Vergütung von
dem Alleingesellschafter oder, wo dies der Fall ist, von der Hauptversammlung festgelegt werden.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche wird der Reinerlöse

aus der Abwicklung an die Gesellschafter so verteilt, dass ihre Grundlage insgesamt der wirtschaftlich anvisierten Aus-
schüttung der Dividenden entspricht.

Kapitel VII. Anwendbares Recht

Art. 28. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegende Satzung geregelt sind, be-

stimmen sich nach den Gesetzen, insbesondere nach dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915,
in seiner zuletzt geltenden Fassung.

Senningerberg, den 13. November 2006.

Für koordinierte Satzung vom 27. April 2006.
P. Bettingen
<i>Notar

In the year two thousand seven, on the sixth day of the month of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

SG  SEALING  LTD,  a  company  organized  and  existing  under  the  laws  of  Guernsey,  having  its  registered  office  at

Bordeaux court, Les Echelons, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands, SY1 6AW, United Kindgom, with registration
number 42115 at the Guernsey Trade Register (the «Shareholder»),

here represented by M 

e

 Manfred Müller, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given at St. Peter Port, Guernsey, on December 3, 2007.
Said proxy, signed by the shareholder, the proxy holder and the instrumenting notary, shall be annexed to the present

deed for the purpose of registration.

The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of

the  Société  à  responsabilité  limitée  -  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  SaarGummi  TECHNOLOGIES  S.à  r.l.,  a
company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500.-), with registered office at 97, route du Vin, L-5445 Schengen, Grand Duchy of Luxembourg, and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-108.936 (the «Company»),
incorporated following a deed of the undersigned notary of June 20, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés  et  Associations,  number  1127  of  October  31,  2005.  The  articles  of  incorporation  have  last  been  amended
following a notariale deed enacted on April 27, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1642 of August 30, 2006.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the Company's subscribed capital by an amount of sixty-seven million eight hundred eight thousand two

hundred fifty euro (EUR 67,808,250.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro
(EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each to
sixty-seven million eight hundred twenty thousand seven hundred fifty euro (EUR 67,820,750.-), represented by two
million seven hundred twelve thousand eight hundred thirty (2,712,830) shares with a nominal value of twenty-five euro
(EUR 25.-) each.

18792

2. To issue two million seven hundred twelve thousand three hundred thirty (2,712,330) new shares, with a nominal

value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to be issued together with a share premium in the aggregate amount of eighteen
euro forty-seven cent (EUR 18.47), having the same rights as the existing shares and entitling to dividends as from the
day of the resolutions to be taken by the Shareholder, acting in lieu of an extraordinary general meeting of shareholders,
resolving on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription for these two million seven hundred twelve thousand three hundred thirty (2,712,330)

new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each by the Shareholder, and to accept payment in full
of the aggregate nominal value of such new shares and of the share premium thereon, by a contribution in kind consisting
of four hundred (400) ordinary B shares in MELODIA INVESTMENTS LIMITED, a company governed by the laws of
Gibraltar and having its registered office at 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar.

4. To amend article 5, first paragraph, of the Company's articles of incorporation so as to reflect the proposed capital

increase.

5. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions.

<i>First resolution

The Shareholder resolved to increase the Company's subscribed capital by an amount of sixty-seven million eight

hundred eight thousand two hundred fifty euro (EUR 67,808,250.-) so as to raise it from its present amount of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-
five  euro  (EUR  25.-)  each  to  sixty-seven  million  eight  hundred  twenty  thousand  seven  hundred  fifty  euro  (EUR
67,820,750.-), represented by two million seven hundred twelve thousand eight hundred thirty (2,712,830) shares with
a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to issue two million seven hundred twelve thousand three hundred thirty (2,712,330) new

shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to be issued together with a share premium in the
aggregate amount of eighteen euro forty-seven cent (EUR 18.47), having the same rights as the existing shares and entitling
to dividends as from the day of the present resolutions.

<i>Subscription - Payment

There now appeared M 

e

 Manfred Müller, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of the

Shareholder by virtue of the same proxy as referred here above.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Shareholder for the number of shares

mentioned hereafter and to make payment in full for each such new share thus subscribed, including any share premium
thereon, by a contribution in kind consisting of four hundred (400) ordinary B shares (the «Contribution») in MELODIA
INVESTMENTS LIMITED, a company governed by the laws of Gibraltar and having its registered office at 10/8 International
Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar, as follows:

Shareholder and subscriber

Subscribed

Number

Share

and paid-in

of shares premium

capital

(Euro)

(Euro)

SG SEALING LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,808,250.- 2,712,330

18.47

The Contribution represents a net contribution in an aggregate amount of sixty-seven million eight hundred eight

thousand two hundred sixty-eight euro forty-seven cent (EUR 67,808,268.47).

The Shareholder and subscriber, acting through its duly appointed attorney-in-fact, declared that there subsist no

impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without any restriction or limitation and that
valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform
a valid transfer of the Contribution to the Company.

Proof of the ownership by the Shareholder and subscriber of the Contribution has been given to the undersigned

notary.

The Shareholder and subscriber, acting through its duly appointed attorney-in-fact, further stated that a report has

been drawn up by the Shareholder, and signed by Mr Peter G. Radford, director of the Shareholder, wherein the Con-
tribution so contributed is described and valued.

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

<i>Third resolution

Thereupon, the Shareholder resolves to accept said subscription and payment by the subscriber and to allot the two

million seven hundred twelve thousand three hundred thirty (2,712,330) new shares of the Company to the Shareholder
as stated above.

18793

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the Shareholder resolves to amend the articles of incorporation as follows:

« Art. 5. Corporate Capital. (first paragraph). The issued capital of the Company is set at sixty-seven million eight

hundred twenty thousand seven hundred fifty euro (EUR 67,820,750.-), divided into two million seven hundred twelve
thousand eight hundred thirty (2,712,830) shares. Each issued share has a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-)
and is fully paid up.»

<i>Expenses

As following the contribution in kind to the Company made by the Shareholder, consisting of four hundred (400)

ordinary B shares in MELODIA INVESTMENTS LIMITED, prenamed, the Company holds more than 65% (in the present
case: 100%) of the issued share capital of MELODIA INVESTMENTS LIMITED, a company having its place of effective
management and statutory seat in a Member State of the European Union, and as the contribution in kind has been made
exclusively in exchange for newly issued shares in the capital of the Company, which has its place of effective management
and statutory seat in a Member State of the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated 29
December 1971, which provides for capital tax exemption in this case.

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

are estimated at six thousand six hundred euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden textes:

Im Jahre zweitausendsieben, am sechsten Dezember.
Erschien vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxem-

burg).

SG SEALING LTD, eine nach dem Recht der Kanalinseln gegründete Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in Bordeaux

court, Les Echelons, St. Peter Port, Guernsey, Kanalinseln, SY1 6AW, Vereinigtes Königreich, eingetragen im Handels-
register von Guernsey unter Nummer 42115 (die «Gesellschafterin»),

hier vertreten durch Maître Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben in St. Peter Port, Guernsey, am 3. Dezember 2007.
Die oben genannte Vollmacht, unterzeichnet von der Gesellschafterin, dem Bevollmächtigten und dem amtierenden

Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Gesellschafterin hat den amtierenden Notar angewiesen festzuhalten, dass die Gesellschafterin die Alleingesell-

schafterin der Société à responsabilité limitée - Gesellschaft mit beschränkter Haftung SaarGummi TECHNOLOGIES S.à
r.l. ist, einer Gesellschaft luxemburgischen Rechts mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12.500,-), Gesellschaftssitz in 97, route du Vin, L-5445 Schengen, Großherzogtum Luxemburg und eingetragen
ins Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 108.936 (die «Gesellschaft»), gegründet durch
notarielle Urkunde des amtierenden Notars vom 20. Juni 2005, die im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 1127 vom 31. Oktober 2005 veröffentlicht worden ist. Die Satzung der Gesellschaft ist zuletzt abgeändert
worden gemäß notarieller Urkunde vom 27. April 2006, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, Nummer 1642 vom 30. August 2006.

Die Gesellschafterin, vertreten wie eingangs erwähnt, erklärt ausführlich über die Beschlüsse, welche auf Basis der

folgenden Tagesordnung zu fassen sind, informiert zu sein:

<i>Tagesordnung:

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von siebenundsechzig Millionen achthundertachttausendzwei-

hundertfünfzig Euro (EUR 67.808.250,-), um das bestehende Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-),
eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile in einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), auf
siebenundsechzig Millionen achthundertzwanzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 67.820.750,-), eingeteilt in zwei
Millionen siebenhundert-zwölftausendachthundertdreißig (2.712.830) Gesellschaftsanteile in einem Nennwert von jeweils
fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), zu erhöhen.

2. Ausgabe von zwei Millionen siebenhundertzwölftausenddreihundertdreißig (2.712.330) neuen Gesellschaftsanteilen

in einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), zusammen mit einem Agio in einem Gesamtbetrag von
achtzehn Euro siebenundvierzig Cent (EUR 18,47), welche ab dem Tag der Beschlüsse des Gesellschafters -handelnd
anstelle  einer  außerordentlichen  Gesellschafterversammlung-  über  die  vorgeschlagene  Kapitalerhöhung,  die  gleichen

18794

Rechte wie die bestehenden Gesellschaftsanteile haben werden und welche an den Gewinnausschüttungen in der gleichen
Weise beteiligt sein werden.

3. Annahme der Zeichnung dieser zwei Millionen siebenhundertzwölftausenddreihundertdreißig (2.712.330) neuen

Gesellschaftsanteile in einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) durch die Gesellschafterin, Annahme
der vollständigen Einzahlung des Gesamtnennwertes dieser neuen Gesellschaftsanteile und des Agios durch eine Sach-
einlage, bestehend aus vierhundert (400) B-Stammanteilen der MELODIA INVESTMENTS LIMITED, einer Gesellschaft
die dem Recht Gibraltars unterliegt, mit Gesellschaftssitz in 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square,
Gibraltar.

4. Abänderung des Artikels 5, Absatz 1, der Satzung der Gesellschaft, um die vorgeschlagene Kapitalerhöhung wie-

derzugeben.

5. Verschiedenes.
Hat den Notar angewiesen, folgende Beschlüsse aufzunehmen:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterin hat die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von siebenundsechzig Millionen acht-

hundertachttausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 67.808.250,-) beschlossen, um das bestehende Kapital von zwölftau-
sendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile in einem Nennwert von jeweils
fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), auf siebenundsechzig Millionen achthundertzwanzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro
(EUR 67.820.750,-), eingeteilt in zwei Millionen siebenhundertzwölftausendachthundertdreißig (2.712.830) Gesellschafts-
anteile in einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), zu erhöhen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterin hat die Ausgabe von zwei Millionen siebenhundertzwölftausenddreihundertdreißig (2.712.330)

neuen Gesellschaftsanteilen in einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), zusammen mit einem Agio
in einem Gesamtbetrag von achtzehn Euro siebenundvierzig Cent (EUR 18,47), beschlossen, welche ab dem Zeitpunkt
vorliegender Beschlüsse die gleichen Rechte wie die bestehenden Gesellschaftsanteile haben und welche an den Gewinn-
ausschüttungen in der gleichen Weise beteiligt sind.

<i>Zeichnung und Erbringung der Sacheinlage

Daraufhin ist erschienen, Maître Manfred Müller, vorerwähnt, handelnd in seiner Eigenschaft als ordnungsgemäß be-

auftragter Bevollmächtigter der Gesellschafterin, aufgrund der eingangs erwähnten Vollmacht.

Die erschienene Person erklärt die hiernach angegebene Anzahl neuer Gesellschaftsanteile im Namen und für Rechnung

der Gesellschafterin wie folgt zu zeichnen und den Gesamtnennwert dieser neu ausgegebenen Gesellschaftsanteile, zu-
sammen mit diesbezüglichem Agio, durch eine Sacheinlage, bestehend aus vierhundert (400) B-Stammaktien (die «Sach-
einlage»)  der  MELODIA  INVESTMENTS  LIMITED,  einer  Gesellschaft  die  dem  Recht  Gibraltars  unterliegt,  mit
Gesellschaftssitz in 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar, vollständig wie folgt in die Ge-
sellschaft einzuzahlen:

Gesellschafter und Zeichner

Gezeichnetes

Anzahl

Agio

und eingezahltes

Anteile

(Euro)

Kapital

(Euro)

SG SEALING LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67.808.250,- 2.712.330

18,47

Die Sacheinlage entspricht einer Nettoeinlage in der Gesamthöhe von siebenundsechzig Millionen achthundertacht-

tausendzweihundertacht-undsechzig Euro siebenundvierzig Cent (EUR 67.808.268,47).

Die Gesellschafterin und Zeichnerin, vertreten durch ihren ordnungsgemäß beauftragten Bevollmächtigten, erklärt,

dass die Sacheinlage nicht dinglich oder in einer sonstigen Art und Weise belastet ist, dass der freien Übertragung der
Sacheinlage an die Gesellschaft kein Hindernis im Wege steht, und dass sämtliche Anweisungen zur Tätigung aller Mit-
teilungen, Registrierungen und sonstiger Formalitäten gegeben worden sind, die sich als notwendig erweisen, um die
Sacheinlage rechtswirksam an die Gesellschaft zu übertragen.

Der Nachweis des Eigentums der Gesellschafterin und Zeichnerin an der Sacheinlage ist dem amtierenden Notar

erbracht worden.

Die Gesellschafterin und Zeichnerin, vertreten durch ihren ordnungsgemäß beauftragten Bevollmächtigten, erklärt

weiterhin, dass die Gesellschafterin einen Bericht erstellt hat, der durch Herrn Peter G. Radford, dem Verwaltungsrat
der Gesellschafterin, unterzeichnet worden ist, und in dem die eingebrachte Sacheinlage beschrieben und bewertet wird.

Dieser Bericht bleibt vorliegender Urkunde beigefügt und wird mit ihr zusammen bei den Einregistrierungsbehörden

hinterlegt.

<i>Dritter Beschluss

Schließlich beschließt die Gesellschafterin vorgenannte Zeichnung und Zahlung durch die Zeichnerin anzunehmen und

der Gesellschafterin die zwei Millionen siebenhundertzwölftausenddreihundertdreißig (2.712.330) neuen Gesellschafts-
anteile der Gesellschaft wie oben erwähnt zuzuteilen.

18795

<i>Vierter Beschluss

Infolge der obengenannten Beschlüsse beschließt die Gesellschafterin, den ersten Absatz des Artikels 5 des Gesell-

schaftsvertrages wie folgt abzuändern:

«  Art. 5. Gesellschaftskapital, (erster Absatz).  Das  ausgegebene  Kapital  der  Gesellschaft  beträgt  siebenundsechzig

Millionen achthundertzwanzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 67.820.750,-), aufgeteilt in zwei Millionen sieben-
hundertzwölftausendachthundertdreißig (2.712.830) Anteile. Jeder Anteil hat einen Nennwert von fünfundzwanzig Euro
(EUR 25,-) und ist vollständig eingezahlt.»

<i>Kosten

Da infolge der Sacheinlage durch die Gesellschafterin in die Gesellschaft, bestehend aus vierhundert (400) B-Stamm-

aktien der MELODIA INVESTMENTS LIMITED, vorerwähnt, die Gesellschaft mehr als 65% (in vorliegendem Falle 100%)
des ausgegebenen Kapitals der MELODIA INVESTMENTS LIMITED hält, einer Gesellschaft mit Geschäfts- und Gesell-
schaftssitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, und da diese Sacheinlage ausschließlich gegen Ausgabe neuer
Anteile am Kapital der Gesellschaft erfolgt, deren Geschäfts- und Gesellschaftssitz sich in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union befindet, bezieht sich die Gesellschaft auf Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, der für den
vorliegenden Falle eine Steuerbefreiung vorsieht.

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf sechstausendsechshundert Euro geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der oben-

genannten erschienen Person, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst ist;
auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen Textes, wird der
englische Text vorwiegen.

Nach Vorlesung der Urkunde vor dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten Ver-

treter der erschienenen Gesellschafterin, hat derselbe diese Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

The present notarial deed shall be published in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations in compliance with the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, after
having been registered by the instrumenting notary with the collector of registration duties (Receveur de l'Enregistrement)
and filed by the instrumenting notary with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Com-
merce et des Sociétés).

Beles, den 6. Dezember 2007.

Für gleichlautende Ablichtung
J.-J. Wagner
<i>Notar

Référence de publication: 2008018431/250/793.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2008, réf. LSO-CM09700. - Reçu 74 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080018180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2008.

Chimato-Fonds, Fonds Commun de Placement.

Die INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., RC Luxembourg B 8.558, hat als Verwaltungsgesellschaft den

Organismus für gemeinsame Anlagen CHIMATO-FONDS, der den Bestimmungen des Gesetzes vom 13. Februar 2007
über die Spezialfonds unterliegt, mit Zustimmung der Depotbank des Fonds DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE
LUXEMBOURG S.A., am 31. Oktober 2007, gegründet.

Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschafts-

register) hinterlegt.

Luxemburg, den 31. Oktober 2007.

INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A. / DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / <i>Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften

Référence de publication: 2008009126/1207/17.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05603. - Reçu 48 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

18796

Beka-Lux 2007, Fonds Commun de Placement.

Die INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., RC Luxembourg B 8.558, hat als Verwaltungsgesellschaft den

Organismus für gemeinsame Anlagen BEKA-LUX 2007, der den Bestimmungen des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über
die Spezialfonds unterliegt, mit Zustimmung der Depotbank des Fonds DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LU-
XEMBOURG S.A., am 7. November 2007, gegründet.

Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschafts-

register) hinterlegt.

Luxemburg, den 7. November 2007.

INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A. / DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / <i>Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften

Référence de publication: 2008009127/1207/17.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05597. - Reçu 48 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080009446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

Allianz European Pension Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 117.986.

In der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Januar 2008 haben die Anteilinhaber einstimmig folgende Beschlüsse

gefasst:

- Wiederwahl von Frau Elizabeth Corley, Herrn Horst Eich, Herrn Wilfried Siegmund, Herrn Camillo Candia und

Herrn Dr. Michael Hessling als Verwaltungsratsmitglieder.

- Ko-Optierung von Herrn Jean-François Lequoy als Verwaltungsratsmitglied, Berufsanschrift 20 rue le peletier IX

ARR, bureau 02 - C06, 75444 PARIS CEDEX 09 als Verwaltungsratsmitglied.

- Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxemburg, als Wirtschaftsprüfer.

Senningerberg, den 18. Januar 2008.

Für die Richtigkeit des Auszuges
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A.
A. Wolf / S. Maringer

Référence de publication: 2008019520/755/20.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN01795. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

Deka-GlobalConvergenceRenten, Fonds Commun de Placement.

Die DEKA INTERNATIONAL S.A., RC Luxembourg B 28.599, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für

gemeinsame Anlagen DEKA-GLOBALConvergenceRenten, der den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. De-
zember  2002  über  die  Organismen  für  gemeinsame  Anlagen  unterliegt,  mit  Zustimmung  der  Depotbank  des  Fonds
DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., zum 8. Februar 2008, das Sonderreglement geändert.

Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschafts-

register) hinterlegt.

Luxemburg, den 7. Januar 2008.

DEKA INTERNATIONAL S.A. / DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / <i>Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften

Référence de publication: 2008011671/1463/17.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, réf. LSO-CM06933. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

18797

Deka-WorldTopGarant 1, Fonds Commun de Placement.

Die DEKA INTERNATIONAL S.A., RC Luxembourg B 28.599, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für

gemeinsame Anlagen DEKA-WorldTopGarant 1, der den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002
über die Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE
LUXEMBOURG S.A., Luxemburg, als dessen Depotbank beschlossen, den Fonds am 8. Januar 2008 zu gründen.

Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschafts-

register) hinterlegt.

Luxemburg, den 8. Januar 2008.

DEKA INTERNATIONAL S.A. / DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / <i>Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften

Référence de publication: 2008011672/1208/17.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2008, réf. LSO-CM08588. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080013158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Asian Food International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 125.652.

L'an deux mille huit, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de ASIAN FOOD INTERNATIONAL S.A., établie

et ayant son siège à L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 125.652, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 13 mars 2007,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1016 du 31 mai 2007.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Denise Risch, employée privée, demeurant à Mondorf-les-Bains,
qui désigne comme secrétaire André Steyer, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Maître Marc Monossohn, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le Président expose d'abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour

<i>Ordre du jour:

- Suppression de la valeur nominale des actions.
- Réduction du capital social, moyennant dispense partielle de versement du solde des apports, pour le porter de son

montant actuel de trente et un mille (31.000,-) euros à douze mille cinq cents (12.500,-).

- Constatation de libération de capital jusqu'à concurrence de douze mille cinq cents (12.500,-) euros.
- Fixation de la valeur nominale des actions.
- Modification de la dénomination de la société et modification subséquente de l'article 1 

er

 des statuts.

- Modification de l'objet social et modification subséquente de l'article 4 des statuts.
- Révocation de l'administrateur unique.
- Révocation du commissaire aux comptes.
- Transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée et refonte des statuts.
- Souscription des parts sociales.
- Fixation du nombre de gérants.
- Nomination d'un gérant.
- Pouvoir de signature.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-

tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

18798

IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-

blement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social d'un montant de dix-huit mille cinq cents (18.500,-) Euros pour le porter

de son montant actuel de trente et un mille (31.000,-) Euros au montant de douze mille cinq cents (12.500,-), moyennant
dispense partielle de versement du solde des apports.

<i>Troisième résolution

L'assemblée constate que le capital, actuellement libéré à concurrence de huit mille (8.000,-) Euros, vient d'être libéré

jusqu'à concurrence de douze mille cinq cents (12.500,-) Euros, par des versements en espèces, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire.

<i>Quatrième résolution

La dispense de versement du solde des apports de dix-huit mille cinq cents (18.500,-) euros ne deviendra effective

qu'au plus tôt, 30 jours à compter de la publication de la présente délibération au Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, si aucune demande en constitution de suretés n'a été introduite dans ce délai, sinon, si les créanciers ont
obtenu satisfaction ou si le magistrat présidant la chambre de tribunal d'arrondissement siègeant en matière commerciale
et comme en matière de référés n'a pas décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur requête, le tout conformément à
l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales, modifiée par la loi du 24 avril 1983.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide fixer la valeur nominale des actions à cent vingt-cinq (125,-) Euros chacune.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier la dénomination de la société et par conséquent l'article 1 

er

 des statuts comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il est constitué une société sous la dénomination de ASIAN FOOD INTERNATIONAL SARL.»

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'objet social de la société et par conséquent l'article 4 des statuts comme suit:

« Art. 4. La société a pour objet la vente de produits alimentaires de toutes sortes (notamment des produits surgelés)

tant aux consommateurs qu'aux marchands (de type grandes surfaces notamment).

La société a également pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.»

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide de révoquer l'administrateur unique, Madame Marie-Claire Garcia, dirigeant de société, domiciliée

au 45, Pied-Port-Neuf à F-34500 Béziers.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes, à savoir la société à responsabilité limitée VAN CAUTER

- SNAUWAERT &amp; CO SARL, avec siège à L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide de transformer la société en une société à responsabilité limitée et procède à la refonte des statuts,

lesquels auront désormais la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de ASIAN FOOD INTERNATIONAL SARL.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet la vente de produits alimentaires de toutes sortes (notamment des produits surgelés)

tant aux consommateurs qu'aux marchands (de type grandes surfaces notamment).

La société a également pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

18799

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de

leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Onzième résolution

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Eric Nivaggioli, gérant de société, demeurant à F-13200 Arles (France), 51, Chemin de Margaillan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2) Monsieur Eric Ducroquet, gérant de société, demeurant à F-34430 Saint Jean de Védas (France), 2377, route

de l'Averune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

<i>Douzième résolution

L'assemblée fixe le nombre des gérants à un (1).

<i>Treizième résolution

Est nommé gérant pour une durée illimitée, Monsieur Eric Ducroquet, susdit.

<i>Quatorzième résolution

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: D. Risch, A. Steyer, M. Monossohn, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 21 janvier 2008, REM 2008/103. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signe): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 7 février 2008.

R. Arrensdorff.

Référence de publication: 2008017734/218/118.
(080021030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2008.

Weberbank Special Mandate Fund, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. Februar 2008.

Unterschrift.

Référence de publication: 2008019524/2501/10.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2008, réf. LSO-CN00060. - Reçu 42 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080022905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2008.

Haspa PB Ertrag Plus, Fonds Commun de Placement.

Die INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., RC Luxembourg B 8.558, hat als Verwaltungsgesellschaft des

Organismus für gemeinsame Anlagen HASPA PB ERTRAG PLUS, der den Bestimmungen von Teil II des Gesetzes vom
20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der DekaBank DEUTSCHE
GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., Luxemburg, als dessen Depotbank beschlossen, den Fonds am 8. Januar 2008 zu
gründen.

Das Verwaltungsreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesell-

schaftsregister) hinterlegt.

18800

Luxemburg, den 8. Januar 2008.

INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A. / DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / <i>Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften

Référence de publication: 2008011940/1207/18.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2008, réf. LSO-CM08505. - Reçu 36 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080014027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Guliver Sicherheit, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 29. Januar 2008.

LRI INVEST S.A.
Unterschrift

Référence de publication: 2008012648/2501/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2008, réf. LSO-CM08639. - Reçu 58 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080015162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2008.

E&amp;G Fonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 77.618.

Die Bilanz vom 30. September 2007 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 29. Januar 2008.

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2008013001/2501/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2008, réf. LSO-CM08645. - Reçu 52 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080015157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2008.

RP Rendite Plus, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 94.920.

Le bilan au 30 septembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 18 janvier 2008.

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008019521/755/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN01803. - Reçu 116 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

RIA Allocation I, Fonds Commun de Placement.

Die Änderung der §§ 20 und 24 des Verwaltungsreglements 11/2007 des Fonds RIA ALLOCATION I mit Wirkung

vom 8. November 2007 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

18801

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. Januar 2008.

FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG AG
Anell / Tiburzi

Référence de publication: 2008013002/2393/13.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, réf. LSO-CM09295. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080015568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

TriGlobal, Fonds Commun de Placement.

Die Änderung der §§ 20 und 24 des Verwaltungsreglements 11/2007 des Fonds TriGlobal mit Wirkung vom 8. No-

vember 2007 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. Januar 2008.

FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG AG
Anell / Tiburzi

Référence de publication: 2008013003/2393/13.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, réf. LSO-CM09298. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080015566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

RIA, Fonds Commun de Placement.

Die Änderung der §§ 20 und 24 des Verwaltungsreglements 11/2007 der Teilfonds RIA AKTIEN-I, RIA AKTIEN-II, RIA

AKTIEN-III und RIA ABSOLUT-I des Umbrella-Fonds RIA mit Wirkung vom 8. November 2007 wurde beim Handels-
und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. Januar 2008.

FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG AG
Anell / Tiburzi

Référence de publication: 2008013004/2393/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, réf. LSO-CM09302. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080015563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

A &amp; K - AG, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 69.938.

Amber International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 67.170.

Business-Immo International, s. à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 47.562.

BEVING Joseph S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 40.606.

Continental Pacific &amp; Atlantic Holding AG, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 26.266.

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

Par jugements du 24 janvier 2008, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, VI 

e

 section, siégeant en matière

commerciale a été déclaré dissoutes et a ordonné la liquidation des sociétés suivantes:

- A &amp; K - AG S.A., ayant eu son siège social à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II,
- AMBER INTERNATIONAL S.A., ayant eu son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal,
- BUSINESS-IMMO INTERNATIONAL S.à r.l., ayant eu son siège social à L-1631 Luxembourg, 1, rue Glesener,

18802

- BEVING JOSEPH S.à r.l., ayant eu son siège social à L-2610 Luxembourg, 206, route de Thionville,
- CONTINENTAL PACIFIC &amp; ATLANTIC HOLDING AG S.A., ayant eu son siège social à L-2630 Luxembourg-Findel,

7A, route de Trèves.

Les mêmes jugements ont nommé Juge-Commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, Juge au Tribunal d'Arrondissement

de et à Luxembourg, et désigné comme liquidateur Maître Joëlle Niclou, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Lesdits jugements ordonnent aux créanciers de faire leurs déclarations de créances au greffe du Tribunal de Commerce

avant le 22 février 2008.

Pour extrait conforme

e

 J. Niclou

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008017163/7872/44.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2008, réf. LSO-CN01489. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2008, réf. LSO-CN01493. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2008, réf. LSO-CN01495. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2008, réf. LSO-CN01496. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2008, réf. LSO-CN01497. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080020253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2008.
(080020256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2008.
(080020259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2008.
(080020263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2008.
(080020265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2008.

Allianz Global Investors Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 71.182.

In der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Januar 2008 haben die Anteilinhaber einstimmig folgende Beschlüsse

gefasst:

- Wiederwahl der Herren Horst Eich, Wilfried Siegmund und Dr. Christian Finckh als Verwaltungsratsmitglieder.
- Ko-Optierung von Herrn George McKay, Berufsanschrift 20/F., Cheug Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong

Kong als Verwaltungsratsmitglied.

- Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxemburg, als Wirtschaftsprüfer.

Senningerberg, den 18. Januar 2008.

Für die Richtigkeit des Auszuges
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A.
A. Wolf / S. Maringer

Référence de publication: 2008019518/755/19.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN01808. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

FT Europazins, Fonds Commun de Placement.

Die Änderung der §§ 10, 19 und 25 des Verwaltungsreglements 02/2008 des Fonds FT EUROPAZINS mit Wirkung

vom 20. Februar 2008 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

18803

Luxemburg, den 14. Januar 2008.

FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG AG
Anell / Tiburzi

Référence de publication: 2008013005/2393/13.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, réf. LSO-CM09304. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080015558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

FT EuroCorporates, Fonds Commun de Placement.

Die Änderung der §§ 10, 19 und 25 des Verwaltungsreglements 02/2008 des Fonds FT EuroCorporates mit Wirkung

vom 20. Februar 2008 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. Januar 2008.

FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG AG
Anell / Tiburzi

Référence de publication: 2008013006/2393/13.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008, réf. LSO-CM09307. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080015554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2008.

Asian Food International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 125.652.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 7 février 2008.

Pour copie conforme
R. Arrensdorff
<i>Notaire

Référence de publication: 2008017736/218/13.
(080021032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2008.

Moventum S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 75.930.

<i>Extrait des résolutions de l'Associé Commandité de la Société prises en date du 15 novembre 2007

En date du 15 novembre 2007, l'Associé Commandité de la Sociétés MOVENTUM HOLDINGS S.A. a pris la résolution

de ratifier la liste de signataires comme attaché ci-joint en annexe 1.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2007.

MOVENTUM S.C.A.
Signature

<i>Annexe 1 aux résolutions de l'Associé Commandité de MOVENTUM S.C.A. (la «Société»)

<i>en date du 15 novembre 2007

1) Signataires:

<i>Signataires AA

- Gorham Mark A.
- Putnam Jim S.
- Robinson Todd A.

<i>Signataires A

18804

- Ahlborn Pierre
- Pauly John
- Reckinger Robert
- Reiser Sandra

<i>Signataires B

- Belflamme Jean-François
- Belloco Laurent
- Berggreen Sven
- French Karen
- Gérard Pascal
- Gross Andreas
- Holm Rolf Hagen
- Jensen Michael
- Johanns-Patzak Sabine
- Köster Swen
- Liedmann Jörg
- Loh Hartwig
- Muller Frank
- Rochette Laurent
- Scholer Pascal
- Trine Dominique

2) Limites d'autorisation de signature au nom de la Société
Les transferts de comptes bancaires et les engagements au nom de la Société peuvent être autorisés par les signataires

dans les limites des pouvoirs telles que décrites ci-après. Tous les niveaux sont à comprendre comme des exigences
minimales, de sorte que tous deux des signataires AA sont autorisés d'agir en tous cas.

a) Paiements jusqu'à EUR 200.000,-
- Tous deux signataires en commun
b) Paiements entre EUR 200.000,- et EUR 1.000.000,-
- Tous deux signataires en commun, à condition qu'au moins un de ces signataires soit un signataire A
c) Paiements au dessus de EUR 1.000.000,-
- Deux signataires A en commun
d) Transactions de valeurs
- Deux signataires A en commun
e) Contrats légaux
- Tous deux signataires en commun, à condition qu'au moins un de ces signataires soit un signataire A
f) Correspondance
- Tous deux signataire en commun
Référence de publication: 2008018433/250/61.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2008, réf. LSO-CN00103. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080020491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2008.

La Brin Dille s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 137, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 32.377.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 28 janvier 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales , telle
que modifiée, la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité limitée LA BRIN DILLE s.à r.l., avec siège social
à L-2551 Luxembourg, 137, avenue du X Septembre, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Isabelle Jung, juge, et liquidateur Maître Thomas Berger, avocat,

demeurant à Luxembourg.

18805

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 février 2008 au greffe de la dix-huitième

chambre de ce Tribunal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

e

 T. Berger

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008019512/8656/22.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02913. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080022922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2008.

3 R S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1617 Luxembourg, 101, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 50.760.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 28 janvier 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales , telle
que modifiée, la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité limitée 3 R S.à r.l., avec siège social à L-1617
Luxembourg, 101, rue de Gasperich, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Isabelle Jung, juge, et liquidateur Maître Thomas Berger, avocat,

demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 février 2008 au greffe de la dix-huitième

chambre de ce Tribunal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

e

 T. Berger

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008019513/8656/22.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02917. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080022923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2008.

DWS DifferenzChance2013, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung zum 1. Februar 2008 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Besonderer Teil wurde beim Registre

de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS INVESTMENT S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2008020792/1352/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02907. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Pagan S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 66.315.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 28 janvier 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales , telle
que modifiée, la dissolution et la liquidation de la société annonyme PAGAN S.A., dont le siège social à L-1637 Luxem-
bourg, 1, rue Goethe, a été dénoncé le 31 décembre 2001.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Isabelle Jung, juge, et liquidateur Maître Thomas Berger, avocat,

demeurant à Luxembourg.

18806

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 février 2008 au greffe de la dix-huitième

chambre de ce Tribunal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

e

 T. Berger

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008019514/8656/21.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02916. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080022925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2008.

Niko-International GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 20, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 40.965.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 28 janvier 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales , telle
que modifiée, la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité limitée NIKO-INTERNATIONAL GmbH, avec
siège social à L-1648 Luxembourg, 20, place Guillaume, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Isabelle Jung, juge, et liquidateur Maître Thomas Berger, avocat,

demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 février 2008 au greffe de la dix-huitième

chambre de ce Tribunal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

e

 T. Berger

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008019515/8656/22.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02915. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080022926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2008.

Multi Opportunities II, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung zum 11. Februar 2008 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil wurde beim Re-

gistre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS INVESTMENT S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2008020794/1352/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02936. - Reçu 40 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Lebanese African Finance and Trading Co (Holding) S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 28.083.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 28 janvier 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée, la dissolution et la liquidation de la société anonyme LEBANESE AFRICAN FINANCE AND TRADING Co
(HOLDING) S.A., dont le siège social à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, a été dénoncé le 30 juin 1992.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Isabelle Jung, juge, et liquidateur Maître Thomas Berger, avocat,

demeurant à Luxembourg.

18807

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 février 2008 au greffe de la dix-huitième

chambre de ce Tribunal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

e

 T. Berger

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008019516/8656/21.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02914. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080022927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2008.

RP Rendite Plus, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 94.920.

In der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Januar 2008 haben die Anteilinhaber einstimmig folgende Beschlüsse

gefasst:

- Wiederwahl der Herren Wilfried Siegmund, Horst Eich und Herbert Wunderlich als Verwaltungsratsmitglieder.
- Wiederwahl von KPMG AUDIT S.à r.l., Luxemburg, als Abschlussprüfer.

Für die Richtigkeit des Auszuges
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A.
A. Wolf / S. Maringer

Référence de publication: 2008019519/755/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN01800. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

Allianz European Pension Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 117.986.

Le bilan au 30 septembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 18 janvier 2008.

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008019522/755/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN01796. - Reçu 44 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

Allianz Global Investors Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 71.182.

Le bilan au 30 septembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 18 janvier 2008.

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008019523/755/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, réf. LSO-CN01811. - Reçu 300 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080021779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2008.

18808

Multi Opportunities II, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung zum 11. Februar 2008 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Besonderer Teil wurde beim Registre

de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS INVESTMENT S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2008020796/1352/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02937. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080024066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

DWS Flex Aktiv, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung zum 14. Januar 2008 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Besonderer Teil wurde beim Registre

de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS INVESTMENT S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2008020799/1933/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2008, réf. LSO-CN02965. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

DWS Performance Select 2014, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung zum 1. Februar 2008 geänderte Verwaltungsreglement - Besonderer Teil wurde beim Registre de

Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS INVESTMENT S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2008020802/1352/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02909. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

DWS Best Global FX Selection Plus, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung zum 1. Februar 2008 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Besonderer Teil wurde beim Registre

de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS INVESTMENT S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2008020804/1352/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02938. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

DB FCS, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung zum 17. Dezember 2007 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Besonderer Teil wurde beim

Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

18809

DWS INVESTMENT S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2008020807/1352/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02904. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080024049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2008.

Eco Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 87.376.

<i>Extrait des décisions prises par les gérants en date du 31 octobre 2007

- dans le cadre du mandat d'administrateur exercé par A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES

dans la société anonyme de droit luxembourgeois ECO FINANCIERE S.A., R.C.S. Luxembourg B n 

o

 87.376, avec siège

social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Monsieur Eric Magrini, administrateur de so-
ciétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril 1963, demeurant professionnellement à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme représentant permanent chargé de l'exé-
cution  du  mandat  d'administrateur  au  nom  et  pour  compte  de  A.M.S.  ADMINISTRATIVE  AND  MANAGEMENT
SERVICES.

Luxembourg, le 21 décembre 2007.

Pour extrait sincère et conforme
A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008011259/29/22.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2008, réf. LSO-CM03806. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080007815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Solar Capital Luxembourg I, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 190.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 127.949.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2008.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2008016231/242/13.
(080013237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Strapeg S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 66.846.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 27 décembre 2007 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, Place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2008.
L'assemblée générale du 27 décembre 2007 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- Monsieur Aloyse Scherer, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg

18810

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2008.

Luxembourg, le 27 décembre 2007.

<i>Pour STRAPEG S.A.
Signature

Référence de publication: 2008016290/833/22.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, réf. LSO-CM07284. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Comitalu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 28.627.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

<i>Pour COMITALU S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2008016313/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, réf. LSO-CM06806. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Siamstores S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1922 Luxembourg, 2-4, rue Auguste Laval.

R.C.S. Luxembourg B 65.244.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

<i>Pour SIAMSTORES S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2008016316/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM02913. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Locatrans S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Bâtiment CLB - Container Terminal 136.

R.C.S. Luxembourg B 59.239.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

<i>Pour LOCATRANS S.à.r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2008016321/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, réf. LSO-CM06820. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

18811

Finesse Holding S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 45.571.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

<i>Pour FINESSE HOLDING S.A.H.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2008016323/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, réf. LSO-CM06818. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080013539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

N.S.D. Nouvelle Société de Développement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 100.825.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008016329/751/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, réf. LSO-CM08187. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

T-Comalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Am Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 19.366.

Constituée par-devant M 

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 21 avril 1982, acte publié au

Mémorial C n 

o

 179 du 27 juillet 1982, modifiée par-devant le même notaire les 14 juin 1984, 14 juillet 1984, 8 août

1984, 21 février 1986, 21 juillet 1988, 5 mai 1989, 24 décembre 1990 et le 27 mai 1993, actes publiés au Mémorial
C n 

o

 208 du 3 août 1984, C n 

o

 237 du 6 septembre 1984, C n 

o

 261 du 27 septembre 1984, C n 

o

 141 du 28 mai

1986, C n 

o

 282 du 21 octobre 1988, C n 

o

 281 du 4 octobre 1989, C n 

o

 256 du 28 juin 1991, C n 

o

 265 du 9 juillet

1991 et C n 

o

 425 du 15 septembre 1993.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2008.

<i>Pour T-COMALUX S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Référence de publication: 2008016378/1261/21.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2008, réf. LSO-CM06393. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

N.S.D. Nouvelle Société de Développement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 100.825.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

18812

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008016332/751/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, réf. LSO-CM08182. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Gabbiano S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 110.759.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008016347/751/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, réf. LSO-CM08189. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080013565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Elite Coiffure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 93, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 71.031.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

FIDUCIAIRE HELLERS, KOS &amp; ASSOCIES Sàrl
Signature

Référence de publication: 2008016354/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07657. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Gemini Logistics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 106.999.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2007.

<i>Pour GEMINI LOGISTICS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008016457/565/16.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, réf. LSO-CM06763. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Five Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 105.007.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

18813

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

FIDUCIAIRE HELLERS, KOS &amp; ASSOCIES Sàrl
Signature

Référence de publication: 2008016355/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07659. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Heck, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 10, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

R.C.S. Luxembourg B 105.852.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

FIDUCIAIRE HELLERS, KOS &amp; ASSOCIES Sàrl
Signature

Référence de publication: 2008016356/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07661. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

L &amp; P, Lange and Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6755 Grevenmacher, 1, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 89.344.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

FIDUCIAIRE HELLERS, KOS &amp; ASSOCIES Sàrl
Signature

Référence de publication: 2008016357/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07678. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Fëlsberg Promotions S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4830 Rodange, 3, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 108.289.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 24 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008016363/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM06020. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Mahevia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3569 Dudelange, 96, rue Tattenberg.

R.C.S. Luxembourg B 79.805.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

18814

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

FIDUCIAIRE HELLERS, KOS &amp; ASSOCIES Sàrl
Signature

Référence de publication: 2008016358/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07669. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Mecconti S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5440 Remerschen, 124, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 103.999.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

FIDUCIAIRE HELLERS, KOS &amp; ASSOCIES Sàrl
Signature

Référence de publication: 2008016359/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07670. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Select Commerce S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 24.013.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

FIDUCIAIRE HELLERS, KOS &amp; ASSOCIES Sàrl
Signature

Référence de publication: 2008016360/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07675. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Berbo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht.

R.C.S. Luxembourg B 101.771.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 24 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008016365/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, réf. LSO-CM07913. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Unicum SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 71, route de Dudelange.

R.C.S. Luxembourg B 40.483.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

18815

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

FIDUCIAIRE HELLERS, KOS &amp; ASSOCIES Sàrl
Signature

Référence de publication: 2008016362/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07677. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Bonny S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 176, rue Pierre Krier.

R.C.S. Luxembourg B 117.109.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 24 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008016367/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2008, réf. LSO-CM07914. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Afimo, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2145 Luxembourg, 115, rue Cyprien Merjai.

R.C.S. Luxembourg B 25.873.

<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 3 décembre 2007

L'assemblée générale ordinaire de AFIMO a pris ce jour, à l'unanimité, la décision suivante:

<i>Conseil d'administration:

Sont réélus Administrateurs pour la durée de six ans:
- Monsieur Weyland Robert, Administrateur, né le 8 octobre 1945 à Dudelange, demeurant à L-2167 Luxembourg au

62A, rue des Muguets

- Monsieur Weyland Pascal, Administrateur, né le 11 août 1973 à Luxembourg, demeurant à L-2167 Luxembourg au

62A, rue des Muguets

- Madame Weyland Goedert Christiane, née le 27 mai 1952 à Luxembourg, demeurant à L-2167 Luxembourg au 62A,

rue des Muguets

Est réélu Administrateur Délégué pour la durée de six ans:
- Monsieur Weyland Robert, Administrateur, né le 8 octobre 1945 à Dudelange, demeurant à L-2167 Luxembourg au

62A, rue des Muguets

<i>Commissaire aux comptes:

Est élu commissaire aux comptes, en remplacement de la Fiduciaire d'Expertise Comptable et de Révision EVERARD

- KLEIN Sàrl, pour une durée de 5 ans:

- Monsieur Patrick Weyland, né le 8 mai 1980 à Luxembourg, demeurant à 62a, rue des Muguets, L-2167 Luxembourg

Itzig, le 12 décembre 2007.

Pour extrait conforme et sincère
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.
Signature

Référence de publication: 2008016842/1345/30.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2007, réf. LSO-CL06884. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080014282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

18816


Document Outline

3 R S.à r.l.

Afimo

Agaka S.A.

A &amp; K - AG

Alias Mustang International

Allianz European Pension Investments

Allianz European Pension Investments

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund

Amas Fund

Amber International S.A.

Asian Food International S.A.

Asian Food International S.A.

Aurea Finance Company

Bairlinvest S.A.

Beka-Lux 2007

Berbo S.à r.l.

BEVING Joseph S.àr.l.

Blatteus S.A.

Bluegreen S.A.

Bonny S.à r.l.

Bourne Park Capital (Lux) S.A.

Business-Immo International, s. à r.l.

Business Management Group Holding S.A.

Chimato-Fonds

Comitalu S.A.

Compagnie Financière Montchoisi S.A.

Continental Pacific &amp; Atlantic Holding AG

Dailkan S.A.

DB FCS

Defibresil S.A.

Deka-CorporateBond High Yield Euro

Deka-GlobalConvergenceRenten

Deka-WorldTopGarant 1

Demmer-Vermögensverwaltungs-Fonds

DWS Best Global FX Selection Plus

DWS DifferenzChance2013

DWS Flex Aktiv

DWS Performance Select 2014

Eco Financière S.A.

E&amp;G Fonds

Elite Coiffure S.à r.l.

Eurocash-Fund

Fëlsberg Promotions S.àr.l.

F.I.B.M. S.A.

Fincimec Group S.A.

Finesse Holding S.A.H.

Five Management S.A.

FT EuroCorporates

FT Europazins

Gabbiano S.A.

Galli S.A.

Gemini Logistics S.A.

GREIFF America OP

Guliver Sicherheit

Haspa PB Ertrag Plus

Heck, s.à r.l.

Inland Navigation Luxembourg S.A.

Jonathan Finance Holding S.A.

Kensington S.A.

Kordy S.A.

La Brin Dille s.à r.l.

Lebanese African Finance and Trading Co (Holding) S.A.

LF Open Waters OP

Locatrans S.à.r.l.

Lombard Odier Darier Hentsch Invest

L &amp; P, Lange and Partner S.à r.l.

Mahevia S.A.

Manzoni International S.A.

Mecconti S.àr.l.

Moventum S.C.A.

Multi Opportunities II

Multi Opportunities II

Niko-International GmbH

Nova Editior S.A.

N.S.D. Nouvelle Société de Développement S.A.

N.S.D. Nouvelle Société de Développement S.A.

Pagan S.A.

RIA

RIA Allocation I

RP Rendite Plus

RP Rendite Plus

SaarGummi technologies S.à r.l.

Select Commerce S.A.

Serrano S.A.

Siamstores S.A.

Solar Capital Luxembourg I

Star Group Holding S.A.

Strapeg S.A.

T-Comalux S.A.

TriGlobal

UBP Money Market Fund Sicav

Unicum SA

Weberbank Special Mandate Fund