logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 281

2 février 2008

SOMMAIRE

Banian Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13448

Belair Assets SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13479

Bombardier Luxembourg Finance S.A. . . .

13468

Brandenburg Archie 15 Acquico 1 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13461

Fashion Style S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13479

Flona Immo SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13459

Geficar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13488

Habacker LogPark Site One S. à r.l.  . . . . .

13453

Habacker LogPark Site Two S. à r.l.  . . . . .

13469

ING REEIF Germany S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

13446

Isarez S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13488

Les Pléiades S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13480

Les Pléiades S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13481

Les Résidences Brasserie Funck S.A.  . . . . .

13475

Loda Victoria Investment Company S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13475

Mondialconstruction Holding S.A.  . . . . . . .

13475

Parker Hannifin Bermuda Luxembourg

S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13480

Parker Hannifin (Gibraltar) Holding Lu-

xembourg S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13480

Perpetuum Immobilier S.A. . . . . . . . . . . . . .

13480

PRESCO Hoist Investments S.A.  . . . . . . . .

13480

Repco 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13442

Repco 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13442

Repco 3 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13442

Repco 5 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13443

Repco 6 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13443

Repco 7 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13488

Rhapsody International S.à r.l. . . . . . . . . . . .

13481

Verdandi Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

13451

Verdandi Partnership S.C.S. . . . . . . . . . . . . .

13443

WM Findel (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . .

13445

13441

Repco 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 110.206.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue à Luxembourg le 19 novembre 2007

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 19 novembre 2007 que:
1. M. Derek Mc Donald, né le 9 août 1967 à Paisley, Ecosse, demeurant 8 Glen Sannox Grove, Craigmarloch, UK-

Cumbernauld G68 OGH, a démissionné de ses fonctions d'administrateur B de la Société, avec effet immédiat.

2. M. Stuart Watson, né le 15 août 1964 à Lahore, Pakistan, banquier, demeurant 4 Manse Road, Dollar, Clackman-

nanshire, FK14 7AJ, Ecosse, a été nommé administrateur B avec effet immédiat. Son mandat expirera lors de l'assemblée
générale ordinaire de la Société qui sera tenue en vue d'approuver les comptes au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008010628/280/18.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM02857. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080006712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Repco 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 110.475.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue à Luxembourg le 19 novembre 2007

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 19 novembre 2007 que:
1. M. Derek Mc Donald, né le 9 août 1967 à Paisley, Ecosse, demeurant 8 Glen Sannox Grove, Craigmarloch, UK-

Cumbernauld G68 OGH, a démissionné de ses fonctions d'administrateur B de la Société, avec effet immédiat.

2. M. Stuart Watson, né le 15 août 1964 à Lahore, Pakistan, banquier, demeurant 4 Manse Road, Dollar, Clackman-

nanshire, FK14 7AJ, Ecosse, a été nommé administrateur B avec effet immédiat. Son mandat expirera lors de l'assemblée
générale ordinaire de la Société qui sera tenue en vue d'approuver les comptes au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008010632/280/18.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM02859. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Repco 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 110.471.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue à Luxembourg le 19 novembre 2007

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 19 novembre 2007 que:
1. M. Derek Mc Donald, né le 9 août 1967 à Paisley, Ecosse, demeurant 8 Glen Sannox Grove, Craigmarloch, UK-

Cumbernauld G68 OGH, a démissionné de ses fonctions d'administrateur B de la Société, avec effet immédiat.

2. M. Stuart Watson, né le 15 août 1964 à Lahore, Pakistan, banquier, demeurant 4 Manse Road, Dollar, Clackman-

nanshire, FK14 7AJ, Ecosse, a été nommé administrateur B avec effet immédiat. Son mandat expirera lors de l'assemblée
générale ordinaire de la Société qui sera tenue en vue d'approuver les comptes au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008010634/280/18.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM02860. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

13442

Repco 5 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 110.742.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue à Luxembourg le 19 novembre 2007

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 19 novembre 2007 que:
1. M. Derek Mc Donald, né le 9 août 1967 à Paisley, Ecosse, demeurant 8 Glen Sannox Grove, Craigmarloch, UK-

Cumbernauld G68 OGH, a démissionné de ses fonctions d'administrateur B de la Société, avec effet immédiat.

2. M. Stuart Watson, né le 15 août 1964 à Lahore, Pakistan, banquier, demeurant 4 Manse Road, Dollar, Clackman-

nanshire, FK14 7AJ, Ecosse, a été nommé administrateur B avec effet immédiat. Son mandat expirera lors de l'assemblée
générale ordinaire de la Société qui sera tenue en vue d'approuver les comptes au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008010636/280/18.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM02865. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080006687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Repco 6 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 110.747.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue à Luxembourg le 19 novembre 2007

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 19 novembre 2007 que:
1. M. Derek Mc Donald, né le 9 août 1967 à Paisley, Ecosse, demeurant 8 Glen Sannox Grove, Craigmarloch, UK-

Cumbernauld G68 OGH, a démissionné de ses fonctions d'administrateur B de la Société, avec effet immédiat.

2. M. Stuart Watson, né le 15 août 1964 à Lahore, Pakistan, banquier, demeurant 4 Manse Road, Dollar, Clackman-

nanshire, FK14 7AJ, Ecosse, a été nommé administrateur B avec effet immédiat. Son mandat expirera lors de l'assemblée
générale ordinaire de la Société qui sera tenue en vue d'approuver les comptes au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008010638/280/18.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM02866. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Verdandi Partnership S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 130.416.

In the year two thousand seven, on the thirtieth of November.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

- RHENUS YUGEN SEKININ JIGYO KUMIAI, a limited liability partnership incorporated under the laws of Japan,

having its registered office at 1-8, Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, registered with the Tokyo Company
Registry under number 0199-05-011469, here represented by Mr. Bob Calmes, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue
of a proxy given on 27 November 2007;

- VERDANDI MANAGEMENT S.à r.l., a company established and existing in Luxembourg under the form of a société

à responsabilité limitée, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, recorded with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B, number 130 803, here represented by Mr. Bob Calmes,
LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 22 November 2007.

The said proxies, initialed ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain attached to this deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders of VERDANDI PARTNERSHIP S.C.S., a company established and existing

in Luxembourg under the form of a société en commandite simple, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt,

13443

L-1717 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B, number 130 416,
incorporated as a société en commandite simple pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in
Luxembourg,  Grand-Duchy  of  Luxembourg,  on  25  June  2007,  published  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations of 20 September 2007, number 2037 (hereafter the «Company»).

The appearing parties, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda

of the meeting is as follows:

1. Increase of the share capital of the Company.
2. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company.

<i>First resolution

The shareholders resolved to increase the share capital from its present amount of thousand one Euro (EUR 1,001.-),

represented by thousand one (1,001) shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, up to seventy-five thousand
two hundred fifty-one Euro (EUR 75,251.-), represented by seventy-five thousand two hundred fifty-one (75,251) shares
having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, through the issue of seventy-four thousand two hundred fifty (74,250)
shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

All such shares have been entirely subscribed and paid up for the value of one Euro (EUR 1.-) per share in cash, by

RHENUS YUGEN SEKININ JIGYO KUMIAI, aforementioned, at a total price of seventy-four thousand two hundred fifty
Euro (EUR 74,250.-), out of which the entirety has been allocated to the share capital of the Company so that the total
amount of seventy-four thousand two hundred fifty Euro (EUR 74,250.-) is at the disposal of the Company, as it has been
shown to the undersigned notary,

here represented by Mr Bob Calmes, LL.M., by virtue of a proxy given on 27 November 2007.
The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to this deed to be filed

at the same time with the registration authorities.

<i>Second resolution

The shareholder resolves that as a consequence of the above resolution, article 5 of the articles of association of the

Company is amended and shall read as follows:

« Art. 5. The share capital is set at seventy-five thousand two hundred fifty-one Euro (EUR 75,251.-), consisting of

seventy-five thousand two hundred fifty-one (75,251) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

person, this deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, said person appearing signed together

with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundsieben, den dreißigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

-  RHENUS  YUGEN  SEKININ  JIGYO  KUMIAI,  ein  limited  liability  partnership  japanischen  Rechts,  mit  Sitz  in  1-8,

Uchisaiwaicho  2-chome,  Chiyoda-ku,  Tokyo,  Japan,  eingetragen  im  Gesellschaftsregister  Tokyo  unter  der  Nummer
0199-05-011469, rechtmäßig vertreten durch Herrn Bob Calmes, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher
Vollmacht, ausgestellt am 27. November 2007;

- VERDANDI MANAGEMENT S.à r.l., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-1717 Luxemburg, 8-10,

rue Mathias Hardt, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister, unter der Nummer B 130 803,
rechtmäßig  vertreten  durch  Herrn  Bob  Calmes,  LL.M.,  wohnhaft  in  Luxemburg,  gemäß  privatschriftlicher  Vollmacht,
ausgestellt am 22. November 2007;

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienenen Parteien sind die Gesellschafterinnen der VERDANDI PARTNERSHIP S.CS., eine société en com-

mandite simple Luxemburgischen Rechts, mit Geschäftssitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg, eingetragen
im Luxemburger Handelsund Gesellschaftsregister unter Nummer B 130 416, gegründet auf Grund einer Urkunde des
Notars M 

e

 Martine Schaeffer vom 25. Juni 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom

25 Juni 2007, Nummer 2037 (nachfolgend die «Gesellschaft»).

Die erschienenen Parteien, die das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten, erklärten Folgendes und

ersuchte den Notar Folgendes zu beurkunden:

13444

1. Anhebung des Aktienkapitals der Gesellschaft.
2. Nachfolgend Abänderung des Artikels 5 der Statuten der Gesellschaft.

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterinnen beschließen das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen Wert von

tausendundeins Euro (EUR 1.001,-), vertreten durch tausendundeine (1.001) Aktie mit einem Nennwert von einem Euro
(EUR 1,-) pro Aktie, auf fünfundsiebzigtausendzweihunderteinundfünfzig Euro (EUR 75.251,-) zu erheben, vertreten durch
fünfundsiebzigtausendzweihunderteinundfünfzig (75.251) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Aktie
durch die Ausgabe von vierundsiebzigtausendzweihundertfünfzig (74.250) neuen Aktien der Gesellschaft mit einem Nenn-
wert von einem Euro (EUR 1,-) pro Aktie.

Sämtliche dieser Aktien wurden vollständig eingezahlt und gezeichnet für einen Betrag von einem Euro (EUR 1,-) pro

Aktie in Bar, durch RHENUS YUGEN SEKININ JIGYO KUMIAI, vorgenannt, für einen Gesamtpreis von vierundsiebzig-
tausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 74.250,-), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurden, so dass der
Gesamtbetrag von vierundsiebzigtausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 74.250,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht,
wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde,

hier vertreten durch Herrn Bob Calmes, LL.M., aufgrund einer Vollmacht gegeben in am 27. November 2007.
Welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Mandanten, den Versammlungsvorstand und den un-

terzeichnenden Notar, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.

<i>Zweiter Beschluss

Als Folge des vorausgegangenen Beschlusses wird Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie

folgt:

«  Art.  5.  Das  Stammkapital  der  Gesellschaft  beträgt  fünfundsiebzigtausendzweihunderteinundfünfzig  Euro  (EUR

75.251,-), eingeteilt in fünfundsiebzigtausendzweihunderteinundfünfzig (75.251) Anteile zu je einem Euro (EUR 1,-).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.»
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der Er-

schienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage
der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische
Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Vertreter der Erschienenen haben dieselben mit dem Notar

gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Calmes, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007. LAC/2007/39398. — Reçu 742,50 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008010678/5770/113.
(080006516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

WM Findel (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 106.004.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008011057/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM02858. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

13445

ING REEIF Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.803.300,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 112.009.

In the year two thousand and seven, on the thirtieth November.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) ING REEIF SOPARFI A S. à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office in L-2453 Luxembourg,

5, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg, number B 105.688, duly represented by its manager ORANGEFIELD TRUST
(LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, here represented by Mrs
Corinne Petit, employee, with professional address in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy
given in Luxembourg on November 29, 2007;

2) ING REAL ESTATE EUROPEAN INDUSTRIAL FUND C.V., a limited partnership (commanditaire vennootschap),

governed by the laws of the Netherlands, having its registered office in NL-2595 AS The Hague, 65, Schenkkade, registered
at the Kamer van Koophandel Haaglanden, under the number 27272545, duly represented by its general partner ING
REEIF MANAGEMENT B.V., (beherend vennot), a company governed by the laws of the Netherlands, having its registered
office in NL-2595 AS The Hague, 65, Schenkkade, hereby represented by Mrs Corinne Petit, prenamed, by virtue of a
proxy given in The Hague, on November 29, 2007.

The said proxies, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present

deed for the purpose of registration.

The appearing parties, acting in their capacity as the only partners, have requested the undersigned notary to enact

the following:

The appearing parties ING REEIF SOPARFI A S. à r.l. and ING REAL ESTATE EUROPEAN INDUSTRIAL FUND C.V.

are the only partners of ING REEIF GERMANY S. à r. I., an limited liability corporation with registered office in L-2453
Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, incorporated by deed of the notary Martine Schaeffer, then residing in Remich, on
November 18th, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 381 dated February
21st, 2006. These Articles of Association have been amended for the last time by deed of the same notary on July 10th,
2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2510 dated November 6th, 2007.

The capital of the company is fixed six million five hundred three thousand and three hundred euro (6,503,300.- EUR)

represented by sixty-five thousand thirty-three (65,033) parts, with a nominal value of one hundred euro (100.- EUR)
each, entirely paid in.

The appearing parties take the following resolutions:

<i>First resolution

The partners resolve to increase the corporate capital by an amount of three hundred thousand euro (300,000.- EUR),

so as to raise it from its present amount of six million five hundred three thousand and three hundred euro (6,503,300.-
EUR) to six million eight hundred and three thousand three hundred euro (6,803,300.-EUR), by issuing three thousand
(3.000) new parts with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, having the same rights and obligations as the
existing parts.

<i>Subscription and liberation

The appearing partner ING REEIF SOPARFI A S. à r.l. declares to subscribe the three thousand (3,000) new parts and

to pay them up, fully in cash, at its par value of one hundred euro (100.- EUR), so that the amount of three hundred
thousand euro (300,000.- EUR) is at the free disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned
notary.

<i>Second resolution

The appearing partners resolve to amend article 6 of the articles of incorporation, so as to reflect the increase of

capital, -which shall henceforth have the following wording:

« Art. 6. The capital is set at six million eight hundred three thousand and three hundred euro (6,803,300.- EUR)

represented by sixty-eight thousand thirty-three (68,033) parts of a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.»

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party,

this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the appearing persons signed together with

the notary the present original deed.

13446

Suit la version française:

L'an deux mille sept, le trente novembre
Par-devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) ING REEIF SOPARFI A S. à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5,

rue  Eugène  Ruppert,  inscrite  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  sous  le  numéro  B  105.688,  dûment
représentée par son gérant ORANGEFIELD TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5,
rue Eugène Ruppert, ici représenté par Madame Corinne Petit, employée, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxem-
bourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 29 novembre 2007;

2) ING REAL ESTATE EUROPEAN INDUSTRIAL FUND EUROPE C.V., une société de droit néerlandais (comman-

ditaire vennootschap), avec siège social à NL-2595 AS La Haye, 65, Schenkkade, inscrite à la Kamer van Koophandel
Haaglanden sous le numéro 27272545, dûment représentée par son associée commanditée (beherend vennoot) ING
REEIF MANAGEMENT B.V., une société de droit néerlandais, avec siège social à NL-2595 AS La Haye, 65, Schenkkade,
ici représentée par Madame Corinne Petit, prénommée, en vertu d'une procuration délivrée à La Haye, le 29 novembre
2007.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, agissant en leur qualité d'associées, ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce

qui suit:

Les sociétés comparantes ING REEIF SOPARFI A S. à r.l. et ING REAL ESTATE EUROPEAN INDUSTRIAL FUND

EUROPE C.V. sont les seules associées de la société à responsabilité limitée ING REEIF GERMANY S. à r. I., avec siège
social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Schaeffer, de
résidence à Remich, en date du 18 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
381 du 21 février 2006 dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire
en date du 10 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2510 du 6 novembre 2007.

Le capital social de la société est fixé à six millions cinq cent trois mille trois cents euros (6.503.300,- EUR) représenté

par soixante-cinq mille trente-trois (65.033) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les associées prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associées décident d'augmenter le capital social de la société d'un montant de trois cent mille euros (300.000,-

EUR) afin de le porter de son montant actuel de six millions cinq cent trois mille trois cents euros (6.503.300,- EUR) à
six millions huit cent trois mille trois cents euros (6.803.300,- EUR), par l'émission de trois mille (3.000) parts sociales
nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes.

<i>Souscription et libération

Et à l'instant, les trois mille (3.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) ont été

souscrites par l'associée ING REEIF SOPARFI A S. à r.l. et entièrement libérée en espèces, de sorte que le montant de
trois cent mille euros (300.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

Les associées décident, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à six millions huit cent trois mille trois cents euros (6.803.300.- EUR) représenté par

soixante- huit mille trente-trois (68.033) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et la
traduction française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par noms,

prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Petit, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2007. LAC/2007/39794. — Reçu 3.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

13447

Luxembourg, le 10 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008010691/5770/114.
(080006431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Banian Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.625,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 117.617.

In the year two thousand and seven, on the twelfth of October.
Before US Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

SHR GROSVENOR SQUARE, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 114.490, incorporated under the name PINGLETON HOLDING S.à R.L. pursuant to a
deed of Me Henry Hellinckx, notary then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, dated February 14, 2006,
published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, no. 947 on May 15, 2006, whose articles of
association have been amended pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated August
30, 2006, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, no. 2148 on November 17, 2006,
here represented by Me Grégory Beltrame, Avocat, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given
on October 11th, 2007.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
- SHR GROSVENOR SQUARE S.à r.l. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of BANIAN FINANCE S.à r.l., a

Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, rue de
la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 117.617,
incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, dated June 28, 2006, published in
the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, no.1674 on September 5, 2006 (the Company);

- the Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into one

hundred (100) shares of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed capital by an amount of one hundred twenty-five euro (EUR

125.-) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to twelve thousand six
hundred twenty-five euro (EUR 12,625.-) by the issuance of one (1) new share with a nominal value of one hundred
twenty-five euro (EUR 125.-), having the same rights as the already existing shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for the one (1)

new share and to fully pay up such share by way of a contribution in kind consisting of five hundred and one (501) shares,
with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, in GROSVENOR SQUARE HOTEL S.à r.l. (the Shares), a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 94.377 (GSHS), repre-
senting 100% of its issued share capital; the surplus between the value of the contribution in kind and the nominal value
of the issued shares being transferred to a share premium account of the Company.

The Shares so contributed represent a contribution in kind in an aggregate amount of twelve thousand five hundred

and twenty-five euro (EUR 12,525.-).

It results from the certificate issued on October 11th, 2007 by the management of GSHS and the management of the

Company that, as of the date of such certificate and declaration:

- the Sole Shareholder is the owner of the Shares, representing 100% (one hundred per cent) of the share capital of

GSHS;

- the Shares are fully paid-up;
- the Sole Shareholder is the legal owner solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the

Shares;

13448

- none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct

on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that

one or more of the Shares be transferred to him;

- according to applicable law, the Shares are freely transferable;
- all formalities required in Luxembourg subsequent to the contribution in kind of the Shares will be effected upon

receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind; and

- on October 8th, 2007, based on general accepted accounting principles, the worth of the Shares is valued at least an

amount of twelve thousand five hundred twenty-five euro (EUR 12,525.-).

Said valuation statement referred to above, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of

association of the Company in order to reflect the above resolution, which will henceforth have the following wording:

« Art. 6. The capital is set at twelve thousand six hundred twenty five euro (EUR 12,625.-) represented by one hundred

one (101) shares in registered form with a nominal value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, all
subscribed and fully paid-up.»

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

empowers and authorizes any manager of the Company, any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and CITCO
LUXEMBOURG to proceed on behalf of the Company to the registration of the above changes in the share register of
the Company.

<i>Tax exemption

Given that the Company acquires shares issued by a company incorporated in the European Union, which represent

more than 65% of the share capital of the relevant company (in specie 100%), the Company refers to article 4-2 of the
law dated December 29, 1971, which provides for contribution tax exemption in such case.

<i>Declaration

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said person appearing, through its prox-

yholder, signed together with the notary the present original deed.

Follows the French translation:

L'an deux mille sept, le douze octobre.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SHR GROSVENOR SQUARE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social sis au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 114.490, constituée sous le nom de PINGLETON HOLDING S.à R.L. suivant un acte de

e

 Henry Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, Grand Duché de Luxembourg, en date du 14 février 2006,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial Sociétés et Associations n 

o

 947 du 15 mai 2006, dont les statuts ont été amendés

suivant un acte M 

e

 Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date de du 30 août 2006, publié au Mémorial

C, Recueil Spécial Sociétés et Associations n 

o

 2148 du 17 novembre 2006, ici représentée par M 

e

 Grégory Beltrame,

Avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 11 octobre 2007.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
- SHR GROSVENOR SQUARE S.à r.l. est l'associé unique (l'Associé Unique) de BANIAN FINANCE S.à r.l., une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.617, constituée
suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 28 juin 2006 publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations n 

o

 1674 du 5 septembre 2006 (la Société);

13449

- le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Sur ce, la partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-)

pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un montant de douze mille six
cent vingt-cinq euros (EUR 12.625,-) par la création et l'émission de une (1) nouvelle part sociale, ayant une valeur
nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-), ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

<i>Souscription et libération

Ensuite, l'Associé Unique, défini et représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire une (1) nouvelle part sociale

et la libérer intégralement par un apport en nature consistant en cinq cent une (501) parts sociales, d'une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, dans GROSVENOR SQUARE HOTEL S.à r.l. (les Parts Sociales), une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, enre-
gistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.377 (GSHS), représentant 100 %
de son capital social; la différence entre la valeur de l'apport en nature et la valeur nominale de la part sociale émise étant
attribuée à un compte prime d'émission de la Société.

Les Parts Sociales ainsi apportées représentent un apport en nature d'un montant total de douze mille cinq cent vingt-

cinq euros (EUR 12.525,-).

Il résulte du certificat émis le 11 octobre 2007 par la gérance de GSHS et la gérance de la Société que, à la date de ce

certificat:

- l'Associé Unique est le propriétaire des Parts Sociales, représentant 100 % du capital social de GSHS;
- les Parts Sociales sont entièrement libérées;
- l'Associé Unique est l'unique propriétaire des Parts Sociales et a tout pouvoir de disposer des Parts Sociales;
- les Parts Sociales ne sont pas gagées ou grevées d'un usufruit; il n'existe aucun droit pour acquérir quelque gage ou

usufruit que ce soit sur les Parts Sociales et aucune Part Sociale ne fait l'objet d'une saisie;

- il n'existe aucun droit de préemption ou tout autre droit permettant à une personne de demander le transfert des

Parts Sociales à son profit;

- conformément à la loi applicable, Les Parts Sociales sont librement transmissibles;
- toutes les formalités requises relatives au transfert des Parts Sociales à la Société requises sous toutes lois applicables

seront effectuées après réception d'une copie certifiée conforme de la présente assemblée actant la présente contribution
en nature; et

Au 8 octobre 2007, conformément aux principes comptables généralement acceptées la valeur des Parts Sociales

s'élève à un montant d'au moins douze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 12.525,-).

Ledit certificat après avoir été signé ne varietur par le représentant et par le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

<i>Deuxième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société,

qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille six cent vingt-cinq euros (EUR 12.625,-) représenté par

cent une (101) parts sociales nominatives de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées».

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'amender le registre des associés de la Société de sorte à refléter les changements exposés

ci-dessus et mandate et autorise tout gérant de la Société ainsi que tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY et
CITCO LUXEMBOURG de procéder, au nom de la Société, à la mise à jour conséquente du registre des associés de la
Société.

<i>Droit d'apport

Étant donné que la Société acquiert des parts sociales émises par une société établie dans l'Union Européenne qui

représentent plus de 65% du capital social de la société en cause (in specie 100 %), la Société se réfère à l'article 4-2 de
la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

13450

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: G. Beltrame, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, LAC/2007/31814. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008010692/5770/171.
(080006443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Verdandi Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 26.250,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 130.803.

In the year two thousand and seven, on the thirtieth of November.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

RHENUS YUGEN SEKININ JIGYO KUMIAI, a limited liability partnership incorporated under the laws of Japan, having

its  registered  office  at  1-8,  Uchisaiwaicho  2-chome,  Chiyoda-ku,  Tokyo,  Japan,  registered  with  the  Tokyo  Company
Registry under number 0199-05-011469, here represented by Mr Bob Calmes, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue
of a proxy given on 27 November 2007.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to this deed to be filed

at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole member of VERDANDI MANAGEMENT S. à r.l., a company established and existing

in Luxembourg under the form of a société à responsabilité limitée, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt,
L-1717 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B, number 130.803,
incorporated as a société à responsabilité limitée pursuant to a deed of Maître Marline Schaeffer, notary residing in
Luxembourg,  Grand  Duchy  of Luxembourg,  on 25 June  2007, published  in  the Mémorial  C, Recueil  des  Sociétés  et
Associations of 26 September 2007, number 2106 (hereafter the «Company»).

The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of

the meeting is as follows:

1. Increase of the share capital of the Company.
2. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company.

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to increase the share capital from its present amount of twelve thousand five hundred

Euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one Euro (EUR
1.-) each, up to twenty-six thousand two hundred fifty Euro (EUR 26,250.-), represented by twenty-six thousand two
hundred fifty (26,250) shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, through the issue of thirteen thousand seven
hundred fifty (13,750) shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

All such shares have been entirely subscribed and paid up for the value of one Euro (EUR 1.-) per share in cash, by

RHENUS YUGEN SEKININ JIGYO KUMIAI, aforementioned, at a total price of thirteen thousand seven hundred fifty
Euro (EUR 13,750.-) out of which the entirety has been allocated to the share capital of the Company so that the total
amount of thirteen thousand seven hundred fifty Euro (EUR 13,750.-) is at the disposal of the Company, as it has been
shown to the undersigned notary,

here represented by Mr Bob Calmes, LL.M., by virtue of a proxy given on 27 November 2007.
The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to this deed to be filed

at the same time with the registration authorities.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, article 6 of the articles of association of the Company is amended and shall

read as follows:

« Art. 6. The Company's share capital is set at twenty-six thousand two hundred fifty Euro (EUR 26,250.-), represented

by twenty-six thousand two hundred fifty (26,250) shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»

13451

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

person, this deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, said person appearing signed together

with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundsieben, den dreißigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

RHENUS YUGEN SEKININ JIGYO KUMIAI, ein limited liability partnership japanischen Rechts, mit Sitz in 1-8, Uchi-

saiwaicho  2-chome,  Chiyoda-ku,  Tokyo,  Japan,  eingetragen  im  Gesellschaftsregister  Tokyo  unter  der  Nummer
0199-05-011469, rechtmäßig vertreten durch Herrn Bob Calmes, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher
Vollmacht, ausgestellt am 27. November 2007.

Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei ist die alleinige Gesellschafterin der VERDANDI MANAGEMENT S. à r.l., eine société à res-

ponsabilité limitée Luxemburgischen Rechts, mit Geschäftssitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg, eingetragen
im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 130.803, gegründet auf Grund einer Urkunde des
Notars M 

e

 Martine Schaeffer vom 25. Juni 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom

26. September 2007, Nummer 2106 (nachfolgend die «Gesellschaft»).

Die erschienene Partei, das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertretend, erklärte Folgendes und ersuchte

den Notar Folgendes zu beurkunden:

1. Anhebung des Aktienkapitals der Gesellschaft.
2. Nachfolgend Abänderung des Artikels 6 der Statuten der Gesellschaft.

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen Wert von

zwölftausendfünfhundert  Euro  (EUR  12.500,-)  vertreten  durch  zwölftausendfünfhundert  (12.500)  Aktien  mit  einem
Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) auf sechsundzwanzigtausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 26.250,-) zu erheben,
vertreten durch sechsundzwanzigtausendzweihundertfünfzig (26.250) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro (EUR
1,-) pro Aktie, durch die Ausgabe von dreizehntausendsiebenhundertfünfzig (13.750) neuen Aktien der Gesellschaft mit
einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Aktie.

Sämtliche dieser Aktien wurden vollständig eingezahlt und gezeichnet für einen Betrag von einem Euro (EUR 1,-) pro

Aktie in Bar, durch RHENUS YUGEN SEKININ JIGYO KUMIAI, vorgenannt, für einen Gesamtpreis von dreizehntau-
sendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 13.750,-), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurden, so dass der
Gesamtbetrag von dreizehntausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 13.750,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie
dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde,

hier vertreten durch Herrn Bob Calmes, LL.M., aufgrund einer Vollmacht gegeben in am 27 November 2007.
Eelche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Mandanten, den Versammlungsvorstand und den un-

terzeichnenden Notar, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.

<i>Zweiter Beschluss

Als Folge des vorausgegangenen Beschlusses wird Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie

folgt:

« Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt sechsundzwanzigtausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 26.250,-), aufgeteilt

in sechsundzwanzigtausendzweihundertfünfzig (26.250) Anteile zu je einem Euro (EUR 1,-).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.»
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der Er-

schienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage
der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische
Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Vertreter der Erschienenen haben dieselben mit dem Notar

gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Calmes, M. Schaeffer.

13452

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, LAC/2007/39397. — Reçu 137,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008010686/5770/106.
(080006569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Habacker LogPark Site One S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 135.041.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the fourth of December.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

HABACKER LogPark HOLDING S. à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registration with the Lux-
embourg Trade and Companies' Register pending, duly represented by Mr Michael Habacker, residing at Robert-Bemadis-
Straße 8, 40474 Düsseldorf, Germany and Ms Stephanie Habacker-Arndt, residing at Robert-Bernadis-Straße 8, 40474
Düsseldorf, Germany who may validly bind HABACKER LogPark HOLDING S.à r.l., by his/her sole signature, duly rep-
resented  by  Jean-Baptiste  Beauvoir-Planson,  maître  en  droit,  residing  in  Luxembourg,  by  virtue  of  a  proxy  given  in
Düsseldorf, Germany, on 4th December, 2007.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. This private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») is hereby estab-

lished by the current shareholder and all those who may become shareholders in future, and shall be governed by the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present Articles of Association.

Art. 2. The purpose of the Company is the development of a business park and the construction of industrial and

logistics real estate property and, more generally, the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment

of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration,  control  and  development.  For  that  purpose,  the  Company  may  require  and  retain  the  assistance  of  other
advisors.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of HABACKER LogPark SITE ONE S. à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders.
Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a resolution of the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

13453

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only
be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general
meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares
are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any member of the board of managers.

The sole manager or the board of managers may grant powers of attorney by authentic proxy or by private instrument.

Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also

choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
board of managers.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company's object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone conference, videoconference or

by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board
of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entire
set of such circular resolutions will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

13454

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which it

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as it holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of these Articles of Association requires the approval of a majority of shareholders representing at

least three quarters of the share capital.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

Art. 23. The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by HABACKER LogPark HOLDING S.à r.l., prenamed, for a

total price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date hereof and shall terminate on 31 December 2008.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, the Grand Duchy

of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as the managers of the Company for an undetermined period:
- Mr Michael Habacker, born on 22 May 1964 in Ibbenbüren residing at Robert-Bernadis-Straße 8, 40474 Düsseldorf,

Germany; and

- Ms Stephanie Habacker-Arndt, born 30 May 1974 in Münster residing at Robert-Bernadis-Straße 8, 40474 Düsseldorf,

Germany.

13455

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed, together with the notary,

the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, den vierten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

HABACKER LogPark HOLDING S. à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach

dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg, noch nicht im
Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg eingetragen, hier vertreten durch Herr Jean-Baptiste Beauvoir-Plan-
son, maître en droit, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Düsseldorf, am
4. Dezember 2007.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhaber der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Gesell-

schafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesellschaft»)
gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung eines Gewerbeparks und die Errichtung von Industrie- und Logis-

tikimmobilien und allgemein das Halten von Beteiligungen in jeglicher Form in Luxemburger oder ausländischen Gesell-
schaften und jede andere Form von Investment, der Erwerb von Wertpapieren aller Art durch Kauf, Zeichnung oder auf
andere Weise als auch deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder anderweitig und die Verwaltung, Kontrolle und
Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ferner Garantien geben, Darlehen gewähren oder diejenigen Gesellschaften, in welchen sie eine

direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche Teil derselben Gruppe von Gesellschaften sind wie die Gesellschaft
selbst, anderweitig unterstützen.

Die Gesellschaft kann kaufmännische, industrielle oder finanzielle Aktivitäten wahrnehmen, die sie in Erfüllung ihres

Gesellschaftszwecks für nützlich erachtet.

Insbesondere wird die Gesellschaft innerhalb ihres Portfolios die Gesellschaften mit den Diensten versorgen, die für

deren Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung notwendig sind. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft die Unterstützung
anderer Berater in Anspruch nehmen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung HABACKER LogPark SITE ONE S. à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Haupt-

versammlung  der  Gesellschafter  an  jeden  beliebigen  Ort  im  Großherzogtum  Luxemburg  verlegt  werden.  Innerhalb
derselben Gemeinde kann der Sitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführerrats verlegt werden. Die Gesellschaft
kann Filialen oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die

mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

13456

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft endet nicht mit dem Tod, dem Verlust der Bürgerrechte, dem Konkurs oder der Zahlungs-

unfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensgütern oder

Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen.
Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die

Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen
werden.

Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch die Unterschrift vom alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus mindestens

zwei Geschäftsführern verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft unter allen Umständen durch die einzige Unterschrift
von einem Mitglied des Geschäftsführerrats verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat auf Grund notariell beglau-

bigter Urkunde oder privatschriftlich erteilt.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner
Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied
zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Telefon, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung. Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder
vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der je-
weiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Telefon, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund

auch immer, aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

13457

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel

des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

E. Geschäftsjahr - Kontengewinnausschüttungen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 23. Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines

von den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur
Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag selbstverständlich nicht die seit dem Ende des letztes Steuerjahres
erzielten Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich
der übertragenen Verluste und der Summen, die einer gesetzlich oder durch diese Satzung vorgeschriebenen Reserve
zugewiesen werden.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von HABACKER LogPark HOLDING S. à r.l., vorgenannt, für einen

Gesamtpreis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

zweitausend Euro (EUR 2.000,-) geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Unverzüglich  nach  Gesellschaftsgründung  hat  der  Gesellschafter,  der  das  gesamte  gezeichnete  Gesellschaftskapital

vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg.

2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern ernannt:
- Herr Michael Habacker, Immobilien-Kaufmann geboren am 22. Mai 1964 in Ibbenbüren, wohnhaft in Robert-Bernadis-

Straße 8, 40474 Düsseldorf, Deutschland; und

- Frau Stephanie Habacker-Arndt, Kauffrau, geboren am 30. Mai 1974 in Münster, wohnhaft in wohnhaft in Robert-

Bernadis-Straße 8, 40474 Düsseldorf, Deutschland.

13458

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.-B. Beauvoir-Planson, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, LAC/2007/39102. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008010710/5770/330.
(080006880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Flona Immo SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 67, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 135.050.

STATUTS

L'an deux mille sept, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

1. Fabrice Laurent, employé privé, demeurant professionnellement à L-1741 Luxembourg, 67, rue de Hollerich;
2. Ali Bouamara, employé privé, demeurant professionnellement à L-1741 Luxembourg, 67, rue de Hollerich;
tous deux ici représentés par Stéfan Rodrigues, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu de deux procurations lui délivrées sous seing privé en date du 19 novembre 2007,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire instrumentant et par les comparants resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme il est dit, ont requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société

anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: FLONA IMMO SA.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement

par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil
d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la dispa-
rition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières

se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le
développement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par trois cent dix (310) actions de

cent (100,-) euros chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l'actionnaire au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son

sein. Elle peut être administrée par un administrateur unique dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle. Ils sont
nommés pour un terme n'excédant pas six années.

13459

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs et dans le cas d'une société

anonyme unipersonnelle par la signature de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle de la personne à ce
déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n'excédant pas six années.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier pour finir le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mars à 17.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- Fabrice Laurent, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- Ali Bouamara, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: Trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, de sorte que le capital social au

montant de trente et un mille (31.000,-) euros est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales

et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ mille deux cent cinquante (1.250,-) euros.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2008.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2009.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, représentés comme il est dit, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

13460

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:
1. Fabrice Laurent, employé privé, demeurant professionnellement à L-1741 Luxembourg, 67, rue de Hollerich.
2. Ali Bouamara, employé privé, demeurant professionnellement à L-1741 Luxembourg, 67, rue de Hollerich.
3. Nataliya Laurent, employée privée, demeurant professionnellement à L-1741 Luxembourg, 67, rue de Hollerich,

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes: EUROPRAXIS LTD, avec siège social à BN1 2NW Brighton, East Sussex, 91,

Western Road, Unit 16.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.

<i>Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-1741 Luxembourg, 67, rue de Hollerich.
Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et de l'article 7 des

présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

<i>Déclaration

En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et

de l'infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l'objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées
à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, représentés comme il est dit, tous connus du notaire

par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signe: S. Rodrigues, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 29 novembre 2007, Relation: REM/2007/1867. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 9 janvier 2008.

R. Arrensdorff.

Référence de publication: 2008010713/218/123.
(080007040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Brandenburg Archie 15 Acquico 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 135.037.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the eighteenth of December.
Before Maître Martine Schaeffer, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

BRANDENBURG PROPERTIES S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered

office at 65, boulevard de la Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade
and companies' register under number B 115.636.

The founder is here represented by Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following articles of a «société à responsabilité limitée» which it

declares to incorporate.

13461

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present

articles  of  incorporation  and  by  current  Luxembourg  laws,  especially  the  laws  of  August  10th,  1915  on  commercial
companies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité
limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercises the powers devolved to the General Meeting of partners.

Art. 2. The Company's name is BRANDENBURG ARCHIE 15 ACQUICO 1 S.à r.l.

Art. 3. The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial

or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution,
underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to
manage and develop them; the Company may issue fixed or variable interest or equity linked securities or any other form
of financial instruments; the Company may grant to enterprises in which the Company has an interest, or to enterprises
which belong to the same group of enterprises as the Company, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to
perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company's purpose shall further be to invest in, own and divest itself of real estate related investments either

directly or through direct or indirect participations in subsidiaries owning such investments.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of managers of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any partner.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances, to

require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of
the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five euro) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-partners unless members representing at least three-quarter of the

corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers and the managers are responsible for the management

and the control of the Company's business. If several managers have been appointed, they will constitute a board of
managers. In this case, managers will be appointed as type A manager or type B manager. The manager(s) need not be
partners. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority
of votes. The type B managers must be Luxembourg resident. UK resident managers must at all times form a minority
of the total number of Managers.

13462

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers, who shall (to the exclusion of
the partners) manage the business of the Company.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of a type A manager together with a type B manager. The B managers are authorized under their sole
signature to sign bank transfers up to an amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-).

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, meetings of boards of managers will be validly held provided that there is at least an

equal number of type A managers present or represented as there are type B managers present or represented.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member

of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this
technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by phone. No person who is physically present in the United Kingdom may participate in a meeting
of the Board of Managers via videoconference equipment or conference call.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers. These meetings take place in the Grand

Duchy in of Luxembourg at the registered seat of the Company or at any other place in the Grand Duchy of Luxembourg
as indicated in the convening notice. A manager may participate by phone or videoconference. In no circumstances may
a meeting take place in the United Kingdom or in any jurisdiction unless Managers have been competently advised that
to do so would not give rise to adverse fiscal consequences for the Company.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another

manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers (other than any Manager who is in the United Kingdom at

the relevant time) shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted

by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Partners decisions

Art. 14. Partners' decisions are taken by partner's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the number of partners is less than twenty-five.
In such case, the board of Managers can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a second

meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be

represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of partners

representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of

the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on April 1st and closes on March 31st, with the exception of the first

year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on March 31st 2008.

13463

Art. 17. Each year, as of the 31st of March, the management will draw up the balance sheet which will contain a record

of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting

of partners together with the balance sheet.

Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the partners.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined by

the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extra-
ordinary reserve.

The partners may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves,
but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles
of incorporation.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the

pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment

of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1 shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide otherwise.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on March 31, 2008.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by BRANDENBURG PROP-

ERTIES S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred
euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand three hundred (2,300.-)
euro.

<i>General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration
- Mr Michael Van Messel, accountant, born on May 2, 1964 at London (England), with professional address at Bond

Street House, 14 Clifford Street, London W1S 4JU, England, as type A manager;

- Mrs Helen Foster Green, accountant, born on January 6, 1963 at Bath (England), with professional address at Saffery

Champness, PO Box 141, La Tonnelle House, Les Banques, St Sampson, Guernsey GY1 3HS, as type A manager;

- Mr Jean-Christophe Dauphin, born on November 20, 1976, in Nancy (France), with professional address at 65,

boulevard de la Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, as type B manager;

- Mr Benoît Nasr, born on May 26, 1975, at Charleroi (Belgium), with professional address at 65, boulevard de la

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, as type B manager.

In accordance with article eleven of the articles, the Company shall be bound by the joint signature of a type A manager

together with a type B manager.

13464

2) The Company shall have its registered office at 65, boulevard de la Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed:

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-huit décembre
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

BRANDENBURG PROPERTIES S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 65, boulevard

de la Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 115.636.

Le Fondateur est ici représenté par Florence Bal, résident au Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé

lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l'article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera BRANDENBURG ARCHIE 15 ACQUICO 1 S.à r.l.

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales,industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir tous titres et droits par
voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment d'acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; la Société peut émettre des
titres à intérêt fixe ou variable, des titres liés à des fonds propres ou tous autres instruments financiers; la Société peut
octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt ou à toute entreprise appartenant au même groupe que la
Société, tous concours, prêts, avances ou garanties, afin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques
se rattachant directement ou indirectement à son objet.

L'objet de la Société est aussi d'investir dans, de détenir et de revendre les immeubles liés à ces investissements soit

directement soit au travers de participations directes ou indirectes dans les filiales ou succursales détenant de tels in-
vestissements.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l'activité de la Société normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à
l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille
déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

13465

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants et les gérants sont responsables de la gestion et du contrôle

des affaires de la Société. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Dans ce cas, le conseil
de gérance est composé au moins d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obliga-
toirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des
associés titulaires de la majorité des votes. Les gérants de classe B doivent être résidents luxembourgeois. A tout moment
les gérants résidant au Royaume-Uni doivent représenter une minorité du nombre total des gérants.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance qui dirigera (à l'exclusion des associés)
les affaires de la Société.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

collective d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B. Les gérants de classe B sont autorisés à signer des virements
bancaires pour un montant total maximal de cent mille euros (EUR 100.000,-).

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement pour autant qu'il y ait au

moins un nombre égal de gérants de classe A présents ou représentés et de gérants de classe B présents ou représentés.

Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de
technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la
vidéo.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des

premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination. Aucune personne physiquement présente au Royaume-
Uni ne peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par video conference ou par téléphone.

Art. 12. Le gérant ou les gérants (si tel est le cas), n'assume(nt), en raison de sa/leur fonction, aucune responsabilité

personnelle par rapport à tout engagement valablement fait par lui/ eux au nom de la Société.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance. Ces réunions prennent place au

Grand-Duché du Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg tel
qu'indiqué dans la convocation. Un gérant pourra participer par téléphone ou vidéoconférence. En aucune circonstance,
une réunion ne peut prendre place au Royaume Uni ou dans toute autre juridiction à moins que les gérants aient été
informés de manière compétente qu'il n'y a aucune conséquence fiscale pour la Société.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants (n'importe quel gérant qui se trouve au Royaume

Uni au moment de la réunion), produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

13466

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, le conseil de gérance peut décider que chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou

des décisions à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, élec-
tronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier avril et se termine le 31 mars, à l'exception du premier exercice social

qui débutera au jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 mars 2008.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 mars, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la

Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que
les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec

le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices
reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu
d'une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le

capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à

sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

13467

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1 

er

 , ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application

partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 mars 2008.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par BRAN-

DENBURG PROPERTIES S.à r.l., prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte
que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille trois cents (2.300,-) euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée
- Monsieur Michael Van Messel, comptable, né le 2 mai 1964 à Londres (Angleterre), avec adresse professionelle à

Bond Street House, 14, Clifford Street, Londres W1S 4JU, Angleterre, comme gérant de classe A;

- Madame Helen Foster Green, comptable, née le 6 janvier 1963 à Bath (Angleterre), avec adresse professionelle au

Saffery Champness, PO Box 141, La Tonnelle House, Les Banques, St Sampson, Guernsey GY1 3HS, comme gérant de
classe A;

- Monsieur Jean-Christophe Dauphin, né le 20 novembre 1976 à Nancy (France), avec adresse professionnelle au 65,

boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, comme gérant de classe B;

- Monsieur Benoît Nasr, né le 26 mai 1975 à Charleroi (Belgique), avec adresse professionelle au 65, boulevard Grande

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, comme gérant de classe B.

Conformément à l'article 11 des statuts, la société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas

de pluralité de gérants, par la signature collective d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

2) Le siège social de la Société est établi au 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante

les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version-anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: F. Bal, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2007, LAC/2007/43261. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008010731/5770/387.
(080006847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Bombardier Luxembourg Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 73.989.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 49934 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2008011132/211/11.
(080006422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

13468

Habacker LogPark Site Two S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 135.040.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the fourth of December.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

HABACKER LogPark HOLDING S. à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registration with the Lux-
embourg Trade and Companies' Register pending, duly represented by Mr. Michael Habacker, residing at Robert-Bernadis-
Straße 8, 40474 Düsseldorf, Germany and Ms. Stephanie Habacker-Arndt, residing at Robert-Bernadis-Straße 8, 40474
Düsseldorf, Germany who may validly bind HABACKER LogPark HOLDING S.à r.l., by his/her sole signature, duly rep-
resented  by  Jean-Baptiste  Beauvoir-Planson,  maître  en  droit,  residing  in  Luxembourg,  by  virtue  of  a  proxy  given  in
Düsseldorf, Germany, on 4th December 2007.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. This private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») is hereby estab-

lished by the current shareholder and all those who may become shareholders in future, and shall be governed by the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present Articles of Association.

Art. 2. The purpose of the Company is the development of a business park and the construction of industrial, and

logistics real estate property and, more generally, the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment

of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration,  control  and  development.  For  that  purpose,  the  Company  may  require  and  retain  the  assistance  of  other
advisors.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of HABACKER LogPark SITE TWO S. à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders.
Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a resolution of the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only

13469

be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general
meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares
are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any member of the board of managers.

The sole manager or the board of managers may grant powers of attorney by authentic proxy or by private instrument.

Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also

choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
board of managers.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company's object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone conference, videoconference or

by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board
of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entire
set of such circular resolutions will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which it

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as it holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of these Articles of Association requires the approval of a majority of shareholders representing at

least three quarters of the share capital.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

13470

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

Art. 23. The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by HABACKER LogPark HOLDING S. à r.l., prenamed, for a

total price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date hereof and shall terminate on 31 December 2008.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, the Grand Duchy

of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as the managers of the Company for an undetermined period:
- Mr Michael Habacker, born on 22 May 1964 in Ibbenbüren residing at Robert-Bernadis-Straße 8, 40474 Düsseldorf,

Germany; and

- Ms Stephanie Habacker-Arndt, born 30 May 1974 in Münster residing at Robert-Bernadis-Straße 8, 40474 Düsseldorf,

Germany.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person, appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, den vierten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

13471

HABACKER LogPark HOLDING S. à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach

dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg, noch nicht im
Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg eingetragen, hier vertreten durch Herrn Jean-Baptiste Beauvoir-Plan-
son, maître en droit, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Düsseldorf, am
4. Dezember 2007.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhaber der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Gesell-

schafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesellschaft»)
gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung eines Gewerbeparks und die Errichtung von Industrie- und Logis-

tikimmobilien und allgemein das Halten von Beteiligungen in jeglicher Form in Luxemburger oder ausländischen Gesell-
schaften und jede andere Form von Investment, der Erwerb von Wertpapieren aller Art durch Kauf, Zeichnung oder auf
andere Weise als auch deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder anderweitig und die Verwaltung, Kontrolle und
Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ferner Garantien geben, Darlehen gewähren oder diejenigen Gesellschaften, in welchen sie eine

direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche Teil derselben Gruppe von Gesellschaften sind wie die Gesellschaft
selbst, anderweitig unterstützen.

Die Gesellschaft kann kaufmännische, industrielle oder finanzielle Aktivitäten wahrnehmen, die sie in Erfüllung ihres

Gesellschaftszwecks für nützlich erachtet.

Insbesondere wird die Gesellschaft innerhalb ihres Portfolios die Gesellschaften mit den Diensten versorgen, die für

deren Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung notwendig sind. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft die Unterstützung
anderer Berater in Anspruch nehmen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung HABACKER LogPark SITE TWO S. à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Haupt-

versammlung  der  Gesellschafter  an  jeden  beliebigen  Ort  im  Großherzogtum  Luxemburg  verlegt  werden.  Innerhalb
derselben Gemeinde kann der Sitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführerrats verlegt werden. Die Gesellschaft
kann Filialen oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die

mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft endet nicht mit dem Tod, dem Verlust der Bürgerrechte, dem Konkurs oder der Zahlungs-

unfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensgütern oder

Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen.

13472

Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die

Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen
werden.

Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch die Unterschrift vom alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus mindestens

zwei Geschäftsführern verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft unter allen Umständen durch die einzige Unterschrift
von einem Mitglied des Geschäftsführerrats verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat auf Grund notariell beglau-

bigter Urkunde oder privatschriftlich erteilt.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner
Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied
zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Telefon, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung. Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder
vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der je-
weiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Telefon, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund

auch immer, aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel

des Gesellschaftskapitals vertreten.

13473

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

E. Geschäftsjahr - Kontengewinnausschüttungen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 23. Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines

von den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur
Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag selbstverständlich nicht die seit dem Ende des letztes Steuerjahres
erzielten Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich
der übertragenen Verluste und der Summen, die einer gesetzlich oder durch diese Satzung vorgeschriebenen Reserve
zugewiesen werden.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von HABACKER LogPark HOLDING S. à r.l., vorgenannt, für einen

Gesamtpreis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

zweitausend Euro (EUR 2.000,-) geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Unverzüglich  nach  Gesellschaftsgründung  hat  der  Gesellschafter,  der  das  gesamte  gezeichnete  Gesellschaftskapital

vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg.

2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern ernannt:
- Herr Michael Habacker, Immobilien-Kaufmann geboren am 22. Mai 1964 in Ibbenbüren, wohnhaft in Robert-Bernadis-

Straße 8, 40474 Düsseldorf, Deutschland; und

- Frau Stephanie Habacker-Arndt, Kauffrau, geboren am 30. Mai 1974 in Münster, wohnhaft in wohnhaft in Robert-

Bernadis-Straße 8, 40474 Düsseldorf, Deutschland.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.-B. Beauvoir-Planson, M. Schaeffer.

13474

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2007, LAC/2007/39103. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demade de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008010734/5770/330.
(080006869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Mondialconstruction Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 71.404.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le Domiciliataire

Référence de publication: 2008010819/58/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07816. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080007077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Loda Victoria Investment Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 45.915.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le Domiciliataire

Référence de publication: 2008010822/58/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, réf. LSO-CL07823. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080007080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Les Résidences Brasserie Funck S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 135.048.

STATUTS

L'an deux mille sept, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1) La société anonyme FOOTPRINT S.A. ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill,

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.906, constituée aux termes d'un
acte reçu par le notaire instrumentaire, le 9 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
954 du 28 septembre 2005,

ici représentée conformément à l'article 12 de ses statuts par deux de ses administrateurs, Monsieur Werner Lizen,

administrateur de sociétés, né à Genk (Belgique) le 23 août 1943, demeurant à B-3140 Keerbergen (Belgique), 66, Emiel
Opdebeecklaan et Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1340
Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

2) La société à responsabilité limitée MAMMOT LUX Sàrl, ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 3-5, place

Winston Churchill, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.302, con-

13475

stituée aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 25 août 2005, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1413 du 19 décembre 2005,

ici représentée conformément à l'article 12 de ses statuts par son gérant unique, Monsieur Hubertus Goessens, ad-

ministrateur  de  sociétés,  né  à  Heer  (Pays-Bas)  le  26  octobre  1959,  demeurant  à  B-3080  Tervuren  (Belgique),  97
Museumlaan.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elles

déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LES RESIDENCES BRASSERIE FUNCK S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la promotion l'administration, l'exploitation, la mise en valeur

par vente, échange, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières et l'exercice de toutes activités
accessoires nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre matière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. D'une
façon générale, la société pourra, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, effectuer tous actes, transactions
ou opérations susceptibles d'être utiles à l'accomplissement de son objet social».

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) représenté par 25.000 (vingt-cinq

mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire. Un registre des actionnaires nominatifs, tenu au

siège de la société, contiendra la désignation précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre de ses actions et, le
cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 3.000.000,- (trois millions d'euros) qui sera

représenté par 300.000 (trois cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 21 décembre 2012,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

13476

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. L'assemblée générale des actionnaires fixe le pouvoir de signature.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le quatrième mercredi du mois de mars à 10 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

13477

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) La première assemblée générale annuelle se réunira en l'an 2009.
2) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2008.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

Actions

1.- La société anonyme FOOTPRINT S.A., préqualifiée, douze mille cinq cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

2.- La société à responsabilité limitée MAMMOT LUX S.à.r.l., préqualifiée, douze mille cinq cents . . . . .

12.500

Total: vingt-cinq mille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de sorte que

la somme de deux cent cinquante mille euros (€ 250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ quatre mille euros (€ 4.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à quatre.
Sont appelés aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant à l'assemblée générale de 2013:
- Monsieur Werner Lizen, administrateur de sociétés, demeurant à B-3140 Keerbergen (Belgique), 66, Emiel Opde-

beecklaan

- Monsieur Hubertus Goessens, administrateur de sociétés, demeurant à B-3080 Tervuren (Belgique), 97, Museumlaan.
- Monsieur Chris Hendrickx, administrateur de sociétés, demeurant à B-2870 Puurs (Belgique), 64, Liezele-Dorp.
- Madame Freia Peeters, adjointe de direction, demeurant à B-9090 Melle, 86C, Tuinstraat.

13478

Par dérogation à l'article 7 des statuts et à l'article 11, le premier Président du Conseil d'administration et le premier

administrateur-délégué sont nommés par cette assemblée générale extraordinaire à savoir:

Monsieur Werner Lizen, administrateur de sociétés, demeurant à B-3140 Keerbergen (Belgique), 66, Emiel Opde-

beecklaan, son mandat expirant à l'assemblée générale de 2013.

Monsieur Werner Lizen, pourra en sa qualité d'administrateur-délégué engager la société par sa seule signature pour

ce qui relève de la gestion journalière et avec la cosignature obligatoire de Monsieur Hubertus Goessens pour tous les
actes et documents qui sont en rapport avec l'objet social de la société et son autorisation d'établissement.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

La société à responsabilité limitée AUDIT.LU ayant son siège social à L-6131 Junglinster, 18, rue Hiel, immatriculée au

RCS Luxembourg sous le numéro B 113.620.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

<i>Remarque

L'attention des comparants a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d'obtenir des autorités com-

pétentes les autorisations requises afin d'exercer les activités telles que décrites à l'article quatre des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: W. Lizen, H. Grisius, H. Goessens, M. Lecuit.
Enregistré à Mersch, le 28 décembre 2007, MER/2007/1942. — Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 11 janvier 2008.

M. Lecuit.

Référence de publication: 2008010739/243/206.
(080006947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Belair Assets SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 72.692.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Référence de publication: 2008010856/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01765. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Fashion Style S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 126.905.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2007.

P. Frieders
<i>Notaire

Référence de publication: 2008011134/212/12.
(080006509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

13479

Perpetuum Immobilier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3598 Dudelange, 13, route de Zoufftgen.

R.C.S. Luxembourg B 101.535.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 14 janvier 2008.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Pour Maître J. Seckler
<i>Notaire
M. Goeres

Référence de publication: 2008011143/231/15.
(080006803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Parker Hannifin Bermuda Luxembourg S.C.S., Société en Commandite simple,

(anc. Parker Hannifin (Gibraltar) Holding Luxembourg S.C.S.).

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R.C.S. Luxembourg B 113.245.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2007.

P. Frieders
<i>Notaire

Référence de publication: 2008011135/212/13.
(080006540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

PRESCO Hoist Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 133.853.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2008.

C. Doerner
<i>Notaire

Référence de publication: 2008011133/209/12.
(080006592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Les Pléiades S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 69.276.

Le bilan au 31 août 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2008010807/58/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01848. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080007056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

13480

Les Pléiades S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 69.276.

Le bilan au 31 août 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2008010808/58/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01852. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080007057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Rhapsody International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 135.047.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the sixth of December.
Before M 

e

 Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

RHAPSODY AMERICA LLC, a company organised under the laws of the State of Delaware, United States of America,

having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,

hereby  represented  by  Mr  Fabio  Trevisan,  lawyer,  residing  in  Luxembourg,  by  virtue  of  a  proxy  given  in  Seattle,

Washington, USA, dated November 8, 2007; which proxy after having been signed ne varietur by the proxy holder and
the undersigned notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as indicated above, has requested the notary to draw up the following articles of

incorporation of a société à responsabilité limitée which it declared to form:

Title I. Denomination - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, especially the law of August

10, 1915 on commercial companies as amended (the «Companies' Law») and the present articles of association.

Art. 2. The denomination of the company is RHAPSODY INTERNATIONAL S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purposes to hold participations and securities, in any form whatsoever,

in Luxembourg and foreign companies, to acquire by purchase, subscription, or in any other manner as well as to transfer
by sale, exchange or otherwise stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, to possess, to administer,
to develop and to manage its portfolio.

The company may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise exclusively to its parent undertakings,

its subsidiaries or other subsidiaries of its parent undertakings. The company may borrow in any form, save that it may
not raise funds from the public.

The company may also participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial

enterprises.

In particular, the company shall engage in the business of selling music and software consisting in electronic games,

radio and TV broadcasting through web sites. The company shall equally enter the business of electronically supplied
services.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, industrial or commercial,

movable or immovable, operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The company is formed for an unlimited period.

13481

Title II. Capital - Shares

Art. 6. The capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- €) represented by twelve thousand five

hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (1.- €) each, entirely subscribed and fully paid up.

Art. 7. Every share entitles its owner to one (1) vote.
Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non-shareholders may only be

made with the prior approval of shareholders representing three quarters (3/4) of the corporate capital.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Companies' Law.
The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one (1) owner for each of them.
Shares in the company shall not be redeemable at the request of a shareholder.
The company, however, may redeem its shares whenever the board of managers consider this to be in the best interest

of the company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by these articles
of association and by law.

Unless the share redemption is immediately followed by a share capital reduction, any such redemption shall only be

made out of the company's retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding any
reserve required by Luxembourg law. The redemption price shall be determined by the board of managers.

Art. 8. The life of the company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Title III. Management

Art. 9. The company is managed by one or more manager(s), whether shareholder(s) or not.
The manager(s) (are) is appointed for an undetermined term by the sole shareholder or by the general meeting of

shareholders, which may at any time remove them without giving reasons.

The powers and remunerations of any manager possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

The office of a manager shall be vacated if:
1. he resigns his office by notice to the company, or
2. he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a manager,
3. he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
4. he is removed from office by resolution of the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of

shareholders.

Art. 10. The sole manager or the board of managers is (are) invested with the broadest powers to perform all acts of

administration and disposition in compliance with the corporate object, except those expressly reserved by law or by
the present articles of association to the general meeting of shareholders.

The manager (or the board of managers) represents the company towards third parties and any litigation involving the

company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the manager.

The manager (or the board of managers) may decide to make a distribution of interim dividends. A decision to distribute

interim dividends may only be taken on the basis of interim financial statements (balance sheet and profit and loss account)
which evidence that the company has sufficient distributable amounts to fund the distribution.

The amount capable of being distributed by way of an interim distribution shall not exceed the amount of net profits

realised since, as the case may be, either the date of incorporation or the close of the last financial year preceding the
distribution (provided the annual financial statements pertaining to that year have been approved), increased by profits
carried forward and amounts drawn from the available free reserves and reduced by losses carried forward and amounts
allocated to the legal reserve.

Art. 11. If more than one manager has been appointed, the Board of managers may elect among its members a chairman;

in the absence of the chairman, another manager may preside over the meeting.

Meetings of the board of managers shall exclusively be held in Luxembourg and are quorate if a majority of members

are physically present in Luxembourg. The decisions of the board of managers shall be taken by the majority of the
managers present or represented.

A manager unable to take part in a board meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member

of the board to represent him at the meeting and to vote in his name.

Any member of the board of managers who participates in the proceedings of a board meeting by means of a com-

munications device (including a telephone or video conference) which allows all the other members of the board of
managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications device) to hear
and to be heard by the other members at any time shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.
Members of the board of managers who participate in the proceedings of a meeting of the board of managers by means
of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing a copy of the minutes of the meeting.

13482

The board of managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him, as often as the interest

of the company so requires.

Each manager is entitled to one (1) vote unless he also acts as a proxy holder in which case he has one (1) additional

vote per proxy. The chairman of the board of managers has a casting vote.

The board resolutions will be recorded in minutes signed by the chairman and/or the secretary appointed in the given

board meeting. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly
signed by the chairman of the meeting or any two (2) managers.

Art. 12. The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one (1)

or more managers, who will be called «director(s)».

The board of managers may also appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their

sole signature, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 13. Unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers

or proxies given by the manager or the board of managers pursuant to article 12 above, the company is committed by
either the sole signature of the sole manager, or, should there be more than one manager appointed, the joint signature
of any two (2) managers.

Art. 14. A manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the company; as a proxyholder he is only responsible for the execution of his mandate.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of

the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

Title IV. General meeting of the shareholders

Art. 15. The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section

XII of the Companies' Law.

All decisions exceeding the powers of the board of managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case

may be, by the general meeting of shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special
register.

In case there is more than one (1) but less than twenty-five (25) shareholders, decisions of shareholders shall be taken

in a general meeting or by written consultation at the initiative of the management. No decision is deemed validly taken
until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the capital.

General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

Title V. Financial year - Profits - Reserves - Audit - Liquidation

Art. 16. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of the same year.

Exceptionally the first financial year shall begin on the day of formation of the company and close on the thirty-first of
December 2008.

Art. 17. Each year, as of the thirty-first of December, the management will draw up a balance sheet, which will (i)

contain a record of all movable and immovable property of, and all the debts owed to and by, the company and (ii) be
accompanied by an annex summarising all the commitments of the company and debts of the managers and/or auditors
to the company.

At the same time the management will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting

of shareholders together with the above-mentioned balance sheet. Profits of the company shall be calculated in accordance
with the provisions of Section XII of the Companies' Law and the provisions of Chapter II of the law on accounting and
financial statements of December 19, 2002, as such laws may be amended, superseded or supplemented from time to
time.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the registered office the balance sheet, inventory and the profit and loss

account during the fortnight preceding the annual general meeting.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges

and provisions represents the net profit of the company.

Each year, five per cent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to

be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth (1/10) of the capital but must be resumed until the
reserve fund is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been reduced below such proportion.
The balance is at the disposal of the general meeting of shareholders.

Art. 20. The audit of the company's annual accounts may be entrusted, at the discretion of the shareholder(s), to one

(1) or several auditor(s). In such case, the auditor(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders, which
shall determine their number, remuneration and the term of their mandates. The auditor(s) is/are re-eligible.

13483

Art. 21. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one (1) or more liquidators

who need not to be shareholder(s), designated by the general meeting of shareholders at the majority defined by article
142 of the Companies' Law.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts

of the company.

Art. 22. For all matters not provided for in the present articles of association, it is referred to the existing applicable

laws.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the appearing party declares to subscribe the capital as follows:

shares

RHAPSODY AMERICA LLC, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500
Total: twelve thousand five hundred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500

The shares have been fully paid up by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro

(12,500.- €) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,900.-€.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the above-named sole shareholder took the following resolutions:
1) The number of managers is fixed at one.
2) Is appointed as manager for an unlimited period:
- Mr Ian Greaves, manager, residing in London (UK).
3) The company shall have its registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,

the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing person, known to the notary by surname, given name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille sept, le six décembre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

RHAPSODY AMERICA LLC, une société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats -Unis d'Amérique, ayant

son siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,

ici représentée par M 

e

 Fabio Trevisan, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

par acte sous seing privé donnée à Seattle, Washington, USA, en date du 8 novembre 2007; laquelle procuration, après
avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles
elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une

société à responsabilité limitée, qu'elle a déclaré vouloir constituer comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les
Sociétés»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est RHAPSODY INTERNATIONAL S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales.

13484

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège

social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 4. La société a pour objet de détenir des participations ou valeurs mobilières, sous quelque forme que ce soit,

dans des entreprises luxembourgeoises et étrangères, acquérir par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi
qu'aliéner par vente, échange ou de toute autre manière des titres, obligations, créances, billets et autres valeurs mobilières
de toutes espèces, posséder, administrer, développer et gérer son portefeuille.

La société peut prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière exclusivement à

ses sociétés mères, ses filiales ou d'autres filiales de ses sociétés mères. La société peut emprunter sous toutes les formes
à l'exception de levées de fonds auprès du public.

La société pourra participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale.

En particulier, la société pourra exploiter des sites internet avec la finalité de vendre de la musique, des logiciels de

jeux électroniques, ou la diffusion d'émissions de radio ou de télévision. Elle pourra également fournir tous services
électroniques.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, industrielles ou commerciales, mobilières ou immobilières, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II. Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- €) divisé en douze mille cinq cents (12.500)

parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (1,- €) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une (1) voix.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non-

associés ne peuvent être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois-
quarts (3/4) du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui n'admet qu'un (1) seul titulaire à son égard pour chaque

part sociale.

Les parts sociales de la société ne sont pas remboursables à la demande des associés.
La société peut, toutefois, lorsque le conseil de gérance considère que cela est dans l'intérêt de la société, aux con-

ditions et aux termes qu'elle fixe et dans les limites prévues par la loi et les présents statuts, racheter ses propres parts
sociales.

A moins que le rachat des parts sociales soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement

ne pourra être effectué qu'au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce compris
les réserves excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat sera
déterminé par le conseil de gérance.

Art. 8. La faillite, l'insolvabilité, le décès ou l'incapacité d'un associé ne mettent pas fin à la société.

Titre III. Administration

Art. 9. La société est administrée par un gérant unique ou par plusieurs gérants, associé(s) ou non. Le(s) gérant(s)

(sont) est nommé(s) pour une durée indéterminée par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, qui a le
pouvoir de les révoquer à tout moment et sans justification.

Les pouvoirs et rémunérations de tout gérant éventuellement nommé postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Le poste d'un gérant sera vacant si:
1. il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
2. il cesse d'être gérant par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste de

gérant, ou

3. il tombe en faillite ou conclut un arrangement avec ses créanciers, ou
4. il est révoqué par une résolution du/des associé(s)

Art. 10. Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social, à l'exception de ceux expressément réservés
par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale des associés.

13485

Le gérant unique ou le conseil de gérance représente la société à l'égard des tiers et tout contentieux dans lequel la

société est impliquée soit comme demandeur soit comme défendeur sera géré au nom de la société par le conseil de
gérance.

Le gérant unique ou le conseil de gérance peut décider de distribuer des dividendes intérimaires. Une décision de

distribuer des dividendes intérimaires ne peut être prise que sur base d'un état comptable intérimaire (bilan et compte
de perte et profits) qui prouve que la société dispose de montants distribuables suffisants pour financer la distribution.

Le montant susceptible d'être distribué par distribution intérimaire ne pourra excéder le montant des bénéfices nets

réalisés depuis, selon le cas, soit le jour de la constitution, soit la clôture du dernier exercice social précédant la distribution
(pourvu que le bilan annuel concernant cet exercice ait été approuvé), augmenté des bénéfices reportés et des montants
prélevés sur des réserves libres disponibles, et réduit des pertes reportées et des montants à allouer à la réserve légale.

Art. 11. Si un conseil de gérance est nommé, il peut désigner parmi ses membres un président; en cas d'absence du

président, la présidence peut être conférée à un autre gérant présent lors de la réunion en cause.

Les réunions du conseil de gérance devront être tenues exclusivement à Luxembourg et le conseil ne peut délibérer

ni agir que si la majorité de ses membres sont présents physiquement à Luxembourg. Toutes les résolutions doivent être
adoptées à l'unanimité des gérants présents ou représentés.

Chaque gérant empêché de participer à une réunion du conseil de gérance peut désigner par courrier, télégramme,

télex ou téléfax un autre membre du conseil de gérance comme son mandataire aux fins de le représenter et de voter
en son nom.

Tout membre du conseil de gérance qui participe à une réunion du conseil de gérance via un moyen de communication

(incluant une télé ou vidéo conférence) qui permet aux autres membres du conseil de gérance présents à cette réunion
(soit en personne soit par mandataire ou par l'intermédiaire d'un tel moyen de communication) d'entendre à tout moment
ce membre et permettant à ce membre d'entendre à tout moment les autres membres sera autorisé à voter sur les
matières traitées à cette réunion. Les membres du conseil de gérance qui participent à une réunion du conseil de gérance
via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du procès-verbal
de cette réunion.

Le conseil de gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui, aussi souvent que l'intérêt

de la société l'exige.

Chaque gérant a droit à une (1) voix sauf s'il agit aussi dans le cadre d'un mandataire titulaire d'une procuration qui,

dans ce cas ci, aura une (1) voix supplémentaire par procuration. Le président du conseil de gérance a une voix prédo-
minante.

Les résolutions du conseil seront actées dans un procès-verbal signé par le président et/ou le secrétaire nommé dans

ladite réunion du conseil de gérance. Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d'une procédure judiciaire
ou ailleurs seront valablement signées par le président de la réunion ou par tous deux (2) gérants.

Art. 12. Si plusieurs gérants sont en fonctions, le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société

à un (1) ou plusieurs gérants qui prendra/ont la dénomination de «délégué(s) à la gestion journalière».

Le conseil de gérance peut également nommer des mandataires de la société, qui ont le pouvoir d'engager la société

sous leur seule signature, mais uniquement dans les limites déterminées par leur mandat.

Art. 13. Sauf si des décisions spéciales sont prises concernant les pouvoirs de signature en cas de délégation de pouvoirs

données par le gérant unique ou par le comité de gérance conformément à l'article 12 ci-dessus, la société est engagée
par la seule signature du gérant unique ou les signatures conjointes de deux (2) gérants si plusieurs gérants sont en
fonctions.

Art. 14. Un gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte

ou de responsabilité l'affectant du fait de l'exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.

Titre IV. Assemblée générale des associés

Art. 15. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section

XII de la Loi sur les Sociétés.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du conseil de gérance seront prises par l'associé unique ou, le cas échéant,

par l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

S'il y a plus d'un (1), mais moins de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée

générale ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est censée être valablement prise jusqu'à
ce qu'elle soit adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise.

13486

Titre V. Exercice social - Profits - Réserves - Audit - Liquidation

Art. 16. L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

A l'exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un
décembre 2008.

Art. 17. Chaque année le trente et un décembre, la gérance établit un bilan, (i) y compris un inventaire des valeurs

mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société et (ii) accompagné d'une annexe
résumant tous les engagements de la société et dettes des gérants et/ou commissaires envers la société.

En même temps, la gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l'assemblée générale des associés

en même temps que le bilan susmentionné. Les profits de la société seront calculés conformément aux dispositions de
la section XII de la Loi sur les Sociétés et celles du chapitre II de la loi du 19 décembre 2002 concernant la comptabilité
et les comptes annuels des entreprises, et toutes autres dispositions légales de lois qui viendront modifier, remplacer, ou
compléter lesdites dispositions.

Art. 18. Chaque associé aura le droit de consulter auprès du siège social le bilan, l'inventaire et le compte de pertes

et profits, pendant la quinzaine précédent l'assemblée générale annuelle.

Art. 19. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième (1/10) du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
L'excédent est à la libre disposition des associés.

Art. 20. La révision des comptes de la société peut être confiée, à la discrétion du/des associé(s), à un (1) ou plusieurs

réviseur(s). Dans tel cas, le(s) réviseur(s) sera/seront nommé(s) par l'assemblée générale des associés, qui déterminera
leur nombre, rémunération et la durée de leur mandat. Le(s) réviseur(s) est/sont rééligible(s).

Art. 21. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un (1) ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou

non, à désigner par l'assemblée générale des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la Loi sur les Sociétés.

Le(s) liquidateur(s) aura/ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la

société.

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales applicables.

<i>Souscription

Les statuts ayant ainsi été établis, le comparant déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:

parts

sociales

RHAPSODY AMERICA LLC, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Total: douze mille cinq cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Les parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en numéraire, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (12.500,- €) est à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu'il a été certifié au notaire
instrumentaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à 1.900,-€.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après la constitution de la société, l'associé unique prénommé a immédiatement pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre de gérants est fixé à un
2) Est nommé gérant pour une période indéterminée:
- Monsieur Ian Greaves, administrateur de sociétés, domicilié à Londres (GB).
3) Le siège social de la société est établi au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même comparante il est
spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Trevisan, P. Frieders.

13487

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2007. Relation: LAC /2007/ 39925. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2008.

P. Frieders.

Référence de publication: 2008010741/212/371.
(080006932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Geficar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 91, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 75.717.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008010836/2025/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01511. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Isarez S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 91, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 73.706.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008010837/2025/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01512. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Repco 7 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 110.748.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue à Luxembourg le 19 novembre 2007

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 19 novembre 2007 que:
1. M. Derek Mc Donald, né le 9 août 1967 à Paisley, Ecosse, demeurant 8 Glen Sannox Grove, Craigmarloch, UK-

Cumbernauld G68 OGH, a démissionné de ses fonctions d'administrateur B de la Société, avec effet immédiat.

2. M. Stuart Watson, né le 15 août 1964 à Lahore, Pakistan, banquier, demeurant 4 Manse Road, Dollar, Clackman-

nanshire, FK14 7AJ, Ecosse, a été nommé administrateur B avec effet immédiat. Son mandat expirera lors de l'assemblée
générale ordinaire de la Société qui sera tenue en vue d'approuver les comptes au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2008010641/280/18.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM02868. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

13488


Document Outline

Banian Finance S.à r.l.

Belair Assets SA

Bombardier Luxembourg Finance S.A.

Brandenburg Archie 15 Acquico 1 S.à r.l.

Fashion Style S.à r.l.

Flona Immo SA

Geficar S.A.

Habacker LogPark Site One S. à r.l.

Habacker LogPark Site Two S. à r.l.

ING REEIF Germany S.à r.l.

Isarez S.A.

Les Pléiades S.A.

Les Pléiades S.A.

Les Résidences Brasserie Funck S.A.

Loda Victoria Investment Company S.A.

Mondialconstruction Holding S.A.

Parker Hannifin Bermuda Luxembourg S.C.S.

Parker Hannifin (Gibraltar) Holding Luxembourg S.C.S.

Perpetuum Immobilier S.A.

PRESCO Hoist Investments S.A.

Repco 1 S.A.

Repco 2 S.A.

Repco 3 S.A.

Repco 5 S.A.

Repco 6 S.A.

Repco 7 S.A.

Rhapsody International S.à r.l.

Verdandi Management S.à r.l.

Verdandi Partnership S.C.S.

WM Findel (Luxembourg) S.à r.l.