This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 250
30 janvier 2008
SOMMAIRE
AES Carly S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11965
Anderton Global Energy Limited . . . . . . . .
11957
Anderton Global Energy Limited S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11957
Aster 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11957
Carlyle/Riverstone Participations II S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11999
Carlyle/Riverstone Participations S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11967
Charterhouse Stone S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
11999
Entreprise de Construction Erpelding S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11974
GS Draco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11962
GSIP I Mezzanine Global and International
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11962
LuxCo 66 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12000
Macquarie Luxembourg Gas S. à r.l. . . . . .
11957
MDC Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11975
MIF Germany Four S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
11967
Murada S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11956
Nortel Networks (Luxembourg) S.A. . . . .
11954
Parfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11999
Quinn Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11968
Sitinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11991
Tishman Speyer French Core Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11985
Tishman Speyer French Core II S.à r.l. . . .
11968
Tishman Speyer French Core V S.à r.l. . . .
11993
Vestigor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11991
11953
Nortel Networks (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 45.815.
DISSOLUTION
In the year two thousand and seven, on the seventh day of December.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
NORTEL NETWORKS LIMITED, a company incorporated under the Canada Business Corporations Act with Cor-
poration No. 125147-3, whose registered office is at 2351 Boulevard Alfred-Nobel, St. Laurent, Quebec Canada H4S
2A9,
duly represented by Mélanie Sauvage, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given
on December 4, 2007 (the Parent).
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder, acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration
authorities.
The appearing party, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state that:
- the Parent holds all the shares in NORTEL NETWORKS (LUXEMBOURG) S.A., a public limited liability company
(société anonyme), organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 45.815 (the Company),
incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, then notary public residing in Luxembourg,
on December 10, 1993, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 156, page 7445 of
1994, whose articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary
residing in Luxembourg, on April 26, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
570 of July 23, 1999;
- the Company's capital is set at seven hundred eight million nine hundred and twenty-five thousand US Dollars (USD
708,925,000.-) represented by seven hundred eight thousand nine hundred and twenty-five (708,925) shares, having a par
value of one thousand US Dollars (USD 1,000.-) each;
- the Parent, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, hereby resolves to proceed with the dissolution
of the Company with effect from today;
- the Parent assumes the role of liquidator of the Company;
- the Parent has full knowledge of the articles of association of the Company and perfectly knows the financial situation
of the Company;
- the closing financial statement of the Company for the period from January 1, 2007 through November 15, 2007 is
approved, a copy of which shall remain attached to the present deed;
- the Parent grants full discharge to the directors of the Company for their respective mandates from the date of their
respective appointments up to the date of the present meeting;
- the Parent grants full discharge to Mr. Anthony James McArdle in his capacity as auditor of the Company for its
mandate from the date of its appointment up to the date of the present meeting;
- the Parent as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities
of the Company have been settled or fully provided for, that the Parent is vested with all the assets and hereby expressly
declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular those hidden or
any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;
- the Parent shall perform, register, execute or undertake any other step required in order to transfer to it all the
assets and/or all outstanding liabilities (if any) of the Company;
- consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed; and
- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting
at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the above-appearing party,
the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version shall prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
11954
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le septième jour du mois de décembre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
NORTEL NETWORKS LIMITED, une société organisée selon les lois du Canada, dont le siège social est à 2351
Boulevard Alfred-Nobel, St. Laurent,
dûment représentée par Mélanie Sauvage, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée le 4 décembre 2007 (la Société Mère).
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire
instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
- la Société Mère détient toutes les parts sociales de NORTEL NETWORKS (LUXEMBOURG) S.A., une société
anonyme organisée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
enregistrée au registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45.815 (la Société); constituée
suivant un acte de Maître André-Jean Joseph Schwachtgen, alors notaire résidant à Luxembourg, le 10 décembre 1993
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 156, page 7445 de 1994, dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant un acte de Maître Gérard Lecuit, de résidence à Luxembourg, le 26 avril 1999, publiés au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 570 du 23 juillet 1999;
- le capital social de la Société est fixé à sept cent huit millions neuf cent vingt-cinq mille dollars américains (USD
708.925.000,-) représenté par sept cent huit mille neuf cent vingt-cinq (708.925) parts sociales ayant une valeur nominale
de mille dollars américains (USD 1.000,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées;
- la Société Mère, en sa qualité d'associé unique de la Société et bénéficiaire économique finale de l'opération, décide
de procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat;
- la Société Mère assume le rôle de liquidateur de la Société;
- la Société Mère a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de la Société;
- les comptes de clôture de la Société pour la période du 1
er
janvier 2007 au 15 novembre 2007 ont été approuvés,
une copie desdits comptes devra restée annexée au présent acte;
- la Société accorde décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour leurs mandats à compter de la date de
leurs nominations respectives jusqu'à la date de la présente assemblée;
- La Société Mère accorde décharge pleine et entière au commissaire de la Société, M. Antony James Mc Ardle, pour
son mandat à partir de la date de sa désignation jusqu'à la date de l'assemblée de ce jour;
- la Société Mère, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif
connu de la Société a été payé ou provisionné, que la Société Mère est investie de tout l'actif et qu'elle s'engage expres-
sément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif
impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;
- la Société Mère accomplira, enregistrera, exécutera ou entreprendra tout autre étape requise afin de transférer à
elle-même tout l'actif et/ou passif impayé de la Société;
- partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée; et
- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date
de la présente assemblée 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, certifie par les présentes qu'à la demande de la partie com-
parante, le présent acte a été créé en anglais suivi d'une traduction française, et en cas de divergences entre les versions
anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: M. Sauvage, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2007. Relation: LAC/2007/40740. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2008009814/242/108.
(080005250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.
11955
Murada S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 46.486.
DISSOLUTION
L'an deux mille sept, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée MAROWINIA HOLDING S.A., avec siège social à L-2311
Luxembourg, 3, avenue Pasteur,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, agissant en vertu d'une procuration
sous seing privé lui délivrée annexée aux présentes,
Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:
- que la société dénommée MURADA S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 3,
avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B n
o
46.486 a été constituée aux
termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 janvier 1994, publié au Mémorial C numéro 161 du 25
avril 1994
dont le capital social a été converti en euros aux termes d'une assemblée générale tenue sous seing privé en date du
30 mars 2000, dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 784 du 23 mai 2002.
- que le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (€ 31.250,-), représenté par mille deux
cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25,-).
- qu'elle s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société MURADA S.A.;
- que l'activité de la société étant réduite, la comparante décide la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat,
cette décision étant prise au nom de la société MAROWINIA HOLDING S.A., prénommée, en assemblée générale
extraordinaire en sa qualité d'actionnaire unique de la société MURADA S.A.;
- que la société MAROWINIA HOLDING S.A. est nommée liquidateur de la société MURADA S.A., qu'en cette qualité,
la comparante requiert le notaire instrumentant de documenter:
- que la société dissoute n'a pas de passif et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment
provisionné,
- que par rapport à d'éventuels passifs de la société MURADA S.A., actuellement inconnus et non payés à l'heure
actuelle, elle assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence, tout le passif de
ladite société est considéré comme réglé,
- que le rapport du liquidateur est annexé aux présentes;
- que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport établi en date du 14 décembre
2007 par la FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A., établie et ayant son siège à L-2012 Luxembourg, 16, Allée Marconi,
désignée «commissaire à la liquidation» par l'actionnaire unique de la société MURADA S.A., lequel rapport est annexé
aux présentes;
- que la liquidation de la société MURADA S.A. est à considérer comme faite et clôturée;
- qu'est accordée décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société MU-
RADA S.A.;
- que les livres et documents de la société MURADA S.A. sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège
social de la Société.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Dax, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le décembre 2007. Relation: EAC/2007/16419. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 4 janvier 2008.
F. Kesseler.
Référence de publication: 2008009812/219/54.
(080005258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.
11956
Macquarie Luxembourg Gas S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 24.850,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 101.699.
Par résolution signée en date du 21 novembre 2007, les associés ont nommé Monsieur Philippe Salpetier, avec adresse
professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2007.
Référence de publication: 2008008705/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01599. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(080003774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.
Aster 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 102.802.
Par résolution circulaire en date du 13 décembre 2007, les actionnaires ont nommé Monsieur Peter Koivula, avec
adresse professionnelle au 8, Mannerheimintie, 00100 Helsinki, Finlande, en tant qu'administrateur avec effet immédiat
et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes annuels de
l'exercice se clôturant au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2008008706/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01596. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080003771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.
Anderton Global Energy Limited S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Anderton Global Energy Limited).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 124.149.
In the year two thousand and seven, on the fifth day of December,
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of ANDERTON GLOBAL ENERGY
LIMITED S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered
office at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 124.149 (the Company). The Company was incorporated and organised
under the laws of the Cayman Islands and migrated to Luxembourg with the entire restatement of the articles of asso-
ciation of the Company (the Articles) pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated
December 13, 2006 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 597 of April 13, 2007.
There appeared:
1) WOODBOURNE TRUSTEES Ltd, a company incorporated and organized under the laws of Bermuda, having its
registered office at 20 Parliament Street, P.O. Box HM 1475, Hamilton, HM 12, Bermuda, registered with the Bermuda
Monetary Authority under the number 17741,
represented by Michael Meylan, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
2) Wallace Cook, born on 10 September 1939 in Jamaica, New York, United States of America, residing at 1 Peabody
Lane, Darien, Connecticut, 06820-5922, United States of America,
represented by Michael Meylan, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
3) Mahesh Naithani, born on 3 January 1946 in Allahabad, U.P., India, residing at 255 West 94th Street Apt.21E, New
York, 10013 New York, United States of America,
11957
represented by Michael Meylan, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
4) Elizabeth A. Turner, born on 28 May 1939 in Brooklyn, New York, United States of America, residing at 34 Chester
Terrace, London, NW1 4ND, United Kingdom,
represented by Michael Meylan, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
5) Brian D. Beglin, born on 10 December 1951 in New York, New York, United States of America, residing at 115
White Plains Road, Bronxville, 10708 New York, United States of America,
represented by Michael Meylan, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
6) THE HARBOUR TRUST COMPANY, a company incorporated and organized under the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at One Capital Place, P.O. Box 897GT, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with Cayman
Island Monetary Authority under the number 16091,
represented by Michael Meylan, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
7) Lawrence Cooley, born on 10 June 1935 in Oxford, England, residing at 18, boulevard des Cretes, Sinopolis 83580,
Gassin, France,
represented by Michael Meylan, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
8) Alexandra E. Turner, born on 15 December 1973 in Lake Forest, Illinois, United States of America, residing at 35
East 85th Street Apt.3B-N, New York, NY 10028-0961, United States of America,
represented by Michael Meylan, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
9) Lisa A. Turner, born on 21 April 1972 in Lake Forest, Illinois, United States of America, residing at 34 Chester
Terrace, London, NW1 4ND, United Kingdom,
represented by Michael Meylan, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
10) ZRH NOMINEES (0047) Ltd., a company incorporated and organized under the laws of the British Virgin Islands,
having its registered office at Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered
with Territory of the BVI under the number IBC No. 294149,
represented by Michael Meylan, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
(the individuals and entities mentioned under 1) to and including 10) above are collectively referred to as the Share-
holders).
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record that:
I. Thirty-two thousand five hundred (32,500) shares of the Company with a nominal value of twenty-five Euro (EUR
25.-) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this meeting which is
consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.
II. The proxies, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties, and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
III. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices.
2. Reduction of the share capital of the Company by an amount of eight hundred thousand Euro (EUR 800,000.-) so
as to bring it from its current amount of eight hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR 812,500.-) represented
by thirty-two thousand five hundred (32,500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), by way of the redemption and cancellation of an aggregate number of thirty-
two thousand (32,000) shares in an aggregate amount of eight hundred thousand Euro (EUR 800,000.-) to be paid in cash
to the shareholders of the Company.
3. Recording of the new shareholding in the Company as a consequence of the share capital reduction.
4. Subsequent amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles).
5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the share capital reduction of the
Company, with power and authority to any manager of the Company and any lawyer or employee of LOYENS WINANDY
to proceed on behalf of the Company to the registration of the cancellation of the shares in the register of shareholders
of the Company.
6. Miscellaneous.
IV. After due deliberation, the Shareholders unanimously resolve to take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having
perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to reduce and hereby reduce the share capital of the Company by an amount of eight hundred
thousand Euro (EUR 800,000.-) so as to bring it from its current amount of eight hundred twelve thousand five hundred
Euro (EUR 812,500.-) represented by thirty-two thousand five hundred (32,500) shares with a nominal value of twenty-
11958
five Euro (EUR 25.-) each, to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), by way of the redemption and cancellation
of an aggregate number of thirty-two thousand (32,000) shares in an aggregate amount of eight hundred thousand Euro
(EUR 800,000.-) to be paid in cash as follows:
Name of Shareholder
Number
Redemption
of shares
Price
redeemed
EUR
1. WOODBOURNE TRUSTEES Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,000
400,000.-
2. Wallace Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,134
53,350.-
3. Mahesh Naithani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,266
106,650.-
4. Elizabeth A. Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,052
76,300.-
5. Brian D. Beglin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
574
14,350.-
6. THE HARBOUR TRUST COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
657
16,425.-
7. Lawrence Cooley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
657
16,425.-
8. Alexandra E. Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,526
38,150.-
9. Lisa A. Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,526
38,150.-
10. ZRH NOMINEES (0047) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,608
40,200.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32,000
800,000.-
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to record that the shareholding of the Company is, further to the above share capital
reduction, as follows:
Shareholders
Number
of
shares
1. WOODBOURNE TRUSTEES Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
2. Wallace Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
3. Mahesh Naithani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
4. Elizabeth A. Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
5. Brian D. Beglin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6. THE HARBOUR TRUST COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
7. Lawrence Cooley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
8. Alexandra E. Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
9. Lisa A. Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
10. ZRH NOMINEES (0047) LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 5.1 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:
«5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by
five hundred (500) shares in registered form, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and
fully paid-up.»
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above share
capital reduction of the Company, with power and authority to any manager of the Company and any lawyer or employee
of LOYENS WINANDY to proceed on behalf of the Company to the registration of the cancellation of the shares in the
register of shareholders of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately 1,600.- Euro.
The undersigned notary, who speaks and reads English, states that upon request of the appearing parties, the present
deed is worded in English followed by a French version, and in case of discrepancies between the English and the French
texts, the English version shall prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, he proxyholder signed together with the
notary the present deed.
11959
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le cinq décembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés d'ANDERTON GLOBAL ENERGY
LIMITED S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 64, rue Principale,
L-5367 Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 124.149 (la Société). La Société a été constituée et organisée selon les lois des Iles Cayman et a
migré au Luxembourg, avec une refonte complète des statuts de la Société suivant un acte de Maître Jospeh Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg, daté du 13 décembre 2006 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 597 du 13 avril 2007.
Ont comparu:
1) WOODBOURNE TRUSTEES Ltd, une société constituée et organisée selon les lois des Bermudes ayant son siège
social au 20 Parliament Street, P.O. Box HM 1475, Hamilton, HM 12, Bermudes, enregistrée auprès de Bermuda Monetary
Authority sous le numéro 17741,
représentée par Michael Meylan, Avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé;
2) Wallace Cook, né le 10 septembre 1939 à Jamaica, New York, Etats-Unis d'Amérique, demeurant au 1 Peabody
Lane, Darien, Connecticut, 06820-5922, Etats-Unis d'Amérique,
représenté par Michael Meylan, Avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé;
3) Mahesh Naithani, né le 3 janvier 1946 à Allahabad, U.P., Inde, demeurant au 255 West 94th Street Apt.21E, New
York, 10013 New York, Etats-Unis d'Amérique,
représenté par Michael Meylan, Avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé;
4) Elizabeth A. Turner, née le 28 mai 1939 à Brooklyn, New York, Etats-Unis d'Amérique, demeurant au 4 Chester
Terrace, Londres, NW1 4ND, Royaume-Uni,
représentée par Michael Meylan, Avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé;
5) Brian D. Beglin, né le 10 décembre 1951 à New York, New York, Etats-Unis d'Amérique, demeurant au 115 White
Plains Road, Bronxville, 10708 New York, Etats-Unis d'Amérique,
représenté par Michael Meylan, Avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé;
6) THE HARBOUR TRUST COMPANY, une société constituée et organisée selon les lois des Iles Cayman, ayant son
siège social au One Capital Place, P.O. Box 897GT, Grand Cayman, Iles Cayman, inscrite auprès de Cayman Island
Monetary Authority sous le numéro 16091,
représentée par Michael Meylan, Avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé;
7) Lawrence Cooley, né le 10 juin 1935 à Oxford, Angleterre, demeurant au 18, boulevard des Cretes, Sinopolis 83580,
Gassin, France,
représentée par Michael Meylan, Avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé;
8) Alexandra E. Turner, née le 15 décembre 1973 à Lake Forest, Illinois, Etats-Unis d'Amérique, demeurant au 35 East
85th Street Apt.3B-N, New York, NY 10028-0961, Etats-Unis d'Amérique,
représentée par Michael Meylan, Avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé;
9) Lisa A. Turner, née le 21 avril 1972 à Lake Forest, Illinois, Etats-Unis d'Amérique, demeurant au 34 Chester Terrace,
Londres, NW1 4ND, Royaume-Uni,
représentée par Michael Meylan, Avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé;
10) ZRH NOMINEES (0047) Ltd., une société constituée et organisée selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant
son siège social à Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, inscrite au Territory
of the BVI sous le numéro IBC No. 294149,
représentée par Michael Meylan, Avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé;
(les individus et entités mentionnés au point 1) à 10) inclus sont désignés collectivement les Associés).
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Trente-deux mille cinq cents (32.500) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée, qui est par conséquent
régulièrement constituée et peut délibérer sur tous les points de l'ordre du jour, reproduit ci-après.
II. Les procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentaire,
resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci auprès de l'enregistrement.
III. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Réduction du capital social de la Société d'un montant de huit cent mille euros (EUR 800.000,-) afin de le porter de
son montant actuel de huit cent douze mille cinq cents euros (EUR 812.500,-) représenté par trente-deux mille cinq cents
11960
(32.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) par le rachat et l'annulation d'un nombre total de trente-deux mille (32.000) parts sociales pour un montant
total de huit cent mille euros (EUR 800.000,-) à payer en numéraire aux associés de la Société.
3. Enregistrement du nouvel actionnariat de la Société en conséquence de la réduction du capital social.
4. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts).
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter la réduction du capital social de la Société avec
pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY afin de procéder
pour le compte de la Société à l'inscription de l'annulation des parts sociales dans le registre des associés de la Société.
6. Divers.
IV. Après délibération, les Associés décident à l'unanimité de prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux for-
malités de convocation, les Associés représentés à l'Assemblée se considérant eux-mêmes dûment convoqués et déclarant
avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de réduire et réduisent par les présentes le capital social de la Société d'un montant de huit
cent mille euros (EUR 800.000,-) afin de le porter de son montant actuel de huit cent douze mille cinq cents euros (EUR
812.500,-) représenté par trente-deux mille cinq cents (32.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) par le rachat et l'annulation d'un nombre total de
trente-deux mille (32.000) parts sociales pour un montant total de huit cent mille euros (EUR 800.000,-) à payer en
numéraire de la manière suivante:
Non de l'Associé
Nombre
Prix de
de parts
Rachat
sociales
EUR
rachetées
1. WOODBOURNE TRUSTEES Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.000
400.000,-
2. Wallace Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.134
53.350,-
3. Mahesh Naithani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.266
106.650,-
4. Elizabeth A. Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.052
76.300,-
5. Brian D. Beglin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
574
14.350,-
6. THE HARBOUR TRUST COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
657
16.425,-
7. Lawrence Cooley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
657
16.425,-
8. Alexandra E. Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.526
38.150,-
9. Lisa A. Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.526
38.150,-
10. ZRH NOMINEES (0047) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.608
40.200,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.000
800.000,-
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident d'enregistrer que l'actionnariat de la Société est, en conséquence de la réduction de capital
social ci-dessus, le suivant:
Associé
Nombre
de parts
sociales
1. WOODBOURNE TRUSTEES Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
2. Wallace Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
3. Mahesh Naithani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
4. Elizabeth A. Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
5. Brian D. Beglin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6. THE HARBOUR TRUST COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
7. Lawrence Cooley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
8. Alexandra E. Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
9. Lisa A. Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
10. ZRH NOMINEES (0047) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
11961
«5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes sou-
scrites et entièrement libérées.»
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter la réduction du capital social
de la Société avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY
afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription de l'annulation des parts sociales dans le registre des associés
de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit relatifs au présent acte, qui
incomberont à la Société, s'élèvent à environ 1.600,- Euros.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte
est établi en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergence entre la version anglaise et française, la version
anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Après lecture faite au mandataire des comparantes, ce dernier a signé avec le notaire le présent acte en original.
Signé: M. Meylan, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2007, Relation LAC/2007/39695. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2008009757/211/269.
(080006069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.
GSIP I Mezzanine Global and International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GS Draco S.à r.l.).
Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 119.011.
In the year two thousand and seven, on the ninth of November.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. GS INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., a limited partnership formed and existing under the
laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under registration
number CT-17579, having its registered office at c/o Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, acting through its general partner GS INFRASTRUCTURE ADVISORS
2006, L.L.C., here represented by Hassane Diabate, juriste, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
2. GS GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of
the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4105157, having its
registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, New Castle County, 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting through its general partner GS INFRASTRUCTURE ADVISORS 2006,
L.L.C., here represented by Hassane Diabate, juriste, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
Which proxies shall be signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary and shall be attached
to the present deed to be filed at the same time.
The above named parties, represented as mentioned above, declare:
I. That GS INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P. and GS GLOBAL INFRASTRUCTURE PART-
NERS I, L.P., prenamed, are the shareholders of GSIP I MEZZANINE GLOBAL AND INTERNATIONAL S.à r.l., a société
à responsabilité limitée, with registered office at 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under registration number B 119.011 (the «Company»), incorporated by deed of Maître
Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, dated August 31, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 1808 of September 27, 2006. The Company's articles of association have been amended by deed
of the undersigned notary dated January 3, 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
590 of April 12, 2007.
11962
II. That the capital is fixed at 12,500.- € (twelve thousand five hundred euro) represented by 500 (five hundred) shares
with a nominal value of 25.- € (twenty-five euro) each, entirely subscribed for and fully paid up.
III. That the agenda is as follows:
<i>Agenda:i>
1. Change of the currency of the Company's share capital from euro into Pounds Sterling. The rate to be used for the
conversion will be 1.- € equals 0.68 GBP;
2. Change of the nominal value of each share from 25.- € (twenty-five euro) into 0.01 GBP (one penny Pound Sterling);
3. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of 1,500.- GBP (one thousand five hundred
Pounds Sterling) to bring it from its present amount of 12.500.- € (twelve thousand five hundred euro), which when
converted into Pound Sterling is equal to 8,500.- GBP (eight thousand five hundred Pounds Sterling) to 10,000.- GBP (ten
thousand Pounds Sterling) by the creation and the issue of 150,000 (one hundred fifty thousand) new shares having a par
value of 0.01 GBP (one penny Pound Sterling) each, having the same rights and obligations as the existing shares.
4. Subscription for all the 150,000 (one hundred fifty thousand) new shares by the two above-mentioned shareholders
and paying up of these shares by a contribution in cash of an amount of 1,500.- GBP (one thousand five hundred Pounds
Sterling).
5. Amendment of Article 6 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the above changes.
6. Amendment of Article 13 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the above changes.
After this had been set forth, the above named shareholders of the Company, representing the entire capital of the
Company, now request the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to change the actual currency of the Company's share capital from euro into Pounds Sterling.
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolve to change the actual nominal value of each share from 25.- € (twenty-five euro) into 0.01-
GBP (one penny Pound Sterling).
<i>Third resolutioni>
The shareholders resolve to increase the subscribed share capital of the company by an amount of 1,500.- GBP (one
thousand five hundred Pounds Sterling) to bring it from its present amount of 12,500.- € (twelve thousand five hundred
euro), which when converted into Pounds Sterling is equal to 8,500.- GBP (eight thousand five hundred Pounds Sterling)
to 10,000.- GBP (ten thousand Pounds Sterling) by the creation and the issue of 150,000 (one hundred fifty thousand)
new parts having a par value of 0.01 GBP (one penny Pound Sterling) each.
<i>Subscriptioni>
1. GS INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., hereby declares to subscribe for 111,000 (one hun-
dred and eleven thousand) new shares each with a par value of 0.01 GBP (one penny Pound Sterling), and paying up by
a contribution in cash;
2. GS GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., hereby declares to subscribe for 39,000 (thirty-nine thousand)
new shares each with a par value of 0.01 GBP (one penny Pound Sterling), and paying up by a contribution in cash.
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders resolve to amend Article 6 of the articles of incorporation of the Company, which shall now read
as follows:
« Art. 6. The capital is fixed at 10,000.- GBP (ten thousand Pounds Sterling), represented by 1,000,000 (one million)
shares, each with a nominal value of 0.01 GBP (one penny Pound Sterling), entirely subscribed for and fully paid up.»
<i>Fifth resolutioni>
The shareholders resolve to amend Article 13 of the articles of incorporation of the Company, which shall now read
as follows:
« Art. 13. The company is bound by the sole signature of any one manager for decisions having a value of an amount
of up to ten thousand Pounds Sterling (10,000.- GBP). For decisions having a value of an amount over ten thousand Pounds
Sterling (10,000.- GBP), the company is bound by the joint signature of at least two managers.»
<i>Valuation and expensesi>
For registration purposes, the amount of 1,500.- GBP is valued at 2,142.- €.
The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated approximately at 1,400.- €.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,
the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
11963
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by surname, given name, civil status
and residence, the said person signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L'an deux mille sept, le neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) GS INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., un limited partnership constitué et opérant sous le
droit de l'Etat des Iles Caïman, enregistré auprès du Register of Exempted Limited Partnership in the Cayman Islands sous
le numéro 17579 ayant son siège social à c/o Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands, agissant par l'intermédiaire de son general partner GS INFRASTRUCTURE AD-
VISORS 2006, L.L.C., ici représenté par Hassane Diabate, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
lui conférée sous seing privé.
2) GS GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., un limited partnership constitué et opérant sous le droit de
l'Etat du Delaware, enregistré auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 4105157 ayant son siège social
THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, New Castle County, 1209 Orange Street, Wil-
mington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, agissant par l'intermédiaire de son general partner GS INFRASTRUC-
TURE ADVISORS 2006, L.L.C. ici représenté par Hassane Diabate, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une
procuration lui conférée sous seing privé.
Lesquelles procurations sont signées ne varietur par le mandataire des comparants susnommés et le notaire soussigné
et resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent que:
I. Les sociétés prénommées sont les uniques associés représentant l'intégrité du capital de GSIP I MEZZANINE GLO-
BAL AND INTERNATIONAL S.à r.l. («la Société»), ayant son siège social au 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B119.011, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 31 août
2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1808 du 27 septembre 2006. Les statuts ont
été modifies suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 590 du 12 avril 2007.
II. Le capital social de la société est fixé à 12.500,- € (douze mille cinq cents euros) divisé en 500 (cinq cents) parts
sociales de 25,- € (vingt-cinq euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.
III. L'ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la devise du capital social d'euros à Livres Sterling. Le taux de change qui sera utilisé sera le suivant:
1,- euro équivaut à 0,68 GBP.
2. Changement de la valeur nominale de chaque part de 25,- € (vingt-cinq euros) en 0,01 GBP (un cent de Livre Sterling).
3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 1.500,- GBP (mille cinq cents Livres Sterling) pour le
porter de son montant actuel de 12.500,- € (douze mille cinq cents euros), équivalant à 8.500,- GBP (huit mille cinq cents
Livres Sterling) à 10.000,- GBP (dix mille Livres Sterling) par la création et l'émission de 150.000,- (cent cinquante mille)
nouvelles parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 GBP (un cent de Livre Sterling), ayant les mêmes
droits et obligations que les parts existantes.
4. Souscription de 150.000 (cent cinquante mille) nouvelles parts sociales par les deux actionnaires préexistants; et
paiement de ces parts par un apport en numéraire d'un montant de 1.500,- GBP (mille cinq cents Livres Sterling).
5. Modification de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter les changements ci-dessus.
6. Modification de l'article 13 des statuts de la Société afin de refléter les changements ci-dessus.
Ceci ayant été exposé, les associés prénommés de la Société, représentant l'intégralité du capital de la Société, re-
quièrent désormais le notaire instrumentaire de prendre acte des décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés de la Société décident de modifier la devise du capital social de la Société de l'euro à la Livre Sterling.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés de la Société décident de modifier la valeur nominale de chacune des parts sociales de 25,- € (vingt-cinq
euros) à 0,01 GBP (un cent de Livre Sterling).
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social d'un montant de 1.500,- GBP (mille cinq cents Livres Sterling) pour
le porter de son montant actuel de 12.500,- € (douze mille cinq cents euros), converti en Livres Sterling égal à 8.500,-
11964
GBP (huit mille cinq cents Livres Sterling) à 10.000,- GBP (dix mille Livres Sterling) par la création et l'émission de 150.000
(cent cinquante mille) nouvelles parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 GBP (un cent de Livre Sterling).
<i>Souscriptioni>
1) GS INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., a déclaré souscrire 111.000 (cent onze mille) nou-
velles parts sociales, ayant une valeur nominale chacune de 0,01 GBP (un cent de Livre Sterling) et paiement de ces parts
par un apport en numéraire;
2) GS GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., a déclaré souscrire 39.000 (trente-neuf mille) nouvelles parts
sociales, ayant une valeur nominale chacune de 0,01 GBP (un cent de Livre Sterling) et paiement de ces parts par un
apport en numéraire.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à 10.000,- GBP (dix mille Livres Sterling) divisé en 1.000.000 (un million)
de parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 GBP (un cent de Livre Sterling), entièrement souscrites et
libérées.»
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés de la Société décident de modifier l'Article 13 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 13. La société est engagée par la seule signature d'un gérant pour toute décision ayant une valeur jusqu'à un
montant de dix mille Livres Sterling (10.000,- GBP). Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à dix mille
Livres Sterling (10.000,- GBP), la société est engagée par les signatures conjointes d'au moins deux gérants.»
<i>Evaluation et coûtsi>
Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de 1.500,- GBP est évalué à 2.142,- €.
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte, s'élèvent approximativement à 1.400,- €.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare par la présente que sur demande du comparant, le
présent acte a été établi en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de
divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état
et demeure, ledit comparant a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Diabate, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007. LAC/2007/35656. — Reçu 21,42 euros.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): F. Schneider.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2007.
P. Frieders.
Référence de publication: 2008009762/212/178.
(080005235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.
AES Carly S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 79.116.
In the year two thousand and seven, on the seventh day of December.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
AES DEVIN CO, a company incorporated under the laws of Ireland, having its registered office at 1 Guild Street,
International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland, registered with the Companies Registration Office in Ireland
under the number 316323,
here represented by Ms Melanie Sauvage, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a
proxy given on December 6, 2007.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
11965
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. AES DEVIN CO is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Luxembourg private limited liability company
(société à responsabilité limitée) existing under the name of AES CARLY S.à r.l., having its registered office at 5, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of commerce and companies under the
number B 79.116 (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxem-
bourg, dated November 27, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of June 15, 2001,
page 21361. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last
time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, dated May
29, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of August 24, 2006, page 1609.
II. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully
paid-up.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to grant full discharge to the Class A managers and Class B managers of the Company
for the performance of their duties.
<i>Third resolutioni>
Notwithstanding article seventeen of the Articles, the Sole Shareholder resolves to appoint SIRAM INVESTMENTS
B.V., a limited liability company incorporated and organised under the law of the Netherlands, having its registered address
at Parklaan 32, 3016BC Rotterdam, the Netherlands, registered with the trade register of the Chamber of Commerce
of Rotterdam, the Netherlands, under number 33167502, as liquidator of the Company (the Liquidator) and grants to
the Liquidator (i) powers to prepare a detailed inventory of the Company's assets and liabilities and (ii) broadest powers
to perform its duties.
The Sole Shareholder further resolves and acknowledges that the Company will be bound towards third parties by
the sole signature of the Liquidator.
There being no further business, the meeting is closed.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties
the present deed is worded in English, followed by a French version at the request of the same appearing parties. In case
of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing person, the person appearing signed together with Us, the notary,
this original notarial deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le septième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
AES DEVIN CO, une société constituée selon les lois irelandaises, ayant son siège social à 1 Guild Street, International
Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland, immatriculée auprès du Companies Registration Office en Ireland sous le
numéro 316323,
ici représentée par M
e
Mélanie Sauvage, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée le 6 décembre 2007.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. AES DEVIN CO est l'associé unique (l'Associé Unique) de la société à responsabilité limitée constituée et organisée
selon les lois de Luxembourg, AES CARLY S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.116 (la Société),
constituée par acte reçu du notaire Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre
2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 15 juin 2001, page 21361. Les statuts de la Société
(les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois conformément à un acte reçu de Maître Martine
Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand Duché de Luxembourg, en date du 29 mai 2006, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations du 24 août 2006, page 1609.
11966
II. Le capital social de la Société est fixé à un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par
cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de procéder à la dissolution de la Société et de mettre la Société en liquidation.
<i>Seconde résolutioni>
L'Associé Unique décide de donner pleine et entière décharge aux gérants de Classe A et aux gérants de Classe B
pour l'exercice de leur mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer la société SIRAM INVESTMENTS B.V., une société à responsabilité limitée con-
stituée et organisée selon les lois néerlandaises, ayant son siège social à Parklaan 32, 3016BC Rotterdam, Pays Bas,
immatriculée auprès de la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays Bas, sous le numéro 33167502 en tant que
liquidateur de la Société (le Liquidateur) et octroie au Liquidateur (i) tous les pouvoirs pour préparer un inventaire détaillé
des actifs et passifs de la Société (ii) les pouvoirs les plus étendus pour effectuer sa mission.
L'Associé Unique décide et prend acte que la Société sera engagée à l'égard des tiers par la signature unique du
Liquidateur.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des même comparants et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Sauvage, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2007. Relation: LAC/2007/39903. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): F. Sandt.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2008009807/242/99.
(080005345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.
Carlyle/Riverstone Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.018.000,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 104.545.
EXTRAIT
La société CARLYLE/RIVERSTONE PARTICIPATIONS S.à r.l., a changé son siège social du 30, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2007.
Pour extrait conforme
ATOZ
Signature
Référence de publication: 2008009005/4170/18.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02122. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080004223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.
MIF Germany Four S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 130.485.
L'adresse exacte de l'associé, MIF HOLDINGS S.à.r.l. est le 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
11967
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2008008708/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01601. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080003760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.
Quinn Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 109.510.
Par résolution signée en date du 26 novembre 2007, l'associé unique a renouvelé le mandat de PricewaterhouseCoo-
pers, avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises avec effet immédiat
et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes annuels de
l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2008008709/581/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01583. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080003764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.
Tishman Speyer French Core II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 134.947.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the nineteenth of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
TISHMAN SPEYER FRENCH CORE HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) incorporated and organized under the Luxembourg law, having its registered office at 34-38, avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg, under process of registration with the Luxembourg Trade and Company Register,
here represented by Mr Gael Toutain, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by
virtue of a proxy established on December 19th, 2007.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the
articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the devel-
opment of such participating interests.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees
or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part
of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliates).
11968
In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take
any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with
its purposes or which are liable to promote their development or extension.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may be
convertible.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name TISHMAN SPEYER FRENCH CORE II S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is fixed at fifty-three thousand two hundred fifty Euro (€ 53,250.-) represented by two thousand
one hundred thirty (2,130) shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-
holders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers composed of at least three managers divided into two categories, respectively denomi-
nated «Category A Managers» and «Category B Managers». The manager(s) need not to be shareholder(s). The manager
(s) may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.
Art. 13. In dealing with third parties, the sole manager or the board of managers will have all powers to act in the
name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the sole manager or the board of managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of the sole manager or, in case of plurality
of managers, by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.
The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers shall have the rights to give special proxies
for determined matters to one or more proxyholders, selected from its members or not either shareholders or not.
Art. 14. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may delegate the day-to-day
management of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and will determine the manager's/agent's respon-
sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his
agency. It is understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition,
disposition, financing and refinancing have to obtain the prior approval from the sole manager or the board of managers.
In case of plurality of managers, the board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman
is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.
In case of plurality of managers, the board of managers may elect a secretary from among its members.
In case of plurality of managers, the meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary
or by any two managers. The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present
or represented.
In case of plurality of managers, a manager may be represented by another member of the board of managers, and a
member of the board of managers may represent several managers.
In case of plurality of managers, the board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its
members is present or represented by proxies and with at least the presence or the representation of one Category B
11969
manager. Any decisions taken by the board of managers shall require a simple majority including at least the favourable
vote of one Category B manager. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.
In case of plurality of managers, one or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or
by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to
simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the
meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same
content signed by all the members having participated.
In case of plurality of managers, a written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been
adopted at a meeting of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented
in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board
of managers.
The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on
the basis of a statement of accounts prepared by the sole manager or the board of managers showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by the Articles.
Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.
Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 17. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each
year.
Art. 18. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the sole manager or the
board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-
termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-
first of December 2008.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, TISHMAN SPEYER FRENCH CORE HOLDINGS S.à r.l.,
prenamed, declared to subscribe the two thousand one hundred thirty (2,130) shares and have them fully paid up in
nominal value by contribution in cash of fifty-three thousand two hundred fifty Euro (€ 53,250.-).
The amount of fifty-three thousand two hundred fifty Euro (€ 53,250.-) has been fully paid up in cash and is now
available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at two thousand five hundred Euro (€ 2,500.-).
11970
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder resolves to:
1. Appoint the sole shareholder as sole manager of the Company for an unlimited period of time.
2. Fix the registered seat of the Company at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TISHMAN SPEYER FRENCH CORE HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social aux 34-38, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en cours d'enregistrement auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg,
ici représentée par M. Gael Toutain, employé privé, avec adresse professionnelle au 1 B Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg, en vertu d'une procuration donnée le 19 décembre 2007,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société à respon-
sabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets. Elle peut (par voie de prêts, avances, cautionnement, sûretés ou autres) accorder tout
concours aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation, ou bien qui font partie du groupe de
sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou filiales).
En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou
immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'autres ins-
truments qui pourront être convertibles.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination TISHMAN SPEYER FRENCH CORE II S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante-trois mille deux cent cinquante Euro (€ 53.250,-) représenté par deux mille
cent trente (2.130) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.
11971
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-
semblée générale des associés, en conformité avec l'article 16 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance composé d'au moins trois gérants divisés en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie
A» et «Gérants de catégorie B». Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Il(s) peut(vent) être
révoqué(s) à tout moment, avec ou sans justification, par une décision des associés représentant une majorité des voix.
Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique ou le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir au nom
de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à
l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance.
Envers les tiers, la société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique, ou, en cas de pluralité de
gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés
parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.
Art. 14. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière
de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle)
des gérants/ mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il
est convenu que la gestion journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition,
de disposition, de financement et refinancement doivent être préalablement approuvés par le gérant unique ou le conseil
de gérance.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut
être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou
par deux gérants. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont
présents ou représentés.
En cas de pluralité de gérants, un gérant peut en représenter un autre au conseil de gérance, et un gérant peut
représenter plusieurs gérants.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une
majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et qu'au moins un gérant de catégorie B est
présent ou représenté. Toute décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote
affirmatif d'un gérant de catégorie B. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.
En cas de pluralité de gérants, chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par con-
férence call ou par tout autre moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les
gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront
censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans
plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.
En cas de pluralité de gérants, une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au
même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de gérance, dûment convoquée et tenue. Cette décision peut
être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur
dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérante unique ou le conseil de gérance duquel il ressort que des
fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le
montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distri-
11972
buables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou
statutaire.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 16. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 18. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant unique ou le
conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider
qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre
2008.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, TISHMAN SPEYER FRENCH CORE HOLDINGS S.à r.l., désigné ci-
dessus, déclare souscrire aux deux mille cent trente (2.130) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale
par apport en numéraire de cinquante-trois mille deux cent cinquante Euro (€ 53.250,-).
Un montant de cinquante-trois mille deux cent cinquante Euro (€ 53.250,-) a été intégralement libéré en numéraire
et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille cinq cents Euro (€
2.500,-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
L'associé unique décide de:
1. Nommer l'associé unique comme gérant unique de la Société pour une durée indéterminée
2. Fixer l'adresse du siège social aux 34-38, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: G. Toutain, J. Elvinger.
11973
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2007, Relation: LAC/2007/42092. — Reçu 532,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2008.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2008010030/211/306.
(080005404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.
Entreprise de Construction Erpelding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3233 Bettembourg, 26, rue de l'Ecole.
R.C.S. Luxembourg B 24.570.
L'an deux mille sept, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Roland Urbing, technicien, né à Luxembourg, le 28 octobre 1948, époux de Madame Christiane Adam,
demeurant à L-8436 Steinfort, 31, rue de Kleinbettingen;
2.- Madame Christiane Adam, dessinatrice, née à Saint-Hubert (Belgique), le 27 janvier 1951, épouse de Monsieur
Roland Urbing, demeurant à L-8354 Garnich, 4, Cité Bourfeld;
Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION ERPELDING S.àr.l. (N
o
Matricule 19862403595), avec siège social à L-3233 Bettembourg, 26, rue
de l'Ecole;
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 24.570;
constituée suivant acte reçu par le notaire Jacqueline Hansen-Peffer, alors de résidence à Capellen, en date du 12 juin
1986, publié au Mémorial C de 1986, page 13.297;
modifié suivant acte reçu par le notaire Jacqueline Hansen-Peffer, alors de résidence à Capellen, en date du 16 décembre
1988, publié au Mémorial C de 1989, page 5158
et modifié suivant acte reçu par le notaire Jacqueline Hansen-Peffer, alors de résidence à Capellen, en date du 18 juillet
1990, publié au Mémorial C de 1991, page 3431;
Lesquels comparants se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de changer le premier alinéa de l'article 5.-des statuts qui aura la teneur suivante:
« Art. 5. premier alinéa. La société est constituée pour une durée indéterminée.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de l'assemblée générale extraordi-
naire, s'élève approximativement à la somme de Mille neuf cent cinquante euros (1.950,- EUR).
Les associés déclarent qu'il s'agit d'une société familiale alors qu'ils sont époux.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue de nous notaire par son nom, prénom usuel,
état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Adam, R. Urbing, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2007 Relation: EAC/2007/16697. — Reçu 897,15 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Bettembourg, le 8 janvier 2008.
C. Doerner.
Référence de publication: 2008009693/209/43.
(080005675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.
11974
MDC Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 134.988.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the seventh day of December.
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared the following:
LB UK RE HOLDINGS LTD., a company incorporated in England and Wales under Company number 05347966, with
registered address located at 25 Bank Street, London E14 5LE, United Kingdom,
represented by Mr Laurent Forget, private employee, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 5 December 2007,
which proxy, signed by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the
purpose of registration.
The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is established a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).
The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not
exceeding forty (40) shareholders.
The Company will exist under the name of MDC HOLDCO S.à r.l.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Manager(s).
Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolutions of the
Manager(s).
In the event that in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are
imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the Manager(s).
Art. 3. Object. The object of the Company is (i) the acquisition and holding, in any kind or form, of assets and/or of
interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such
assets and/or interests as well as (iii) the direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds
a participation or which are members of its group of companies.
The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any
stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued
by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial
instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which it holds a
participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guarantees in
any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever; (iv) make
loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry out any
transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables, which are
directly or indirectly connected with its object.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by the applicable
laws or by these Articles of Incorporation, as the case may be, for any amendment of these Articles of Incorporation.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Capital. The issued capital of the Company is set at one hundred fifty thousand South Africa Rand (ZAR
150,000.-) divided into one hundred fifty thousand (150,000) shares with a nominal value of one South Africa Rand (ZAR
1.-) each, all of which are fully paid up.
11975
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions
validly adopted by the shareholder(s).
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed
amongst them or not.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders
and the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the shareholders representing at
least three quarters of the issued capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding
upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance
of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law, in view of their immediate
cancellation.
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced by a
resolution of the shareholder(s) voting with the quorum and majority rules set by the applicable laws or by these Articles
of Incorporation, as the case may be, for any amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.
Chapter III. Managers, Auditors
Art. 9. Managers. The Company shall be managed and administered by one or several managers who need not be
shareholders themselves (the «Manager(s)»).
If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the «Board of Managers»).
The Manager(s) will be elected by the shareholder(s), which will determine the duration of his (their) mandate and
their number. The Manager(s) are eligible for re-election and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the «Class A Managers») and
class B Managers (the «Class B Managers»).
Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary
or useful for accomplishing the Company's object.
All powers not expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation to shareholder(s) are in the competence
of the Managers.
Art. 11. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Managers.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) days written
notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place and the agenda of the
meeting. Any Manager may waive his right to be convened as set out above. No separate notice is required for meetings
held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers shall be held at the registered office or at such other place as the Board of
Managers may from time to time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of half of the Managers holding office,
provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers and Class B Managers, such quorum
shall only be met if at least one Class A Manager and one Class B Manager are present.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
11976
One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any
similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Art. 12. Recording of the resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the
secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be
signed by the sole Manager or by any two Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Art. 13. Management Fees and Expenses. Subject to the approval of the shareholder(s), the Managers may receive a
management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and shall in addition be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by him/them in relation with such management of the Company or the pursuit
of the Company's corporate object.
Art. 14. Managers' Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal
obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any Manager is only liable for the performance
of his duties.
The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company
of which the Company is the shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation
to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not
commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the relevant
Manager or officer may be entitled.
Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Any person
related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that one or more of the Managers of the Company have or may have any
personal interest in any transaction of the Company, they shall make known to the other Manager(s) such personal
interest. The conflicted Manager(s) shall not consider or vote on any such transaction and such transaction and such
Managers' interest therein shall be reported to the shareholder(s).
The foregoing provisions do not apply if and when the relevant transaction is entered into under fair market conditions
and falls within the ordinary course of business of the Company.
Art. 16. Representation of the Company - Delegation of Powers. The Company will be bound towards third parties
by the individual signature of the sole Manager or by the joint signatures of any two Manager(s) if more than one Manager
has been appointed.
However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers and Class B Managers, the Company
will only be bound towards third parties by the joint signature of one Class A Manager and one Class B Manager.
The Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to
persons or committees chosen by them.
The Company will also be bound by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory
power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such power
Art. 17. Auditors. Except where according to the laws the Company's annual statutory and/or consolidated accounts
must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory
auditors who need not be shareholders themselves.
The auditors, if any, will be elected by the shareholder(s), which will determine the duration of their mandate. The
auditors are eligible for re-election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the
shareholder(s).
11977
Chapter IV. Shareholders
Art. 18. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises
the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th,
1915, are not applicable to that situation.
If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, the resolutions
of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions can be documented in a single document or in several
separate documents having the same content and each of them signed by one or several shareholder. Should the reso-
lutions to be adopted, be sent by the Manager(s) to the shareholders, the shareholders are under the obligation to, within
a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolutions, cast their written vote and return
it to the Company by any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and
majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis
mutandis apply to the adoption of written resolutions.
Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon
issuance of a convening notice sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting by the Manager(s), the
auditors or shareholders representing half of the corporate capital. The convening notice will specify the time and place
and the agenda of the meeting.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting should be held in the Grand Duchy of Lux-
embourg. They may be held abroad if circumstances of force majeure so require.
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 19. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to
the applicable laws and these Articles of Incorporation.
Art. 20. Annual General Meeting of Shareholders. The annual general meeting of shareholders to be held in case the
Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such
other place in the Grand Duchy of Luxembourg, as may be specified in the notice convening the meeting on 30th May
each year at 3.00 p.m..
If such day is a day on which banks are not open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next
following business day.
Art. 21. Procedure and Vote at Meetings. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of
shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder, as his
proxy.
Any resolution the purpose of which is to amend the present Articles of Incorporation or the adoption of which is
subject by virtue of the applicable laws or these Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and majority
rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, will be taken by (i) a majority of shareholders in number
(ii) representing at least three quarters of the capital.
Except as otherwise required by the applicable laws or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions
will be taken by shareholders representing more than half of the capital. If such majority is not reached at the first meeting
or consultation in writing, the shareholders shall be convened or consulted a second time and resolutions will then be
taken by a majority of the votes cast notwithstanding the proportion of the capital represented.
The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present or their proxy holders
or by the chairman, the secretary and the scrutineer of the meeting if such a bureau has been appointed.
The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s), as well as of the minutes of the general
meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
any two Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 22. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of each year.
Art. 23. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Manager(s)
draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the
applicable laws.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
11978
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.
If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 24. Appropriation of Profits. From the net profits of the Company, five per cent (5%) shall each year be allocated
to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
The shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to
allocate the whole or part of the remainder to a reserve, to carry it forward to the next following financial year or to
distribute it together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s) as
dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends. The Manager(s)
fix the amount and the date of payment of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 25. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the shareholder(s), voting with the
same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the managers or such other persons (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company including the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed equally to the shareholder(s) pro rata to the number of the shares held by them.
Chapter VII. Applicable law
Art. 26. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been adopted,
LB UK RE HOLDINGS LTD., prenamed, declared to subscribe for one hundred fifty thousand (150,000) shares with
a nominal value of one South Africa Rand (ZAR 1.-) per share and to fully pay in cash the nominal value of these shares.
The amount of one hundred fifty thousand South Africa Rand (ZAR 150,000.-) was thus as from that moment at the
disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the condi-
tions provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Estimation - Expensesi>
For the purpose of registration, the amount of one hundred fifty thousand South Africa Rand (ZAR 150,000.-) is valued
at EUR 15,234.90.
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand euro (EUR 2,000).
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last
day of December 2008.
<i>Shareholders resolutionsi>
<i>First resolutioni>
The number of Managers is set at five (5), and
(i) the following two persons are appointed as Class A Managers for a term expiring at the annual general meeting of
shareholders which shall deliberate on the annual accounts as at 31 December 2008:
- Mr Eric Scussel, private employee, with professional address at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
and
- Mr Francesco Moglia, private employee, with professional address at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(ii) the following three (3) persons are appointed as Class B Managers for a term expiring at the annual general meeting
of shareholders which shall deliberate on the annual accounts as at 31 December 2008:
- Mr Laurent Forget, private employee, with professional address at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg;
- Mr Gregory Lambertie, bank employee, with professional address at 25 Bank Street, London E14 5LE, United King-
dom; and
- Mr Joe Cohen, bank executive, with professional address at 25 Bank Street, London E14 5LE, United Kingdom.
11979
<i>Second Resolutioni>
The registered office shall be at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil status
and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le sept décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
A comparu:
LB UK RE HOLDINGS LTD., une société constituée suivant le droit de l'Angleterre et du Pays de Galles sous le
numéro 05347966 avec siège social au 25, Bank Street, Londres E14 5LE, Royaume-Uni,
représentée par Monsieur Laurent Forget, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 5 décembre 2007,
laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins
d'enregistrement.
Les statuts suivants de la société ont ensuite été adoptés:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est constitué une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par le droit
du Grand-Duché du Luxembourg et par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société peut être composée d'un associé unique, détenant la totalité des parts sociales, ou de plusieurs associés,
sans pouvoir excéder quarante (40) associés.
La Société adopte la dénomination MDC HOLDCO S.à r.l.
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une résolution des Gérants.
Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par une
résolution des Gérants.
Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social
sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, ils pourront transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure
provisoire n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle demeura régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les Gérants.
Art. 3. Objet Social. La Société a pour objet (i) l'acquisition et la détention, sous toute forme que ce soit, d'actifs et/
ou de participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l'administration, la gestion et la mise
en valeur de ces actifs et/ou participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des entreprises dans lesquelles
elle participe ou qui font partie de son groupe.
La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d'achat d'échange ou autrement des actions, parts
et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu'ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelconques
attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quelle
qu'elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts,
d'avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance sous
quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière privée
tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit, et (v) accomplir toutes opérations généralement quelconques de
quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirec-
tement à son objet.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
conformément aux dispositions légales ou, le cas échéant, aux présents Statuts pour toute modification des présents
Statuts.
11980
Chapitre II. Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital Social. Le capital souscrit de la Société est fixé à cent cinquante mille Rand Sud-Africain (ZAR 150.000,-)
divisé en cent cinquante mille (150.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Rand Sud-Africain (ZAR 1,-) chacune,
celles-ci étant entièrement libérées.
En plus du capital social, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront versées les primes payées pour
toutes nouvelles actions en plus de leur valeur nominale. Le solde de ce compte peut être utilisé pour rembourser les
associés en cas de rachat de parts sociales par la Société, pour compenser toute perte nette réalisée, pour procéder à
des distributions aux associés ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une voix.
La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement
adoptées par les associés.
Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné
ou non parmi eux.
Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales
ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital
social.
La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing-privé. Une telle cession
n'est opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été notifiée ou acceptée par elle conformément à l'article 1690
du code civil luxembourgeois.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales, en vue de leur annulation
immédiate.
Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit
par une résolution du/des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité requises conformément aux dis-
positions légales ou, le cas échéant, aux présents Statuts pour toute modification des présents Statuts.
Art. 8. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé. L'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement
similaire affectant les associés n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.
Chapitre III. Gérants, Commissaires aux comptes
Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoins d'être associés
(les «Gérants»).
Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.
Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
Les Gérants seront élus par les associés, qui détermineront la durée de leur mandat ainsi que leur nombre. Les Gérants
sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.
Les associés pourront qualifiés les gérants nommés de Gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et
Gérants de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).
Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les Statuts aux associés relèvent de la
compétence des Gérants.
Art. 11. Réunions du Conseil de Gérance. Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes
s'appliqueront:
Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également choisir un
secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de Gérance.
Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous les participants, une convocation écrite sera adressée à tous
les Gérants pour toute réunion du Conseil de Gérance au moins trois (3) jours avant la date prévue pour cette réunion
par tout moyen de communication permettant la transmission d'un écrit. Cette convocation indiquera la date, le lieu et
l'ordre du jour de cette réunion. Tout Gérant peut renoncer à son droit d'être convoqué conformément à la procédure
décrite ci-dessus. Aucune convocation spéciale pour les réunions se tenant à des dates et à des lieux déterminés préala-
blement par une résolution adoptée par le Conseil de Gérance ne sera requise.
Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront au siège social ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance
pourra déterminer.
Tout Gérant peut se faire représenter à une réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit, transmis par tout
moyen de communication permettant la transmission d'un écrit, un autre Gérant comme son mandataire.
11981
Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité des Gérants en fonction sont présents ou
représentés, sous réserve que dans l'hypothèse où des Gérants de Catégorie A et des Gérants de Catégorie B ont été
désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B sont présents.
Les décisions seront adoptées à la majorité des voix exprimées par les Gérants présents ou représentés à cette réunion.
Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout
autre moyen de communication similaire permettant à plusieurs personnes de communiquer simultanément les unes avec
les autres. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.
Une décision écrite, signée par tous les Gérants, sera considérée comme régulière et valable de la même manière que
si elle avait été adoptée au cours d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision
pourra être consignée dans un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, chacun signé par un ou plusieurs
Gérants.
Art. 12. Procès-verbaux des Réunions du Conseil de Gérance. Les résolutions des Gérants doivent être consignées
par écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président et par le secrétaire (le cas
échéant). Les procurations demeureront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produit en justice ou ailleurs,
pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.
Art. 13. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l'accord du/des associés, les Gérants peuvent être rémunérés
pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposés dans
le cadre de leur fonction ou pour la poursuite de l'objet social de la Société.
Art. 14. Responsabilité des Gérants-Indemnisation. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque,
dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société. Chaque Gérant est uni-
quement responsable de l'accomplissement de ses fonctions.
La Société indemnisera tout Gérant ou fondé de pouvoirs ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et
administrateurs de biens pour tous les frais raisonnables qu'ils auront exposés à la suite de leur comparution en tant que
défendeurs au cours d'actions en justice, de procès ou de poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes de Gérant ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande de la Société, de toute
autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancière et dont ils ne peuvent obtenir indemnisation, exception
faite pour les cas où ils seront déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la
Société. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement
transactionnel et pour lesquelles la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'a
pas manqué à ses devoirs. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres
droits auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 15. Conflits d'Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera
affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondé de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront gérant, associé, membre, fondé de pouvoirs ou employé. Toute personne ayant les liens ci-dessus décrit
avec une société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas,
en raison de l'appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir
quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.
Nonobstant ce qui précède, dans l'hypothèse où un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans
une opération de la Société, ils en aviseront les autres Gérants. Le Gérant ayant un conflit d'intérêt ne pourra prendre
part au vote sur cette transaction et celle-ci de même que l'intérêt du Gérant sera porté à la connaissance des associés.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas lorsque la transaction considérée est conclue à des conditions de
marché normales et qu'elle porte sur une opération courante de la Société.
Art. 16. Représentation de la Société - Délégation de pouvoirs. A l'égard des tiers, la Société sera engagée par la
signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.
Toutefois, si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société ne
sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie
B.
La Société peut également déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou
temporaires à des personnes ou des comités de son choix.
La Société sera également engagée par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes auxquelles ce pouvoir
de signature aura été confié par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 17. Auditeur. Sauf dans les cas où, en vertu des Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la
Société doivent être vérifiés par un réviseur indépendant, les affaires de la Société et sa situation financière, et en particulier
ses documents comptables, doivent, dans les cas prévus par les dispositions légales, être vérifiés par un ou plusieurs
commissaires aux comptes qui ne doivent pas nécessaire être associé.
11982
Les commissaires aux comptes, le cas échéant, seront élus par les Associés qui détermineront la durée de leur mandat.
Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.
Chapitre IV. Assemblée générale des associés
Art. 18. Assemblée Générale des Associés. Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs
dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dès lors, les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 Août 1915 ne
sont pas applicables.
Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25), ces derniers peuvent prendre des résolutions
par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu
signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont été envoyées par les Gérants aux Associés,
les associés sont tenus d'exprimer leur vote par écrit et de l'envoyer dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception
du texte de la résolution par tout moyen de communication permettant la transmission d'un écrit. Les exigences de
quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'applique mutatis mutandis à
l'adoption de résolution écrites.
A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale dans un délai de huit
(8) à compter de la convocation adressée par lettre recommandée par le/les Gérants, les commissaires aux comptes et
les associés représentant la moitié du capital social. La convocation indiquera la date, le lieu et l'ordre du jour de la
réunion.
Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été informés de
l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, se tiendront au Grand-Duché du
Luxembourg. Elles pourront se tenir à l'étranger si des circonstances de force majeure l'exigent.
Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.
Art. 19. Pouvoirs des Associés. Les/les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par la loi ou par les présents
Statuts.
Art. 20. Assemblée Générale Annuelle. L'assemblée générale annuelle, devant se tenir lorsque la Société compte plus
de vingt-cinq (25) associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand Duché du Luxembourg
tel qu'indiqué dans l'avis de convocation le 30 mai chaque année à 15 heures.
Si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 21. Procédure - Vote. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée
générale.
Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un écrit,
un mandataire qui n'a pas besoin d'avoir la qualité d'associé pour participer à une assemblée.
Toute décision destinée à modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est soumise par les présents Statuts, ou
selon le cas, par la loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des Statuts, sera prise par (i) une
majorité en nombre des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital.
Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation ou consul-
tation par écrit, les associés seront de nouveau convoqués ou consultés et les résolutions seront alors adoptées, sur
deuxième convocation, à la majorité des voix exprimées sans tenir compte de la part du capital représenté.
Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents ou par leur mandataire ou
par le président, le secrétaire, le scrutateur de l'assemblée si un tel bureau a été désigné.
Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions adoptées par les associés à produire en justice ou ailleurs sont signés par le
Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 22. Exercice Social. L'exercice social de la Société débute le 1
er
janvier et s'achève le 31 décembre de chaque
année.
Art. 23. Approbation des Comptes Annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les
Gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux
dispositions légales en vigueur.
Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis à l'approbation du/des associés.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société.
Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours qui
précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.
11983
Art. 24. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices de l'exercice, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) qui seront affectés
à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social de la Société.
L'associé unique ou les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de
verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer
avec tout bénéfice reporté à nouveau, réserves distribuable ou prime d'émission, aux associés comme dividendes.
Les Gérants peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Les
Gérants détermineront le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 25. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des associés délibérant aux mêmes
conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les Gérants ou toute autre personne (personne
physique ou morale) nommées par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs rémunération.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net sera réparti
équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 26. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément
à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et Paiementi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été adoptés,
LB UK RE HOLDINGS LTD., prénommée, a déclaré souscrire cent cinquante mille (150.000) parts sociales ayant une
valeur nominale d'un Rand Sud-Africain (ZAR 1,-) par part sociale et libérer intégralement en espèces la valeur nominale
de ces parts sociales.
Le montant de cent cinquante mille Rand Sud-Africains (EUR 150.000,-) étant dès cet instant à la disposition de la
société, la preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Estimation - Fraisi>
Pour les besoin de l'enregistrement, le montant de cent cinquante mille Rand Sud-Africains (EUR 150.000,-) est évalué
à EUR 15.234,90 EUR.
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ deux mille euros (2.000,- EUR).
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera à la date de constitution et finira le dernier jour du mois de décembre 2008.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
<i>Première résolutioni>
Le nombre de Gérants est fixé à cinq (5), et
(i) les deux (2) personnes suivantes ont été nommée en tant que Gérants de Catégorie A pour une durée se terminant
lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui délibère sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:
- Monsieur Eric Scussel, employé privé, avec résidence professionnelle aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Monsieur Francesco Moglia, employé privé, avec résidence professionnelle aux 19-21, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
(ii) les trois (3) personnes suivantes ont été nommées en tant que Gérants de Catégorie B pour une durée se terminant
lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui délibère sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:
- Monsieur Laurent Forget, employé privé, avec résidence professionnelle au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Gregory Lambertie, employé de banque, avec résidence professionnelle au 25, Bank Street, E14 5LE Lon-
dres, Royaume-Uni; et
- Monsieur Joe Cohen, directeur de banque, avec résidence professionnelle au 25, Bank Street, E14 5LE Londres,
Royaume-Uni.
<i>Seconde résolutioni>
Le siège social est établi au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Grand Duché de Luxembourg.
11984
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Forget, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2007, LAC/2007/39861. — Reçu 152,65 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2008.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2008010056/220/561.
(080006085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.
Tishman Speyer French Core Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 134.950.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the eighteenth day of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
TISHMAN SPEYER HOLDINGS (TSEC) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated and organized under the Luxembourg law, having its registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, under number 130.391,
here represented by Ms. Rachel Uhl, lawyer, with professional address at 15, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg, by
virtue of a proxy established on December 18th, 2007.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the
articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the devel-
opment of such participating interests.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees
or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part
of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliates).
In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take
any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with
its purposes or which are liable to promote their development or extension.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may be
convertible.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name TISHMAN SPEYER FRENCH CORE HOLDINGS S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
11985
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is fixed at one hundred sixty-one thousand four hundred seventy-five Euro (€ 161,475.-)
represented by six thousand four hundred fifty-nine (6,459) shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-
holders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers composed of at least three managers divided into two categories, respectively denomi-
nated «Category A Managers» and «Category B Managers». The manager(s) need not to be shareholder(s). The manager
(s) may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.
Art. 13. In dealing with third parties, the sole manager or the board of managers will have all powers to act in the
name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the sole manager or the board of managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of the sole manager or, in case of plurality
of managers, by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.
The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers shall have the rights to give special proxies
for determined matters to one or more proxy holders, selected from its members or not either shareholders or not.
Art. 14. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may delegate the day-to-day
management of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and will determine the manager's/agent's respon-
sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his
agency. It is understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition,
disposition, financing and refinancing have to obtain the prior approval from the sole manager or the board of managers.
In case of plurality of managers, the board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman
is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.
In case of plurality of managers, the board of managers may elect a secretary from among its members.
In case of plurality of managers, the meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary
or by any two managers. The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present
or represented.
In case of plurality of managers, a manager may be represented by another member of the board of managers, and a
member of the board of managers may represent several managers.
In case of plurality of managers, the board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its
members is present or represented by proxies and with at least the presence or the representation of one Category B
manager. Any decisions taken by the board of managers shall require a simple majority including at least the favourable
vote of one Category B manager. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.
In case of plurality of managers, one or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or
by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to
simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the
meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same
content signed by all the members having participated.
In case of plurality of managers, a written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been
adopted at a meeting of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented
in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board
of managers.
11986
The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on
the basis of a statement of accounts prepared by the sole manager or the board of managers showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by the Articles.
Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.
Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 17. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each
year.
Art. 18. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the sole manager or the
board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-
termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-
first of December 2008.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, TISHMAN SPEYER HOLDINGS (TSEC) S.à r.l., prenamed,
declared to subscribe the six thousand four hundred fifty-nine (6,459) shares and have them fully paid up in nominal value
by contribution in cash of one hundred sixty-one thousand four hundred seventy-five Euro (€ 161,475.-).
The amount of one hundred sixty-one thousand four hundred seventy-five Euro (€ 161,475.-) has been fully paid up
in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at three thousand five hundred Euro (€ 3,500.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder resolves to:
1. Appoint the following persons as managers of the Company for an unlimited duration:
<i>Category A Managers:i>
- Mr Paul Anthony Galiano, Senior Managing Director, born on the 9th of March 1965 in New York (United States of
America), residing at 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, United States of America;
- Ms Geraldine Copeland-Wright, Managing Director European Counsel, born on March 25, 1971, in Leeds (United
Kingdom), with professional address at St Catherine's House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, United Kingdom;
- Mr Jerry I Speyer, Chairman and Chief Executive Officer, born on the 23rd of June 1940 in Wisconsin (United States
of America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;
11987
- Mrs Katherine Farley, Senior Managing Director, born on the 12th of October 1949 in New York (United States of
America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;
- Mr Robert J Speyer, President, born on the 11th of October 1969 in New York (United States of America), residing
at 265, East 66th Street, New York, NY 10021, United States of America;
- Mr Michael Philip Maurice Spies, Senior Managing Director, born on the 4th of September 1957 in Massachusetts
(United States of America), residing at 66, Redcliffe Road, London SW10 9MQ, United Kingdom.
- Mr James Arthur Rosenthal, Senior Managing Director & Chief Financial Officer, born on the 12th of May 1953 in
New York (United States of America), residing at 148, 5th Avenue, New York, NY 10128, United States of America.
<i>Category B Manager:i>
- Mr Marcel Stephany, Company Director, born on the 4th of September 1951 in Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg), residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg.
The Company shall be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.
2. Fix the registered seat of the Company at 34-38, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TISHMAN SPEYER HOLDINGS (TSEC) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social aux 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 130.391,
ici représentée par Madame Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, cote d'Eich, L-1450 Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration donnée le 18 décembre 2007,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société à respon-
sabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets. Elle peut (par voie de prêts, avances, cautionnement, sûretés ou autres) accorder tout
concours aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation, ou bien qui font partie du groupe de
sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou filiales).
En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou
immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'autres ins-
truments qui pourront être convertibles.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination TISHMAN SPEYER FRENCH CORE HOLDINGS S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
11988
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à cent soixante et un mille quatre cent soixante-quinze Euro (€ 161.475,-) représenté
par six mille quatre cent cinquante-neuf (6.459) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-
semblée générale des associés, en conformité avec l'article 16 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance composé d'au moins trois gérants divisés en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie
A» et «Gérants de catégorie B». Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Il(s) peut(vent) être
révoqué(s) à tout moment, avec ou sans justification, par une décision des associés représentant une majorité des voix.
Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique ou le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir au nom
de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à
l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance.
Envers les tiers, la société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique, ou, en cas de pluralité de
gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés
parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.
Art. 14. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière
de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle)
des gérants/ mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il
est convenu que la gestion journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition,
de disposition, de financement et refinancement doivent être préalablement approuvés par le gérant unique ou le conseil
de gérance.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut
être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou
par deux gérants. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont
présents ou représentés.
En cas de pluralité de gérants, un gérant peut en représenter un autre au conseil de gérance, et un gérant peut
représenter plusieurs gérants.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une
majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et qu'au moins un gérant de catégorie B est
présent ou représenté. Toute décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote
affirmatif d'un gérant de catégorie B. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.
En cas de pluralité de gérants, chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par con-
férence call ou par tout autre moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les
gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront
censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans
plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.
11989
En cas de pluralité de gérants, une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au
même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de gérance, dûment convoquée et tenue. Cette décision peut
être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur
dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérante unique ou le conseil de gérance duquel il ressort que des
fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le
montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distri-
buables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou
statutaire.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 16. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 18. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant unique ou le
conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider
qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre
2008.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, TISHMAN SPEYER HOLDINGS (TSEC) S.à r.l., désigné ci-dessus,
déclare souscrire aux six mille quatre cent cinquante-neuf (6.459) parts sociales et les libérer entièrement en valeur
nominale par apport en numéraire de cent soixante et un mille quatre cent soixante-quinze Euro (€ 161.475,-).
Un montant de cent soixante et un mille quatre cent soixante-quinze Euro (€ 161.475,-) a été intégralement libéré en
numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ trois mille cinq cents Euro (€
3.500,-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
L'associé unique décide de:
1. Nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une durée illimitée:
11990
<i>Gérants de Catégorie A:i>
- M. Paul Anthony Galiano, Senior Managing Director, né le 9 mars 1965 à New York (Etats-Unis d'Amérique), de-
meurant au 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, Etats-Unis d'Amérique;
- Mlle Geraldine Copeland-Wright, Managing Director Conseil Européen, née le 25 mars 1971 à Leeds (Royaume-
Uni), ayant son adresse professionnelle à St Catherine's House, 14 Kingsway, London WC2B 6LH, Royaume-Uni;
- M. Jerry I. Speyer, Chairman et Président Directeur Général, né le 23 juin 1940 à Wisconsin (Etats-Unis d'Amérique),
demeurant au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d'Amérique;
- Mme Katherine Farley, Senior Managing Director, née le 12 octobre 1949 à New York (Etats-Unis d'Amérique),
demeurant au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d'Amérique;
- M. Robert J. Speyer, President, né le 11 octobre 1969 à New York (Etats-Unis d'Amérique), demeurant au 56 Crosby
Street Apt 4B, New York, NY 1012 -4435, Etats-Unis d'Amérique;
- M. Michael Philip Maurice Spies, Senior Managing Director, né le 4 septembre 1957 à Massachusetts (Etats-Unis
d'Amérique), demeurant au 66, Redcliffe Road, Londres SW10 9MQ, Royaume-Uni.
- M. James Arthur Rosenthal, Senior Managing Director et Directeur Financier, né le 12 mai 1953 à New York (Etats-
Unis d'Amérique), demeurant au 1148, 5
è
Avenue, New York, NY 10128, Etats-Unis d'Amérique.
<i>Gérant de Catégorie B:i>
- M. Marcel Stephany, Administrateur de Sociétés, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg (Grand Duché de Luxem-
bourg), demeurant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand Duché de Luxembourg.
La Société est valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant de Catégorie A et d'un gérant de Catégorie
B.
2. Fixer l'adresse du siège social à 34-38, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2007, Relation: LAC/2007/42079. — Reçu 1.614,75 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2008.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2008010031/211/345.
(080005432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.
Sitinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 74.941.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2008008997/762/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2007, réf. LSO-CL04200. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080004034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.
Vestigor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 53.464.
DISSOLUTION
In the year two thousand seven, on the eleventh of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
11991
There appeared:
VESTIGOR INVESTMENTS LIMITED, having its registered office at Tortola, British Virgin Islands,
here represented by Annick Braquet, with professional address in Luxembourtg,
by virtue of a proxy under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholders of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of VESTIGOR S.A., having its registered office at L-2346 Luxembourg, 20, rue
de la Poste, incorporated by a deed of M
e
Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, on December 14, 1995
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 129 of March 14, 1996. The articles of incor-
poration have been modified by a deed of Me Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, on September 12, 2001,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 287 of February 20, 2002;
- that the capital of the Company VESTIGOR S.A. is fixed at thirty-one thousand two hundred and fifty euro (31,250.-
EUR) represented by one thousand two hundred and fifty euro (1,250.- EUR) with a par value of twenty-five euro (25.-
EUR) each, fully paid;
- that VESTIGOR INVESTMENTS LIMITED has decided to dissolve the Company VESTIGOR S.A. with immediate
effect as the business activity of the Company has ceased;
- that VESTIGOR INVESTMENTS LIMITED, being sole owner of the shares and liquidator of VESTIGOR S.A., declares,
- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume
the obligation to pay for such liabilities;
with the result that the liquidation of VESTIGOR S.A. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the Company for the exercise of their
mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2346 Luxembourg,
20, rue de la Poste.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le onze décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
VESTIGOR INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg.
en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires du comparant et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'il est le seul et unique actionnaire de la société VESTIGOR S.A., constituée suivant acte reçu par Maître Gérard
Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 14 décembre 1995, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 129 du 14 mars 1996, dont les statuts furent modifiés suivant acte reçu par Maître Gérard
Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 12 septembre 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 287 du 20 février 2002;
- que le capital social de la société VESTIGOR S.A. s'élève actuellement à trente et un mille deux cent cinquante euros
(31.250,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-
EUR) chacune, entièrement libérées;
- que VESTIGOR INVESTMENTS LIMITED a décidé de dissoudre et de liquider la société VESTIGOR S.A., celle-ci
ayant cessé toute activité;
11992
- que VESTIGOR INVESTMENTS LIMITED, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société VESTIGOR S.A.,
qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:
- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-
vocablement l'obligation de les payer,
de sorte que la liquidation de la société VESTIGOR S.A. est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la société, pour
l'exercice de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2346 Luxembourg,
20, rue de la Poste.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Braquet, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2007. Relation: LAC/2007/40756. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): F. Sandt.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2008009815/242/84.
(080005249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.
Tishman Speyer French Core V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 134.949.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the nineteenth of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
TISHMAN SPEYER FRENCH CORE HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) incorporated and organized under the Luxembourg law, having its registered office at 34-38, avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg, under process of registration with the Luxembourg Trade and Company Register,
here represented by Mr Gael Toutain, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
by virtue of a proxy established on December 19th, 2007.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the
articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the devel-
opment of such participating interests.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees
or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part
of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliates).
11993
In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take
any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with
its purposes or which are liable to promote their development or extension.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may be
convertible.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name TISHMAN SPEYER FRENCH CORE V S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is fixed at fifty-three thousand two hundred fifty Euro (€ 53,250.-) represented by two thousand
one hundred thirty (2,130) shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-
holders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers composed of at least three managers divided into two categories, respectively denomi-
nated «Category A Managers» and «Category B Managers». The manager(s) need not to be shareholder(s). The manager
(s) may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.
Art. 13. In dealing with third parties, the sole manager or the board of managers will have all powers to act in the
name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the sole manager or the board of managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of the sole manager or, in case of plurality
of managers, by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.
The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers shall have the rights to give special proxies
for determined matters to one or more proxyholders, selected from its members or not either shareholders or not.
Art. 14. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may delegate the day-to-day
management of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and will determine the manager's / agent's re-
sponsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of his agency. It is understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of
acquisition, disposition, financing and refinancing have to obtain the prior approval from the sole manager or the board
of managers.
In case of plurality of managers, the board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman
is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.
In case of plurality of managers, the board of managers may elect a secretary from among its members.
In case of plurality of managers, the meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary
or by any two managers. The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present
or represented.
In case of plurality of managers, a manager may be represented by another member of the board of managers, and a
member of the board of managers may represent several managers.
11994
In case of plurality of managers, the board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its
members is present or represented by proxies and with at least the presence or the representation of one Category B
manager. Any decisions taken by the board of managers shall require a simple majority including at least the favourable
vote of one Category B manager. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.
In case of plurality of managers, one or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or
by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to
simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the
meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same
content signed by all the members having participated.
In case of plurality of managers, a written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been
adopted at a meeting of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented
in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board
of managers.
The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on
the basis of a statement of accounts prepared by the sole manager or the board of managers showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by the Articles.
Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.
Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 17. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each
year.
Art. 18. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the sole manager or the
board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-
termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-
first of December 2008.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, TISHMAN SPEYER FRENCH CORE HOLDINGS S.à r.l.,
prenamed, declared to subscribe the two thousand one hundred thirty (2,130) shares and have them fully paid up in
nominal value by contribution in cash of fifty-three thousand two hundred fifty Euro (€ 53,250.-).
The amount of fifty-three thousand two hundred fifty Euro (€ 53,250.-) has been fully paid up in cash and is now
available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.
11995
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at two thousand five hundred Euro (€ 2,500.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder resolves to:
1. Appoint the sole shareholder as sole manager of the Company for an unlimited period of time.
2. Fix the registered seat of the Company at 34-38, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TISHMAN SPEYER FRENCH CORE HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à 34-38, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en cours d'enregistrement auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg,
ici représentée par M. Gael Toutain, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg, en vertu d'une procuration donnée le 19 décembre 2007,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société à respon-
sabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets. Elle peut (par voie de prêts, avances, cautionnement, sûretés ou autres) accorder tout
concours aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation, ou bien qui font partie du groupe de
sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou filiales).
En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou
immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'autres ins-
truments qui pourront être convertibles.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination TISHMAN SPEYER FRENCH CORE V S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
11996
Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante-trois mille deux cent cinquante Euro (€ 53.250,-) représenté par deux mille
cent trente (2.130) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-
semblée générale des associés, en conformité avec l'article 16 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance composé d'au moins trois gérants divisés en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie
A» et «Gérants de catégorie B». Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Il(s) peut(vent) être
révoqué(s) à tout moment, avec ou sans justification, par une décision des associés représentant une majorité des voix.
Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique ou le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir au nom
de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à
l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance.
Envers les tiers, la société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique, ou, en cas de pluralité de
gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés
parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.
Art. 14. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière
de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle)
des gérants/ mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il
est convenu que la gestion journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition,
de disposition, de financement et refinancement doivent être préalablement approuvés par le gérant unique ou le conseil
de gérance.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut
être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou
par deux gérants. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont
présents ou représentés.
En cas de pluralité de gérants, un gérant peut en représenter un autre au conseil de gérance, et un gérant peut
représenter plusieurs gérants.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une
majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et qu'au moins un gérant de catégorie B est
présent ou représenté. Toute décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote
affirmatif d'un gérant de catégorie B. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.
En cas de pluralité de gérants, chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par con-
férence call ou par tout autre moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les
gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront
censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans
plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.
En cas de pluralité de gérants, une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au
même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de gérance, dûment convoquée et tenue. Cette décision peut
être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur
dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérante unique ou le conseil de gérance duquel il ressort que des
11997
fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le
montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distri-
buables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou
statutaire.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 16. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 18. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant unique ou le
conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider
qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre
2008.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, TISHMAN SPEYER FRENCH CORE HOLDINGS S.à r.l., désignée ci-
dessus, déclare souscrire aux deux mille cent trente (2.130) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale
par apport en numéraire de cinquante-trois mille deux cent cinquante Euro (€ 53.250,-).
Un montant de cinquante-trois mille deux cent cinquante Euro (€ 53.250,-) a été intégralement libéré en numéraire
et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille cinq cents Euro (€
2.500,-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
L'associé unique décide de:
1. Nommer l'associé unique comme gérant unique de la Société pour une durée indéterminée
2. Fixer l'adresse du siège social aux 34-38, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
11998
Signé: G. Toutain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2007, Relation: LAC/2007/42096. — Reçu 532,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2008.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2008010028/211/307.
(080005415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.
Charterhouse Stone S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 61.750,00.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 115.704.
<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés de la Société en date du 13 décembre 2007i>
Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 13 décembre 2007 que le siège social de la
Société a été transféré de son adresse actuelle, étant le 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 8, rue Notre-
Dame, L-2240 Luxembourg avec effet au 30 juillet 2007.
Pour extrait
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2008009003/5499/17.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2008, réf. LSO-CM02366. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080004378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.
Carlyle/Riverstone Participations II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 108.231.
EXTRAIT
La société CARLYLE/RIVERSTONE PARTICIPATIONS II S.à r.l., a changé son siège social du 30, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2007.
Pour extrait conforme
ATOZ
Signature
Référence de publication: 2008009006/4170/18.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02141. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080004243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.
Parfin S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 5.370.
DISSOLUTION
L'an deux mille sept, le cinq décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous
11999
le numéro B 18.433, ici représentée par son Directeur Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse pro-
fessionnelle à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La société anonyme PARFIN S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, a été constituée
suivant acte notarié en date du 21 mai 1954 et les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 472 du 22 juin 2001.
- La société a actuellement un capital social de un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR) représenté
par quatre cents (400) actions sans désignation de valeur nominale.
- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, savoir la société
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société PARFIN S.A. Il assume la fonction de liquidateur.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société PARFIN
S.A.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.
- L'actionnaire unique est investi de tous les actifs de la Société et se chargera en sa qualité de liquidateur de l'apurement
du passif de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'ac-
tionnaire unique. Il répondra de tous les engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle et réglera également
les frais des présentes.
- Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société PARFIN S.A.
- Les livres et documents comptables de la Société demeureront conservés pendant cinq ans à l'ancien social de la
société dissoute à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure,
le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Reckinger, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2007. Relation: LAC/2007/40578. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2008009816/242/42.
(080005244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.
LuxCo 66 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 133.213.
Il résulte du contrat de vente du 5 novembre 2007 que toutes les parts sociales ordinaires de la Société détenues par
TMF CORPORATE SERVICES S.A. ont été transférées à Monsieur John McCall MacBain, né le 13 février 1958 à Niagara
Falls (Canada), demeurant au 101, route de Villette, CH-1226 Thonex, Geneva (Suisse), de sorte que M. John McCall
MacBain détient désormais 500 parts sociales ordinaires de la Société représentant l'entièreté de son capital.
Luxembourg, le 18 décembre 2007.
<i>Pour la société
i>TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant unique
i>Signatures
Référence de publication: 2008008795/805/18.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2008, réf. LSO-CM02064. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(080004098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2008.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
12000
AES Carly S.à r.l.
Anderton Global Energy Limited
Anderton Global Energy Limited S.à.r.l.
Aster 2 S.A.
Carlyle/Riverstone Participations II S.à r.l.
Carlyle/Riverstone Participations S.à r.l.
Charterhouse Stone S.à r.l.
Entreprise de Construction Erpelding S.à r.l.
GS Draco S.à r.l.
GSIP I Mezzanine Global and International S.à r.l.
LuxCo 66 S.à r.l.
Macquarie Luxembourg Gas S. à r.l.
MDC Holdco S.à r.l.
MIF Germany Four S.àr.l.
Murada S.A.
Nortel Networks (Luxembourg) S.A.
Parfin S.A.
Quinn Finance S.à r.l.
Sitinvest S.A.
Tishman Speyer French Core Holdings S.à r.l.
Tishman Speyer French Core II S.à r.l.
Tishman Speyer French Core V S.à r.l.
Vestigor S.A.