logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2866

11 décembre 2007

SOMMAIRE

Asia Alternatives Luxembourg S.à r.l. . . . .

137564

BAY-RUM Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . .

137526

BE Investco Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . .

137526

Bergasa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137527

BTI-Building Technology International

Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137539

Caleche Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137530

Camberwell S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137564

Corporate Credit (Europe) S.A.  . . . . . . . . .

137522

Crosslink Investment Consulting S.A.  . . . .

137559

Danidin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137527

DHCRE II Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

137538

e2 advance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137539

East Europe Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . .

137535

Elektra Finanzierung A.G.  . . . . . . . . . . . . . .

137568

Elvas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137535

Euro-Connect S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137537

European Education Holdings S.à.r.l. . . . . .

137530

Federale Management S.A.  . . . . . . . . . . . . .

137540

Financière du Transvaal S.A.  . . . . . . . . . . . .

137567

Foxworth Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

137528

Geralux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137540

Graci International Holding  . . . . . . . . . . . . .

137536

HAWK Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137528

I.07 Pabeierbierg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137537

KEV Germany 3 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137522

La Beauté S.àr.l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137541

Landmark S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137522

L'Arcobaleno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137528

Lincolnwood S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137536

Macquarie Global Infrastructure Funds 2

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137537

Macquarie Storage Luxco 1 S.à r.l. . . . . . . .

137527

Macquarie Storage Luxembourg 2 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137528

Magna Park JV Units - Germany S.à r.l.  . .

137556

Merrill Lynch Asian Holdco S.à r.l.  . . . . . . .

137562

Merrill Lynch Orion Holdings S.à r.l.  . . . . .

137562

Millicom International Cellular S.A. . . . . . .

137526

MX International S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

137526

Night Investments 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

137562

Patri Participations Holding . . . . . . . . . . . . .

137538

Peehold S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137529

Plastiche S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137568

responsAbility BOP Investments S.C.A. SI-

CAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137541

Schutz et Wagner S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

137540

Season International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

137538

SmartStream Acquisitions S.à r.l.  . . . . . . .

137559

Soprogest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137536

STAR s. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137539

Tekton S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137566

Tricat Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137537

Universal Commerce and Finance S.A.H.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137538

Werasp S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137567

WGC - Worldwide Glass and Ceramics In-

vestment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137541

137521

Landmark S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 107.905.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 17 septembre 2007 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- MAMMOT LUX SARL, Administrateur, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, représentée par Monsieur

Hubertus Goessens;

- Monsieur Chris Hendrickx, Administrateur, administrateur de sociétés, Liezele-Dorp 64, B2870 Puurs, Belgique;
- FOOTPRINT S.A., Administrateur-Délégué, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, représentée par

Monsieur Werner Lizen.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.
L'assemblée générale du 17 septembre 2007 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster, RCS Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

Luxembourg, le 17 septembre 2007.

<i>Pour LANDMARK S.A.
Signature

Référence de publication: 2007136433/833/23.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00939. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Corporate Credit (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 81.490.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 17 septembre 2007

En date du 17 septembre 2007, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d'accepter la démission de M. Steven Andrew Blakey en tant qu'administrateur en date du 11 mai 2007.
- de ratifier la cooptation de M. Jürgen Meisch, Hölderlinstrasse, 8, 50968, Köln, Allemagne, en tant qu'administrateur

avec effet au 11 mai 2007, en remplacement de M. Steven Andrew Blakey, démissionnaire.

- de renouveler les mandats d'administrateurs de M. Patrick Zurstrassen, M. Clive Mace Gilchrist, M. Scott Edel, M.

Alfonso De Maqua, M. Jürgen Meisch, M. James Pope et M. Nicholas Cranston jusqu'à la prochaine Assemblée Générale
Annuelle en 2008.

Luxembourg, le 18 septembre 2007.

Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2007136472/1024/21.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ04007. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

KEV Germany 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 127.049.

In the year two thousand and seven, on the sixth day of August.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

is held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of KEV GERMANY 3 S.A. (the «Company»), a «société

anonyme», established and having its registered office at 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg,
section B number 127.049),

137522

incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg,

acting in replacement of notary Jean-Joseph Wagner, prenamed, on 5 April 2007, published in the Mémorial C Recueil
des Sociétés et Associations, on 15 June 2007, number 1170.

The Meeting is declared open and is presided over by Mr Joseph Hansen, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

who appoints as secretary of the Meeting Mrs Nadia Weyrich, employee, residing professionally in Belvaux (Luxembourg).

The meeting elects as scrutineer Mrs Kitty Wong, employee, residing professionally in Belvaux (Luxembourg).
The chairman requests the notary to record that:
a) The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

b) As appears from the attendance list, the three hundred and ten (310) shares, representing the entire subscribed

capital of the Company currently fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) are represented at the present Ex-
traordinary General Meeting of the shareholders, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

c) That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Increase in the Company's subscribed share capital by an amount of seven hundred thirty thousand three hundred

euro (730,300.- EUR) in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) divided
into three hundred and ten (310) shares having each a par value of one hundred euro (100.- EUR) to an amount of seven
hundred sixty-one thousand three hundred euro (761,300.- EUR) divided into seven thousand six hundred thirteen (7,613)
shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, by the issuance of seven thousand three hundred three
(7,303) new additional shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR), each share with the same rights an
privileges as the existing shares.

2) Subscription of the new issued shares by the current shareholder KENMORE EUROPEAN VENTURES S.à r.l., with

registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, the other existing shareholder having to the extent necessary
waived its preferential subscription right and payment of each such new issued share by the same shareholder KENMORE
EUROPEAN VENTURES S.à r.l. and by contribution in cash in a total amount of seven hundred thirty tousand three
hundred (730,300.- EUR).

3) Amendment of Article five, first paragraph of the Company's by-laws.
After the foregoing was approved by the Meeting, the Meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Extraordinary General Meeting of shareholders resolves to increase the subscribed share capital by an amount of

seven hundred thirty thousand three hundred euro (730,300.- EUR) in order to raise it from its present amount of thirty-
one thousand euro (31,000.- EUR) divided into three hundred and ten (310) shares having each a par value of one hundred
euro (100.- EUR) to an amount of seven hundred sixty-one thousand three hundred euro (761,300.- EUR) divided into
seven thousand six hundred thirteen (7,613) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, by the issuance
of seven thousand three hundred three (7,303) new additional shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR),
each share with the same rights an privileges as the existing shares.

<i>Second resolution

The Extraordinary General Meeting of shareholders acknowledges that one of the existing shareholders duly waived

his preferential subscription right to the extent necessary and resolves to accept the other current shareholder KEN-
MORE EUROPEAN VENTURES S.à r.l., a company incorporated under Luxembourg law, with registered office at 1, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, to the subscription of the total seven thousand three hundred three (7,303) new shares.

<i>Subscription - payment

Thereupon, KENMORE EUROPEAN VENTURES S.à r.l., as mentioned here above, represented by:
Mr Joseph Hansen, prenamed,
by virtue of a proxy given on 3 August 2007,
which proxy after being signed ne varietur by all the members of the Board and the undersigned notary shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

declares to subscribe to the seven thousand three hundred three (7,303) new additional shares at the par value of

hundred euro (100.- EUR) per share, and to entirely pay up each such new share issued by the Company by contribution
in cash.

The above mentioned subscriber declares and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that

each new share issued has been entirely paid up in cash, so that the Company has at its free disposal the amount of seven
hundred thirty thousand three hundred euro (730,300.- EUR), proof of which has been given to the undersigned notary
who expressly states this.

137523

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to replace the existing Article 5. first paragraph of the

Company's Articles of Incorporation with the following new paragraph in order to reflect the increase of the issued
corporate capital:

« Art. 5. The subscribed capital of the Company is fixed at seven hundred sixty-one thousand three hundred euro

(761,300.- EUR) divided into seven thousand six hundred thirteen (7,613) shares with a par value of one hundred euro
(100.- EUR) per share.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately nine thousand five hundred euro.

Nothing else being on the agenda, the chairman closed thereupon the meeting.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, states herewith that on the request of

the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a German translation. On request of
the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will
prevail.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surnames Christian names,

civil status and residences, said appearing persons signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, am sechsten August.
Vor der unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),

fand die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft KEV GERMANY 3 S.A. (die «Gesellschaft»), eine

Aktiengesellschaft, mit Sitz in 14A, rue des Bains, L-1212 Luxemburg (R.C.S. Luxemburg, B Nr. 127.049),

gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notarin Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz zu Remich (Großher-

zogtum Luxemburg) in Vertretung ihres verhinderten Kollegen Notar Jean-Joseph Wagner, vorgenannt, am 5. April 2007,
welche Urkunde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 15. Juni 2007 unter der Nummer 1170 veröf-
fentlicht wurde.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Joseph Hansen, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in

Luxemburg, der zum Schriftführer ernennt, Frau Nadia Weyrich, Angestellte, beruflich wohnhaft in Beles (Luxemburg).

Die Gesellschafterversammlung wählt zum Stimmenzähler Frau Kitty Wong, Angestellter, beruflich wohnhaft in Beles

(Luxemburg).

Der Vorsitzende bittet den Notar folgendes festzuhalten:
a) Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien sowie der anwesenden und vertretenen Aktionären bei-

gebogen. Diese Liste und auch die Vollmachten werden, nachdem sie unterschrieben wurden, mit der gegenwärtigen
Urkunde einregistriert.

b) Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle dreihundertzehn (310) Aktien, die das gesamte Aktienkapital in

Höhe von einunddreißigtausend euro (31.000,- EUR) darstellen, bei dieser außerordentlichen Generalversammlung ver-
treten sind, so dass gegenwärtige Versammlung rechtsmäßig zusammengetreten ist.

c) Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:

<i>Tagesordnung:

1) Aufstockung des Gesellschaftskapitals in Höhe von siebenhundertdreißigtausenddreihundert euro (730.300,- EUR)

um es von seinem jetzigen Betrag von einunddreißigtausend euro (31.000,- EUR) eingeteilt in dreihundertzehn (310)
Aktien von je einem Nennwert von einhundert euro (100,- EUR) auf denjenigen von siebenhunderteinundsechzigtau-
senddreihundert euro (761.300,- EUR) eingeteilt zu werden in siebentausendsechshundertdreizehn (7.613) Aktien von
einem Nennwert von einhundert euro (100,- EUR) zu erhöhen durch die Ausgabe von siebentausenddreihundertdrei
(7.303) neuen zusätzlichen Aktien, mit einem Nominalwert von je einhundert euro (100,- EUR), welche dieselben Rechte
und Vorteile verbriefen wie de schon bereits bestehenden Aktien.

2) Zeichnung der neuen ausgegebenen Aktien durch den bestehenden Aktionär KENMORE EUROPEAN VENTURES

S.à  r.l.,  mit  Gesellschaftssitz  in  1,  allée  Scheffer,  L-2520  Luxemburg,  nach  Feststellung  dass  der  andere  gegenwärtige
Aktionär rechtsmäßig auf sein bevorzugtes Zeichnungsrecht zur Zeichnung der neuen Aktien verzichtet hat und Einzahlung
in bar des Betrages von siebenhundertdreißigtausenddreihundert euro (730.300,- EUR) für die neuen ausgegebenen Aktien
durch den vorgezeichneten Aktionär KENMORE EUROPEAN VENTURES S.à r.l.

3) Abänderung von Artikel fünf, erster Absatz der Gesellschaftssatzung.
Nach Beratung fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

137524

<i>Erster Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von

siebenhundertdreißigtausenddreihundert euro (730.300,- EUR) aufzustocken um es von seinem jetzigen Betrag von ein-
unddreißigtausend euro (31.000,- EUR) eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien von je einem Nennwert von einhundert
euro (100,- EUR) auf denjenigen von siebenhunderteinundsechzigtausenddreihundert euro (761.300,- EUR) eingeteilt zu
werden in siebentausendsechshundertdreizehn (7.613) Aktien von einem Nennwert von einhundert euro (100,- EUR) zu
erhöhen durch die Ausgabe von siebentausenddreihundertdrei (7.303) neuen zusätzlichen Aktien, mit einem Nominalwert
von je einhundert euro (100,- EUR), welche dieselben Rechte und Vorteile verbriefen wie de schon bereits bestehenden
Aktien.

<i>Zweiter Beschluss

Nachdem sie festgestellt hat, dass einer der gegenwärtigen Aktionäre, soweit notwendig, auf sein Vorzugsrecht zur

Zeichnung der neuen Aktien verzichtet hat, beschließt die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre, den
nachbenannten Zeichner und Aktionär, KENMORE EUROPEAN VENTURES S.à r.l., eine Gesellschaft die dem Luxem-
burger Recht unterliegt, mit Sitz in 1, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, zur Zeichnung aller siebentausenddreihundertdrei
(7.303) neuen soeben ausgegebenen Aktien, zuzulassen:

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alsdann erklärt KENMORE EUROPEAN VENTURES S.à r.l., vorbenannt,
hier vertreten durch:
Herrn Joseph Hansen, vorgenannt,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht gegeben am 3. August 2007,
welche Vollmacht, nachdem sie von allen Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet

wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen,

die soeben durch die Gesellschaft neu ausgegebenen siebentausenddreihundertdrei (7.303) Aktien mit einem Nenn-

wert von je einhundert euro (100,- EUR) zu zeichnen und dieselben vollständig und in bar einzuzahlen.

Der oben erwähnte Zeichner erklärt und alle, in dieser Außerordentlichen Generalversammlung, Beteiligten erkennen

an, dass jede dieser neuen Aktien voll und ganz in bar eingezahlt wurde, so dass der Gesellschaft der Betrag von sieben-
hundertdreißigtausenddreihundert euro (730.300,- EUR) zur freien Verfügung steht, so wie es dem unterzeichneten Notar
nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich anerkennt.

<i>Dritter Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt den ersten Absatz von Artikel 5 der Satzung

durch den folgenden neuen ersten Absatz zu ersetzen, um der vorgetätigten Kapitalerhöhung Rechnung zu tragen:

«  Art.  5.  Das  gezeichnete  Aktienkapital  der  Gesellschaft  beträgt  siebenhundertsechzigtausenddreihundert  euro

(761.300,- EUR) eingeteilt in siebentausendsechs-hundertdreizehn (7.613) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert
euro (100,- EUR).»

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallen, werden auf zirka neuntausendfünfhundert

Euro geschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der

Komparenten die gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Gemäss dem Wunsch derselben Komparenten und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: J. Hansen, N. Weyrich, K. Wong, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch/Alzette, am 10. August 2007, Relation: EAC/2007/9844. — Erhalten 7.303 euros.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und

Vereinigungen.

Beles, den 21. September 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007117743/239/172.
(070135124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2007.

137525

BE Investco Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 112.259.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 49429 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007136999/211/11.
(070159336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Millicom International Cellular S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 40.630.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 16 novembre 2007.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

Référence de publication: 2007137000/206/13.
(070158887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

MX International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 116.384.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 49510 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007136998/211/11.
(070159323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

BAY-RUM Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 34.691.

La société DMC S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B 107.314, nommée administrateur en date du 15 novembre 2005, a désigné Madame Saliha
Boulhais, employée privée, née le 7 juin 1966, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'an 2011.

La société LOUV S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B 89.272, nommée administrateur en date du 15 novembre 2005, a désigné Monsieur Marc
Limpens, né le 17 février 1951, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'an 2011.

La société EFFIGI S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à

Luxembourg sous le numéro B 107313, nommée administrateur en date du 15 novembre 2005, a désigné Monsieur Jean-
Robert Bartolini, né le 10 novembre 1962, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'an 2011.

Luxembourg, le 22 juin 2007.

<i>BAY-RUM IMMOBILIERE S.A.
DMC S.à r.l. / LOUV S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur

137526

S. Boulhais / M. Limpens
<i>Représentant permanent / Représentant permanent

Référence de publication: 2007137131/795/27.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2007, réf. LSO-CK04139. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Danidin, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 72.239.

Constituée par-devant M 

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 octobre 1999, acte publié au

Mémorial C n 

o

 999 du 27 décembre 1999 et modifiée pour la dernière fois par-devant le même notaire en date du

8 avril 2005, acte publié au Mémorial C n 

o

 1349 du 13 juillet 2006.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DANIDIN
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007137054/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007, réf. LSO-CK03525. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Bergasa Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 49.590.

Constituée par-devant M 

e

 Marthe Thyes-Walch, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 décembre

1994, acte publié au Mémorial C n 

o

 127 du 22 mars 1995. Les statuts ont été modifiés par acte sous seing privé

dans le cadre de la conversion du capital en euros en date du 30 décembre 1999 et l'avis afférent a été publié au
Mémorial C n 

o

 235 du 29 mars 2000.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BERGASA HOLDING S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007137057/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007, réf. LSO-CK03610. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Macquarie Storage Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 128.357.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 49367 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007136987/211/11.
(070159209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

137527

HAWK Group S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 108.359.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 49390 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007136988/211/11.
(070159201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Macquarie Storage Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 128.227.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 49366 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007136989/211/11.
(070159212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Foxworth Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8354 Garnich, 1, Cité Bourfeld.

R.C.S. Luxembourg B 117.311.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 17 octobre 2007 que M. Marco Ries, avec

adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommé aux fonctions de
Commissaire aux Comptes en remplacement de CHESTER CLARK Ltd, démissionnaire, avec mission à partir des comptes
au 31 décembre 2007.

Son mandat arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2007137144/521/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01423. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

L'Arcobaleno, Société Anonyme.

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 42, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 128.240.

L'an deux mille sept, le treize septembre.
Par devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme L'ARCOBALENO avec siège

social à L-5750 Frisange, 3, rue de Bettembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4
juin 2007, publié au Mémorial C numéro 1449 du 13 juillet 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, sous le numéro B 128.240.

La séance est ouverte à 14.00 heures, sous la présidence de Monsieur Graziano Franceschini, gérant, né le 25 avril

1959 à Joeuf (F) demeurant à L-5750 Frisange, 3, rue de Bettembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jérôme Schmit, employé privé, demeurant professionnellement à

Esch-sur-Alzette.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Marco Franceschini, chef de chantier, né le 12 juin 1957 à

Mondolfo (I) demeurant à F-57100 Thionville, 64A, rue de Verdun.

137528

Le Président expose ensuite:
- Qu'il résulte de la liste de présence que les trois cent dix (310) actions d'valeur nominale de cent euros (EUR 100,-),

représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la
présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur
les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée
ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

- Ladite liste de présence ainsi que les procurations émanant des actionnaires représentés resteront annexées au

présent procès-verbal pour être soumises avec lui, aux formalités de l'enregistrement.

- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Décision de transférer le siège de la société de L-5750 Frisange, 3, rue de Bettembourg, à L-4140 Esch-sur-Alzette,

42, rue Victor Hugo.

2.- Modification afférente du deuxième alinéa de l'article premier des statuts de la société.
3.- Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-5750 Frisange, 3, rue de Bettembourg, à

L-4140 Esch-sur-Alzette, 42, rue Victor Hugo.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier en conséquence le deuxième alinéa de

l'article premier des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.»
Les autres alinéas de l'article 1 

er

 restent inchangés.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: G. Franceschini, J. Schmit, M. Franceschini, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 septembre 2007, Relation: EAC/2007/10969. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): A. Santioni.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007110774/272/52.
(070126235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Peehold S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 95.066.

Constituée par-devant M 

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 juillet 2003, acte publié au

Mémorial C n 

o

 917 du 8 septembre 2003 et modifiée par-devant le même notaire, en date du 26 août 2004, acte

publié au Mémorial C n 

o

 1148 du 13 novembre 2004.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PEEHOLD S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007137059/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007, réf. LSO-CK03615. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

137529

Caleche Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 83.996.

Constituée par-devant M 

e

 Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 septembre 2001,

acte publié au Mémorial C n 

o

 261 du 15 février 2002.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CALECHE HOLDING S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007137149/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007, réf. LSO-CK03618. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070158923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

European Education Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 125.331.

In the year two thousand and seven, on the ninth day of July.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- BRIDGEPOINT EUROPE III NOMINEES 1 LIMITED, an English company incorporated in England and Wales, having

its principal place of business at 30 Warwick Street, London W1B 5AL, registered with the UK Companies House under
number 6169735, here represented by Mrs Nadia Weyrich, employee, residing in Arlon, by virtue of a proxy given on
July 9, 2007,

- BRIDGEPOINT EUROPE III NOMINEES 2 LIMITED, an English company incorporated in England and Wales, having

its principal place of business at 30 Warwick Street, London W1B 5AL, registered with the UK Companies House under
number 6169755, here represented by Mrs Nadia Weyrich, previously named, by virtue of a proxy given on July 9, 2007,

- BRIDGEPOINT EUROPE III NOMINEES 3 LIMITED, an English company incorporated in England and Wales, having

its principal place of business at 30 Warwick Street, London W1B 5AL, registered with the UK Companies House under
number 6220900, here represented by Mrs Nadia Weyrich, previously named, by virtue of a proxy given on July 9, 2007.

- BRIDGEPOINT EUROPE III NOMINEES 4 LIMITED, an English company incorporated in England and Wales, having

its principal place of business at 30 Warwick Street, London W1B 5AL, registered with the UK Companies House under
number 6220922, here represented by Mrs Nadia Weyrich, previously named, by virtue of a proxy given on July 9, 2007.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholder of EUROPEAN EDUCATION HOLDINGS S.à r.l., a société a responsabilité

limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its registered office at 174, route de Longwy,
L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under RCS B no 125.331, incorpo-
rated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary on 14 March 2007, and whose articles have not yet been
published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Association. The articles of incorporation of the Company
have been amended for the last time on 4 June 2007 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published.

The appearing parties representing the whole issued share capital require the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of

nine million two hundred and twenty-nine thousand two hundred and ninety Euro (EUR 9,229,290.-) in order to raise it
from its current amount of seventy-eight thousand Euro (EUR 78,000.-) to nine million three hundred and seven thousand
two hundred and ninety Euro (EUR 9,307,290.-), by a contribution in kind consisting in several unquestionable debt against
the Company held by each of the shareholders and the new subscribers, and by creating and issuing nine hundred and
twenty-two thousand nine hundred and twenty-nine (922,929) new Class A Shares (the «New Class A Shares»), nine
hundred and twenty-two thousand nine hundred and twenty-nine (922,929) new Class B Shares (the «New Class B
Share»), nine hundred and twenty-two thousand nine hundred and twenty-nine (922,929) new Class C Shares (the «New
Class C Shares»), nine hundred and twenty-two thousand nine hundred and twenty-nine (922,929) new Class D Shares

137530

(the «New Class D Shares»), nine hundred and twenty-two thousand nine hundred and twenty-nine (922,929) new Class
E Shares (the «New Class E Shares»), nine hundred and twenty-two thousand nine hundred and twenty-nine (922,929)
new Class F Shares (the «New Class F Shares»), nine hundred and twenty-two thousand nine hundred and twenty-nine
(922,929) new Class G Shares (the «New Class G Shares»), nine hundred and twenty-two thousand nine hundred and
twenty-nine (922,929) new Class H Shares (the «New Class H Shares»), nine hundred and twenty-two thousand nine
hundred and twenty-nine (922,929) new Class I Shares (the «New Class I Shares») and nine hundred and twenty-two
thousand nine hundred and twenty-nine (922,929) new Class J Shares (the «New Class J Shares»), each of such new shares
having the same rights and obligations as the existing shares, with nominal value of one euro (EUR 1.-) each, which are
subscribed as follows:

(i) BRIDGEPOINT EUROPE III NOMINEES 1 LIMITED, prenamed, represented as stated above, declares through its

proxyholder to subscribe to 207,576 New Class A Shares, 207,576 New Class B Shares, 207,576 New Class C Shares,
207,576 New Class D Shares, 207,576 New Class E Shares, 207,576 New Class F Shares, 207,576 New Class G Shares,
207,576 New Class H Shares, 207,576 New Class I Shares and 207,576 New Class J Shares, paid up by a contribution in
kind consisting in a claim owned against the Company in the amount of two million seventy-five thousand seven hundred
and sixty euro (EUR 2,075,760.-). The total contribution of two million seventy-five thousand seven hundred and sixty
euro (EUR 2,075,760.-) related to such new shares is entirely allocated to the Company's share capital.

(ii) BRIDGEPOINT EUROPE III NOMINEES 2 LIMITED, prenamed, represented as stated above, declares through its

proxyholder to subscribe to 207,576 New Class A Shares, 207,576 New Class B Shares, 207,576 New Class C Shares,
207,576 New Class D Shares, 207,576 New Class E Shares, 207,576 New Class F Shares, 207,576 New Class G Shares,
207,576 New Class H Shares, 207,576 New Class I Shares and 207,576 New Class J Shares, paid up by a contribution in
kind consisting in a claim owned against the Company in the amount of two million seventy-five thousand seven hundred
and sixty euro (EUR 2,075,760.-). The total contribution of two million seventy-five thousand seven hundred and sixty
euro (EUR 2,075,760.-) related to such new shares is entirely allocated to the Company's share capital.

(iii) BRIDGEPOINT EUROPE III NOMINEES 3 LIMITED, prenamed, represented as stated above, declares through its

proxyholder to subscribe to 207,576 New Class A Shares, 207,576 New Class B Shares, 207,576 New Class C Shares,
207,576 New Class D Shares, 207,576 New Class E Shares, 207,576 New Class F Shares, 207,576 New Class G Shares,
207,576 New Class H Shares, 207,576 New Class I Shares and 207,576 New Class J Shares, paid up by a contribution in
kind consisting in a claim owned against the Company in the amount of two million seventy-five thousand seven hundred
and sixty euro (EUR 2,075,760.-). The total contribution of two million seventy-five thousand seven hundred and sixty
euro (EUR 2,075,760.-) related to such new shares is entirely allocated to the Company's share capital.

(iv) BRIDGEPOINT EUROPE III NOMINEES 4 LIMITED, prenamed, represented as stated above, declares through its

proxyholder to subscribe to 207,576 New Class A Shares, 207,576 New Class B Shares, 207,576 New Class C Shares,
207,576 New Class D Shares, 207,576 New Class E Shares, 207,576 New Class F Shares, 207,576 New Class G Shares,
207,576 New Class H Shares, 207,576 New Class I Shares and 207,576 New Class J Shares, paid up by a contribution in
kind consisting in a claim owned against the Company in the amount of two million seventy-five thousand seven hundred
and sixty euro (EUR 2,075,760.-). The total contribution of two million seventy-five thousand seven hundred and sixty
euro (EUR 2,075,760.-) related to such new shares is entirely allocated to the Company's share capital.

(v) STICHTING MANAGEMENT EEH, a foundation incorporated under the laws of The Netherlands, having its having

its registered office at Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, the Netherlands and principal place of business at Locatelli-
kade 1, 1076AZ Amsterdam, the Netherlands, duly represented by Ms Nadia WEYRICH, previously named, by virtue of
a proxy given on July 9, 2007, hereto annexed, declares to subscribe to 50,615 New Class A Shares, 50,615 New Class
B Shares, 50,615 New Class C Shares, 50,615 New Class D Shares, 50,615 New Class E Shares, 50,615 New Class F
Shares, 50,615 New Class G Shares, 50,615 New Class H Shares, 50,615 New Class I Shares and 50,615 New Class J
Shares. Such new shares to be paid up by a contribution in kind consisting in a claim owned against the Company in the
amount of five hundred and six thousand one hundred and fifty euro (EUR 506,150.-). The total contribution of five
hundred and six thousand one hundred and fifty euro (EUR 506,150.-) related to such new shares will be entirely allocated
to the Company's share capital.

(vi) EEH MANAGEMENT GMBH &amp; CO. KG, a limited liability partnership under German law (Kommanditgesellschaft),

registered with the commercial register of the local court of Frankfurt am Main, having its registered office at Clifford
Chance, at Mainzer Landstrasse 46, 60325 Frankfurt am Main, Germany, duly represented by Ms Nadia Weyrich, previ-
ously named, by virtue of a proxy, given on July 9, 2007, hereto annexed, declares to subscribe to 6,074 New Class A
Shares, 6,074 New Class B Shares, 6,074 New Class C Shares, 6,074 New Class D Shares, 6,074 New Class E Shares,
6,074 New Class F Shares, 6,074 New Class G Shares, 6,074 New Class H Shares, 6,074 New Class I Shares and 6,074
New Class J Shares. Such new shares to be paid up by a contribution in kind consisting in a claim owned against the
Company in the amount of sixty thousand seven hundred and forty euro (EUR 60,740.-). The total contribution of sixty
thousand seven hundred and forty euro (EUR 60,740.-) related to such new shares will be entirely allocated to the
Company's share capital.

(vii) Mr Fred Grainger, born at Billingham, Teesside, on 27 August 1953, publisher, residing at Hampton Court, Hamp-

ton Green, Minchin Hampton, Gloucester, GL6 9AD, England, duly represented by Ms Nadia Weyrich, previously named,
by virtue of a proxy, given on July 9, 2007, hereto annexed, declares to subscribe to 35,936 New Class A Shares, 35,936
New Class B Shares, 35,936 New Class C Shares, 35,936 New Class D Shares, 35,936 New Class E Shares, 35,936 New

137531

Class F Shares, 35,936 New Class G Shares, 35,936 New Class H Shares, 35,936 New Class I Shares and 35,936 New
Class J Shares. Such new shares to be paid up by a contribution in kind consisting in a claim owned against the Company
in the amount of three hundred and fifty-nine thousand three hundred and sixty euro (EUR 359,360.-). The total contri-
bution of three hundred and fifty-nine thousand three hundred and sixty euro (EUR 359,360.-) related to such new shares
will be entirely allocated to the Company's share capital.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolutions, the general meeting of shareholders decides to amend Article 6.1 of the

articles of incorporation of the Company so as to reflect the above decisions, which shall henceforth read as follows:

«6.1 The issued share capital of the Company is set at nine million three hundred and seven thousand two hundred

and ninety euro (EUR 9,307,290.-) divided into:

- nine hundred and thirty thousand seven hundred and twenty-nine (930,729) class A shares (the «Class A Shares»),
- nine hundred and thirty thousand seven hundred and twenty-nine (930,729) class B shares (the «Class B Shares»),
- nine hundred and thirty thousand seven hundred and twenty-nine (930,729) class C shares (the «Class C Shares»),
- nine hundred and thirty thousand seven hundred and twenty-nine (930,729) class D shares (the «Class D Shares»),
- nine hundred and thirty thousand seven hundred and twenty-nine (930,729) class E shares (the «Class E Shares»),
- nine hundred and thirty thousand seven hundred and twenty-nine (930,729) class F shares (the «Class F Shares»),
- nine hundred and thirty thousand seven hundred and twenty-nine (930,729) class G shares (the «Class G Shares»),
- nine hundred and thirty thousand seven hundred and twenty-nine (930,729) class H shares (the «Class H Shares»),
- nine hundred and thirty thousand seven hundred and twenty-nine (930,729) class I shares (the «Class I Shares»), and
- nine hundred and thirty thousand seven hundred and twenty-nine (930,729) class J shares (the «Class J Shares»),
each Share with a nominal value of one euro (EUR 1.-) and with such rights and obligations as set out in the present

Articles.»

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the presently stated increase of capital are estimated at ninety-eight thousand five hundred euro.

Whereof the present deed is drawn up in Belvaux, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le neuf juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- BRIDGEPOINT EUROPE III NOMINEES 1 LIMITED, une société anglaise régie par les lois d'Angleterre et du Pays

de Galles, ayant son siège social au 30 Warwick Street, Londres W1B 5AL, immatriculée auprès du UK Companies House
(Registre des Sociétés du Royaume Uni) sous le numéro 6169735, ici représentée par Madame Nadia Weyrich, employée
privée, demeurant à Arlon, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 9 juillet 2007;

- BRIDGEPOINT EUROPE III NOMINEES 2 LIMITED, une société anglaise régie par les lois d'Angleterre et du Pays

de Galles, ayant son siège social au 30 Warwick Street, Londres W1B 5AL, immatriculée auprès du UK Companies House
(Registre des Sociétés du Royaume Uni) sous le numéro 6169755, ici représentée par Madame Nadia Weyrich, prén-
ommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 9 juillet 2007;

- BRIDGEPOINT EUROPE III NOMINEES 3 LIMITED, une société anglaise régie par les lois d'Angleterre et du Pays

de Galles, ayant son siège social au 30 Warwick Street, Londres W1B 5AL, immatriculée auprès du UK Companies House
(Registre des Sociétés du Royaume Uni) sous le numéro 6220900, ici représentée par Madame Nadia Weyrich, prén-
ommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 9 juillet 2007;

- BRIDGEPOINT EUROPE III NOMINEES 4 LIMITED, une société anglaise régie par les lois d'Angleterre et du Pays

de Galles, ayant son siège social au 30 Warwick Street, Londres W1B 5AL, immatriculée auprès du UK Companies House
(Registre des Sociétés du Royaume Uni) sous le numéro 6220922, ici représentée par Madame Nadia Weyrich, prén-
ommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 9 juillet 2007.

Les procurations signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement

137532

Lesquelles parties comparantes sont les associés de EUROPEAN EDUCATION HOLDINGS S.à.r.l., une société à

responsabilité limitée, constitué selon les lois du Grand Duché du Luxembourg ayant son siège social au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 125331, constituée selon un acte reçu par le notaire soussigné le 14 mars 2007, et dont les statuts n'ont pas
encore été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Association. Les statuts de la Société ont été amendés
pour la dernière fois le 4 juin 2007.

Lesquelles parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social émis de la Société à concurrence de neuf millions deux cent vingt-

neuf mille deux cent quatre-vingt-dix Euros (EUR 9.229.290,-) pour le porter de son montant actuel de soixante-dix huit
mille Euros (EUR 78.000,-) à neuf millions trois cent sept mille deux cent quatre vingt dix Euros (EUR 9.307.290.-), par
un apport en nature consistant en plusieurs dettes non remises en question contre la Société détenues par chacun des
associés et les nouveaux souscripteurs, et par la création et l'émission de neuf cent vingt-deux mille neuf cent vingt-neuf
(922.929) nouvelles Parts Sociales de Classe A (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe A»), neuf cent vingt-deux mille
neuf cent vingt-neuf (922.929) nouvelles Parts Sociales de Classe B (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe B»), neuf cent
vingt-deux mille neuf cent vingt-neuf (922.929) nouvelles Parts Sociales de Classe C (les «Nouvelles Parts Sociales de
Classe C»), neuf cent vingt-deux mille neuf cent vingt-neuf (922.929) nouvelles Parts Sociales de Classe D (les «Nouvelles
Parts Sociales de Classe D»), neuf cent vingt-deux mille neuf cent vingt-neuf (922.929) nouvelles Parts Sociales de Classe
E (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe E»), neuf cent vingt-deux mille neuf cent vingt-neuf (922.929) nouvelles Parts
Sociales de Classe F (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe F»), neuf cent vingt-deux mille neuf cent vingt-neuf (922.929)
nouvelles Parts Sociales de Classe G (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe G»), neuf cent vingt-deux mille neuf cent
vingt-neuf (922.929) nouvelles Parts Sociales de Classe H (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe H»), neuf cent vingt-
deux mille neuf cent vingt-neuf (922.929) nouvelles Parts Sociales de Classe I (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe I»)
et neuf cent vingt-deux mille neuf cent vingt-neuf (922.929) nouvelles Parts Sociales de Classe J (les «Nouvelles Parts
Sociales de Classe J»), chacune de ces nouvelles parts sociales ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs que les parts
sociales existantes avec une valeur nominal d'un euro (EUR 1,-) chacune, qui sont souscrites comme suit:

(i) BRIDGEPOINT EUROPE III NOMINEES 1 LIMITED, sus-mentionnée, représentée comme déclarée ci-dessus, dé-

clare par le biais de sa mandataire souscrire à 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe A, 207.576 Nouvelles Parts
Sociales de Classe B, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe C, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe D, 207.576
Nouvelles Parts Sociales de Classe E, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe F, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de
Classe G, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe H, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe I et 207.576 Nouvelles
Parts Sociales de Classe J, payées par un apport en nature consistant en une dette détenue contre la Société d'un montant
de deux millions soixante quinze mille sept cent soixante euros (EUR 2.075.760,-). L'apport total de deux millions soixante
quinze mille sept cent soixante euros (EUR 2.075.760,-) lié à ces nouvelles parts sociales est entièrement alloué au capital
social de la Société.

(ii)  BRIDGEPOINT  EUROPE  III  NOMINEES  2  LIMITED,  sus-mentionnée,  représentée  comme  déclarée  ci-dessus,

déclare par le biais de sa mandataire souscrire à 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe A, 207.576 Nouvelles Parts
Sociales de Classe B, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe C, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe D, 207.576
Nouvelles Parts Sociales de Classe E, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe F, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de
Classe G, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe H, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe I et 207.576 Nouvelles
Parts Sociales de Classe J, payées par un apport en nature consistant en une dette détenue contre la Société d'un montant
de deux millions soixante quinze mille sept cent soixante euros (EUR 2.075.760,-). L'apport total de deux millions soixante
quinze mille sept cent soixante euros (EUR 2.075.760,-) lié à ces nouvelles parts sociales est entièrement alloué au capital
social de la Société.

(iii) BRIDGEPOINT EUROPE III NOMINEES 3 LIMITED, sus-mentionnée, représentée comme déclarée ci-dessus,

déclare par le biais de sa mandataire souscrire à 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe A, 207.576 Nouvelles Parts
Sociales de Classe B, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe C, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe D, 207.576
Nouvelles Parts Sociales de Classe E, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe F, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de
Classe G, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe H, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe I et 207.576 Nouvelles
Parts Sociales de Classe J, payées par un apport en nature consistant en une dette détenue contre la Société d'un montant
de deux millions soixante quinze mille sept cent soixante euros (EUR 2.075.760,-). L'apport total de deux millions soixante
quinze mille sept cent soixante euros (EUR 2.075.760,-) lié à ces nouvelles parts sociales est entièrement alloué au capital
social de la Société.

(iv) BRIDGEPOINT EUROPE III NOMINEES 4 LIMITED, sus-mentionnée, représentée comme déclarée ci-dessus,

déclare par le biais de sa mandataire souscrire à 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe A, 207.576 Nouvelles Parts
Sociales de Classe B, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe C, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe D, 207.576
Nouvelles Parts Sociales de Classe E, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe F, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de
Classe G, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe H, 207.576 Nouvelles Parts Sociales de Classe I et 207.576 Nouvelles
Parts Sociales de Classe J, payées par un apport en nature consistant en une dette détenue contre la Société d'un montant

137533

de deux millions soixante quinze mille sept cent soixante euros (EUR 2.075.760,-). L'apport total de deux millions soixante
quinze mille sept cent soixante euros (EUR 2.075.760,-) lié à ces nouvelles parts sociales est entièrement alloué au capital
social de la Société.

(v) STICHTING MANAGEMENT EEH, une fondation constituée selon les lois des Pay-Bas, ayant son siège statutaire

à Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, Pays Bas, et son lieu principal d'affaires à Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam,
Pays Bas, dûment représentée par Madame Nadia Weyrich, sus-mentionnée, en vertu d'une procuration, donnée le 9
juillet 2007, ci-annexée, déclare souscrire à 50.615 Nouvelles Parts Sociales de Classe A, 50.615 Nouvelles Parts Sociales
de Classe B, 50.615 Nouvelles Parts Sociales de Classe C, 50.615 Nouvelles Parts Sociales de Classe D, 50.615 Nouvelles
Parts Sociales de Classe E, 50.615 Nouvelles Parts Sociales de Classe F, 50,615 50.615 Nouvelles Parts Sociales de Classe
G, 50.615 Nouvelles Parts Sociales de Classe H, 50.615 Nouvelles Parts Sociales de Classe I et 50.615 Nouvelles Parts
Sociales de Classe J. Ces nouvelles parts sociales seront payées par un apport en nature consistant en une dette détenue
contre la Société d'un montant de cinq cent six mille cent cinquante euros (EUR 506.150,-). L'apport total de cinq cent
six mille cent cinquante euros (EUR 506.150,-) lié à ces nouvelles parts sociales est entièrement alloué au capital social
de la Société.

(vi) EEH MANAGEMENT GMBH &amp; CO. KG, une société en commandite par actions sous le droit allemand (Kom-

manditgesellschaft), immatriculée auprès du registre commercial de la cour local de Frankfurt am Main et ayant son siège
statutaire au cabinet Clifford Chance de Francfort, à Mainzer Landstrasse 46, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne, dûment
représentée par Madame Nadia Weyrich, sus-mentionnée, en vertu d'une procuration, donnée le 9 juillet 2007, ci-an-
nexée, déclare souscrire à 6.074 Nouvelles Parts Sociales de Classe A, 6.074 Nouvelles Parts Sociales de Classe B, 6.074
Nouvelles Parts Sociales de Classe C, 6.074 Nouvelles Parts Sociales de Classe D, 6.074 Nouvelles Parts Sociales de
Classe E, 6.074 Nouvelles Parts Sociales de Classe F, 6.074 Nouvelles Parts Sociales de Classe G, 6,074 6.074 Nouvelles
Parts Sociales de Classe H, 6.074 Nouvelles Parts Sociales de Classe I et 6.074 Nouvelles Parts Sociales de Classe J. Ces
nouvelles parts sociales seront payées par un apport en nature consistant en une dette détenue contre la Société d'un
montant de soixante mille sept cent quarante euros (EUR 60.740,-). L'apport total de soixante mille sept cent quarante
euros (EUR 60.740,-) lié à ces nouvelles parts sociales est entièrement alloué au capital social de la Société.

(vii) Monsieur Fred Grainger, né à Bllingham, Teesside, le 27 août 1953, éditeur, résidant à Hampton Court, Hampton

Green, Minchin Hampton, Gloucester, GL6 9AD, Angleterre, dûment représentée par Madame Nadia Weyrich, sus-
mentionnée, en vertu d'une procuration, donnée le 9 juillet 2007, ci-annexée, déclare souscrire à 35.936 Nouvelles Parts
Sociales de Classe A, 35.936 Nouvelles Parts Sociales de Classe B, 35.936 Nouvelles Parts Sociales de Classe C, 35.936
Nouvelles Parts Sociales de Classe D, 35.936 Nouvelles Parts Sociales de Classe E, 35.936 Nouvelles Parts Sociales de
Classe F, 35.936 Nouvelles Parts Sociales de Classe G, 35.936 Nouvelles Parts Sociales de Classe H, 35.936 Nouvelles
Parts Sociales de Classe I et 35.936 Nouvelles Parts Sociales de Classe J. Ces nouvelles parts sociales seront payées par
un apport en nature consistant en une dette détenue contre la Société d'un montant de trois cent cinquante-neuf mille
trois cent soixante euros (EUR 359.360,-). L'apport total de trois cent cinquante-neuf mille trois cent soixante euros
(EUR 359.360,-) lié à ces nouvelles parts sociales est entièrement alloué au capital social de la Société.

<i>Seconde résolution

En conséquence de la résolution ci-dessus, les associés décident de modifier l'Article 6.1 des statuts de la Société de

façon à refléter la résolution ci-dessus, qui doit être lu comme-suit:

«6.1 Le capital social émis de la Société est fixé à la somme de neuf millions trois cent sept mille deux cent quatre-

vingt dix Euros (EUR 9.307.290,-) divisé en:

- neuf cent trente mille sept cent vingt-neuf (930.729) parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe A»),
- neuf cent trente mille sept cent vingt-neuf (930.729) parts sociales de classe B (les «Parts Sociales de Classe B»),
- neuf cent trente mille sept cent vingt-neuf (930.729) parts sociales de classe C (les «Parts Sociales de Classe C»),
- neuf cent trente mille sept cent vingt-neuf (930.729) parts sociales de classe D (les «Parts Sociales de Classe D»),
- neuf cent trente mille sept cent vingt-neuf (930.729) parts sociales de classe E (les «Parts Sociales de Classe E»),
- neuf cent trente mille sept cent vingt-neuf (930.729) parts sociales de classe F (les «Parts Sociales de Classe F»),
- neuf cent trente mille sept cent vingt-neuf (930.729) parts sociales de classe G (les «Parts Sociales de Classe G»),
- neuf cent trente mille sept cent vingt-neuf (930.729) parts sociales de classe H (les «Parts Sociales de Classe H»),
- neuf cent trente mille sept cent vingt-neuf (930.729) parts sociales de classe I (les «Parts Sociales de Classe I»), et
- neuf cent trente mille sept cent vingt-neuf (930.729) parts sociales de classe J (les «Parts Sociales de Classe J»),
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et les droits et obligations comme prévus dans les présents

Statuts.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice a la somme de quatre-dix-huit mille cinq cents euros.

Dont acte, passé à Belvaux, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

137534

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent
acte.

Signé: N. Weyrich, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 2007. Relation: EAC/2007/8311. - Reçu 92.292,90 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 10 août 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007120199/239/284.
(070137322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

East Europe Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 85.222.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 26 octobre 2007, que

le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa

fonction d'Administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet
immédiat, Monsieur Olivier Conrard, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en rem-
placement de Monsieur Mirko La Rocca, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur
qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2007.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomi-

nation définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2007.

Le Conseil d'Administration
D. Murari / O. Conrard
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007137137/43/24.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01304. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Elvas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 61.403.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 17 septembre 2007, que

le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci de

sa fonction d'Administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet
immédiat, Monsieur Olivier Conrard, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en rem-
placement  de  Monsieur  Jean-Philippe  Fiorucci,  démissionnaire.  L'Administrateur  coopté  termine  le  mandat  de  son
prédécesseur qui expirera à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2006.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomi-

nation définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

137535

Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Le Conseil d'Administration
D. Murari / M. La Rocca
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007137138/43/24.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09187. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Lincolnwood S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.409.

Constituée par-devant M 

e

 Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 2 décembre 2005,

acte publié au Mémorial C n 

o

 463 du 3 mars 2006.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LINCOLNWOOD S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007137153/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007, réf. LSO-CK03622. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Soprogest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1279 Luxembourg, 23, rue Général Omar N. Bradley.

R.C.S. Luxembourg B 29.320.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour compte de SOPROGEST S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Référence de publication: 2007137233/752/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02268. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Graci International Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 21.011.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour compte de GRACI INTERNATIONAL HOLDING, en liquidation
FIDUPLAN S.A.
Signature

Référence de publication: 2007137223/752/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2007, réf. LSO-CK02783. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

137536

Euro-Connect S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1747 Luxembourg, 2, Op der Heed.

R.C.S. Luxembourg B 47.655.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour compte de EURO-CONNECT S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Référence de publication: 2007137224/752/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2007, réf. LSO-CK02802. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070158693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

I.07 Pabeierbierg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 70.081.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007137218/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04291. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Macquarie Global Infrastructure Funds 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 103.975.

Les comptes annuels pour la période du 28 octobre 2004 (date de constitution) au 30 juin 2005 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007137216/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04281. - Reçu 42 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Tricat Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 47.228.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007137217/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04286. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

137537

DHCRE II Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.168.

Les comptes annuels pour la période du 9 novembre 2005 (date de constitution) au 31 décembre 2006 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007137219/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04293. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070158676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Patri Participations Holding, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 92.821.

Les comptes annuels au 30 septembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007137220/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2007, réf. LSO-CK04198. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Universal Commerce and Finance S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 32.116.

Constituée en date du 9 novembre 1989 par-devant M 

e

 Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié

au Mémorial C n 

o

 118 en 1990.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour UNIVERSAL COMMERCE AND FINANCE S.A.H.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007137210/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08841. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Season International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 42.535.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 12 novembre 2007

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Sophie Jacquet, née le 7 mai 1974 à Messancy (Belgique),

employée privée demeurant professionnellement 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, de sa fonction
d'administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour, Madame Gabrielle Mingarelli, née le 15

mai 1959 à Villerupt (France), employée privée, demeurant professionnellement 19-21, bd du Prince Henri L-1724 Lu-
xembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

137538

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque Domiciliaire
Signatures

Référence de publication: 2007137225/24/22.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04455. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

e2 advance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 84.473.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour compte de E2 ADVANCE Sàrl
FIDUPLAN S.A.
Signature

Référence de publication: 2007137229/752/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02260. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

BTI-Building Technology International Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 73.303.

- Les administrateurs suivants ont démissionné:
* TMF CORPORATE SERVICES S.A. a démissionné avec effet immédiat le 2 novembre 2007;
* Monsieur Armin Kircher a démissionné avec effet immédiat le 24 juillet 2007; et

* Monsieur Hugo Neuman a démissionné avec effet immédiat le 1 

er

 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2007.

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007137236/805/18.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04360. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

STAR s. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8017 Strassen, 11, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 19.968.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

137539

<i>Pour compte de STAR Sàrl
FIDUPLAN S.A.
Signature

Référence de publication: 2007137242/752/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02267. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Federale Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 76.557.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 25 octobre 2007 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
Monsieur Marc Bandella, LES ASSURANCES FEDERALES, 12, rue de l'Etuve, B-1000 Bruxelles
Monsieur Vincent Favier, Président du Conseil d'Administration des Entreprises FAVIER S.A., 1, rue Albert Mille,

B-7740 Pecq

Monsieur Tom Meeus, LES ASSURANCES FEDERALES, 12, rue de l'Etuve, B-1000 Bruxelles
Monsieur Francis Vroman, LES ASSURANCES FEDERALES, 12, rue de l'Etuve, B-1000 Bruxelles
en  leur  qualité  d'administrateurs  pour  une  période  d'un  an  prenant  fin  lors  de  la  prochaine  Assemblée  Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2008,

- de renouveler le mandat de:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., Le Dôme Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle, L-2013 Luxembourg,

RCS B 71.178

en tant que Réviseur d'entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2008.

<i>Pour FEDERALE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK, Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2007137243/1126/26.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00362. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Schutz et Wagner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3730 Rumelange, 1, rue de l'Usine.

R.C.S. Luxembourg B 15.157.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour compte de SCHUTZ ET WAGNER S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Référence de publication: 2007137239/752/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02265. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Geralux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1279 Luxembourg, 23, rue Général Omar N. Bradley.

R.C.S. Luxembourg B 18.942.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

137540

<i>Pour compte de GERALUX S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Référence de publication: 2007137237/752/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02262. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

WGC - Worldwide Glass and Ceramics Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 73.315.

- Les administrateurs suivants ont démissionné:
* TMF CORPORATE SERVICES S.A. a démissionné avec effet immédiat le 2 novembre 2007;
* Monsieur Armin Kircher a démissionné avec effet immédiat le 24 juillet 2007; et
* Monsieur Hugo Neuman a démissionné avec effet immédiat le 1 

er

 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2007.

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007137238/805/18.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04358. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

La Beauté S.àr.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3358 Leudelange, 10, rue du Lavoir.

R.C.S. Luxembourg B 109.638.

EXTRAIT

Il découle d'un acte de cession de parts sous seing privé du 22 octobre 2007 enregistré à Luxembourg-Sociétés, en

date du 31 octobre 2007, référence LSO CJ/10090, que:

le capital de la société LA BEAUTE S.à r.l., se trouve actuellement réparti comme suit:

Parts

- Madame Peggy Ambrosini, demeurant à L-4993 Sanem, 26, Cité Schmiedenacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- Madame Denise Mousel, demeurant à L-4986 Sanem, 28, rue des Aulnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre à des fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2007.

<i>Pour le notaire
Mlle Muhovic

Référence de publication: 2007137142/203/22.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2007, réf. LSO-CK03873. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

responsAbility BOP Investments S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 132.074.

In the year two thousand and seven, on the thirteenth day of November.

137541

Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of responsAbility BOP INVESTMENTS S.C.A. SICAR,

a Luxembourg company under the form of a limited partnership by shares (société en commandite par actions), qualifying
as an investment company in risk capital (société d'investissement en capital à risque), having its registered office at 5,
rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 132.074, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 17 September
2007, published in the Mémorial C, number 2305, on 15 October 2007 (the «Company»).

The extraordinary general meeting was opened at 11.45 a.m. and was presided by Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing

professionally in Luxembourg, who appointed as secretary Mr Mustafa Nezar, lawyer, residing professionally in Luxem-
bourg.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Mrs Elke Leenders, lawyer, residing in Luxembourg.
The bureau of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested

the notary to state that:

I. The agenda of the extraordinary general meeting is as follows:
1. Amendment of the following definitions in the definition section, so that it is worded as follows:
««Closings» means the First and the Subsequent Closings at which the Commitment(s) of the Initial and New Investors

are accepted by the General Partner in accordance with the Prospectus and the Articles of Incorporation

«Equalization Factor» means the Equalization Factor with respect to the Lock Up Period, as described in more detail

in section 5.4.2 of the Prospectus

«Equalization Fee» means the Equalization Fee with respect to the period of time starting after the end of the Lock

Up Period, as described in more detail in section 5.4.3 of the Prospectus

«First Closing» means the first date determined by the General Partner on which Subscription Agreements in relation

to the first issuance of Ordinary Shares have been received and accepted by the General Partner and marks the difference
between Initial Investors and New Investors, i.e. 15 November 2007

«Lock-Up Period» means the period which starts at the First Closing and ends on the fifth anniversary of the First

Closing, i.e. 14 November 2012, during which the Company will not repurchase Ordinary Shares at the request of Limited
Shareholders

«NAV Disclosure Day» means ninety (90) calendar days after each Valuation Day when the NAV per Ordinary Share

as of the Valuation Day concerned if disclosed by the General Partner in accordance with the Prospectus and the Articles
of Incorporation. If such a calendar day is not a Bank Business Day, the NAV Disclosure Day will be the next following
Bank Business Day

«Subsequent Closing» means a closing after the First Closing which may be held on any Bank Business Day determined

in the sole discretion of the General Partner.

In addition, the definition of «redemption period» shall be deleted.»
2. Amendment of the first and second paragraph of article 3.5 headed «Closings», so that it is worded as follows:
«The Company will accept subscriptions from Investors at the First Closing and at any Subsequent Closing.
The First Closing will take place on 15 November 2007. There can be one or more Subsequent Closing(s). No Sub-

sequent Closings will be held if the Company is to be dissolved and liquidated in accordance with section 10 of the
Prospectus and the Articles of Incorporation.»

3. Amendment of article 3.6.2 headed «Issue of Ordinary Shares during the Lock Up Period», so that it is worded as

follows:

«(a) From the day of the First Closing until the first NAV Disclosure Day (i.e. 6 months and ninety (90) calendar days

after the First Closing), Ordinary Shares are issued on each Draw Down Date at the Initial Price of one thousand (1,000.-)
USD each.

(b) After the first NAV Disclosure Day, Ordinary Shares are issued to Investors on each Draw Down Date at the

latest available Net Asset Value per Ordinary Share.

In order to balance the interests of the existing and the new Shareholders, New Investors will be charged a one-time

Equalization Factor (the «Equalization Factor») on the day on which their respective Subscription Agreement is accepted
by the General Partner. The Equalization Factor will be levied at a rate of three point nine per cent (3.9%) per annum
applied on the Commitment of the concerned Investor. The relevant period will start on the First Closing and end on
the day of the relevant Subsequent Closing at which the New Investor's Commitment is accepted, with a maximum
duration of up to twenty-four (24) months. The Equalization Factor is payable together with the first Drawdown regarding
the New Investor. The Equalization Factor represents the past Management Fee, the opportunity costs of capital of the
existing Investors plus a participation in the formation expenses of the Company, the acquisition costs relating to the
investments already carried out by the Company as well as any deferred tax liabilities of the Company or of its subsidiaries,
the foregoing enumeration not being limitative.

The Equalization Factor will be levied for the benefit of the Company which may pay a certain part thereof to the

General Partner in the framework of the Management Fee as further detailed in the section headed «Fees and Expenses».

137542

For the avoidance of doubt, it is expressly provided that each New Investor's relevant Commitment will be reduced

accordingly.

For the avoidance of doubt, it is stated that if an Investor paid its relevant Equalization Factor to the Company to the

fullest extend possible, it may acquire any additional Ordinary Share(s) (in the framework of its Commitment) at a price
based on the applicable Net Asset Value per Ordinary Share only i.e. without having to pay an additional subsequent
Equalization Factor.

For the avoidance of doubt, it is expressly provided that the Initial Investors do not have to pay any Equalization Factor.
If during the Lock Up Period the General Partner estimates in its sole discretion that the Initial Price or the corre-

sponding Net Asset Value per Ordinary Share, as the case may be, does not reflect the value of the underlying investments
of the Company, subscriptions will be honoured by issuing Ordinary Share at a specifically calculated Net Asset Value.»

4. Amendment of article 3.6.3 headed «Issue of Ordinary Shares after the Lock Up Period», so that it is worded as

follows:

«After the Lock Up Period, Ordinary Shares are issued to Investors on each Draw Down Date at the latest available

Net Asset Value per Ordinary Share.

In order to balance the interests of the existing and the new Shareholders and to respect the equal treatment of

Investors, new Investors will be charged a one-time Equalization Fee on the day on which their respective Subscription
Agreement is accepted by the General Partner. The Equalization Fee will be levied at a rate as deemed appropriate by
the General Partner in its sole discretion, will be applied on the Commitment of the Investor concerned and will be
payable together with the first Drawdown regarding the Investor concerned.

The Equalization Fee will be levied for the benefit of the Company which may pay a certain part thereof to the General

Partner in the framework of the Management Fee as further detailed in the section headed «Fees and Expenses».

For the avoidance of doubt, it is expressly provided that each Investor's Unfunded Commitment will be reduced

accordingly.

For the avoidance of doubt, it is stated that if an Investor paid its relevant Equalization Fee to the Company to the

fullest extend possible, it may acquire any additional Ordinary Share(s) (in the framework of its Commitment) at a price
based on the applicable Net Asset Value per Ordinary Share only i.e. without having to pay an additional subsequent
Equalization Fee.»

5. Amendment of article 3.7.1 headed «General», so that it is worded as follows:
«Commitments from Investors will be payable, either in whole or in part, to the Company after the Investor concerned

received the relevant Drawdown Notice from the General Partner and the Company will commit itself to issue, at the
applicable issue price plus the taking into account of the Equalization Factor or the Equalization Fee (if any), the corre-
spondent amount of fully paid-in Ordinary Shares to the Investor to the extent that the Investor's Commitment has been
called up and paid in. The General Partner is also entitled to make Drawdowns for Organisational Expenses and Operating
Expenses.

Drawdowns will be made on giving at least eight (8) Bank Business Days' notice by the sending of a Drawdown Notice

to Investors. Payment by Investors should be made in accordance with the instructions set out in the Drawdown Notice.

During the whole lifetime of the Company, the General Partner will, until the end of the relevant Commitment Period

of each Investor, at moments determined in its discretion, draw down Commitments from Investors as a general rule on
a first committed, first drawn down basis, in such instalments as the General Partner considers in its sole discretion will
be needed by the Company.»

6. Amendment of the first paragraph of article 3.7.2 headed «Drawdown Scheme», so that it is worded as follows:
«The following drawdown scheme is with respect to the Drawdown Percentages applied to the Initial Investors in the

initial Commitment Round and to the New Investors in the subsequent Commitment Rounds. As a general rule, at each
Drawdown Date, every Investor (being either an Initial Investor or a New Investor) having an Unfunded Commitment
will be drawn down to a maximum amount of twenty per cent (20%) of its total Commitment (the «Drawdown Per-
centage») as determined by the General Partner in its sole discretion. Investors will be called on a «first committed, first
drawn down» basis up to the Drawdown Percentage, unless the General Partner in its reasonable discretion decides to
override such rule in order to balance the interests of the various Investors concerned by the different Commitment
Rounds.»

7. Amendment of article 3.10.2 headed «Redemption at the request of Limited Shareholders» sub (a) Description, so

that it is worded as follows:

«After the end of the Lock-Up Period, each Limited Shareholder may request the Company to repurchase some or

all of the Ordinary Shares it holds twice a year on 30 June and on 31 December (each a «Redemption Acceptance Day»)
at the Net Asset Value as of each Redemption Acceptance Day.

Redemption requests must be received by the Central Administration Agent at the latest three (3) Bank Business Days

before the relevant Redemption Acceptance Day.

As a general rule each Limited Shareholder may in its sole discretion redeem one or more Ordinary Share(s) it holds

at each Redemption Acceptance Day. However the maximum amount of Ordinary Shares that may be redeemed at each
Redemption Acceptance Day is limited to five per cent (5%) of the aggregate amount of the outstanding Ordinary Shares.

137543

If the redemption requests received by the Central Administration Agent at a particular Redemption Acceptance Day
exceed five per cent (5%) of the outstanding Ordinary Shares, they may be scaled down on a pro rata basis to ensure
that they do not exceed five per cent (5%) of the outstanding Ordinary Shares at the Redemption Acceptance Day
concerned.

The following may however apply:
1. Each Limited Shareholder has the right to redeem at least five per cent (5%) of its outstanding Ordinary Shares.
2. For Limited Shareholders that wish to redeem more Ordinary Shares than described under 1 above, the following

allocation process shall be used:

Redemption requests in excess of 1. above shall be defined as «Unsatisfied Redemption of Ordinary Shares».
Having due regard to the equal treatment of the Limited Shareholders and subject always to the fact that the maximum

amount of Ordinary Shares that may be redeemed at each Redemption Acceptance Day is five per cent (5%) of the
outstanding Ordinary Shares, the percentage of the Unsatisfied Redemption of Ordinary Shares of each Limited Share-
holder that will be additionally redeemed by the General Partner will be proportionate to the requested Unsatisfied
Redemption of Ordinary Shares of all the Limited Shareholders.

The General Partner may decide in its sole discretion whether it redeems all or part of the Unsatisfied Redemption

of Ordinary Shares at each Redemption Acceptance Day, while maintaining equal treatment of the Shareholders.

The amount of Ordinary Shares, that a Limited Shareholder has requested to redeem, but that has not been accepted,

will not be considered as a redemption request for any following Redemption Acceptance Day.

A confirmation of acceptance statement will be sent to the Limited Shareholder detailing the number of Ordinary

Shares which will be redeemed.».

8. Insertion of a new subparagraph (b) in article 3.10.2 headed «Redemption Price», and subsequently renumbering

article 3.10.2, so that it is worded as follows:

The Redemption Price of each Ordinary Share which has been tendered for redemption at a particular Redemption

Acceptance Day will be the Net Asset value per Ordinary Share at such Redemption Acceptance Day. Such Net Asset
Value will be available at the next following NAV Disclosure Day and the Redemption proceeds will be paid to the
redeeming Limited Shareholder(s) within fifteen (15) Bank Business days as of the NAV Disclosure Day concerned.

If, however, an extraordinary Valuation Day is organized by the General Partner in its sole discretion between the

relevant  Redemption  Acceptance  Day  and  the  NAV  Disclosure  Day,  the  Redemption  Price  of  each  Ordinary  Share
concerned will be the Net Asset Value per Ordinary Share as of such extraordinary Valuation Day.

No Redemption fee will be levied.
For the avoidance of doubt, redemption requests will not preclude the Company from making any distributions pur-

suant to its distribution policy and funds received and/or allocated for distribution will not necessarily be used to fund
redemptions requests.

In case that a Limited Shareholder with an outstanding redemption request applies for a withdrawal of such request,

the General Partner reserves the right, in its sole and absolute discretion, to decide on the refusal or the acceptance of
such request.

Upon redemption, the corresponding Ordinary Shares will be cancelled immediately in the register of Shareholders.

Any taxes, commissions and other fees incurred in the respective countries in which the Ordinary Shares are sold will
be charged to the redeeming Limited Shareholders.».

9. Paragraph four of the new subparagraph (c) of article 3.10.2 headed «Procedure» will be amended, so that it is

worded as follows:

«Redemption applications received by the Central Administration Agent, in respect of any Redemption Acceptance

Day, before the redemption deadline, which is three (3) Bank Business Days prior to such Redemption Acceptance Day,
at 5.00 p.m. (Luxembourg time) (the «Redemption Deadline»), will be taken into consideration for acceptance on such
Redemption Acceptance Day, except where the General Partner decides, in accordance with the above, to scale down
the redemption requests.».

10. Insertion of the following sentence at the end of the first paragraph of article 3.12.1 headed «Calculation of the

Net Asset Value of the Company», so that it is worded as follows:

«No Valuation Day occurs within six (6) months of the First Closing.».
11. Amendment of the third paragraph of article 4.6 headed «Conflict of Interests», so that it is worded as follows:
«If any Advisory Committee Representative has a conflict of interest, it must declare such conflict to the chairman

before the relevant vote but is not required to refrain from voting on the relevant recommendation.».

12. Amendment of article 5.2 headed «Annual General Meeting», so that it is worded as follows:
«The annual general meeting of Shareholders is held at the registered office of the Company on the second Tuesday

of November at 11.30 a.m. (Luxembourg time), unless such date falls on a legal bank holiday, in which case it will be held
on the next following Bank Business Day. The initial annual general meeting of Shareholders will be held in 2008.».

13. Amendment of the third paragraph of article 8.3.1 headed «Annual Management Fee», so that it is worded as

follows:

137544

«The Management Fee will be payable quarterly in advance on the last day of the previous quarter, provided that the

initial payment of the Management Fee will be paid on the first Drawdown and will be based on the number of days
remaining in that quarter.»

2. Determination of the effective date of the above items of the agenda.
II. The shareholders present or represented and the number of shares they hold are shown on the attendance list,

signed by the members of the bureau and the undersigned notary. This list, together with the proxies initialled ne varietur
by the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to this deed in order to be filed with the
registration authorities.

III. It appears from the attendance list that out of fifty (50) shares, representing the entire share capital, all the shares

are present or represented at the present extraordinary general meeting an that the shareholders may, hence, waive the
convening formalities.

IV. The present extraordinary general meeting is thus regularly constituted and can validly decide on the items of its

agenda.

The extraordinary general meeting deliberated and adopted the following resolutions unanimously:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the following definitions in the definition section, so that it is

worded as follows:

««Closings» means the First and the Subsequent Closings at which the Commitment(s) of the Initial and New Investors

are accepted by the General Partner in accordance with the Prospectus and the Articles of Incorporation

«Equalization Factor» means the Equalization Factor with respect to the Lock Up Period, as described in more detail

in section 5.4.2 of the Prospectus

«Equalization Fee» means The Equalization Fee with respect to the period of time starting after the end of the Lock

Up Period, as described in more detail in section 5.4.3 of the Prospectus

«First Closing» means the first date determined by the General Partner on which Subscription Agreements in relation

to the first issuance of Ordinary Shares have been received and accepted by the General Partner and marks the difference
between Initial Investors and New Investors, i.e. 15 November 2007

«Lock-Up Period» means the period which starts at the First Closing and ends on the fifth anniversary of the First

Closing, i.e. 14 November 2012, during which the Company will not repurchase Ordinary Shares at the request of Limited
Shareholders

«NAV Disclosure Day» means ninety (90) calendar days after each Valuation Day when the NAV per Ordinary Share

as of the Valuation Day concerned if disclosed by the General Partner in accordance with the Prospectus and the Articles
of Incorporation. If such a calendar day is not a Bank Business Day, the NAV Disclosure Day will be the next following
Bank Business Day

«Subsequent Closing» means a closing after the First Closing which may be held on any Bank Business Day determined

in the sole discretion of the General Partner.

In addition, the definition of «redemption period» shall be deleted.»

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the first and second paragraph of article 3.5 headed «Closings»,

so that it is worded as follows:

«The Company will accept subscriptions from Investors at the First Closing and at any Subsequent Closing.
The First Closing will take place on 15 November 2007. There can be one or more Subsequent Closing(s). No Sub-

sequent Closings will be held if the Company is to be dissolved and liquidated in accordance with section 10 of the
Prospectus and the Articles of Incorporation.».

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 3.6.2 headed «Issue of Ordinary Shares during the Lock

Up Period», so that it is worded as follows:

«(a) From the day of the First Closing until the first NAV Disclosure Day (i.e. 6 months and ninety (90) calendar days

after the First Closing), Ordinary Shares are issued on each Draw Down Date at the Initial Price of one thousand (1,000.-)
USD each.

(b) After the first NAV Disclosure Day, Ordinary Shares are issued to Investors on each Draw Down Date at the

latest available Net Asset Value per Ordinary Share.

In order to balance the interests of the existing and the new Shareholders, New Investors will be charged a one-time

Equalization Factor (the «Equalization Factor») on the day on which their respective Subscription Agreement is accepted
by the General Partner. The Equalization Factor will be levied at a rate of three point nine per cent (3.9%) per annum
applied on the Commitment of the concerned Investor. The relevant period will start on the First Closing and end on
the day of the relevant Subsequent Closing at which the New Investor's Commitment is accepted, with a maximum
duration of up to twenty-four (24) months. The Equalization Factor is payable together with the first Drawdown regarding

137545

the New Investor. The Equalization Factor represents the past Management Fee, the opportunity costs of capital of the
existing Investors plus a participation in the formation expenses of the Company, the acquisition costs relating to the
investments already carried out by the Company as well as any deferred tax liabilities of the Company or of its subsidiaries,
the foregoing enumeration not being limitative.

The Equalization Factor will be levied for the benefit of the Company which may pay a certain part thereof to the

General Partner in the framework of the Management Fee as further detailed in the section headed «Fees and Expenses».

For the avoidance of doubt, it is expressly provided that each New Investor's relevant Commitment will be reduced

accordingly.

For the avoidance of doubt, it is stated that if an Investor paid its relevant Equalization Factor to the Company to the

fullest extend possible, it may acquire any additional Ordinary Share(s) (in the framework of its Commitment) at a price
based on the applicable Net Asset Value per Ordinary Share only i.e. without having to pay an additional subsequent
Equalization Factor.

For the avoidance of doubt, it is expressly provided that the Initial Investors do not have to pay any Equalization Factor.
If during the Lock Up Period the General Partner estimates in its sole discretion that the Initial Price or the corre-

sponding Net Asset Value per Ordinary Share, as the case may be, does not reflect the value of the underlying investments
of the Company, subscriptions will be honoured by issuing Ordinary Share at a specifically calculated Net Asset Value.».

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 3.6.3 headed «Issue of Ordinary Shares after the Lock

Up Period», so that it is worded as follows:

«After the Lock Up Period, Ordinary Shares are issued to Investors on each Draw Down Date at the latest available

Net Asset Value per Ordinary Share.

In order to balance the interests of the existing and the new Shareholders and to respect the equal treatment of

Investors, new Investors will be charged a one-time Equalization Fee on the day on which their respective Subscription
Agreement is accepted by the General Partner. The Equalization Fee will be levied at a rate as deemed appropriate by
the General Partner in its sole discretion, will be applied on the Commitment of the Investor concerned and will be
payable together with the first Drawdown regarding the Investor concerned.

The Equalization Fee will be levied for the benefit of the Company which may pay a certain part thereof to the General

Partner in the framework of the Management Fee as further detailed in the section headed «Fees and Expenses».

For the avoidance of doubt, it is expressly provided that each Investor's Unfunded Commitment will be reduced

accordingly.

For the avoidance of doubt, it is stated that if an Investor paid its relevant Equalization Fee to the Company to the

fullest extend possible, it may acquire any additional Ordinary Share(s) (in the framework of its Commitment) at a price
based on the applicable Net Asset Value per Ordinary Share only i.e. without having to pay an additional subsequent
Equalization Fee.».

<i>Fifth resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 3.7.1 headed «General», so that it is worded as follows:
«Commitments from Investors will be payable, either in whole or in part, to the Company after the Investor concerned

received the relevant Drawdown Notice from the General Partner and the Company will commit itself to issue, at the
applicable issue price plus the taking into account of the Equalization Factor or the Equalization Fee (if any), the corre-
spondent amount of fully paid-in Ordinary Shares to the Investor to the extent that the Investor's Commitment has been
called up and paid in. The General Partner is also entitled to make Drawdowns for Organisational Expenses and Operating
Expenses.

Drawdowns will be made on giving at least eight (8) Bank Business Days' notice by the sending of a Drawdown Notice

to Investors. Payment by Investors should be made in accordance with the instructions set out in the Drawdown Notice.

During the whole lifetime of the Company, the General Partner will, until the end of the relevant Commitment Period

of each Investor, at moments determined in its discretion, draw down Commitments from Investors as a general rule on
a first committed, first drawn down basis, in such instalments as the General Partner considers in its sole discretion will
be needed by the Company.».

<i>Sixth resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the first paragraph of article 3.7.2 headed «Drawdown Scheme»,

so that it is worded as follows:

«The following drawdown scheme is with respect to the Drawdown Percentages applied to the Initial Investors in the

initial Commitment Round and to the New Investors in the subsequent Commitment Rounds. As a general rule, at each
Drawdown Date, every Investor (being either an Initial Investor or a New Investor) having an Unfunded Commitment
will be drawn down to a maximum amount of twenty per cent (20%) of its total Commitment (the «Drawdown Per-
centage») as determined by the General Partner in its sole discretion. Investors will be called on a «first committed, first
drawn down» basis up to the Drawdown Percentage, unless the General Partner in its reasonable discretion decides to

137546

override such rule in order to balance the interests of the various Investors concerned by the different Commitment
Rounds.».

<i>Seventh resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 3.10.2 headed «Redemption at the request of Limited

Shareholders» sub (a) Description, so that it is worded as follows:

«After the end of the Lock-Up Period, each Limited Shareholder may request the Company to repurchase some or

all of the Ordinary Shares it holds twice a year on 30 June and on 31 December (each a «Redemption Acceptance Day»)
at the Net Asset Value as of each Redemption Acceptance Day.

Redemption requests must be received by the Central Administration Agent at the latest three (3) Bank Business Days

before the relevant Redemption Acceptance Day.

As a general rule each Limited Shareholder may in its sole discretion redeem one or more Ordinary Share(s) it holds

at each Redemption Acceptance Day. However the maximum amount of Ordinary Shares that may be redeemed at each
Redemption Acceptance Day is limited to five per cent (5%) of the aggregate amount of the outstanding Ordinary Shares.
If the redemption requests received by the Central Administration Agent at a particular Redemption Acceptance Day
exceed five per cent (5%) of the outstanding Ordinary Shares, they may be scaled down on a pro rata basis to ensure
that they do not exceed five per cent (5%) of the outstanding Ordinary Shares at the Redemption Acceptance Day
concerned.

The following may however apply:
1. Each Limited Shareholder has the right to redeem at least five per cent (5%) of its outstanding Ordinary Shares.
2. For Limited Shareholders that wish to redeem more Ordinary Shares than described under 1 above, the following

allocation process shall be used:

Redemption requests in excess of 1. above shall be defined as «Unsatisfied Redemption of Ordinary Shares».
Having due regard to the equal treatment of the Limited Shareholders and subject always to the fact that the maximum

amount of Ordinary Shares that may be redeemed at each Redemption Acceptance Day is five per cent (5%) of the
outstanding Ordinary Shares, the percentage of the Unsatisfied Redemption of Ordinary Shares of each Limited Share-
holder that will be additionally redeemed by the General Partner will be proportionate to the requested Unsatisfied
Redemption of Ordinary Shares of all the Limited Shareholders.

The General Partner may decide in its sole discretion whether it redeems all or part of the Unsatisfied Redemption

of Ordinary Shares at each Redemption Acceptance Day, while maintaining equal treatment of the Shareholders.

The amount of Ordinary Shares, that a Limited Shareholder has requested to redeem, but that has not been accepted,

will not be considered as a redemption request for any following Redemption Acceptance Day.

A confirmation of acceptance statement will be sent to the Limited Shareholder detailing the number of Ordinary

Shares which will be redeemed.».

<i>Eighth resolution

The extraordinary general meeting resolves to insert a new subparagraph (b) in article 3.10.2 headed «Redemption

Price», and subsequently renumbering article 3.10.2, so that it is worded as follows:

The Redemption Price of each Ordinary Share which has been tendered for redemption at a particular Redemption

Acceptance Day will be the Net Asset value per Ordinary Share at such Redemption Acceptance Day. Such Net Asset
Value will be available at the next following NAV Disclosure Day and the Redemption proceeds will be paid to the
redeeming Limited Shareholder(s) within fifteen (15) Bank Business days as of the NAV Disclosure Day concerned.

If, however, an extraordinary Valuation Day is organized by the General Partner in its sole discretion between the

relevant  Redemption  Acceptance  Day  and  the  NAV  Disclosure  Day,  the  Redemption  Price  of  each  Ordinary  Share
concerned will be the Net Asset Value per Ordinary Share as of such extraordinary Valuation Day.

No Redemption fee will be levied.
For the avoidance of doubt, redemption requests will not preclude the Company from making any distributions pur-

suant to its distribution policy and funds received and/or allocated for distribution will not necessarily be used to fund
redemptions requests.

In case that a Limited Shareholder with an outstanding redemption request applies for a withdrawal of such request,

the General Partner reserves the right, in its sole and absolute discretion, to decide on the refusal or the acceptance of
such request.

Upon redemption, the corresponding Ordinary Shares will be cancelled immediately in the register of Shareholders.

Any taxes, commissions and other fees incurred in the respective countries in which the Ordinary Shares are sold will
be charged to the redeeming Limited Shareholders.».

<i>Ninth resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend paragraph four of the new subparagraph (c) of article 3.10.2

headed «Procedure», so that it is worded as follows:

137547

«Redemption applications received by the Central Administration Agent, in respect of any Redemption Acceptance

Day, before the redemption deadline, which is three (3) Bank Business Days prior to such Redemption Acceptance Day,
at 5.00 p.m. (Luxembourg time) (the «Redemption Deadline»), will be taken into consideration for acceptance on such
Redemption Acceptance Day, except where the General Partner decides, in accordance with the above, to scale down
the redemption requests.».

<i>Tenth resolution

The extraordinary general meeting resolves to insert the following sentence at the end of the first paragraph of article

3.12.1 headed «Calculation of the Net Asset Value of the Company», so that it is worded as follows:

«No Valuation Day occurs within six (6) months of the First Closing.».

<i>Eleventh resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the third paragraph of article 4.6 headed «Conflict of Interests»,

so that it is worded as follows:

«If any Advisory Committee Representative has a conflict of interest, it must declare such conflict to the chairman

before the relevant vote but is not required to refrain from voting on the relevant recommendation.».

<i>Twelfth resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend article 5.2 headed «Annual General Meeting», so that it is worded

as follows:

«The annual general meeting of Shareholders is held at the registered office of the Company on the second Tuesday

of November at 11.30 a.m. (Luxembourg time), unless such date falls on a legal bank holiday, in which case it will be held
on the next following Bank Business Day. The initial annual general meeting of Shareholders will be held in 2008.».

<i>Thirteenth resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the third paragraph of article 8.3.1 headed «Annual Management

Fee», so that it is worded as follows:

«The Management Fee will be payable quarterly in advance on the last day of the previous quarter, provided that the

initial payment of the Management Fee will be paid on the first Drawdown and will be based on the number of days
remaining in that quarter.»

<i>Fourteenth resolution

The extraordinary general meeting resolves that the above resolutions shall be effective as from the date of the present

deed, being 13 November 2007.

<i>Cost

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed is valued at approximately two thousand euro (€ 2,200.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, given names, civil

status and residences, the members of the bureau of the extraordinary general meeting signed together with the notary
the present deed.

Follows the German translation of the preceding text:

Im Jahre zweitausendsieben, am dreizehnten November.
Vor Maître Gérard Lecuit, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Wurde eine außerordentliche Hauptversammlung der Anteilinhaber der responsAbility BOP INVESTMENTS S.C.A.

SICAR, eine luxemburgische Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital (société d'investissement en capital à ris-
que) in der Form einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions), mit Sitz 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter
B 132.074, gegründet gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 17. September 2007, veröffentlicht im Mémorial
C, Nr. 2305, am 15. Oktober 2007 («Gesellschaft»).

Die außerordentliche Hauptversammlung wurde um 11.45 Uhr eröffnet; als Vorsitzende fungierte Herr Benoit Tas-

signy, Jurist, beruflich wohnhaft in Luxemburg, welcher Herr Mustafa Nezar, Jurist beruflich wohnhaft in Luxemburg, zum
Versammlungssekretär (secretary) ernannte.

Die außerordentliche Hauptversammlung wählte Frau Elke Leenders, Juristin (juriste), wohnhaft in Luxemburg, als

Stimmenzähler (scrutineer) aus.

Nachdem in dieser Weise der Vorsitz (bureau) der außerordentlichen Hauptversammlung konstituiert wurde, erklärte

die Vorsitzende und bat den Notar um Protokollierung, dass

137548

II. die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung lautet wie folgt:
3. Änderung der folgenden Definitionen im Abschnitt «Definitionen», der folgendermaßen neu gefasst wird:
««Closings»: Das erste Closing und die späteren Closings, an denen die Kapitalzusage(n) der ersten Anleger und der

neuen Anleger vom Komplementär gemäß dem Prospekt und der Satzung angenommen werden.

«Ausgleichsbetrag»: Der Ausgleichsbetrag bezüglich der Sperrfrist, wie in Ziffer 5.4.2 des Prospekts näher beschrieben.
«Ausgleichsgebühr»: Die Ausgleichsgebühr bezüglich des Zeitraums beginnend nach dem Ende der Sperrfrist, wie in

Ziffer 5.4.3 des Prospekts näher beschrieben.

«Erstes Closing»: Der erste Termin, der von dem Komplementär festgelegt wird, an dem Zeichnungsvereinbarungen

für die erste Emission von Stammaktien beim Komplementär eingegangen und von diesem angenommen worden sind,
und anhand dessen zwischen ersten Anlegern and neuen Anlegern unterschieden wird, d.h. der 15. November 2007.

«Sperrfrist»: Der mit dem ersten Closing beginnende und am fünften Jahrestag des ersten Closing, d.h. am 14. No-

vember 2012 endende Zeitraum, während dessen die Gesellschaft keine Stammaktien auf Antrag der Kommanditaktionäre
zurückkaufen wird.

«Tag der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts»: Neunzig (90) Kalendertage nach jedem Bewertungstag, wenn der

Nettoinventarwert pro Stammaktie zum jeweiligen Bewertungstag vom Komplementär gemäß dem Prospekt und der
Satzung veröffentlicht wird. Falls dieser Kalendertag kein Bankgeschäftstag ist, ist der Tag der Veröffentlichung des Net-
toinventarwerts der nächste darauffolgende Bankgeschäftstag.

«Späteres Closing»: Ein Closing nach dem ersten Closing, das an einem beliebigen, nach Ermessen des Komplementärs

festgelegten Bankgeschäftstag stattfinden kann.

Darüber hinaus wird die Definition des Begriffs «Rücknahmefrist» gelöscht».»
2. Änderung des ersten und zweiten Absatzes von Artikel 3.5 mit der Überschrift «Closings», der folgendermaßen neu

gefasst wird:

«Die Gesellschaft nimmt Zeichnungen von Anlegern am ersten Closing und an jedem späteren Closing an.
Das erste Closing findet am 15. November 2007 statt. Es kann ein späteres Closing oder mehrere geben. Es finden

keine späteren Closings statt, wenn die Gesellschaft gemäß Ziffer 10 des Prospekts und der Satzung aufgelöst und liquidiert
werden muss.»

3. Änderung von Artikel 3.6.2 mit der Überschrift «Ausgabe von Stammaktien während der Sperrfrist», der folgen-

dermaßen neu gefasst wird:

«(a) Ab dem Tag des ersten Closing bis zum Tag der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts (d.h. 6 Monate und

neunzig  (90)  Kalendertage  nach  dem  ersten  Closing)  werden  zu  jedem  Tag  der  Inanspruchnahme  Stammaktien  zum
Erstausgabepreis von jeweils eintausend (1.000,-) USD ausgegeben.

(b) Nach dem ersten Tag der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts werden Stammaktien an Anleger zu jedem Tag

der Inanspruchnahme zum jeweils letzten verfügbaren Nettoinventarwert pro Stammaktie ausgegeben.

Zum Zwecke eines Interessenausgleichs zwischen den vorhandenen und den neuen Anteilinhabern wird neuen Anle-

gern ein einmaliger Ausgleichsbetrag («Ausgleichsbetrag») zu dem Tag in Rechnung gestellt, zu dem ihre Zeichnungsver-
einbarung von dem Komplementär angenommen wird. Der Ausgleichsbetrag wird mit drei Komma neun Prozent (3,9%)
p.a. der Kapitalzusage des betreffenden Anlegers festgesetzt. Der maßgebliche Zeitraum beginnt mit dem ersten Closing
und endet an dem Tag des jeweiligen späteren Closing, zu dem die Kapitalzusage des neuen Anlegers angenommen wird,
und dauert höchstens vierundzwanzig (24) Monate. Der Ausgleichsbetrag ist zusammen mit der ersten Inanspruchnahme
der Kapitalzusage des neuen Anlegers zu zahlen. Der Ausgleichsbetrag stellt einen Ausgleich für in der Vergangenheit
erhobene Verwaltungsgebühr, Opportunitätskosten von Kapital der vorhandenen Anteilinhaber sowie einen Anteil an
den Gründungskosten der Gesellschaft, den Erwerbskosten für von der Gesellschaft bereits getätigte Investitionen, sowie
latenten Steuerverbindlichkeiten der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften dar, wobei die vorstehende Aufzäh-
lung nicht als abschließend zu verstehen ist.

Der  Ausgleichsbetrag  wird  zugunsten  der  Gesellschaft  erhoben,  die  einen  gewissen  Anteil  davon  im  Rahmen  der

Verwaltungsgebühr an den Komplementär entrichten kann, wie in der Ziffer mit der Überschrift «Gebühren und Kosten»
näher erläutert.

Klarstellend wird festgehalten, dass ausdrücklich vorgesehen ist, dass die entsprechende Kapitalzusage eines jeden

neuen Anlegers entsprechend zu verringern ist.

Klarstellend wird festgehalten, dass festgelegt ist, dass, wenn ein Anleger seinen Ausgleichsbetrag in vollem Umfang an

die Gesellschaft entrichtet hat, er (im Rahmen seiner Kapitalzusage) weitere Stammaktien zu einem Preis erwerben kann,
der nur auf dem einschlägigen Nettoinventarwert pro Stammaktie beruht, d.h., ohne dass er ein weiteres Mal den Aus-
gleichsbetrag zu entrichten hätte.

Klarstellend wird festgehalten, dass ausdrücklich vorgesehen ist, dass die ersten Anleger keinen Ausgleichsbetrag zu

zahlen haben.

Wenn während der Sperrfrist der Komplementär zu der Einschätzung kommt, dass der Erstausgabepreis oder gege-

benenfalls der entsprechende Nettoinventarwert pro Anteil den Wert der zugrundeliegenden Anlagen der Gesellschaft

137549

nicht angemessen wiedergibt, werden Zeichnungen durch Ausgabe von Stammaktien zu einem speziell berechneten Net-
toinventarwert eingelöst.»

4. Änderung von Artikel 3.6.3 mit der Überschrift «Ausgabe von Stammaktien nach der Sperrfrist», der folgendermaßen

neu gefasst wird:

«Nach der Sperrfrist werden Stammaktien an Anleger zu jedem Tag der Inanspruchnahme zum jeweils letzten ver-

fügbaren Nettoinventarwert pro Stammaktie ausgegeben.

Zum  Zwecke  eines  Interessenausgleichs  zwischen  den  vorhandenen  und  den  neuen  Anteilinhabern  und  um  dem

Grundsatz der Gleichbehandlung von Anlegern Rechnung zu tragen, wird neuen Anlegern eine einmalige Ausgleichsgebühr
zu dem Tag in Rechnung gestellt, zu dem ihre Zeichnungsvereinbarung von dem Komplementär angenommen wird. Die
Festlegung der Ausgleichsgebühr in geeigneter Höhe liegt im Ermessen des Komplementärs und erfolgt als Prozentsatz
der Kapitalzusage des betreffenden Anlegers; sie ist zusammen mit der ersten Inanspruchnahme der Kapitalzusage des
betreffenden Anlegers zu zahlen.

Die  Ausgleichsgebühr  wird  zugunsten  der  Gesellschaft  erhoben,  die  einen  gewissen  Anteil  davon  im  Rahmen  der

Verwaltungsgebühr an den Komplementär zahlen kann, wie in der Ziffer mit der Überschrift «Gebühren und Kosten»
näher erläutert.

Klarstellend wird festgehalten, dass ausdrücklich vorgesehen ist, dass die unerfüllte Kapitalzusage eines jeden Anlegers

entsprechend zu verringern ist.

Klarstellend wird festgehalten, dass festgelegt ist, dass, wenn ein Anleger seine Ausgleichsgebühr in vollem Umfang an

die Gesellschaft entrichtet hat, er (im Rahmen seiner Kapitalzusage) weitere Stammaktien zu einem Preis erwerben kann,
der nur auf dem einschlägigen Nettoinventarwert pro Stammaktie beruht, d.h., ohne dass er ein weiteres Mal die Aus-
gleichsgebühr zu entrichten hätte.»

5. Änderung von Artikel 3.7.1 mit der Überschrift «Allgemeines», der folgendermaßen neu gefasst wird:
«Kapitalzusagen von Anlegern sind entweder ganz oder teilweise an die Gesellschaft zu zahlen, nachdem der betref-

fende Anleger die einschlägige Mitteilung über die Inanspruchnahme vom Komplementär erhalten hat; die Gesellschaft
verpflichtet sich, die entsprechende Menge voll eingezahlter Stammaktien zum jeweils geltenden Ausgabepreis - unter
Berücksichtigung von (gegebenenfalls) anfallenden Ausgleichsbeträgen oder Ausgleichsgebühren an den Anleger auszu-
geben, soweit seine Kapitalzusage eingefordert worden und eingezahlt ist. Der Komplementär ist auch befugt, Kapital-
zusagen wegen Gründungskosten und Betriebskosten in Anspruch zu nehmen.

Inanspruchnahmen  der  Kapitalzusagen  erfolgen  mit  einer  Frist  von  mindestens  acht  (8)  Bankgeschäftstagen  durch

Übermittlung einer Mitteilung über die Inanspruchnahme an Anleger. Zahlung durch Anleger sollte gemäß den in der
Mitteilung über die Inanspruchnahme enthaltenen Anweisungen erfolgen.

Während des gesamten Bestehens der Gesellschaft wird der Komplementär bis zum Ende des jeweiligen Zeitraums

zur Erfüllung der Kapitalzusage eines Anlegers zu Zeitpunkten, die er nach eigenem Ermessen bestimmt, Kapitalzusagen
von Anlegern grundsätzlich in der Reihenfolge in Anspruch nehmen, in der die Anleger die Verpflichtungen eingegangen
sind und in Teilbeträgen, die der Komplementär nach eigenem Ermessen als für die Gesellschaft erforderlich erachtet.»

6. Änderung des ersten Absatzes von Artikel 3.7.2 mit der Überschrift «Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme der

Kapitalzusagen», der folgendermaßen neu gefasst wird:

«Die folgende Darstellung der Inanspruchnahme von Kapitalzusagen bezieht sich auf den Prozentsatz der Inanspruch-

nahme der ersten Anleger im Rahmen der ersten Kapitalzusagerunde und der neuen Anleger in den späteren Kapitalzu-
sagerunden. Grundsätzlich gilt, dass an jedem Tag der Inanspruchnahme jeder Anleger (entweder ein erster Anleger oder
ein neuer Anleger) mit einer unerfüllten Kapitalzusage in Höhe eines Betrags in Anspruch genommen wird, den der
Komplementär nach eigenem Ermessen festlegt, der aber maximal zwanzig Prozent (20%) der gesamten Kapitalzusage
(«Prozentsatz der Inanspruchnahme») des Anlegers entspricht. Anleger werden in der Reihenfolge, in der sie die Ver-
pflichtungen übernommen haben, bis in Höhe des Prozentsatzes der Inanspruchnahme in Anspruch genommen, wenn der
Komplementär diese Reihenfolge nicht aufgrund einer angemessenen Ermessensentscheidung ändert, um den Interessen
der verschiedenen, im Rahmen der diversen Kapitalanlagerunden einbezogenen Anleger Rechnung zu tragen.»

7. Änderung Artikel 3.10.2 mit der Überschrift «Rücknahme auf Verlangen von Kommanditaktionären», der folgen-

dermaßen neu gefasst wird:

«Nach Ende der Sperrfrist kann jeder Kommanditaktionär die Gesellschaft zwei Mal jährlich, am 30. Juni und am 31.

Dezember (jeweils «Rücknahmestichtag»), auffordern, alle von ihm gehaltenen Stammaktien zum Nettoinventarwert zum
jeweiligen Rücknahmestichtag zurückzukaufen.

Rücknahmeanträge müssen bei der zentralen Verwaltungsstelle spätestens drei (3) Bankgeschäftstage vor dem maß-

geblichen Rücknahmestichtag eingehen.

Grundsätzlich liegt es im Ermessen eines jeden Kommanditaktionärs, zu jedem Rücknahmestichtag eine oder mehrere

der von ihm gehaltenen Stammaktien zurücknehmen. Maximal dürfen allerdings an einem Rücknahmestichtag fünf Prozent
(5%) der in Umlauf befindlichen Stammaktien zurückgenommen werden. Wenn zu einem Rücknahmestichtag bei der
zentralen Verwaltungsstelle Anträge auf Rücknahme von mehr als fünf Prozent (5%) der in Umlauf befindlichen Stamm-
aktien eingegangen sind, können sie anteilig herabgesetzt werden, um sicherzustellen, dass sie sich insgesamt auf nicht
mehr als fünf Prozent (5%) der zum betreffenden Rücknahmestichtag in Umlauf befindlichen Stammaktien beziehen.

137550

Allerdings gilt folgendes:
1. Jeder Kommanditaktionär hat Anspruch auf Rücknahme von mindestens fünf Prozent (5%) seiner in Umlauf befind-

lichen Stammaktien.

2. Für Kommanditaktionäre, die mehr als die unter Punkt 1 oben angegebene Anzahl an Stammaktien zurücknehmen

möchten, gilt nachstehendes Verteilungsverfahren:

Bei Anträgen auf Rücknahme von mehr als der unter Punkt 1 angegebenen Anzahl an Stammaktien ist die Rede von

«Stammaktien, deren Rücknahme beantragt, aber noch nicht erfolgt ist.».

Unter angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Kommanditaktionäre und angesichts

des Umstands, dass an einem Rücknahmestichtag höchstens fünf Prozent (5%) der in Umlauf befindlichen Stammaktien
zurückgenommen werden können, erfolgt die Rücknahme durch den Komplementär von Stammaktien, deren Rücknahme
beantragt,  aber  noch  nicht  erfolgt  ist,  darüber  hinaus  für  einen  einzelnen  Kommanditaktionär  im  Verhältnis  zu  allen
Stammaktien, deren Rücknahme beantragt, aber noch nicht erfolgt ist.

Es liegt im Ermessen des Komplementärs, zu jedem Rücknahmestichtag unter Berücksichtigung des Grundsatzes glei-

cher Behandlung der Anteilinhaber zu entscheiden, ob er die Stammaktien, deren Rücknahme beantragt, aber noch nicht
erfolgt ist, ganz oder teilweise zurücknimmt.

Wenn ein Kommanditaktionär die Rücknahme für Stammaktien beantragt hat, diese aber nicht angenommen wurde,

gilt dies nicht als Rücknahmeantrag für einen späteren Rücknahmestichtag.

An den Kommanditaktionär wird eine Annahmebestätigung unter Angabe der Anzahl der zurückzunehmenden Stamm-

aktien versandt.»

8. Einfügung eines neuen Unterabschnitts (b) mit der Überschrift «Rücknahmepreis», in Artikel 3.10.2 und anschließend

neue Nummerierung von Artikel 3.10.2:

«Der Rücknahmepreis einer jeden Stammaktie, deren Rücknahme zu einem bestimmten Rücknahmestichtag beantragt

ist, ist der Nettoinventarwert pro Stammaktie zu diesem Rücknahmestichtag. Der Nettoinventarwert ist jeweils am nächst
folgenden Tag der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts verfügbar und der Rücknahmeerlös wird dem (oder den)
zurückgebenden Kommanditaktionär(en) innerhalb von fünfzehn (15) Bankgeschäftstagen ab dem jeweiligen Tag der Ver-
öffentlichung des Nettoinventarwerts ausgezahlt.

Wenn allerdings zwischen dem maßgeblichen Rücknahmestichtag und dem Tag der Veröffentlichung des Nettoinven-

tarwerts  ein  außergewöhnlicher  Bewertungstag  angesetzt  wird,  was  im  Ermessen  des  Komplementärs  liegt,  ist  der
Rücknahmepreis einer jeden Stammaktie der Nettoinventarwert pro Stammaktie zu diesem außerordentlichen Bewer-
tungstag.

Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben.
Klarstellend wird erwähnt, dass die Gesellschaft aufgrund von Rücknahmeanträgen nicht daran gehindert ist, Aus-

schüttungen im Rahmen ihrer Ausschüttungspolitik vorzunehmen; Gelder, die zu Ausschüttungszwecken eingenommen
wurden und/oder zu verwenden sind, werden nicht notwendigerweise zur Finanzierung von Rücknahmeanträgen ver-
wendet.

Für den Fall, dass ein Kommanditaktionär einen noch nicht ausgeführten Rücknahmeantrag widerrufen möchte, behält

sich der Komplementär das Recht vor, nach eigenem und uneingeschränktem Ermessen über Annahme oder Ablehnung
eines solchen Widerrufs zu entscheiden.

Bei Rücknahme werden die entsprechenden Stammaktien unverzüglich im Register der Anteilinhaber gelöscht. Steuern,

Provisionen und andere Gebühren, die in den Ländern angefallen sind, in denen die Stammaktien verkauft werden, werden
den zurücknehmenden Kommanditaktionären in Rechnung gestellt.»

9. Änderung des vierten Absatzes des neuen Unterabschnitts (c) von Artikel 3.10.2 mit der Überschrift «Verfahren»,

der folgendermaßen neu gefasst wird:

«Rücknahmeanträge bezüglich eines Rücknahmestichtags, die vor Ablauf der Rücknahmefrist, d.h., drei (3) Bankge-

schäftstage vor dem Rücknahmestichtag um 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) (die «Rücknahmefrist») eingehen, werden zu
diesem  Rücknahmestichtag  berücksichtigt,  außer  sofern  der  Komplementär  gemäß  den  vorstehenden  Bestimmungen
entscheidet, die Bearbeitung der Rücknahmeanträge proportional zu reduzieren.»

10. Einfügung des folgenden Satzes am Ende des ersten Absatzes von Artikel 3.12.1 mit der Überschrift «Berechnung

des Nettoinventarwerts der Gesellschaft» mit folgendem Wortlaut:

«Innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem ersten Closing findet kein Bewertungstag statt.»
11. Änderung des dritten Absatzes von Artikel 4.6 mit der Überschrift «Interessenkonflikte», der folgendermaßen neu

gefasst wird:

«Wenn bei einem Mitglied des beratenden Ausschusses ein Interessenkonflikt besteht, hat es den Konflikt dem Vor-

sitzenden vor der Abstimmung mitzuteilen, ist aber nicht verpflichtet, sich bei der Abstimmung über die jeweilige Anlage-/
Veräußerungsvorhaben zu enthalten.»

12. Änderung von Artikel 5.2 mit der Überschrift «Jahreshauptversammlung», der folgendermaßen neu gefasst wird:
«Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber wird am zweiten Dienstag im November um 11.30 Uhr (Luxemburger

Zeit) am Sitz der Gesellschaft abgehalten, außer wenn dieser Tag auf einen gesetzlichen Bankfeiertag fällt; in diesem Fall

137551

wird die Versammlung an dem nächstfolgenden Bankgeschäftstag abgehalten. Die erste Jahreshauptversammlung der An-
teilinhaber findet 2008 statt.»

13. Änderung des dritten Absatzes von Artikel 8.3.1 mit der Überschrift «Jährliche Verwaltungsgebühr», der folgen-

dermaßen neu gefasst wird:

«Die Verwaltungsgebühr ist vierteljährlich im voraus am letzten Tag des vorherigen Quartals zu zahlen, wobei die erste

Zahlung der Verwaltungsgebühr bei der ersten Inanspruchnahme der Kapitalzusage auf Grundlage der Zahl der in diesem
Quartal verbleibenden Kalendertage erfolgt.»

4. Festlegung des Tags des Inkrafttretens der vorstehend genannten Tagesordnungspunkte.
II. Die anwesenden oder ordnungsgemäß vertretenen Anteilinhaber und die Anzahl der von ihnen vertretenen Anteile

sind in der Anwesenheitsliste angegeben und von den Mitgliedern des Vorsitzes und dem unterzeichneten Notar abge-
zeichnet.  Diese  Liste  bleibt,  zusammen  mit  den  von  den  Erschienenen  und  dem  unterzeichneten  Notar  ne  varietur
paraphierten Vollmachten, dieser Urkunde beigefügt und wird gleichzeitig mit ihr bei den Registrierungsbehörden einge-
reicht.

III. Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass alle fünfzig (50) Anteile, die das gesamte Grundkapital verbriefen, bei

der derzeitigen außerordentliche Hauptversammlung anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, so dass die Anteil-
inhaber dementsprechend auf die formalen Anforderungen an die Einberufung verzichten können.

IV. Die derzeit stattfindende außerordentliche Hauptversammlung ist demnach ordnungsgemäß zusammengetreten

und kann wirksam über die Tagesordnung beschließen.

Die außerordentliche Hauptversammlung hat nach Beratung einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

5. Es ergeht ein Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung zur Änderung der folgenden Definitionen im

Abschnitt «Definitionen», der folgendermaßen neu gefasst wird:

««Closings»: Das erste Closing und die späteren Closings, an denen die Kapitalzusage(n) der ersten Anleger und der

neuen Anleger vom Komplementär gemäß dem Prospekt und der Satzung angenommen werden.

«Ausgleichsbetrag»: Der Ausgleichsbetrag bezüglich der Sperrfrist, wie in Ziffer 5.4.2 des Prospekts näher beschrieben.
«Ausgleichsgebühr»: Die Ausgleichsgebühr bezüglich des Zeitraums beginnend nach dem Ende der Sperrfrist, wie in

Ziffer 5.4.3 des Prospekts näher beschrieben.

«Erstes Closing»: Der erste Termin, der von dem Komplementär festgelegt wird, an dem Zeichnungsvereinbarungen

für die erste Emission von Stammaktien beim Komplementär eingegangen und von diesem angenommen worden sind,
und anhand dessen zwischen ersten Anlegern and neuen Anlegern unterschieden wird, d.h. der 15. November 2007.

«Sperrfrist»: Der mit dem ersten Closing beginnende und am fünften Jahrestag des ersten Closing, d.h. am 14. No-

vember 2012 endende Zeitraum, während dessen die Gesellschaft keine Stammaktien auf Antrag der Kommanditaktionäre
zurückkaufen wird.

«Tag der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts»: Neunzig (90) Kalendertage nach jedem Bewertungstag, wenn der

Nettoinventarwert pro Stammaktie zum jeweiligen Bewertungstag vom Komplementär gemäß dem Prospekt und der
Satzung veröffentlicht wird. Falls dieser Kalendertag kein Bankgeschäftstag ist, ist der Tag der Veröffentlichung des Net-
toinventarwerts der nächste darauffolgende Bankgeschäftstag.

«Späteres Closing»: Ein Closing nach dem ersten Closing, das an einem beliebigen, nach Ermessen des Komplementärs

festgelegten Bankgeschäftstag stattfinden kann.

Darüber hinaus wird die Definition des Begriffs «Rücknahmefrist» gelöscht.»

<i>Zweiter Beschluss

Es ergeht ein Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung zur Änderung des ersten und zweiten Absatzes von

Artikel 3.5 mit der Überschrift «Closings», der folgendermaßen neu gefasst wird:

«Die Gesellschaft nimmt Zeichnungen von Anlegern am ersten Closing und an jedem späteren Closing an.
Das erste Closing findet am 15. November 2007 statt. Es kann ein späteres Closing oder mehrere geben. Es finden

keine späteren Closings statt, wenn die Gesellschaft gemäß Ziffer 10 des Prospekts und der Satzung aufgelöst und liquidiert
werden muss.»

<i>Dritter Beschluss

Es ergeht ein Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung zur Änderung von Artikel 3.6.2 mit der Überschrift

«Ausgabe von Stammaktien während der Sperrfrist», der folgendermaßen neu gefasst wird:

«(a) Ab dem Tag des ersten Closing bis zum Tag der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts (d.h. 6 Monate und

neunzig  (90)  Kalendertage  nach  dem  ersten  Closing)  werden  zu  jedem  Tag  der  Inanspruchnahme  Stammaktien  zum
Erstausgabepreis von jeweils eintausend (1.000,-) USD ausgegeben.

(b) Nach dem ersten Tag der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts werden Stammaktien an Anleger zu jedem Tag

der Inanspruchnahme zum jeweils letzten verfügbaren Nettoinventarwert pro Stammaktie ausgegeben.

137552

Zum Zwecke eines Interessenausgleichs zwischen den vorhandenen und den neuen Anteilinhabern wird neuen Anle-

gern ein einmaliger Ausgleichsbetrag («Ausgleichsbetrag») zu dem Tag in Rechnung gestellt, zu dem ihre Zeichnungsver-
einbarung von dem Komplementär angenommen wird. Der Ausgleichsbetrag wird mit drei Komma neun Prozent (3,9%)
p.a. der Kapitalzusage des betreffenden Anlegers festgesetzt. Der maßgebliche Zeitraum beginnt mit dem ersten Closing
und endet an dem Tag des jeweiligen späteren Closing, zu dem die Kapitalzusage des neuen Anlegers angenommen wird,
und dauert höchstens vierundzwanzig (24) Monate. Der Ausgleichsbetrag ist zusammen mit der ersten Inanspruchnahme
der Kapitalzusage des neuen Anlegers zu zahlen. Der Ausgleichsbetrag stellt einen Ausgleich für in der Vergangenheit
erhobene Verwaltungsgebühr, Opportunitätskosten von Kapital der vorhandenen Anteilinhaber sowie einen Anteil an
den Gründungskosten der Gesellschaft, den Erwerbskosten für von der Gesellschaft bereits getätigte Investitionen, sowie
latenten Steuerverbindlichkeiten der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften dar, wobei die vorstehende Aufzäh-
lung nicht als abschließend zu verstehen ist.

Der  Ausgleichsbetrag  wird  zugunsten  der  Gesellschaft  erhoben,  die  einen  gewissen  Anteil  davon  im  Rahmen  der

Verwaltungsgebühr an den Komplementär entrichten kann, wie in der Ziffer mit der Überschrift «Gebühren und Kosten»
näher erläutert.

Klarstellend wird festgehalten, dass ausdrücklich vorgesehen ist, dass die entsprechende Kapitalzusage eines jeden

neuen Anlegers entsprechend zu verringern ist.

Klarstellend wird festgehalten, dass festgelegt ist, dass, wenn ein Anleger seinen Ausgleichsbetrag in vollem Umfang an

die Gesellschaft entrichtet hat, er (im Rahmen seiner Kapitalzusage) weitere Stammaktien zu einem Preis erwerben kann,
der nur auf dem einschlägigen Nettoinventarwert pro Stammaktie beruht, d.h., ohne dass er ein weiteres Mal den Aus-
gleichsbetrag zu entrichten hätte.

Klarstellend wird festgehalten, dass ausdrücklich vorgesehen ist, dass die ersten Anleger keinen Ausgleichsbetrag zu

zahlen haben.

Wenn während der Sperrfrist der Komplementär zu der Einschätzung kommt, dass der Erstausgabepreis oder gege-

benenfalls der entsprechende Nettoinventarwert pro Anteil den Wert der zugrundeliegenden Anlagen der Gesellschaft
nicht angemessen wiedergibt, werden Zeichnungen durch Ausgabe von Stammaktien zu einem speziell berechneten Net-
toinventarwert eingelöst.»

<i>Vierter Beschluss

Es ergeht ein Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung zur Änderung von Artikel 3.6.3 mit der Überschrift

«Ausgabe von Stammaktien nach der Sperrfrist», der folgendermaßen neu gefasst wird:

«Nach der Sperrfrist werden Stammaktien an Anleger zu jedem Tag der Inanspruchnahme zum jeweils letzten ver-

fügbaren Nettoinventarwert pro Stammaktie ausgegeben.

Zum  Zwecke  eines  Interessenausgleichs  zwischen  den  vorhandenen  und  den  neuen  Anteilinhabern  und  um  dem

Grundsatz der Gleichbehandlung von Anlegern Rechnung zu tragen, wird neuen Anlegern eine einmalige Ausgleichsgebühr
zu dem Tag in Rechnung gestellt, zu dem ihre Zeichnungsvereinbarung von dem Komplementär angenommen wird. Die
Festlegung der Ausgleichsgebühr in geeigneter Höhe liegt im Ermessen des Komplementärs und erfolgt als Prozentsatz
der Kapitalzusage des betreffenden Anlegers; sie ist zusammen mit der ersten Inanspruchnahme der Kapitalzusage des
betreffenden Anlegers zu zahlen.

Die  Ausgleichsgebühr  wird  zugunsten  der  Gesellschaft  erhoben,  die  einen  gewissen  Anteil  davon  im  Rahmen  der

Verwaltungsgebühr an den Komplementär zahlen kann, wie in der Ziffer mit der Überschrift «Gebühren und Kosten»
näher erläutert.

Klarstellend wird festgehalten, dass ausdrücklich vorgesehen ist, dass die unerfüllte Kapitalzusage eines jeden Anlegers

entsprechend zu verringern ist.

Klarstellend wird festgehalten, dass festgelegt ist, dass, wenn ein Anleger seine Ausgleichsgebühr in vollem Umfang an

die Gesellschaft entrichtet hat, er (im Rahmen seiner Kapitalzusage) weitere Stammaktien zu einem Preis erwerben kann,
der nur auf dem einschlägigen Nettoinventarwert pro Stammaktie beruht, d.h., ohne dass er ein weiteres Mal die Aus-
gleichsgebühr zu entrichten hätte.»

<i>Fünfter Beschluss

Es ergeht ein Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung zur Änderung von Artikel 3.7.1 mit der Überschrift

«Allgemeines», der folgendermaßen neu gefasst wird:

«Kapitalzusagen von Anlegern sind entweder ganz oder teilweise an die Gesellschaft zu zahlen, nachdem der betref-

fende Anleger die einschlägige Mitteilung über die Inanspruchnahme vom Komplementär erhalten hat; die Gesellschaft
verpflichtet sich, die entsprechende Menge voll eingezahlter Stammaktien zum jeweils geltenden Ausgabepreis - unter
Berücksichtigung von (gegebenenfalls) anfallenden Ausgleichsbeträgen oder Ausgleichsgebühren an den Anleger auszu-
geben, soweit seine Kapitalzusage eingefordert worden und eingezahlt ist. Der Komplementär ist auch befugt, Kapital-
zusagen wegen Gründungskosten und Betriebskosten in Anspruch zu nehmen.

Inanspruchnahmen  der  Kapitalzusagen  erfolgen  mit  einer  Frist  von  mindestens  acht  (8)  Bankgeschäftstagen  durch

Übermittlung einer Mitteilung über die Inanspruchnahme an Anleger. Zahlung durch Anleger sollte gemäß den in der
Mitteilung über die Inanspruchnahme enthaltenen Anweisungen erfolgen.

137553

Während des gesamten Bestehens der Gesellschaft wird der Komplementär bis zum Ende des jeweiligen Zeitraums

zur Erfüllung der Kapitalzusage eines Anlegers zu Zeitpunkten, die er nach eigenem Ermessen bestimmt, Kapitalzusagen
von Anlegern grundsätzlich in der Reihenfolge in Anspruch nehmen, in der die Anleger die Verpflichtungen eingegangen
sind und in Teilbeträgen, die der Komplementär nach eigenem Ermessen als für die Gesellschaft erforderlich erachtet.»

<i>Sechster Beschluss

Es ergeht ein Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung zur Änderung des ersten Absatzes von Artikel 3.7.2

mit der Überschrift «Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme der Kapitalzusagen», der folgendermaßen neu gefasst
wird:

«Die folgende Darstellung der Inanspruchnahme von Kapitalzusagen bezieht sich auf den Prozentsatz der Inanspruch-

nahme der ersten Anleger im Rahmen der ersten Kapitalzusagerunde und der neuen Anleger in den späteren Kapitalzu-
sagerunden. Grundsätzlich gilt, dass an jedem Tag der Inanspruchnahme jeder Anleger (entweder ein erster Anleger oder
ein neuer Anleger) mit einer unerfüllten Kapitalzusage in Höhe eines Betrags in Anspruch genommen wird, den der
Komplementär nach eigenem Ermessen festlegt, der aber maximal zwanzig Prozent (20%) der gesamten Kapitalzusage
(«Prozentsatz der Inanspruchnahme») des Anlegers entspricht. Anleger werden in der Reihenfolge, in der sie die Ver-
pflichtungen übernommen haben, bis in Höhe des Prozentsatzes der Inanspruchnahme in Anspruch genommen, wenn der
Komplementär diese Reihenfolge nicht aufgrund einer angemessenen Ermessensentscheidung ändert, um den Interessen
der verschiedenen, im Rahmen der diversen Kapitalanlagerunden einbezogenen Anleger Rechnung zu tragen.»

<i>Siebter Beschluss

Es ergeht ein Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung zur Änderung von Artikel 3.10.2 mit der Überschrift

«Rücknahme auf Verlangen von Kommanditaktionären», der folgendermaßen neu gefasst wird:

«Nach Ende der Sperrfrist kann jeder Kommanditaktionär die Gesellschaft zwei Mal jährlich, am 30. Juni und am 31.

Dezember (jeweils «Rücknahmestichtag»), auffordern, alle von ihm gehaltenen Stammaktien zum Nettoinventarwert zum
jeweiligen Rücknahmestichtag zurückzukaufen.

Rücknahmeanträge müssen bei der zentralen Verwaltungsstelle spätestens drei (3) Bankgeschäftstage vor dem maß-

geblichen Rücknahmestichtag eingehen.

Grundsätzlich liegt es im Ermessen eines jeden Kommanditaktionärs, zu jedem Rücknahmestichtag eine oder mehrere

der von ihm gehaltenen Stammaktien zurücknehmen. Maximal dürfen allerdings an einem Rücknahmestichtag fünf Prozent
(5%) der in Umlauf befindlichen Stammaktien zurückgenommen werden. Wenn zu einem Rücknahmestichtag bei der
zentralen Verwaltungsstelle Anträge auf Rücknahme von mehr als fünf Prozent (5%) der in Umlauf befindlichen Stamm-
aktien eingegangen sind, können sie anteilig herabgesetzt werden, um sicherzustellen, dass sie sich insgesamt auf nicht
mehr als fünf Prozent (5%) der zum betreffenden Rücknahmestichtag in Umlauf befindlichen Stammaktien beziehen.

Allerdings gilt folgendes:
1. Jeder Kommanditaktionär hat Anspruch auf Rücknahme von mindestens fünf Prozent (5%) seiner in Umlauf befind-

lichen Stammaktien.

2. Für Kommanditaktionäre, die mehr als die unter Punkt 1 oben angegebene Anzahl an Stammaktien zurücknehmen

möchten, gilt nachstehendes Verteilungsverfahren:

Bei Anträgen auf Rücknahme von mehr als der unter Punkt 1 angegebenen Anzahl an Stammaktien ist die Rede von

«Stammaktien, deren Rücknahme beantragt, aber noch nicht erfolgt ist».

Unter angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Kommanditaktionäre und angesichts

des Umstands, dass an einem Rücknahmestichtag höchstens fünf Prozent (5%) der in Umlauf befindlichen Stammaktien
zurückgenommen werden können, erfolgt die Rücknahme durch den Komplementär von Stammaktien, deren Rücknahme
beantragt,  aber  noch  nicht  erfolgt  ist,  darüber  hinaus  für  einen  einzelnen  Kommanditaktionär  im  Verhältnis  zu  allen
Stammaktien, deren Rücknahme beantragt, aber noch nicht erfolgt ist.

Es liegt im Ermessen des Komplementärs, zu jedem Rücknahmestichtag unter Berücksichtigung des Grundsatzes glei-

cher Behandlung der Anteilinhaber zu entscheiden, ob er die Stammaktien, deren Rücknahme beantragt, aber noch nicht
erfolgt ist, ganz oder teilweise zurücknimmt.

Wenn ein Kommanditaktionär die Rücknahme von Stammaktien beantragt hat, diese aber nicht angenommen wurde,

gilt dies nicht als Rücknahmeantrag für einen späteren Rücknahmestichtag.

An den Kommanditaktionär wird eine Annahmebestätigung unter Angabe der Anzahl der zurückzunehmenden Stamm-

aktien versandt.

<i>Achter Beschluss

Es ergeht ein Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung zur Einfügung eines neuen Unterabschnitts (b) mit

der Überschrift «Rücknahmepreis», in Artikel 3.10.2 mit anschließender neuer Nummerierung von Artikel 3.10.2:

«Der Rücknahmepreis einer jeden Stammaktie, deren Rücknahme zu einem bestimmten Rücknahmestichtag beantragt

ist, ist der Nettoinventarwert pro Stammaktie zu diesem Rücknahmestichtag. Der Nettoinventarwert ist jeweils am nächst
folgenden Tag der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts verfügbar und der Rücknahmeerlös an dem (oder den) zu-
rückgebenden  Kommanditaktionär(en)  innerhalb  von  fünfzehn  (15)  Bankgeschäftstagen  ab  dem  jeweiligen  Tag  der
Veröffentlichung des Nettoinventarwerts ausgezahlt.

137554

Wenn allerdings zwischen dem maßgeblichen Rücknahmestichtag und dem Tag der Veröffentlichung des Nettoinven-

tarwerts  ein  außergewöhnlicher  Bewertungstag  angesetzt  wird,  was  im  Ermessen  des  Komplementärs  liegt,  ist  der
Rücknahmepreis einer jeden Stammaktie der Nettoinventarwert pro Stammaktie zu diesem außerordentlichen Bewer-
tungstag.

Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben.
Klarstellend wird erwähnt, dass die Gesellschaft aufgrund von Rücknahmeanträgen nicht daran gehindert ist, Aus-

schüttungen im Rahmen ihrer Ausschüttungspolitik vorzunehmen; Gelder, die zu Ausschüttungszwecken eingenommen
wurden und/oder zu verwenden sind, werden nicht notwendigerweise zur Finanzierung von Rücknahmeanträgen ver-
wendet.

Für den Fall, dass ein Kommanditaktionär einen noch nicht ausgeführten Rücknahmeantrag widerrufen möchte, behält

sich der Komplementär das Recht vor, nach eigenem und uneingeschränktem Ermessen über Annahme oder Ablehnung
eines solchen Widerrufs zu entscheiden.

Bei Rücknahme werden die entsprechenden Stammaktien unverzüglich im Register der Anteilinhaber gelöscht. Steuern,

Provisionen und andere Gebühren, die in den Ländern angefallen sind, in denen die Stammaktien verkauft werden, werden
den zurücknehmenden Kommanditaktionären in Rechnung gestellt.»

<i>Neunter Beschluss

Es  ergeht  ein  Beschluss  der  außerordentlichen  Hauptversammlung  zur  Änderung  des  vierten  Absatzes  des  neuen

Unterabschnitts (c) von Artikel 3.10.2 mit der Überschrift «Verfahren», der folgendermaßen neu gefasst wird:

«Rücknahmeanträge bezüglich eines Rücknahmestichtags, die vor Ablauf der Rücknahmefrist, d.h., drei (3) Bankge-

schäftstage vor dem Rücknahmestichtag um 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) (die «Rücknahmefrist») eingehen, werden zu
diesem  Rücknahmestichtag  berücksichtigt,  außer  sofern  der  Komplementär  gemäß  den  vorstehenden  Bestimmungen
entscheidet, die Bearbeitung der Rücknahmeanträge proportional zu reduzieren.»

<i>Zehnter Beschluss

Es ergeht ein Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung zur Einfügung des folgenden Satzes am Ende des

ersten  Absatzes  von  Artikel  3.12.1  mit  der  Überschrift  «Berechnung  des  Nettoinventarwerts  der  Gesellschaft»,  mit
folgendem Wortlaut:

«Innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem ersten Closing findet kein Bewertungstag statt.»

<i>Elfter Beschluss

Es ergeht ein Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung zur Änderung des dritten Absatzes von Artikel 4.6

mit der Überschrift «Interessenkonflikte», der folgendermaßen neu gefasst wird:

«Wenn bei einem Mitglied des beratenden Ausschusses ein Interessenkonflikt besteht, hat es den Konflikt dem Vor-

sitzenden vor der Abstimmung mitzuteilen, ist aber nicht verpflichtet, sich bei der Abstimmung über die jeweilige Anlage-/
Veräußerungsvorhaben zu enthalten.»

<i>Zwölfter Beschluss

Es ergeht ein Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung zur Änderung von Artikel 5.2 mit der Überschrift

«Jahreshauptversammlung», der folgendermaßen neu gefasst wird:

«Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber wird am zweiten Dienstag im November um 11.30 Uhr (Luxemburger

Zeit) am Sitz der Gesellschaft abgehalten, außer wenn dieser Tag auf einen gesetzlichen Bankfeiertag fällt; in diesem Fall
wird die Versammlung an dem nächstfolgenden Bankgeschäftstag abgehalten. Die erste Jahreshauptversammlung der An-
teilinhaber findet 2008 statt.»

<i>Dreizehnter Beschluss

Es ergeht ein Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung zur Änderung des dritten Absatzes von Artikel 8.3.1

mit der Überschrift «Jährliche Verwaltungsgebühr», der folgendermaßen neu gefasst wird:

«Die Verwaltungsgebühr ist vierteljährlich im voraus am letzten Tag des vorherigen Quartals zu zahlen, wobei die erste

Zahlung der Verwaltungsgebühr bei der ersten Inanspruchnahme der Kapitalzusage auf Grundlage der Zahl der in diesem
Quartal verbleibenden Kalendertage erfolgt.»

<i>Vierzehnter Beschluss

Es ergeht ein Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung dahingehend, dass die vorstehenden Beschlüsse

zum Datum der vorliegenden Urkunde, d.h., dem 13. November 2007 in Kraft treten.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aufgrund der vorstehenden Urkunde entstehenden Ausgaben, Kosten, von ihr zu entrichtenden

Vergütungen und in sonstiger Weise zu tragenden Aufwendungen belaufen sich auf schätzungsweise zweitausendzwei-
hundert Euro (EUR 2.200,-).

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass diese Urkunde auf Verlangen der

vorstehend  genannten  Erschienenen  in  englischer  Sprache  verfasst  ist,  und  dem  englischen  Text  noch  eine  deutsche

137555

Version folgt. Auf Wunsch der Erschienenen hat im Falle von Widersprüchen zwischen dem englischen und dem deutschen
Text die englische Version Vorrang.

In Anbetracht dessen wurde diese notarielle Urkunde an dem eingangs genannten Tag in Luxemburg ausgefertigt.
Nachdem die Urkunde den Erschienenen, die dem Notar mit Familiennamen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort

bekannt sind, vorgelesen wurde, unterzeichneten die Mitglieder des Vorsitzes der außerordentlichen Hauptversammlung
gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Originalurkunde.

Gezeichnet: B. Tassigny, M. Nezar, E. Leenders, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2007, LAC/2007/35300. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Luxemburg, den 19. November 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007136342/220/822.
(070158553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Magna Park JV Units - Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 122.389.

In the year two thousand and seven, on the seventh of June.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) CalEast HOLDINGS 2, a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the

Luxembourg Trade and Companies Register under number B 124.779, having its registered office at Centre Place de
Paris, 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

here represented by Ms Sophie Bernabé, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg,

on 5 June 2007.

2) GAZELEY LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of England, registered in Great Britain

under number 02322154, having its registered office at Asda House, Southbank, Great Wilson Street, Leeds LS 5AD,
United Kingdom,

here represented by Ms Sophie Bernabé, previously named, by virtue of a proxy, given in Milton Keynes, on 5 June

2007.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are all the partners of MAGNA PARK JV UNITS - GERMANY S.à r.l. (hereinafter the «Com-

pany»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 122.389, incorporated pursuant to a
notarial deed on 30 November 2006, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations on 6 February
2007, number 124. The articles of incorporation have not been amended since.

The appearing parties representing the whole corporate capital and having waived any notice requirement, the general

meeting of partners is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1.  Increase  of  the  Company's  share  capital  from  its  current  amount  of  twelve  thousand  five  hundred  euro  (EUR

12,500.-) up to seven hundred and twenty-six thousand five hundred and seventy-five euro (EUR 726,575.-) through the
issue of twenty-eight thousand five hundred and sixty-three (28,563) shares, having a par value of twenty-five euro (EUR
25.-) each, which are to be subscribed as follows:

- two thousand eight hundred and fifty-six (2,856) shares, each at a par value of twenty-five euro (EUR 25.-), are to be

subscribed by GAZELEY LIMITED, prenamed, for the price of seventy-one thousand four hundred and eight euro and
thirty-three cent (EUR 71,408.33), consisting of seventy-one thousand four hundred euro (EUR 71,400.-) to be allocated
to the share capital and eight euro and thirty-three cent (EUR 8.33) for the issue premium.

- twenty-five thousand seven hundred and seven (25,707) shares, each at a par value of twenty-five euro (EUR 25.-),

are to be subscribed by CalEast HOLDINGS 2, prenamed, for the price of six hundred and forty-two thousand six hundred
and seventy-five euro (EUR 642,675.-), to be entirely allocated to the share capital.

2. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company.
3. Miscellaneous.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously took the following resolutions:

137556

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the Company's share capital by an amount of seven hundred and fourteen

thousand and seventy-five euro (EUR 714,075.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500.-) up to seven hundred and twenty-six thousand five hundred and seventy-five euro (EUR 726,575.-)
through the issue of twenty-eight thousand five hundred and sixty-three (28,563) shares, having a par value of twenty-
five euro (EUR 25.-) each.

The new shares have been subscribed as follows:
- two thousand eight hundred and fifty-six (2,856) shares have been subscribed by GAZELEY LIMITED, prenamed, for

the price of seventy-one thousand four hundred and eight euro and thirty-three cent (EUR 71,408.33); and

- twenty-five thousand seven hundred and seven (25,707) shares have been subscribed by CalEast HOLDINGS 2,

prenamed, for the price of six hundred and forty-two thousand six hundred and seventy-five euro (EUR 642,675.-).

The shares so subscribed have been paid up by a contribution in cash.
The proof of the existence and of the value of the above contributions has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of seven hundred and fourteen thousand and eighty-three euro and thirty-three cent (EUR

714,083.33) consists of seven hundred and fourteen thousand and seventy-five euro (EUR 714,075.-) allocated to the
share capital and eight euro and thirty-three cent (EUR 8.33) for the issue premium.

<i>Second resolution

As a consequence of such increase of capital, article 5 of the articles of incorporation of the Company is amended and

now reads as follows:

« Art. 5. The Company's share capital is set at seven hundred and twenty-six thousand five hundred and seventy-five

euro (EUR 726,575.-) represented by twenty-nine thousand and sixty-three (29,063) shares with a par value of twenty-
five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to ten thousand five hundred euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le sept juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) CalEast HOLDINGS 2, une société constituée et existant selon les lois de Luxembourg, enregistrée auprès du

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 124.779, ayant son siège social au Centre Place
de Paris, 41, avenue de la Liberté, L-1931, Luxembourg,

ici représentée par Mademoiselle Sophie Bernabé, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous

seing privé donnée à Luxembourg, le 5 juin 2007.

2) GAZELEY LIMITED, une société constituée et existant selon les lois d'Angleterre, enregistrée sous le numéro

02322154, ayant son siège social à Asda House, Southbank, Great Wilson Street, Leeds, LS 5AD, Royaume-Uni,

ici représentée par Mademoiselle Sophie Bernabé, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée

à Milton Keynes, le 5 juin 2007.

Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants sont tous les associés de MAGNA PARK JV UNITS - GERMANY S.à r.l. (ci-après la «Société»), une

société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.389, constituée selon un acte notarié
en date du 30 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 124, le 6 février 2007.
Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

Les comparants représentant l'intégralité du capital social, l'assemblée générale des associés est régulièrement con-

stituée et peut délibérer valablement sur les points suivants portés à l'ordre du jour:

137557

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)

jusqu'à celui de sept cent vingt-six mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 726.575,-) par l'émission de vingt-huit mille
cinq cent soixante-trois (28.563) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, lesquelles
seront souscrites comme suit:

- deux mille huit-cent cinquante-six (2.856) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,

seront à souscrire par GAZELEY LIMITED, précitée, pour la somme de soixante et onze mille quatre cent huit euros et
trente-trois cents (EUR 71.408,33) dont soixante et onze mille quatre cents euros (EUR 71.400,-) seront attribués au
capital social et huit euros et trente-trois cents (EUR 8,33-) seront attribués à la prime d'émission; et

- vingt-cinq mille sept cent sept (25.707,-) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,

seront à souscrire par CalEast HOLDINGS 2, précitée, pour la somme de six cent quarante-deux mille six cent soixante-
quinze euros (EUR 642.675,-) qui sera entièrement attribuée au capital social.

2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société.
Puis, l'assemblée générale des associés, après délibération, a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de sept cent

quatorze mille soixante-quinze euros (EUR 714.075,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) jusqu'à celui de sept cent vingt-six mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 726.575,-) par l'émis-
sion de vingt-huit mille cinq cent soixante-trois (28.563) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune.

Les nouvelles parts sociales ont été souscrites comme suit:
- deux-mille huit cent cinquante-six (2.856) parts sociales ont été souscrites par GAZELEY LIMITED, précitée, pour

la somme de soixante et onze quatre cent huit euros et trente-trois cents (EUR 71.408,33); et

- vingt-cinq mille sept cent sept (25.707) parts sociales ont été souscrites par CalEast HOLDINGS 2, précitée, pour

la somme de six cent quarante-deux mille six cent soixante-quinze euros (EUR 642.675,-).

Les parts sociales ainsi souscrites ont été payées par un apport en numéraire.
Les documents justifiant de l'existence et de la valeur de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.
L'apport total de sept cent quatorze mille quatre-vingt-trois euros et trente-trois cents (EUR 714.083,33) est composé

de sept cent quatorze mille soixante-quinze euros (EUR 714.075,-) qui sont attribués au capital social et de huit euros et
trente-trois cents (EUR 8,33) qui sont attribués au compte de prime d'émission de la Société.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de l'augmentation de capital, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société

qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de sept cent vingt-six mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 726.575,-)

représenté par vingt-neuf mille soixante-trois parts sociales (29.063) d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.»

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et qui sont

mis à sa charge à raison des présentes sont estimés à dix mille cinq cents euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par

nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Bernabé, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juin 2007. Relation: EAC/2007/6308. — Reçu 7.140,83 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 20 novembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007137729/239/150.
(070159699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

137558

SmartStream Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 118.408.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique datées du 19 octobre 2007

1. Le nombre des gérants a été augmenté de 4 à 5.
2. Monsieur Chris Parkin, né le 1 

er

 mai 1973 à Durham (Royaume-Uni), avec domicile au Flat 6, 1 Stanley Gardens,

London W11 2ND (Royaume-Uni), a été nommé gérant A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 22 octobre 2007.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SmartStream ACQUISITIONS S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007136431/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, réf. LSO-CK01848. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070158018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Crosslink Investment Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 56.765.

L'an deux mille sept, le quatre octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

à Bertrange, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société CROSSLINK INVESTMENT

CONSULTING S.A. (la «Société») une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 56.765,
constituée suivant acte notarié dressé en date du 22 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations numéro 25 du 23 janvier 1997.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte notarié reçu par le notaire soussigné, en

date du 1 

er

 février 2002 et dont un extrait a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 932

du 19 juin 2002.

L'assemblée générale extraordinaire a été ouverte sous la présidence de Madame Marie-Line Schul, juriste, avec adresse

professionnelle à Bertrange (Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire Madame Christel Ripplinger, juriste, avec adresse professionnelle à Bertrange

(Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sabine Dessart, employée privée, avec adresse professionnelle à Ber-

trange (Luxembourg).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de soixante-neuf mille euros

(69.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à un montant de cent
mille euros (100.000,- EUR) par la création et l'émission de deux mille sept cent cinquante (2.750) actions nouvelles
supplémentaires sans désignation de valeur nominale, chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions
existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

137559

L'augmentation de capital telle que visée interviendra au moyen de l'apport et transformation en capital de CROSSLINK

INVESTMENT CONSULTING S.A. d'une partie d'une créance certaine liquide et exigible à due concurrence que la société
CARRINGTON DEVELOPMENTS Ltd établie et ayant son siège social à Herald House, PO Box 501, 22 Hill Street, St.
Helier, Jersey JE4 9XB, Channel Islands, possède encore à l'heure actuelle contre la Société.

2.- Acceptation à la souscription et à la libération intégrale des deux mille sept cent cinquante (2.750) actions nouvelles

sans désignation de valeur nominale exclusivement par la société CARRINGTON DEVELOPMENTS Ltd, le second ac-
tionnaire, la société CRITERIA S.à r.l. renonçant expressément à son droit préférentiel de souscription.

3.- Modification afférente de l'article trois (3) des statuts de la Société, dans les deux versions anglaise et française,

pour le mettre en concordance avec l'augmentation de capital réalisée.

4.- Transfert du siège social de la Société et modification afférente dans les deux versions anglaise et française de

l'article premier (1 

er

 ) des statuts;

5.- Modification de l'article six (6) des statuts de la Société par la suppression dans les deux versions anglaise et française

de son septième et avant dernier alinéa.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, actuellement fixé à Trente et un mille euros

(31.000,- EUR) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, est régulièrement
constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l'unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une augmentation de capital social de la

Société à concurrence d'un montant de soixante-neuf mille euros (69.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel
de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans mention de valeur
nominale à un montant de cent mille euros (100.000,- EUR) qui sera représenté par quatre mille (4.000) actions sans
mention de valeur nominale par la création et l'émission de deux mille sept cent cinquante (2.750) actions nouvelles
supplémentaires sans désignation de valeur nominale, chaque action émise avec les mêmes droits et privilèges que les
actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît

en  rapport  avec  la  présente  augmentation  de  capital  que  l'actionnaire  existant  CRITERIA  S.à  r.l.,  avec  siège  social  à
Bertrange, a dans la mesure nécessaire renoncé à son droit préférentiel de souscription et décide d'admettre à la sou-
scription de la totalité des actions nouvelles, l'autre actionnaire existant la société suivante:

CARRINGTON DEVELOPMENTS Ltd établie et ayant son siège social à Herald House, PO Box 501, 22 Hill Street,

St. Helier, Jersey JE4 9XB, Channel Islands.

<i>Intervention

Est ensuite intervenue aux présentes:
Madame Marie-Line Schul, juriste, avec adresse professionnelle au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Betrange,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale du seul souscripteur, la société CARRINGTON DEVELOPMENTS Ltd,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 27 septembre 2007,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire soussigné,

restera annexée au présent procès-verbal pour être enregistrée en même temps avec lui.

<i>Souscription

Laquelle mandataire, agissant ès-dites qualités, et après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir

parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et a déclaré vouloir souscrire au nom et pour
le compte du seul souscripteur, la société CARRINGTON DEVELOPMENTS Ltd, susdite aux deux mille sept cent cin-
quante (2.750) actions nouvellement émises, sans désignation de valeur nominale.

<i>Libération

L'intervenante préqualifiée a libéré intégralement les deux mille sept cent cinquante (2.750) actions ainsi souscrites

par la société CARRINGTON DEVELOPMENTS Ltd, susdite, au moyen de l'apport et transformation en capital de la
Société d'une créance certaine, liquide et exigible tel que figurant à la situation comptable intérimaire de la Société, en
date du 31 août 2007, d'un montant de soixante-neuf mille euros (69.000,- EUR) que le souscripteur préqualifié a encore
sur la Société CROSSLINK INVESTMENT CONSULTING S.A., lequel apport a fait l'objet d'un rapport établi préalable-
ment à l'augmentation de capital par Monsieur Marco Ries, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle au 231,

137560

Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, lequel rapport établi par lui, le 21 septembre 2007, conformément à l'article
26-1 de la loi sur les sociétés, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, conclut comme suit:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale

des apports ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.»

Ledit rapport, après signature ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeurera

annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

<i>Troisième résolution

L'augmentation de capital ci-avant décidée se trouvant ainsi réalisée, l'assemblée générale extraordinaire modifie dans

les deux versions anglaise et française, l'article trois (3) des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

Version française:
« Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) divisé en quatre mille (4.000) actions sans dési-

gnation de valeur nominale.»

English version:
« Art. 3. The corporate capital is set at one hundred thousand euro (100.000, EUR) divided into four thousand (4'000)

shares without a par value.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social statutaire

et  administratif  de  la  Société  du  3,  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882  Luxembourg  au  10B,  rue  des  Mérovingiens,  L-8070
Bertrange.

<i>Cinquième résolution

Afin de refléter ce transfert de siège social de la Société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, décide

de modifier en conséquence et dans les deux versions anglaise et française, le deuxième alinéa de l'article premier (1

er

 ) des statuts de la Société, lequel deuxième alinéa se lira dorénavant comme suit:

Version française:
«  Art. 1 

er

 . deuxième alinéa.  Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être

transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des action-
naires.»

English version:
« Art. 1. second paragraph. The registered office is established in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Sha-
reholders.»

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, décide de modifier l'article six (6) des statuts de la Société en

supprimant purement et simplement dans les deux versions, anglaise et française son septième et avant dernier alinéa,
libellé comme suit:

«La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée

Générale.»

«Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Bertrange, au nouveau siège de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.-L. Schul, C. Ripplinger, S. Dessart, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 octobre 2007. Relation: EAC/2007/12228. — Reçu 690 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 20 novembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007137679/239/144.
(070159718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

137561

Night Investments 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 130.806.

EXTRAIT

Il ressort d'une convention de cession de parts exécutée en date du 1 

er

 octobre 2007 entre ACHADAS WORLD-

WIDE INC., ayant son siège social PO Box 3152 Road Town Tortola British Virgin islands, enregistrée sous le numéro
664117 et CEP III PARTICIPATIONS Sàrl SICAR, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxem-
bourg, enregistrée sous le numéro RCS B 127.711, que 12.500 parts sociales d'une valeur nominale de € 1,- chacune
représentant la totalité du capital social de la Société, sont détenues par CEP III PARTICIPATIONS Sàrl SICAR, prén-
ommée.

Depuis cette date, les 12.500 parts sociales de la Société sont détenues par CEP III PARTICIPATIONS Sàrl SICAR,

prénommée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 30 octobre 2007.

Pour extrait conforme
ATOZ
Signature

Référence de publication: 2007136432/4170/23.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2007, réf. LSO-CK03189. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Merrill Lynch Orion Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Merrill Lynch Asian Holdco S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 131.461.

In the year two thousand and seven, on the fifth of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

MERRILL LYNCH LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l. (MLLH), a société à responsabilité limitée, having its registered

office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

duly represented by Mrs Ute Bräuer, Maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder

and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith,

being the sole shareholder of MERRILL LYNCH ASIAN HOLDCO S.à r.l. (the «Company») a Société à responsabilité

limitée, with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the trade and companies' register of Luxembourg under section B number 131.461, constituted by a deed of the
undersigned notary, on July 19, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 2269 of
October 11, 2007.

The appearing party representing the whole corporate capital then deliberate upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Modification of the denomination of the Company;
2. Subsequent amendment of article 4 of the articles of association of the Company, that now reads as follows:
« Art. 4. The Company will assume the name of MERRILL LYNCH ORION HOLDINGS S.à r.l.»
3. Miscellaneous
and has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to modify the denomination of the Company into MERRILL LYNCH ORION HOLDINGS

S.à r.l.

137562

<i>Second resolution

As a consequence of the above-mentioned change of the denomination of the Company, article four (4) of the articles

of association is modified and now reads as follows:

« Art. 4. The Company will assume the name of MERRILL LYNCH ORION HOLDINGS S.à r.l.»

<i>Estimation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the Company

incurs is approximately at EUR 900.-

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who has personal knowledge of English language, herewith states that on request of the

appearing person, this deed is worded in English followed by French text, the English version will prevail.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, said appearing person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le cinq novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

MERRILL LYNCH LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l. (MLLH), une société à responsabilité limitée, ayant son siège

social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

ici représentée par Madame Ute Bräuer, Maître en droit, résidant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et

par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement,

étant l'associé unique de MERRILL LYNCH ASIAN HOLDCO S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée

ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 131.461, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en
date du 19 juillet 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2269 du 11 octobre 2007.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a délibéré sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination de la Société;
2. Modification subséquente de l'Article 4 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 4. La société prend la dénomination de MERRILL LYNCH ORION HOLDINGS S.à r.l.»
3. Divers

<i>Première résolution

L'associé unique a décidé de modifier la dénomination de la Société en MERRILL LYNCH ORION HOLDINGS S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la modification ci-dessus de la dénomination de la Société qui précède, l'Article quatre (4) des

statuts de la Société, aura désormais la teneur suivante:

« Art. 4. La société prend la dénomination de MERRILL LYNCH ORION HOLDINGS S.à r.l.»

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent è la société

est évalué à la somme de EUR 900.-

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande de la personne comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande de la même personne comparante
et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en entête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: U. Bräuer, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007. Relation: LAC/2007/34515. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

137563

Luxembourg, le 15 novembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007137827/242/85.
(070159761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

Asia Alternatives Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Camberwell S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 127.149.

In the year two thousand and seven, on the twenty-fifth of October.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

- ASIA ALTERNATIVES CAPITAL PARTNERS, LP, a partnership incorporated under the law of Delaware, having its

registered address at 9, East Loockerman Street, Dover, Delaware 19901, United States; and

- OMERS/AACP Investors, LP, a partnership incorporated under the laws of Cayman Islands, having its registered

address at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands.

Here both represented by Mrs Rachel Uhl, lawyer, with professional address at Luxembourg, by virtue of two proxies

established under private seal.

The said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the shareholders of the limited liability company existing in Luxembourg under the name

of CAMBERWELL S.à r.l. (the «Company»), registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B,
under number 127.149, with registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, incorporated pursuant to
a deed of the undersigned notary on March 20th, 2007, published in the Mémorial C n 

o

 1196 of June 19th, 2007.

II. The Company's share capital is set at twelve thousand, five hundred Euro (€ 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.

III. The appearing parties, through their proxyholders, have requested the undersigned notary to document the fol-

lowing resolutions:

<i>First resolution

The shareholders resolved to change the name of the Company from its current name CAMBERWELL S.à r.l. to ASIA

ALTERNATIVES LUXEMBOURG S.à r.l.

<i>Second resolution

Pursuant to the above resolution, the shareholders resolved to amend therefore the article 4 of the articles of incor-

poration, to give it henceforth the following wording:

« Art. 4. the Company will have the name of ASIA ALTERNATIVES LUXEMBOURG S.à r.l.»

<i>Third resolution

The shareholders resolved to cancel the par value of the Company's shares.

<i>Fourth resolution

The shareholders resolved to re-establish a par value in the amount of one Euro (€ 1.-) per share, thus leaving a share

capital amounting to twelve thousand, five hundred Euro (€ 12,500.-) represented by twelve thousand, five hundred
(12,500) shares having a par value of one Euro (€ 1.-) each, without any modification in the current proportion of share
capital held by each shareholder.

<i>Fifth resolution

Pursuant to the above resolutions, the shareholders resolved to amend the article 6 of the articles of incorporation

of the Company, to give it henceforth the following wording:

« Art. 6. the share capital is set at twelve thousand, five hundred Euro (€ 12,500.-) represented by twelve thousand,

five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (€ 1.-) each, all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve».

137564

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the presently stated increase of capital are estimated at two thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- ASIA ALTERNATIVES CAPITAL PARTNERS, LP, un «partnership» constitué sous les lois du Delaware, ayant son

siège3 social au 9, East Loockerman Street, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis; et

- OMERS/AACP INVESTORS, LP, un «partnership» constitué sous les lois des Iles Cayman, having ayant son siège

social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Iles Cayman.

Ici représentées par Madame Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu de deux

procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparantes sont les associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de CAMBERWELL S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 127.149, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 mars 2007, publié au Mémorial C n 

o

 1196 du 19 juin 2007.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-) représenté par cinq cents (500)

parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25,-) chacune.

III. Les associés, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés ont décidé de changer la dénomination sociale de la Société de sa dénomination actuelle CAMBERWELL

S.à r.l. en ASIA ALTERNATIVES LUXEMBOURG S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Les associés ont décidé de modifier l'article 4 des statuts en conséquence, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. la Société a comme dénomination ASIA ALTERNATIVES LUXEMBOURG S.à r.l.»

<i>Troisième résolution

Les associés ont décidé d'annuler la valeur nominale des parts sociales de la Société.

<i>Quatrième résolution

Les associés ont décidé d'établir la valeur nominale des parts sociales de la Société à un Euro (€ 1,-) par part sociale,

laissant donc un capital social de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-) représenté dès lors par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un Euro (€ 1,-) chacune, sans que la proportion actuelle du capital
social détenue par les associés ne soient affectée.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions susmentionnées, les associés ont décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour lui

donner la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-) représenté par 12.500 (douze mille cinq

cents) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (€ 1.-) chacune, chaque part étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.»

137565

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, LAC/2007/33115. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Schneider.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007136949/211/121.
(070159248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Tekton S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 92.130.

Constituée suivant acte reçu par M 

e

 André Schwachtgen, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 7 mars 2003,

publié au Mémorial, Recueil C n 

o

 363 du 3 avril 2003.

Modifiée suivant acre reçu par M 

e

 André Schwachtgen, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 13 no-

vembre 2003, publié au Mémorial, Recueil C n 

o

 1273 du 1 

er

 décembre 2003.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement à L-2450 Luxembourg,

15, boulevard Roosevelt, en date du 4 juillet 2007 que:

* le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat au 15, boulevard Roosevelt à L-2450 Luxembourg.
* démission des administrateurs, à savoir:
- Monsieur Alexis Kamarowsky, Directeur de société, demeurant professionnellement à L-Luxembourg;
- Monsieur Federigo Cannizzaro Di Belmontino, Directeur de société, demeurant professionnellement à L-Luxem-

bourg;

- Monsieur Jean-Marc Debaty, Directeur de société, demeurant professionnellement à L-Luxembourg.
* démission du commissaire aux comptes, à savoir:
- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), avec siège social à L-1371 Luxem-

bourg, 7, Val Sainte Croix.

* ont été nommés en remplacement:
aux postes d'administrateurs:
- Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, 15, bou-

levard Roosevelt L-2450

Monsieur Jean Faber est nommé président du conseil d'administration,
- Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt

L-2450

- Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, 15, boulevard Roo-

sevelt L-2450

au poste de commissaire aux comptes:
- REVILUX S.A. avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
Tous ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

137566

Luxembourg, le 4 juillet 2007.

<i>Pour la société TEKTON S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
<i>Cabinet d'experts comptables
Signature

Référence de publication: 2007137341/687/41.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05469. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Financière du Transvaal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 8, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 90.951.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Weber
<i>Notaire

Référence de publication: 2007136968/236/11.
(070159154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Werasp S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 59.779.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle du 29 octobre 2007, que l'Assemblée a

pris, entre autres, les résolutions suivantes:

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Vincent Thill, en qualité d'Administrateur de la société,

en remplacement de Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 17
septembre 2007.

L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Jean-Philippe Fiorucci en qualité d'Administrateur de la société. Le man-

dat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale de ce jour.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Olivier Conrard, en qualité d'Administrateur de la société,

en remplacement de Monsieur Mirko La Rocca, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 26 octobre
2007.

L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Olivier Conrard en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat

ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale de ce jour.

<i>Septième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

13 avril 2007 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer les Administrateurs
suivants:

- Monsieur Davide Murari, employé privé, au 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, Administrateur; et Président

du Conseil d'Administration;

- Monsieur Vincent Thill, employé privé, au 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Olivier Conrard, employé privé, au 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé

au 31 décembre 2010.

L'Assemblée décide de renommer pour un terme de -1- (un) an, la société FIDUCIAIRE MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau

L-1449 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire ainsi conféré prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exer-

cice clôturé au 31 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

137567

Luxembourg, le 12 novembre 2007.

<i>WERASP S.A.
D. Murari / V. Thill
<i>Président / Administrateur

Référence de publication: 2007137133/43/43.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2007, réf. LSO-CK04034. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Plastiche S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 64.244.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 27 août 2007

- Madame Laurence Mostade, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Lu-

xembourg est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Elke Dosch, qui a démissionné avec effet
au 14 août 2007. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale
Statutaire de l'an 2008.

- La fondation STICHTING ADMINISTRATIE KANTOOR PLASTICHE, avec siège social au Tentstraat 86, NL-6291

BJ Vaals, inscrite auprès de Kamer van Koophandel Nederland de et au Pays-Bas sous le numéro 14073712, a désigné
Madame  Gunhilde  Van  Gorp,  née  le  4  mai  1957,  administrateur  de  sociétés,  demeurant  à  Poederstraat,  51,  B-2370
Arendonk,  comme  représentant  permanent,  avec  effet  à  la  date  de  reconduction  du  mandat  d'Administrateur  de  la
Stichting, à savoir le 18 mai 2007, et ce, pour toute la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée
Générale Statutaire de l'an 2008.

Certifié sincère et conforme
<i>PLASTICHE S.A.
F. Dumont / S. Krancenblum
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007137132/795/24.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2007, réf. LSO-CK04141. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Elektra Finanzierung A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 41.610.

Constituée en date du 2 octobre 1992 par-devant M 

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au

Mémorial C n 

o

 632 du 31 décembre 1992, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 30

octobre 2006 par-devant le même notaire, acte publié au Mémorial C n 

o

 2454 du 30 décembre 2006.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ELEKTRA FINANZIERUNG A.G.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007137053/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007, réf. LSO-CK03600. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070158904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

137568


Document Outline

Asia Alternatives Luxembourg S.à r.l.

BAY-RUM Immobilière S.A.

BE Investco Luxembourg S.à.r.l.

Bergasa Holding S.A.

BTI-Building Technology International Corporation S.A.

Caleche Holding S.A.

Camberwell S.à r.l.

Corporate Credit (Europe) S.A.

Crosslink Investment Consulting S.A.

Danidin

DHCRE II Finance S.à r.l.

e2 advance S.à r.l.

East Europe Real Estate S.A.

Elektra Finanzierung A.G.

Elvas S.A.

Euro-Connect S.A.

European Education Holdings S.à.r.l.

Federale Management S.A.

Financière du Transvaal S.A.

Foxworth Finance S.A.

Geralux S.à r.l.

Graci International Holding

HAWK Group S.A.

I.07 Pabeierbierg

KEV Germany 3 S.A.

La Beauté S.àr.l

Landmark S.A.

L'Arcobaleno

Lincolnwood S.à r.l.

Macquarie Global Infrastructure Funds 2 S.A.

Macquarie Storage Luxco 1 S.à r.l.

Macquarie Storage Luxembourg 2 S.à r.l.

Magna Park JV Units - Germany S.à r.l.

Merrill Lynch Asian Holdco S.à r.l.

Merrill Lynch Orion Holdings S.à r.l.

Millicom International Cellular S.A.

MX International S.à.r.l.

Night Investments 3 S.à r.l.

Patri Participations Holding

Peehold S.A.

Plastiche S.A.

responsAbility BOP Investments S.C.A. SICAR

Schutz et Wagner S.A.

Season International S.A.

SmartStream Acquisitions S.à r.l.

Soprogest S.A.

STAR s. à r.l.

Tekton S.A.

Tricat Europe S.A.

Universal Commerce and Finance S.A.H.

Werasp S.A.

WGC - Worldwide Glass and Ceramics Investment S.A.