This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2782
1
er
décembre 2007
SOMMAIRE
AB Acquisitions Luxco 2 S.à r.l. . . . . . . . . .
133517
Accord Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
133532
Alcmena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133508
Alicor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133509
Batima Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133501
Caam Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133534
Calibois S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133534
Colyzeo II Development S.à r.l. . . . . . . . . .
133510
CommCapital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133507
Constructions Métalliques Kremer S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133503
Crédit Agricole Asset Management Lu-
xembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133502
Crown Corporate Services . . . . . . . . . . . . . .
133520
dfl Luxembourg Two S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
133490
D.W.L. Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
133502
Eastwood S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133508
Eclipse Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
133500
First Web S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133532
Firwind Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133530
Firwind Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133531
Firwind Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133531
Floorings I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133504
Gai Mattiolo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
133534
Galux S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133535
Groupe Minelis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133533
Herinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133508
Hotel Koener S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133502
IBR Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133517
ICG-Gemco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133509
Immo Foyer S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133500
Immo Foyer S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133499
INREDE S.A. (International Nippon Real
Estate Development & Finance S.A.) . . .
133531
InterFact S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133520
International Research and Development
(Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133516
J.B. Investment Company . . . . . . . . . . . . . . .
133533
LBC Holdings GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
133503
LBREP II Europe Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
133522
Loeffler S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133503
LP One Halbergmoos Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
133504
L.S. Lux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133530
Marguy Mootz S.à r.l. unipersonnelle . . . .
133501
Melrose Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133530
MH-SH S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133536
Ocean Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133535
Omnium Européen d'Entreprises O.E.E.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133509
Paul Thiltges Distributions S.à r.l. . . . . . . .
133532
Pembroke S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133509
Prostar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133536
Reliability Engineering S.à.r.l. . . . . . . . . . . .
133530
Revolia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133509
S.E.T.I. Société Européenne de Transac-
tions Immobilières S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
133536
Société Nouvelle Ernzbach S.A. . . . . . . . . .
133502
Sodefi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133501
Technolux Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
133500
Treveria G S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133535
Wintersport Investments Holding S.A. . . .
133531
World Immo Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
133533
133489
dfl Luxembourg Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 133.151.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the thirty-first day of October.
Before Maître Jean-Joseph Wagner notary, residing in Sanem, Luxembourg.
There appeared:
- DFL LUXEMBOURG ONE S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of
Luxembourg, with its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, whose registration with the Lux-
embourg Trade and Companies Register is pending, constituted today by the undersigned notary,
- PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P., a limited partnership and existing under the laws of England and Wales,having
its registered office at Cleveland House 33 King Street, London, SW1Y 6RJ, registered in Cardiff under registration number
LP 10434.
- PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of
England and Wales, having its registered office at Cleveland House 33 King Street, London, SW1Y 6RJ, registered in
Cardiff under registration number LP 10450,
The appearing parties are here represented by Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue
of three proxies given under private seal dated 29 October 2007.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of Incorporation of a private limited liability company («société privée à responsabilité limitée»):
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form - Corporate name. There is formed a private limited liability company under the name DFL LUXEM-
BOURG TWO S.à r.l., which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and
in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by
the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
2.3 However, the sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised
to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.
Art. 3. Object.
3.1 The Company's object is to acquire and hold interests in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign,
commercial, industrial or financial entities, by way of, among others, the subscription or acquisition of any securities and
rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or
financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
3.2 The Company may in particular enter into the following transactions:
3.2.1. borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other equity instruments or debt instruments,
convertible or not into shares of the Company, the use of financial derivatives or otherwise;
3.2.2. advance, lend or deposit money or give credit to Affiliates through, including but not limited to, the subscription
to bonds, notes, certificates and other equity instruments or debt instruments, convertible or not into shares of any
Affiliate.
3.2.3. enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage
or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods,
for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Affiliates, or any director, director
or other agent of the Company or any of the Affiliates, and to render any assistance to the Affiliates, within the limits of
the laws of Luxembourg; and
3.2.4 enter into any agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, mar-
keting agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other services con-
tracts, selling agreements, connected directly or indirectly to the areas described above;
133490
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
3.3 In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions
and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly
or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object
in all areas described above.
Art. 4. Duration.
4.1 The Company is established for an unlimited duration.
Chapter II.- Capital, Shares
Art. 5. Share capital.
5.1 The share capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand
and five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (hereafter referred to as the «Shares»).
The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».
5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).
5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.
Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is
admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 7. Transfer of shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the
requirements of articles 189 and 190 of the Law.
7.3 In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share without
the prior written, consent of the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers.
Chapter III.- Management
Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of
plurality of managers, they will constitute a Board of Managers (the «Board of Managers»).
8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by
a resolution of the shareholder(s).
Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.
9.1 In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, without
prejudice to articles 8 and 10 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.
9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within
the competence of the sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.
Art. 10. Representation of the company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound
by the sole signature of the sole Manager or, in case of plurality of managers, by the sole signature of any one Manager
or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a sole Manager, by the sole Manager
or, in case of plurality of managers, by any one Manager.
Art. 11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers.
11.1 The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers may delegate its/their powers for specific
tasks to one or more ad hoc agents.
11.2 The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers will determine any such agent's respon-
sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.
Art. 12. Meeting of the board of managers.
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager. No meeting
of the Board of managers may validly be held in the United Kingdom.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present
or represented and have waived the convening requirements and formalities.
133491
12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax
or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage except in case where such manager is in the United Kingdom.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or
represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating
Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone. No
Manager may participate in a telephone board meeting whilst being in the United Kingdom.
12.6 A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of
the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.
12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the
meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of
the Board of Managers.
Art. 13. ERISA rights.
13.1 For as long as an ERISA Fund or its nominees are directly or indirectly Shareholders of the Company, that ERISA
Fund will obtain certain management rights in the Company and its subsidiaries in a manner and to the extent permitting
such ERISA Fund to substantially influence or participate in the management of the Company and its subsidiaries. Ac-
cordingly, it is agreed for the benefit of each of the ERISA Funds individually that each ERISA Fund or its nominee shall
have the right (which rights shall belong solely to, and shall be exercised exclusively by, such ERISA Fund for its own
benefit and for its own account) from time to time and at any time by notice in writing to propose up to two persons
for election as Managers of the Company and each of its subsidiaries and the Shareholders and the shareholders of the
subsidiaries shall vote and take such other action as may be necessary to ensure that in each case one person proposed
by each ERISA Fund shall hold office as a Manager of the Company and each of its subsidiaries (collectively the «ERISA
Managers»).
13.2 The shareholders in each of the ERISA Funds include limited partners which are entities governed in the United
States of America by the Employee Retirement Income Security Act 1974 as amended from (ERISA). In order to permit
the limited partners governed by ERISA to treat each of the ERISA Funds as VCOC's for the purposes of ERISA they
need to obtain certain management rights in companies in which they invest in a manner and to an extent that will permit
the ERISA Funds to qualify as a VCOC. Accordingly, it is agreed that as long as an ERISA Fund directly or indirectly holds
any Shares in the Company, the Company and its subsidiaries and their designated representatives shall provide each
ERISA Fund (individually) with the following rights to the extent such rights are permissible under the applicable statutory
laws (which rights shall belong solely to, and shall be exercised exclusively by, such ERISA Fund for its own benefit and
for its own account):
13.2.1 the right to visit and inspect any of the offices and properties of the Company and its subsidiaries and the right
to inspect and copy the books and records of the Company and its subsidiaries, at such times as the ERISA Fund shall
reasonably request;
13.2.2 the right to appoint a representative to attend as an observer each and every meeting of the Board of Managers
of the Company (and the board of directors of each subsidiary thereof). The appointment and removal of such a repre-
sentative shall be by written notice from the ERISA Fund to the Company and shall take effect upon the delivery of written
notice thereof at the Company 's registered office or at any meeting of the Board of Managers;
13.2.3 the right to receive, within a reasonable time after its written request therefore, any information relating to the
Company or its subsidiaries or associated companies as it in its sole discretion deems fit, including without limitation: (i)
within 30 days of the month end monthly consolidated financial information and statements, including but not limited to
a balance sheet, profit and loss and cash flow statements of the Company and each of its subsidiaries and associated
companies; (ii) within 90 days of the end of each accounting period end annual audited consolidated financial statements;
(iii) on an annual basis and no later than 30 days prior to the beginning of the Company's financial year or, if so requested
on a more frequent basis, the business plan, budget and cash flow forecasts and projections of the Company and each of
its subsidiaries and associated companies; (iv) monthly reports including a narrative setting out the progress of the group
on matters materially affecting the business and affairs of the group; and (v) such additional financial or management
information as the ERISA Fund may reasonably request including any operating reports, budgets, other financial reports
and details of material developments or events or significant proposals;
13.2.4 the right to meet on a regular basis with the Managers or other personnel of the Company and its subsidiaries
and associated companies from time to time and upon reasonable notice to the Company (or the applicable subsidiary
or associated company) for the purpose of consulting with, rendering advice, recommendations and assistance to, and
influencing the Managers of the Company (or its subsidiaries and associated companies) or obtaining information regarding
the Company's or any of its subsidiaries' (or associated companies') business operations, financial condition, activities and
prospects and expressing its views thereon including, significant changes in management, personnel and compensation of
employees, introduction of new products or new lines of business, important acquisitions or dispositions of plants and
133492
equipment, significant research and development programmes, the purchasing or selling of important trademarks, licences
or concessions or the proposed commencement or compromise of significant litigation;
13.2.5 the right to submit proposals and suggestions to the Board of Managers of the Company or to the board of any
of its subsidiaries, if hot adopted by management; and
13.2.6 to the extent consistent with applicable law (and with respect to events which require public disclosure, only
following the Company's public disclosure thereof through applicable securities law filings or otherwise), the right to
receive notice in advance with respect to any significant corporate actions, including, without limitation, extraordinary
dividends, mergers, acquisitions or dispositions of assets, issuances of significant amounts of debt or equity and material
amendments to the Articles, and the right to consult with the Company with respect to such actions.
13.3 In the event that the Company ceases to qualify as an «operating company» (as defined in the first sentence of
29 C. F. R. Section 2510 3-101(e)), then the Company and each Shareholder will co-operate in good faith to take all
reasonable action necessary to provide that the investment of PALAMON EE or PALAMON II qualifies as a «venture
capital operating company» (as defined in the Plan Asset Regulations) and shall continue to qualify as a «venture capital
investment» (as defined in the Plan Asset Regulations). This provision shall not be construed as an obligation on any Party
to provide any additional finance to the Company or its subsidiaries.
13.4 For the purpose of this article, ERISA Fund means both or either of PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P. and
PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA L.P.
Chapter IV.- General meeting of shareholders
Art. 14. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes.
14.1 The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting.
14.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his Shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them.
14.3 However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law.
Chapter V.- Business year
Art. 15. Business year.
15.1 The Company's financial year starts on the 1 st January and ends on the 31 st December of each year.
15.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the sole Manager or in case of
plurality of managers, by the Board of Managers and the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
15.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 16. Distribution right of shares.
16.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-
ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.
16.2 From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That
deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's
nominal capital.
16.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by law and by these Articles, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.
16.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a
majority vote of the Shareholders.
16.5 Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).
Chapter VI.- Liquidation
Art. 17. Causes of dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
Art. 18. Liquidation.
18.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by the majority of Shareholders.
133493
18.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
Chapter VII- Applicable law
Art. 19. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31
December 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
Shares
DFL LUXEMBOURG ONE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,498
PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: twelve thousand five hundred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-)
corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal
of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand euros.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named entity, DFL LUXEMBOURG ONE S.à r.l.,
PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P. and PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA L.P., representing the entirety of
the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1- Are appointed as Managers of the Company for an undetermined period:
- Mr Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, born on 29 April 1956 at Briey, France, with professional address at 5,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Mr Pascal Roumiguié, employee, born on 29 October 1964 at Longeville-les-Metz, France, with professional address
at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Dr Holger Kleingarn, investment manager, born on July 17, 1968, resident at 45 Netherhall Gardens, London, NW
3, England.
In accordance with article 10 of the by-laws, the Company shall be bound by the sole signature of any one Manager
or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by any one Manager.
2- The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
Declaration
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
Ont comparu:
- DFL LUXEMBOURG ONE S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois du Luxembourg,
ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, dont l'immatriculation auprès du Registre du Com-
merce et des Sociétés est en cours, constituée aujourd'hui par le notaire soussigné,
- PALAMON EUROPEAN EQUITY, II L.P., un limited partnership, ayant son siège social au Cleveland House, 33 King
Street, Londres, SW1Y 6RJ, enregistrée à Cardiff sous le numéro d'enregistrement LP 10434.
- PALAMON EUROPEAN EQUITY, II BOA L.P., un limited partnership, ayant son siège social au Cleveland House,
33 King Street, Londres, SW1Y 6RJ, enregistrée à Cardiff sous le numéro d'enregistrement LP 10450.
133494
Les comparantes ci-dessus sont représentées par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu de procuration données sous seing privé en date du 29 octobre 2007.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme - Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de DLF
LUXEMBOURG TWO S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier
la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents
statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société
dans la Ville de Luxembourg.
Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet l'acquisition, la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
autres entités commerciales, industrielles ou financières luxembourgeoises ou étrangères, au moyen, entre autre, d'ac-
quisition et de souscription de toutes sûretés et droits par voie de participation, d'apport, de contribution, de prise ferme
ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, ou des instruments de dette financière sous quelque forme
que se soit, et d'administrer, développer et gérer de telles détentions d'intérêts.
3.2 La Société peut en l'espèce entrer dans les transactions suivantes:
3.2.1. emprunter de l'argent sous toutes formes ou obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers,
y compris mais sans être limité, l'émission d'obligations, de titres de prêt, de billets à ordre, de certificats et tous autres
effets de commerce d'equity et de dettes convertibles ou non en Actions de la Société, l'utilisation de dérivés financiers
ou sinon;
3.2.2. octroyer des avances, des prêts, de la monnaie scriptural ou accorder des crédits à ses sociétés liées à travers,
y compris mais sans être limité, la souscription d'obligations, de titres, de certificats et tous autres effets de commerce
d'equity et de dette, convertibles ou non en Parts Sociale de toute Société Liée;
3.2.3 entrer dans toute garantie, gage ou toute autre forme de sûreté, soit par un engagement personnel ou par une
hypothèque ou charge sur tout ou partie des actifs (présents et futurs) de propriété de l'entreprise ou par toutes ou
telles méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligation de la Société ou de ses Sociétés Liées ou tout directeur
ou autre agent de la Société ou de ses Sociétés Liées et pour apporter toute aide à ses Sociétés Liées, dans les limites
prévues par la Loi luxembourgeoise; et
3.2.4 entrer dans tout accord, y compris mais sans être limité aux accords d'association, accords de garantie, accords
de marketing, accords de management, accords consultatifs, accords d'administration et autre contrats de service, accords
de vente, connectés directement ou indirectement aux domaines décris au dessus;
il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité
qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.
3.3 En plus de ce qui précède, la Société peut effectuer toutes opérations légales, commerciales, techniques et finan-
cières, et en générale toutes opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet aussi bien que les opérations
directement ou indirectement liées aux activités décrites dans cet article, afin de faciliter la réalisation de l'objet social
dans tous les domaines décrits plus haut.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II.- Capital, Parts
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par douze mille cinq
cents (12,500) parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR), chacune. Les détenteurs
de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».
5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.
5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
133495
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.
Art. 6. Indivisibilité des parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par
Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la
Société.
Art. 7. Transfert des parts.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-
missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.
7.3 De plus, chaque Associé s'engage à ne pas céder, mettre en gage ou conférer des garanties sur les Parts Sociales
qu'il détient sans le consentement préalable et écrit du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.
Titre III.- Gérance
Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associé(s). En cas
de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec
ou sans motif, par décision des Associé(s).
Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, sans
préjudice des articles 8 et 10 des présents Statuts, a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances
et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent
article aient été respectés.
9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront
de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
Art. 10. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée
par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature unique de tout Gérant
ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique
ou, en cas de pluralité de gérants, par tout Gérant.
Art. 11. Délégation et agent du gérant unique et du conseil de gérance.
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à
un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.
11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants détermine(nt) les responsabilités et la rému-
nération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de
leur mandat.
Art. 12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant. Aucune
réunion du conseil de Gérance ne pourra valablement avoir lieu au Royaume-Uni.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les
gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.
12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant,
pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une
lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation
écrite ultérieure sauf dans l'hypothèse où le Gérant se trouve au Royaume-Uni.
12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres
est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.
12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure
d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Aucun Gérant ne
pourra participer à une réunion téléphonique du conseil alors qu'il se trouve au Royaume-Uni.
12.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants est valable et valide pour autant qu'elle ait été adoptée à une
réunion du Conseil de Gérance, qui a été dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un
document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de
Gérance.
12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés
aux séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant ou
lors de la réunion du Conseil de Gérance.
133496
Art. 13. Droits ERISA.
13.1 Aussi longtemps qu'un Fond ERISA ou ses candidats sont directement ou indirectement Associés, ce Fond ERISA
obtiendra certains droits de gestion dans la Société et ses filiales dans une manière et dans la mesure permettant à ce
Fond ERISA d'influencer substantiellement ou de participer dans la gestion de la Société et de ses filiales. Par conséquent,
il est convenu au bénéfice de chaque Fond ERISA individuellement que chaque Fond ERISA et ses candidats aura le droit
(lesquels droits appartiendront seulement et seront exercés exclusivement par ce Fond ERISA à son profit et pour son
propre compte) de temps en temps et à tout moment avec un préavis par écrit de proposer jusqu'à deux personnes pour
la nomination de gérants de la Société et de chacune de ses filiales et les Associés et les associés des filiales voteront et
prendront toute autre part sociale qui serait nécessaire pour assurer que dans chaque cas ou une personne proposée
par chaque Fond ERISA aura la fonction de gérant de la Société et de chacune de ses filiales (conjointement les «ERISA
Membres du Conseil»).
13.2 Les investisseurs dans chacun des Fonds ERISA comprennent les associés commanditaires qui sont des entités
régies aux Etats-Unis par la Loi de 1974 relative aux régimes de retraite et de couverture médicale ERISA. Dans le but
de permettre aux associés commanditaires régis par ERISA de considérer chaque Fond ERISA comme VCOC's aux fins
de ERISA ils ont besoin d'obtenir certains droits de gestion dans les sociétés dans lesquelles ils investissent dans Une
manière et mes ure qui permettra à la Société de le qualifier comme VCOC. Par conséquent, il est convenu que aussi
longtemps qu'un Fond ERISA détient directement ou indirectement des parts sociales dans la Société, la Société et ses
filiales et leurs représentants désignés garantiront à chaque Fond ERISA (individuellement) les droits suivants (lesquels
droits appartiendront seulement et seront exercés exclusivement par ce Fond ERISA à son profit et pour son propre
compte):
13.2.1 Le droit de visiter et inspecter chacun des bureaux et propriétés de la Société et de ses filiales et le droit
d'inspecter et reproduire les livres et registres de la Société et de ses filiales, aux moments ou le Fond ERISA l'aura
raisonnablement requis.
13.2.2 Le droit de nommer un représentant pour participer comme observateur à chacune des réunions du Conseil
de Gérance de la Société (et chacune des filiales). La nomination et la révocation de ce représentant sera faite par préavis
écrit du Fond ERISA à la Société et prendra effet à la délivrance du préavis écrit au siège social de la Société ou à toute
réunion du Conseil de Gérance.
13.2.3 Le droit de recevoir, dans un temps raisonnable, après sa demande écrite, toutes les informations en relation
avec la Société ou ses filiales ou sociétés affiliées, qu'il considère, à sa seule discrétion, comme appropriées, comprenant
sans limitation sans limitation: (i) dans les 30 jours de la fin du mois les informations et déclarations financières consolidées
mensuellement, incluant mais sans y être limité les bilans, profits et pertes et les déclarations relatives au flux de trésorerie
de la Société et chacune de ses filiales et sociétés affiliées, (ii) dans les 90 jours de la fin de chaque période comptable et
des déclarations financières consolidées annuelles, (iii) sur une base annuelle et pas plus tard que dans les 30 jours qui
précèdent le début de l'exercice social de la Société ou si requis sur une base plus fréquente, le plan d'affaires, le budget
et les prévisions et les estimations du flux de trésorerie de la Société et de chacune de ses filiales et sociétés affiliées; (iv)
des rapports mensuels comprenant un cadre explicatif sur l'évolution du groupe dans des matières affectant matérielle-
ment le commerce et les affaires du groupe; et (v) les informations supplémentaires financières ou de gestion que le Fond
ERISA peut raisonnablement requérir comprenant tous rapports d'exploitation, budgets, autres rapports financiers et les
détails des développements matérielles ou événements ou propositions significatives.
13.2.4 Le droit de rencontrer sur une base régulière les gérants ou autre personnel de la Société et de ses filiales et
ses sociétés affiliées de temps en temps et moyennant un préavis raisonnable à la Société (ou la filiale ou la société affiliée
en question) aux fins de consulter, donner un avis, des recommandations et assistance et influencer les gérants de la
Société (ou ses filiales et sociétés affiliées) ou d'obtenir des informations concernant les opérations commerciales, les
conditions financières, les activités et perspectives de la Société (ou de ses filiales ou de ses sociétés affiliées) et de donner
son point de vue à ce sujet comprenant, sans limitation, des changements significatifs dans la gestion, le personnel et la
rémunération des employés, l'introduction de nouveaux produits ou de nouvelles lignes d'affaires, des acquisitions im-
portantes ou des ventes d'usines et d'équipements, des recherches significatives et des programmes de développement,
l'achat ou la vente d'importantes marques de fabrique, licences ou concessions ou le début proposé ou le compromis
d'un litige important;
13.2.5 Le droit de soumettre des propositions et suggestions au Conseil de Gérance de la Société ou au conseil de
l'une quelconque de ses filiales, s'ils n'ont pas été adoptés par la gérance; et
13.2.6 Dans une mesure compatible avec la loi applicable (et au regard d'événements qui requièrent une divulgation
publique, seulement à la suite de la divulgation publique de la Société au moyen de dépôts légaux de garanties en question
ou autrement), le droit de recevoir un préavis en avance relatif à toutes parts sociales significatives, comprenant, sans
limitation, des dividendes extraordinaires, des fusions, des acquisitions ou des ventes d'actifs, des émissions de montants
significatifs de dette ou capital et des modifications matérielles aux Statuts, et le droit de se consulter avec la Société en
relation à ses parts sociales.
13.3 Au cas ou la Société cesse de qualifier comme une «société opérationnelle» (telle que définie à la première phrase
du 29 C.F.R. Section 2510.3-101 (e), la Société et chaque Associé coopéreront de bonne foi pour prendre toutes les
parts sociales raisonnables nécessaires pour assurer que l'investissement de PALAMON EE ou PALAMON II est qualifié
133497
comme «société opérationnelle à capital risque» (telle que définie dans le Plan de Régulation des Actifs) et doit continuer
à être qualifiée comme «investissement à capital risque» (tel que défini dans le Plan de Régulation des Actifs). Cette
disposition ne doit pas être entendue comme une obligation de toute Partie de fournir toute finance supplémentaire à la
Société ou à ses filiales.
13.4 Pour les besoins de cet article, Fonds ERISA signifie PALAMON EUROPEAN EQUITY II LP et PALAMON EU-
ROPEAN EQUITY II BOA L.P. ensembles ou l'un l'autre.
Titre IV.- Assemblée générale des associés
Art. 14. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés.
14.1 L'Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés.
14.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du
nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié
du capital social les adoptent.
14.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité
d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions
légales.
Titre V.- Exercice social
Art. 15. Exercice social.
15.1 L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
15.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas
de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.
15.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 16. Droit de distribution des parts.
16.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortis-
sements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.
16.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
16.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des
Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds dispo-
nibles soient distribués.
16.4 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.
16.5 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance
peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation
de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à
distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve
établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices
effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).
Titre VI.- Liquidation
Art. 17. Causes de dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils,
d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.
Art. 18. Liquidation.
18.1 La liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés.
18.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Titre VII.- Loi applicable
Art. 19. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence
à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Parts
133498
Sociales
dflLUXEMBOURG ONE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.498
PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: douze mille cinq cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de
douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) correspondant à un capital de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille Euros.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les comparantes précitées, DFL LUXEMBOURG ONE S.à r.l.,
PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P. et PALAMON EUROPEAN EQUITY II BOA L.P., représentant la totalité du
capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1- Sont nommés Gérants de la Société pour une période indéterminée:
- Monsieur Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, né le 29 avril 1956 à Briey, France, avec adresse professionnelle
au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Monsieur Pascal Roumiguie, employé, né le 29 octobre 1964 à Longeville-les-Metz, France, avec adresse profession-
nelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Dr Holger Kleingarn, investment manager, né le 17 juillet 1968, résident au 45 Netherhall Gardens, Londres, NW
3, Angleterre.
Conformément à l'article 10 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de tout Gérant ou par
la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par tout Gérant.
2- Le siège social de la Société est établi à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg,date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 novembre 2007. Relation: EAC/2007/13664. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 8 novembre 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007132912/239/540.
(070153867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
Immo Foyer S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 77.986.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en date du 24 août 2000, acte publié au
Mémorial C n
o
180 du 8 mars 2001, capital converti en Euro suivant avis publié au Mémorial C n
o
506 du 30 mars
2002, modifiée suivant acte publiée au Mémorial C n
o
858 du 6 juin 2002.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
133499
Luxembourg, le 22 octobre 2007.
<i>Pour IMMO FOYER S.à.r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Référence de publication: 2007132504/1261/18.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007, réf. LSO-CJ09084. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Eclipse Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3440 Dudelange, 84, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 55.734.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2007.
<i>ECLIPSE IMMOBILIERE S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature
Référence de publication: 2007132505/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2007, réf. LSO-CK00019. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Technolux Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 78.591.
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 10 octobre 2007i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d'Administration prend note de la démission de M. Philippe Vanderhoven de son poste d'administrateur
de la Société avec effet rétroactif au 30 juin 2007.
<i>Deuxième résolutioni>
En remplacement de Monsieur Philippe Vanderhoven, le Conseil d'Administration décide de coopter Madame Violène
Rosati, résidant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, au poste d'administrateur A de la Société
avec effet rétroactif au 30 juin 2007.
Cette cooptation sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007132810/587/21.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ09958. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Immo Foyer S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 77.986.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 24 août 2000, acte publié au
Mémorial C n
o
180 du 8 mars 2001, capital converti en Euro suivant avis publié au Mémorial C n
o
506 du 30 mars
2002, modifiée suivant acte publiée au Mémorial C n
o
858 du 6 juin 2002.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
133500
Luxembourg, le 22 octobre 2007.
<i>Pour IMMO FOYER S.à.r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Référence de publication: 2007132506/1261/18.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007, réf. LSO-CJ09083. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Batima Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9763 Marnach, 11, Dosberstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 111.061.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2007.
<i>BATIMA INVEST S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature
Référence de publication: 2007132536/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00609. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Sodefi S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 52.389.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le jeudi 20 septembre 2007 à 11.00 heures à Luxembourgi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus
et de la société COSAFIN SA, représentée par Monsieur Jacques Bordet.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Noël Didier arrivant à échéance, l'Assemblée Générale le
remercie de sa précieuse collaboration et nomme en son remplacement la société
VO CONSULTING Lux SA, 8, rue Haute, L-4963 Clémency
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée
approuvant les comptes au 30 juin 2008.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007132838/1172/21.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ04002. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Marguy Mootz S.à r.l. unipersonnelle, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9237 Diekirch, 5, place Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 100.484.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
133501
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 7 novembre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007132573/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2007, réf. DSO-CK00004. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070153231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Hotel Koener S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9710 Clervaux, 14, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 94.755.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 7 novembre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007132574/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2007, réf. DSO-CK00003. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(070153229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Société Nouvelle Ernzbach S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue des Jardins.
R.C.S. Luxembourg B 103.312.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 7 novembre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007132598/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2007, réf. DSO-CK00012. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070153290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Crédit Agricole Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 27.804.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 octobre 2006i>
En date du 27 octobre 2006, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de nommer Monsieur Jean-Jacques Ben-
soussan, CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT PARIS, 90, boulevard Pasteur, F-75015 Paris, en qualité d'Admi-
nistrateur de la Société.
Luxembourg, le 28 octobre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>G. Abel
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2007132827/1024/18.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI10377. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
D.W.L. Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 3, rue du Moulin.
R.C.S. Luxembourg B 98.646.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
133502
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 7 novembre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007132600/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2007, réf. DSO-CK00008. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070153299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Loeffler S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 1, Zone Industrielle Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 9.385.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007132605/832/12.
Enregistré à Diekirch, le 26 octobre 2007, réf. DSO-CJ00227. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070153403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Constructions Métalliques Kremer S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8440 Steinfort, 24, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 85.868.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007132607/832/12.
Enregistré à Diekirch, le 26 octobre 2007, réf. DSO-CJ00232. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070153406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
LBC Holdings GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 112.642.
<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 3 août 2007 à 11.00 heures à Luxembourgi>
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur William H. Wangerin de son poste de gérant et décide à l'una-
nimité de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la société:
Monsieur Olivier Gasche, 4, rue Etienne Jodelle, F-75018 Paris
Monsieur Alexandre Mongellaz, 55 bis, rue Jouffroy d'Abbans, F-75017 Paris.
Les nouveaux gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Pour copie conforme
G. Gasche / A. Mongellaz
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2007132836/1172/18.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08802. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
133503
Floorings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 124.719.
Il est à noter que la nouvelle adresse de Monsieur Michael Tose, gérant A de la société est dorénavant située au 36 St
Elmo Road, London, W12 9DX Grande-Bretagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2007.
<i>Pour FLOORINGS I S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007133206/1005/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01324. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070153977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
LP One Halbergmoos Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 113.794.
In the year two thousand and seven, on the thirty-first day of May.
Before Maître Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
(1) FIRST EURO INDUSTRIAL PROPERTIES II S.à r.l, a Société à responsabilité limitée governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, and registered in the
Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B-95555, represented by Flora Gibert, residing in
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
(2) LOGIC PARK EUROPE S.à r.l., a Société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, and registered in the Register of
Commerce and Companies of Luxembourg under number B-l13.569, represented by Flora Gibert, residing in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal. The above mentioned proxies, signed by the appearing person and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The shareholders have requested the undersigned notary to document that they are the sole shareholders of the
Société à responsabilité limitée LP ONE HALLBERGMOOS S.à r.l., having its registered office at L-1628 Luxembourg, 1,
rue des Glacis, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary dated 10 January, 2006,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 842 dated 27 April 2006, and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-113794 (the «Company»); The shareholders,
represented as above mentioned, having recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of
the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the share capital by an amount of EUR 12,500.- in order to bring the share capital from its former amount
EUR 12,500.- to EUR 25,000.- by way of the issue of 500 new shares having a par value of EUR 25.- each, together with
a share premium of EUR 309,468.-;
2. Subscription and payment to the share capital increase;
3. Subsequent amendment of article 3 of the articles of incorporation;
4. Amendment to the share register of the company;
5. Change of the registered office from 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg to 6, Parc d'Activités Syrdall, L-5365
Munsbach;
6. Subsequent amendment of article 1 of the articles of incorporation;
7. Creation of two categories of managers: Category A and category B;
8. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation; and
9. Statutory elections:
9.1. To approve the resignation of LOGIC PARK EUROPE Sàrl;
133504
9.2. To nominate as manager A: Olivier Dorier; and
9.3. To nominate as managers B: David Swan, Henry A. Thompson, Mohammed Chowd-hury, Asim Zafar.
Request the undersigned notary to document the following resolution:
<i>First resolutioni>
It is decided to increase the corporate capital by an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) so
as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to twenty-five thousand Euro
(EUR 25,000,-) by the issue of five hundred (500) new shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
<i>Second resolutioni>
It is decided to admit to the subscription of the 500 (five hundred) new shares:
1) FIRST EURO INDUSTRIAL PROPERTIES II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
2) LOGIC PARK EUROPE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon the prenamed subscribers, represented by Flora Gibert prenamed, by virtue of the aforementioned proxies;
declared to subscribe to the five hundred (500) new shares, each of them the number to which he has been admitted,
and to have them fully paid up by payment in cash, as well as a share premium amounting to EUR 309,468.- (three hundred
and nine thousand four hundred and sixty-eight Euro) so that from now on the company has at its free and entire disposal
the amount of EUR 321,968.- (three hundred and twenty-one thousand nine hundred and sixty eight Euro) as was certified
to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article 3 of the Articles of Incorporation to
read as follows:
«The share capital of the Company amounts to twenty five thousand euro (€ 25,000.-), divided into one thousand
(1,000) shares, each with a nominal value of € 25.- (twenty-five euro).»
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders decide to transfer the registered office of the company from L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis
to L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall.
<i>Fifth resolutioni>
The shareholders decide to amend the article 1.4 of the articles of incorporation to reflect the above resolution:
« Art. 1.4. The registered office is established in Munsbach.»
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholders decide to create two categories of Managers named Category A Managers and Category B Managers.
<i>Seventh resolutioni>
In order to reflect this resolution, the shareholders decide to amend article 5.1 and 5.3 of the articles of incorporation
as follows:
«5.1 The Company shall have at least three managers, divided into two categories named Category A Managers and
Category B Managers to be appointed or removed at any time, with or without cause, by a respective shareholders'
resolution. The managers may draw up standing rules (Geschäftsordnung) subject to an approving shareholders' resolu-
tion.»
«5.3 The company shall be bound by the joint signature of a Category A Manager and a Category B Manager. All powers
not expressly reserved by law or by the present articles to sole shareholder or the general meeting fall within the
competence of the managers.»
<i>Eighth resolutioni>
The shareholders decide to approve the resignation of LOGIC PARK EUROPE S. à r.l. as Manager.
The shareholders decide to nominate as Manager A: Olivier Dorier professionally residing in L-1628 Luxembourg, 1,
rue des Glacis
Are nominate as Managers B:
- David Swan, professionally residing in London SW1W8ER, 15 Sloane Square, 2nd Floor.
- Henry A. Thompson, professionally residing in London SW1W8ER, 15 Sloane Square, 2nd Floor.
- Mohammed Chowdhury, professionally residing in P.O. Box 1406 Manama Bahrain.
- Asim Zafar, professionally residing in London SW1W8ER, 15 Sloane Square, 2n Floor.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
133505
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille sept, le trente et un mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
(1) FIRST EURO INDUSTRIAL PROPERTIES II S.à r.l, une Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B-95555, représentée aux présentes par Flora Gibert, demeurant à Luxembourg en vertu
d'une procuration sous seing privé.
(2) LOGIC PARK EUROPE S.à r.l, une Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social
à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B-113.569,
représentée aux présentes par Flora Gibert, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé.
Les dites procurations après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné demeurera annexée
aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement. Les associés représentés comme dit est,
ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée LP ONE HAL-
BERGMOOS S. à .r.l. ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, constituée suivant acte reçu le 10
janvier 2006, en cours de publication au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, et immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-113794, («la Société») Les associés tels que
représentés ont déclaré avoir parfaite connaissance des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du Jour:i>
1. Augmentation du capital social d'un montant de EUR 12.500,- afin déporter le capital de son montant actuel de EUR
12.500,- à EUR 25.000,- par l'émission de 500 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune assorties
d'une prime d'émission de EUR 309.468,-;
2. Souscription et paiement;
3. Modification subséquente de l'article 3 des statuts;
4. Modification du registre départs sociales;
5. Transfert du siège social du 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 6, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach;
6. Modification subséquente de l'article 1
er
des statuts
7. Création de deux catégories de Gérants: Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B;
8. Modification subséquente de l'article 5 des statuts;
9. Nominations statutaires
9.1. Approbation de la révocation de LOGIC PARK EUROPE Sàrl;
9.2. Nomination en tant que gérant de catégorie A: Olivier Dorier; et
9.3. Nomination en tant que gérant de catégorie B: David Swan, Henry A. Thompson, Mohammed Chowdhury, Asim
Zafar.
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 12.500,- afin de porter le capital de son montant actuel
de EUR 12.500,- à EUR 25.000,- par l'émission de 500 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé d'admettre à la souscription des cinq cents (500) parts sociales nouvelles:
1) FIRST EURO INDUSTRIAL PROPERTIES II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
2) LOGIC PARK EUROPE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %26
Total: cinq cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ensuite les souscripteurs prédésignés, représentés par Flora Gibert, prénommée, en vertu des procurations dont
mention ci-avant; ont déclaré souscrire aux cinq cent (500) parts sociales nouvelles, chacun le nombre pour lequel il a
été admis,
133506
et les libérer intégralement en numéraire, avec une prime d'émission de EUR 309.468,- de sorte que la société a dès
maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 321.968,- (trois cent vingt et un mille neuf cent soixante-
huit Euro) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article 3.1 des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (€ 25.000,-), eingeteilt in 1.000 (eintausend)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (€ 25,-), die allesamt voll eingezahlt worden sind.»
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social du 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 6, Parc d'Activités
Syrdall, L-5365 Munsbach.
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés décident de modifier l'article 1.4 des statuts comme suit: «Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Münsbach.»
<i>Sixième résolutioni>
Les associés décident de créer deux catégories de gérants dénommés gérants de catégorie A et gérants de catégorie
B.
<i>Septième résolutioni>
Les associés décident de modifier en conséquence les articles 5.1 et 5.3 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Die Gesellschaft wird durch einen Rat der aus wenigstens einem Kategorie A Geschäftsführer und einem Kategorie
B Geschäftsführer besteht, die Gesellschafter sind oder nicht, und die von der Gesellschafterversammlung ernannt wer-
den, verwaltet.»
«Die Gesellschaft wird nach außen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern davon wenigstens
eine Unterschrift der Kategorie A und eine Unterschrift der Kategorie B, verpflichtet.»
<i>Huitième résolutioni>
Les associés décident d'approuver la révocation de LOGIC PARK EUROPE S. à r.l. de ses fonctions de gérant.
Les associés décident de nommer aux fonctions de Gérant A: Olivier Dorier demeurant professionnellement à L-1628
Luxembourg, 1, rue des Glacis.
Et de nommer aux fonctions de Gérants B:
- David Swan, demeurant professionnellement à Londres SW1W8ER, 15 Sloane Square, 2nd Floor.
- Henry A. Thompson, demeurant professionnellement à Londres SW1W8ER, 15 Sloane Square, 2nd Floor.
- Mohammed Chowdhury, demeurant professionnellement à P.O Box 1406 Manama Bahrain.
- Asim Zafar, demeurant professionnellement à Londres SW1W8ER, 15 Sloane Square, 2nd Floor.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2007, Relation: LAC/2007/10983. — Reçu 3.219,68 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007133442/211/188.
(070154433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.
CommCapital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 106.053.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
46460 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
133507
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007133124/211/11.
(070154264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
Herinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 95.149.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 19 octobre 2007 a 11.00 heures à Luxembourgi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de M. Jean Quintus et de la
société COSAFIN S.A. représentée par M. Jacques Bordet ainsi que de M. Pierre Schill, Commissaire aux Comptes.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer comme nouvel Administrateur:
M. Joseph Winandy, 92, rue de l'Horizon, Plateau St-Hubert, L-5960 Itzig
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée
Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2008.
Pour copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007133119/1172/20.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01175. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
Alcmena, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 76.638.
Le bilan au 30 juin 2007 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007133118/4775/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2007, réf. LSO-CK00095. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070154258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
Eastwood S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 26.517.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 22 octobre 2007i>
<i>Résolutionsi>
Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
- de nommer Monsieur Jean Quintus comme Président du Conseil d'Administration.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007133115/1172/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01170. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
133508
Pembroke S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 24.777.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8 octobre 2007 a 10.00 heures a Luxembourgi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats de Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus et de la société
COSAFIN S.A., Administrateurs, et de Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux comptes.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2008.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007133114/1172/18.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01161. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070153821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
Revolia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.759.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 9 novembre 2007.
H. Beck
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007133113/201/12.
(070154049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
ICG-Gemco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Alicor S.à r.l.).
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 127.777.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 7 novembre 2007.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007133112/202/13.
(070153796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
Omnium Européen d'Entreprises O.E.E., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 6.438.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil administration qui s'est tenue le 22 octobre 2007i>
<i>Résolutionsi>
Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
- de nommer Monsieur Jean Quintus comme Président du Conseil d'Administration.
133509
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007133110/1172/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01167. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
Colyzeo II Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.
R.C.S. Luxembourg B 133.184.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
COLYZEO INVESTORS II, L.P., un limited partnership constitué sous les lois anglaise et galloise, enregistré sous le
numéro LP11864, ayant son siège social 10 Upper Bank Street, London, E14 5JJ, United Kingdom,
Ici représentée par Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte d'une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée
1. Forme - Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de COLYZEO II
DEVELOPMENT S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après dénommée la «Société»), et, en
particulier, la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après dénommée la «Loi»),
ainsi que par les présents statuts (ci-après dénommés les «Statuts»).
2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des Associés (définis à l'article 5) délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.3 Toutefois, le Gérant (défini à l'article 8) est autorisé à transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la Ville
de Luxembourg.
2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-
promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de siège
social, restera de nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant.
3. Objet.
3.1 La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres,
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participa-
tions.
La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et droits de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute société ou entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière tous titres et droits, les mettre en valeur, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange
ou autrement, contracter des emprunts ou obtenir toute forme de crédit, délivrer à cet égard toutes garanties pour
couvrir ses obligations et accorder à ses filiales ou toutes sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou
encore à toutes sociétés qui seraient associés de la Société tous concours, prêts, avances ou garanties.
3.2 La Société aura en outre pour objet d'assister sa société mère dans le suivi des projets d'investissement identifiés
par cette dernière, avec pour mission notamment de coordonner les travaux d'analyse et de contrôle engagés sur ces
projets.
133510
3.3 La Société pourra aussi réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers et, en général, toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplisse-
ment de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter
l'accomplissement de son objet social.
4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capital, Parts
5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- €) représenté par cent vingt-cinq (125)
parts sociales (ci-après dénommées les «Parts Sociales» ou, chacune, une «Part Sociale»). Chaque Part Sociale a une valeur
nominale de cent Euros (100,- €). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les «Associés».
5.2 En sus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission
payée pour toute Part Sociale sera versée.
5.3 Toutes les Parts Sociales ont des droits égaux.
6. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, si bien que seul un propriétaire est admis
par Part Sociale. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
7. Transfert des Parts.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par un des Associés sont librement
transmissibles à un autre Associé.
7.3 En cas de cession à un non-Associé, les Parts Sociales détenues par chaque Associé pourront être cédées confor-
mément aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
7.4 Chaque Associé s'engage en outre à ne pas céder, mettre en gage ou conférer des garanties sur les Parts Sociales
qu'il détient sans l'accord écrit préalable du Gérant.
Titre III. Gérance
8. Gérance.
8.1 La Société est gérée par un Gérant (ci-après dénommé le «Gérant»). Le Gérant n'est pas obligatoirement Associé.
8.2 Le Gérant peut être révoqué à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des Associés titulaires
de la majorité des droits de votes.
9. Pouvoirs du Gérant. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en
toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes d'administration et de disposition ainsi que toutes opé-
rations conformes à l'objet social de la Société.
10. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par la seule signature de son Gérant ou par la
signature de toute personne à laquelle ce pouvoir aura été délégué par le Gérant.
11. Délégation et mandataires du Gérant.
11.1 Le Gérant peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.
11.2 Le Gérant détermine, le cas échéant, les responsabilités et la rémunération de tout mandataire, la durée de leur
mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Titre IV. Assemblée Générale des Associés
12. Pouvoirs de l'assemblée générale des Associés - Votes.
12.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés au Gérant par la loi ou les Statuts seront de la compétence de
l'assemblée générale des Associés.
12.2 En particulier, l'assemblée générale des Associés est compétente pour modifier les Statuts, changer la nationalité
de la Société et augmenter les engagements de ses Associés.
12.3 Chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de Parts Sociales qu'il
détient. Chaque Associé possède des droits de vote en proportion avec le nombre de Parts Sociales qu'il détient.
12.3 Lorsqu'un Associé détient toutes les Parts Sociales, il exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée
générale des Associés et ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
13. Tenue d'assemblées générales.
13.1 Des assemblées générales pourront toujours être convoquées par le Gérant.
13.2 Lorsque la Société aura plus de vingt-cinq Associés, il devra être tenu, chaque année, une assemblée générale le
dernier vendredi du mois de juin de chaque année.
133511
13.3 Quel que soit le nombre d'Associés, le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'approbation de
l'Associé (ou des Associés). L'Associé (ou les Associés) se prononcera (ou se prononceront) également par un vote
spécial sur la décharge à donner au Gérant.
14. Majorités.
14.1 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié
du capital social les adoptent. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première réunion ou consultation écrite, les Associés
sont convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées et les décisions sont prises à la majorité des
votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.
14.2 Les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptées que conformément aux dispositions de la Loi et
par une majorité d'Associés représentant les trois quarts du capital social de la Société.
14.3 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Associés ne peuvent
être décidés qu'avec l'accord unanime des Associés et conformément à toute autre disposition légale.
Titre V. Exercice social
15. Exercice social.
15.1 L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
15.2 A la fin de chaque exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant. Le Gérant prépare un
inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
15.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.
16. Droit de distribution sur les Parts.
16.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des amortissements et des
autres charges, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.
16.2 Cinq pour cent (5%) du bénéfice annuel net de la Société ainsi déterminé seront obligatoirement prélevés et
alloués à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que le montant de la réserve légale aura atteint
dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société mentionné à l'article 5 des Statuts ou, le cas échéant, tel qu'il
sera augmenté ou réduit.
16.3 Dans la mesure où des fonds sont disponibles au niveau de la Société aux fins de distribution et dans la mesure
où la loi et les Statuts le permettent, le Gérant pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.
16.4 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer leur montant seront pris par l'assemblée générale des
Associés.
16.5 Des acomptes sur dividendes pourront être versés sur décision du Gérant à condition:
16.5.1 qu'un état comptable intermédiaire soit établi et que ce-dernier fasse apparaître que les fonds disponibles pour
la distribution sont suffisants; et
16.5.2 que le montant à distribuer n'excède pas le montant des résultats réalisés depuis le fin du dernier exercice social
dont les comptes ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les
réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserves en vertu d'une
obligation légale ou statutaire.
Titre VI. Liquidation
17. Causes de dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils,
d'insolvabilité ou de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.
18. Liquidation.
18.1 La liquidation de la Société ne peut être décidée que par la majorité des Associés représentant les trois quarts
du capital social de la Société.
18.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Titre VII. Loi applicable
19. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une stipulation spécifique dans les Statuts il est fait référence à
la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 Décembre 2008.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
133512
Parts
Sociales
COLYZEO INVESTORS II, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Total: cent vingt-cinq Parts Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de
douze mille cinq cents Euros (12.500,- €) correspondant à un capital de douze mille cinq cents Euros (12.500,- €) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille huit cents Euros.
<i>Assemblée Généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris la résolution suivante:
1) Est nommée aux fonctions de Gérant pour une période indéterminée: COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l., société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 88.540.
Conformément à l'article 10 des Statuts, la Société se trouvera valablement engagée par la seule signature de son
Gérant ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par le Gérant.
2) Le siège social de la Société est établi au 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue française, suivi d'une version anglaise, et en cas de divergence entre le texte
français et le texte anglais, le texte français fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and seven, on the twenty-fifth of October.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
COLYZEO INVESTORS II, L.P., a limited partnership established under the law of England and Wales, registered under
the number LP11864 and whose principal place of business is at 10 Upper Bank Street, London, E14 5JJ, United Kingdom
here represented by Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy-holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée):
Articles of incorporation
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Form - Corporate name. There is hereby formed a private limited liability company under the name of COLYZEO
II DEVELOPMENT S.à r.l., which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter referred to as the
«Company»), and, in particular, by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended from time to time
(hereafter referred to as the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter referred to as the
«Articles»).
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its Shareholders (as defined in article 5) deliberating in the manner provided for amend-
ments to the Articles.
2.3 However, the Manager (as defined in article 8) is authorised to transfer the registered office of the Company within
the City of Luxembourg.
133513
2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measure will however
not have any effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered
office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made
by the Manager.
3. Object.
3.1 The corporate object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring
of participating interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign
companies or enterprises, as well as the administration, the management, the control and the development of those
participating interests.
In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and rights of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any company or enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option or in any other
way, any securities and rights, to borrow or to obtain any form of credit facility, to give guarantees in order to secure its
obligations and to grant to its subsidiaries or any other company in which the Company has a direct or indirect interest
or any company being a shareholder of the Company any assistance, loans, advances or guarantees.
3.2 Moreover, the Company will have for purpose to assist its parent company in the follow-up of its investment
projects and in particular, to coordinate the due diligences involved by these projects.
3.3 The Company may also perform all legal, commercial, technical and financial transactions, any transactions in respect
of real estate or moveable property, and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate
object as well as all transactions directly or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the
accomplishment of its corporate object.
4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II. Capital, Shares
5. Share capital.
5.1 The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) represented by one hundred and
twenty-five (125.-) shares (hereafter referred to as the «Shares» and each as a «Share»). Each Share has a nominal value
of one hundred Euro (€ 100.-). The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders.
5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any Share
shall be transferred.
5.3 All Shares will have equal rights.
6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Shares are indivisible, so that only one owner is admitted per Share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
7. Transfer of Shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by one of the Shareholders are freely transferable to another
Shareholder.
7.3 In case of transfer to a non-Shareholder, the Shares held by each Shareholder may be transferred in compliance
with the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
7.4 In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share without
the prior written consent of the Manager.
Chapter III. Management
8. Management.
8.1 The Company is managed by one manager (hereafter referred to as the «Manager»). The Manager needs not to
be Shareholder.
8.2 The Manager may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of Shareholders holding a majority
of voting rights.
9. Power of the Manager. In dealing with third parties, the Manager will have all powers to act in the name and on
behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all administration (actes d'administration) and
disposition acts (actes de disposition) as well as all operations consistent with the Company's object.
10. Representation of the Company. The Company shall validly be bound by the sole signature of its Manager or by
the signature of any person to whom such power shall be delegated by the Manager.
11. Delegation and agent of the Managers.
11.1 The Manager may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
133514
11.2 The Manager will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period
of representation and any other relevant conditions of its agency.
Chapter IV. General Meeting of Shareholders
12. Powers of the general meeting of Shareholders - Votes.
12.1 All powers not expressly reserved to the Manager by law or by the Articles fall within the competence of the
general meeting of Shareholders.
12.2 In particular, the general meeting of the Shareholders is competent to amend the Articles, to change the nationality
of the Company and to increase the commitments of its Shareholders.
12.3 Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares he owns. Each
Shareholder has voting rights commensurate with the number of Shares he holds.
12.4 In case of one Shareholder owning all the Shares, he will assume all powers conferred to the general Shareholders'
meeting and its decisions are recorded in minutes or drawn-up in writing.
13. Holding of general meetings.
13.1 Shareholders meetings may always be convened by the Manager.
13.2 Should the Company have more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be held
each year on the last Friday of February of each year.
13.3 Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the
Shareholder(s) for approval. The Shareholder(s) shall also specifically vote as to whether discharge is to be given to the
Manager.
14. Majorities.
14.1 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the Share capital
adopt them. If that quorum is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be
convened or consulted a second time by registered letter and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast,
regardless of the portion of capital represented.
14.2 Resolutions to alter the Articles may only be adopted in accordance with any provisions of the Law and by the
majority of the Shareholders representing three-quarters of the Company's Share capital.
14.3 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be
increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Chapter V. Business year
15. Business year.
15.1 The Company's financial year starts on the first day of January and ends on the thirty-first of December of each
year.
15.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Manager. The Manager prepares
an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
15.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
16. Distribution right on Shares.
16.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, depreciations and
other charges, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.
16.2 From the annual net profits of the Company thus determined, five percent (5%) shall compulsorily be allocated
to the legal reserve. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten percent
(10%) of the subscribed share capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time
to time.
16.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by law and by these Articles, the Manager shall propose that cash available for remittance be distributed.
16.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the
general meeting of the Shareholders.
16.5 Interim dividends may be paid out upon decision of the Manager provided that:
16.5.1 interim accounts have been drawn-up and show that the funds available for distribution are sufficient; and
16.5.2 the amount to be distributed does not exceed the total profits realised since the end of the last financial year
for which the annual accounts have been approved, increased by any profits carried forward and sums drawn from reserves
available for distribution and reduced by losses carried forward and any sums to be allocated to any reserve pursuant to
the law or the Articles.
Chapter VI. Liquidation
17. Causes of dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
133515
18. Liquidation.
18.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing
three-quarters of the Company' share capital.
18.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
Chapter VII. Applicable Law
19. Applicable Law Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is
made in these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on the 31
December 2008.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
Shares
COLYZEO INVESTORS II, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Total: one hundred and twenty-five Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-)
corresponding to a share capital of twelve thousand five hundred Euros (€ 12,500.-) is forthwith at the free disposal of
the Company, as has been proved to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand eight hundred Euros.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolution:
1) Is appointed as Manager for an undetermined period: COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg (Grand
Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B
88.540.
In accordance with article 10 of the by-laws, the Company shall validly be bound by the sole signature of its single
Manager or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by the Manager.
2) The Company shall have its registered office at 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg (Grand Duchy of Lux-
embourg).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in French, followed by a English version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, Relation: LAC/2007/33097. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): F. Schneider.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007133612/211/360.
(070154458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.
International Research and Development (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 16.291.
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2007, VALON S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon,
L-1150 Luxembourg, LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg et KOFFOUR S.A.,
société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ont été nommées Administrateurs en remplacement de Mme
133516
Romaine Fautsch, M. Jean Bodoni et M. Guy Kettmann, démissionnaires. Leurs mandats s'achèveront à l'issue de l'as-
semblée générale annuelle de 2008.
Luxembourg, le 29 octobre 2007.
<i>Pour INTERNATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT (LUXEMBOURG) S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG
C. Royemans / L. Heck
Référence de publication: 2007133105/1017/18.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00311. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070154321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
IBR Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 132.140.
Par décision des conseils d'administrations du 14 septembre 2007 de VALON S.A. KOFFOUR S.A. et LANNAGE S.A.,
il a été procédé à la nomination de représentants permanents des administrateurs: VALON S.A. a nommé Monsieur Guy
Kettmann comme représentant permanent, KOFFOUR S.A. a nommé Monsieur Guy Baumann comme représentant
permanent, LANNAGE S.A. a nommé Monsieur Jean Bodoni comme représentant permanent.
Luxembourg, le 29 octobre 2007.
<i>Pour IBR INVEST S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG
G. Kettmann / G. Baumann
Référence de publication: 2007133189/1017/17.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00308. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070154105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
AB Acquisitions Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 129.467.
In the year two thousand and seven, on the thirteenth of August.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
- AB ACQUISITIONS HOLDINGS LIMITED, a private limited company organized and existing under the laws of
Gibraltar, registered with the Registrar of Companies Gibraltar under number 98476, having its registered office at 57/63
Line Wall Road, Gibraltar,
here represented by Mrs. Céline Grosjean, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Gibraltar on
the thirteenth of August 2007.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of AB ACQUISITIONS LUXCO 2 S.à r.l., (hereinafter «the Company»)
a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 129.467, incorporated pursuant to a deed of the un-
dersigned notary dated June 26, 2007, whose articles of association have not yet been published in the Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations (the «Mémorial C»), and whose bylaws have not been amended since the incorpo-
ration of the Company.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of three hundred million and two
thousand sterling pounds (GBP 300,002,000.-), so as to raise it from its present amount of ten thousand sterling pounds
(GBP 10,000.-) up to three hundred million and twelve thousand sterling pounds (GBP 300,012,000.-) by the issue of
three hundred million and two thousand (300,002,000) shares, having a par value of one sterling pound (GBP 1.-) each
(collectively referred as the «New Shares») and having the same rights and obligations as the existing shares.
133517
The three hundred million and two thousand (300,002,000) New Shares are subscribed by AB ACQUISITIONS
HOLDINGS LIMITED, prenamed, paid up by a contribution in kind consisting in a part of all the assets and liabilities of
AB ACQUISITIONS HOLDINGS LIMITED, prenamed. The remaining assets and liabilities of AB ACQUISITIONS
HOLDINGS LIMITED are contributed simultaneously to AB ACQUISITION LUXCO 1 S.à r.l., a société à responsabilité
limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 59,
rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 129.314.
The sole shareholder declares that the portion of the all assets and liabilities contributed by AB ACQUISITIONS
HOLDINGS LIMITED are composed as follows as per 13th of August 2007:
- interest free convertible preferred certificates issued by the Company in favour of AB ACQUISITIONS HOLDINGS
LIMITED for an amount of GBP 1,499,910,000.-;
- 10,000 shares of the Company having a par value of one sterling pounds (GBP 1.-) each;
- 10,000 class A shares of AB ACQUISITIONS LUXCO 1 S.à r.l.; and
- a claim against the Company in the amount of GBP 90,000 pursuant to the terms of an interest free loan agreement.
The total contribution of one billion five hundred million and twenty thousand sterling pounds (GBP 1,500,020,000.-)
for the New Shares will be allocated as follows: (a) three hundred million and two thousand sterling pounds (GBP
300,002,000.-) are allocated to the Company's share capital and (b) one billion two hundred million and eighteen thousand
sterling pounds (GBP 1,200,018,000.-) are allocated to the Company's share premium account.
Evidence of the transfer of this part of the assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a copy of
a contribution agreement and of a valuation report established by the management of the Company.
Said report and contribution agreement, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to reduce the share capital of the Company by an amount of ten thousand sterling pounds
(GBP 10,000.-) by the cancellation of ten thousand (10,000) shares with a nominal value of one sterling pound (GBP 1.-)
each and entirely paid up, held by the Company on itself subsequently to the contribution by AB ACQUISITIONS
HOLDINGS LIMITED of a part of its assets and liabilities which includes its shareholding in the Company.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the articles of incorporation of the Company is
amended and now reads as follows:
« Art. 6. The share capital is set at three hundred million and two thousand sterling pounds (GBP 300,002,000.-)
represented by three hundred million and two thousand (300,002,000) shares with a par value of one sterling pound (GBP
1.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»
<i>Estimate of costsi>
Insofar as:
(1) the contribution in kind consists of a part of the all the assets and liabilities constituting of a company (the remaining
portion of the all asset contribution being made simultaneously to another Luxembourg based company);
(2) the contribution is made exclusively against the allotment of new shares and
(3) all the companies enclosed have their registered office in the European Union,
such contribution qualifies under the terms of Article 4-1 of the law date December 29th, 1971, which provides for
capital duty exemption.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to seven thousand euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le treize août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
133518
AB ACQUISITIONS HOLDINGS LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois de
Gibraltar, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Gibraltar sous le numéro 98476 ayant son siège
social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar,
ici représentée par Madame Céline Grosjean, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing
privé donnée à Gibraltar le treize août 2007.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'actionnaire unique de AB ACQUISITIONS LUXCO 2 S.à r.l. (ci après la «Société»),
une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises ayant son siège social au 59, rue
de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.467, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 26 juin 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts n'ont pas été
amendés depuis la constitution de la Société.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trois cent millions et deux
mille livres sterling (GBP 300.002.000,-), afin de le porter de son montant actuel de dix mille livres sterling (GBP 10.000,-)
jusqu'à trois cent millions et douze mille livres sterling (GBP 300.012.000,-) par l'émission de trois cent millions et deux
mille (300.002.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune et ayant les
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les «Nouvelles Parts Sociales»)
Les trois cent millions et deux mille (300.002.000) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par AB ACQUISITIONS
HOLDINGS LIMITED, prénommée, payées par un apport en nature consistant en l'apport d'une partie de l'ensemble du
passif et de l'actif de AB ACQUISITIONS HOLDINGS LIMITED. Les actifs et les passifs restants de AB ACQUISITIONS
HOLDINGS LIMITED sont apportés simultanément à AB ACQUISITION LUXCO 1 S.à r.l., une société à responsabilité
limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 129.314.
L'associé unique déclare que la portion des actifs et passifs d'AB ACQUISITIONS HOLDINGS LIMITED est composé
des éléments suivants au 13 août 2007:
- une dette de GBP 1.499.910.000,- représentée par des convertible preferred certificates sans intérêts émis par la
Société en faveur de AB ACQUISITIONS HOLDINGS LIMITED;
- 10,000 actions de la Société ayant chacune une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-);
- 10,000 actions de Catégorie A de AB ACQUISITIONS LUXCO 1 S.à .r.l.; et
- une dette contre la Société d'un montant de GBP 90.000 suivant un contrat de prêt convertible émis par la Société.
L'apport d'un milliard cinq cent millions et vingt mille livres sterling (GBP 1.500.020.000,-) sera alloué comme suit: (a)
trois cent millions et deux mille livres sterling (GBP 300.002.000,-) seront alloués au capital de la Société et (b) un milliard
deux cent millions et dix-huit mille livres sterling (GBP 1.200.018.000,-) seront alloués au compte de prime d'émission.
Une copie du contrat d'apport ainsi que d'un rapport d'évaluation établi par la gérance de la Société, mettant en
évidence le transfert des actifs et passifs a été remis au notaire instrumentant.
Le rapport et le contrat d'apport signés ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné
resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de réduire le capital social de la société par un montant de dix mille livres sterling (GBP 10.000,-)
par l'annulation de dix mille (10.000) parts sociales d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, toutes
entièrement libérées, détenues par la Société sur elle même à la suite de l'apport d'une partie de ses actifs et passifs fait
par AB ACQUISITIONS HOLDINGS LIMITED, qui comprend sa participation dans la Société.
<i>Troisième résolutioni>
A la suite des résolutions ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme
suit:
« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trois cent millions et deux mille livres sterling (GBP 300.002.000,-)
représenté par trois cent millions et deux mille (300.002.000) parts sociales d'une valeur d'une livre sterling (GBP 1,-)
chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.»
<i>Evaluations de fraisi>
Dans la mesure où:
133519
(1) l'apport en nature consiste dans une partie des actifs et passifs comprenant d'une société (sachant que l'autre partie
des actifs et passifs est apportée simultanément à une autre société);
(2) l'apport est fait exclusivement contre distribution des nouvelles actions, et
(3) toutes les sociétés concernées ont leur siège social dans l'Union Européenne,
un tel apport entre dans le champ d'application de l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exemption
de droit d'apport.
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à sept mille euros.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Grosjean, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 août 2007, Relation: EAC/2007/10112. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 21 septembre 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007133542/239/163.
(070154877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.
Crown Corporate Services, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 77.027.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2007.
M. Schaeffer
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007133805/5770/12.
(070154688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.
InterFact S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 82.163.
In the year two thousand and seven, on the fifth day of the month of November.
Before Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared M
e
Marco Rasqué da Silva, maître en droit, residing in Luxembourg as proxyholder on behalf of
MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the
laws of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, being the sole member of
INTERFACT S.à.r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 2, rue Edmond
Reuter, L-5326 Contern, incorporated by deed of notary M
e
Martine Decker, on 3rd May 2001, published in the Mémorial
C, Recueil des
Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 1113 on 5th December 2001. The articles of incorporation of the
Company have been amended for the last time on 30th April 2003 by deed of notary M
e
Léon Thomas called Tom
Metzler, published in the Mémorial number 563 on 23rd May 2003.
The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all one thousand two hundred and forty (1,240) shares in issue in the Company, so that
decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:
A. Amendment of article 15 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:
133520
« Art. 15. Representation of the Company. Vis-à-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board
of managers) has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise
and approve all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound by the individual signature of
anyone of the manager(s) or by the sole signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated
by anyone of the managers.»
The decision taken by the sole member is as follows:
<i>Sole resolutioni>
It is resolved to amend article 15 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
« Art. 15. Representation of the Company. Vis-à-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board
of managers) has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise
and approve all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound by the individual signature of
anyone of the manager(s) or by the sole signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated
by anyone of the managers.»
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this notarial deed are estimated at € 900.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person, in case
of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Done in Luxembourg on the day beforementioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le cinquième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, Grand Duché de Luxembourg,
A comparu M
e
Marco Rasqué da Silva, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en tant que mandataire de MUL-
TINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE S .à r .l., une société à responsabilité limitée régie par la loi
luxembourgeoise, ayant son siège social au 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, étant l'associé unique de INTERFACT
S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern,
constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Decker, le 3 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le «Mémorial») sous le numéro 1113 du 5 décembre 2001. Les statuts de la Société ont été modifiés pour
la dernière fois le 30 avril 2003 suivant acte reçu par le notaire Léon Thomas dit Tom Metzler, publié au Mémorial numéro
563 du 23 mai 2003.
Le mandataire déclare et prie le notaire d'acter que;
1. L'associé unique détient toutes les mille deux cent quarante (1.240) parts sociales émises de la Société, de sorte
que les décisions peuvent valablement être prises sur les points portés à l'ordre du jour.
2. Les points sur lesquels les résolutions doivent être prises sont les suivants:
A. Modification de l'article 15 des statuts de la Société qui se lira comme suit:
« Art. 15. Représentation de la Société. Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d'un conseil de gérance) ont vis-
à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire,
autoriser et approuver tous actes et opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle
de chacun du/des gérant(s) ou par la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront
été délégués par le ou un des gérants.»
La décision prise par l'associé unique est la suivante:
<i>Résolution uniquei>
Il est décidé de modifier l'article 15 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 15. Représentation de la Société. Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d'un conseil de gérance) ont vis-
à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire,
autoriser et approuver tous actes et opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle
de chacun du/des gérant(s) ou par la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront
été délégués par le ou un des gérants.»
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent
acte sont évaluées à € 900,-.
133521
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la partie comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Rasqué da Silva, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 6 novembre 2007. Relation: EAC/2007/13627. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-AIzette, le 7 novembre 2007.
B. Moutrier.
Référence de publication: 2007133610/272/86.
(070154974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.
LBREP II Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.111.025,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 106.232.
In the year two thousand and seven, on the first of October.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appear:
HARBOR BERMUDA, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered office at
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 36.838;
LBPOL BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered
office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 36.831;
SERICO BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered
office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 36.987;
IPPOCRATE BERMUDA HOLDINGS, LP., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its
registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37.035;
POSEIDON BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its
registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37.034;
LINCO BERMUDA HOLDINGS, LP., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered
office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37.695;
WILLIAM BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its regis-
tered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37.769;
LE PROVENÇAL BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its
registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37893;
SIERRA BIANCA BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its
registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 36811;
ANGEL CITY BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its
registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37771;
WILLIAM II BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its
registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 38357;
NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its reg-
istered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 38628;
CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having
its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 38644;
ZOLIBORZ BERMUDA HOLDINGS, LP., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its reg-
istered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 38212;
SEGOVIA BERMUDA HOLDINGS, L.P., an exempted partnership, having its registered office at Clarendon House, 2
Church Street, Hamilton HM II, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 39005;
DUNA BERMUDA HOLDINGS, L.P., an exempted partnership, having its registered office at Clarendon House, 2
Church Street, Hamilton HM II, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 39033;
LION BERMUDA HOLDINGS, L.P., an exempted partnership, having its registered office at Clarendon House, 2
Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 38888,
133522
ADAM BERMUDA HOLDINGS, L.P., an exempted partnership, having its registered office at Clarendon House, 2
Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 39148,
REPE LBREP II L.L.C., a limited liability company, having its registered office at C/O LEHMAN BROTHERS INC, 399
Park Avenue, New York 10022, USA, registered with the Secretary of State of Delaware under number 3856984,
FOX BERMUDA HOLDINGS, L.P., an exempted partnership, having its registered office at Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 39428,
GRACECHURCH BERMUDA HOLDINGS, L.P., an exempted partnership, having its registered office at Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number
39354,
MC&S BERMUDA HOLDINGS, LP., an exempted partnership, having its registered office at Clarendon House, 2
Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 39682,
GOODWATER BERMUDA HOLDINGS, L.P. an exempted partnership, having its registered office at Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number
39.455.
All here represented by Ms. Stéphanie Colson, employee, with professional address at Senningerberg, by virtue of
twenty-three (23) proxies established on September 29th, 2007.
The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)
existing in Luxembourg under the name of LBREP II EUROPE HOLDINGS S.à r.l., with registered office at 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 106.232,
incorporated by a deed of the undersigned notary of January 19th, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 600, dated June 22nd, 2005, and whose bylaws have been lastly amended by an extraordinary
general meeting held on April 16th, 2007, in front of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 1515, dated July 20th, 2007.
II. The Company's share capital is fixed at eight hundred forty-seven thousand five hundred fifty Euro (€ 847,550.-)
divided into six hundred fifty-five (655) class A ordinary shares, six hundred and three (603) class B ordinary shares, seven
thousand one hundred and seventy-nine (7,179) class C ordinary shares, three thousand five hundred eighty-one (3,581)
class D ordinary shares, two hundred and twenty-three (223) class E ordinary shares, six thousand seventy-five (6,075)
class F ordinary shares, one hundred and one (101) class G ordinary shares, six thousand sixty-one (6,061) class H ordinary
shares, forty (40) class I ordinary shares, forty (40) class J ordinary shares, seventy-five (75) class K ordinary shares,
seventy-five (75) class L ordinary shares, three hundred thirty two (332) class M ordinary shares, seventy-five (75) class
N ordinary shares, seventy-five (75) class O ordinary shares, two thousand eight hundred and ninety-three (2,893) class
P ordinary shares, seventy-five (75) class Q ordinary shares, three thousand eight hundred and forty (3,840) class R
ordinary shares, seventy-five (75) class S ordinary shares, one thousand three hundred seventy-nine (1,379) class T
ordinary shares, seventy-five (75) class U ordinary shares, seventy-five (75) class V ordinary shares, seventy-five (75) class
W ordinary shares, seventy-five (75) class X ordinary shares, seventy-five (75) class Y ordinary shares and seventy-five
(75) class Z ordinary shares, all with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each.
III. The shareholders resolve to increase the Company's corporate capital to the extent of three hundred thousand
one hundred fifty Euro (€ 300,150.-) to raise it from its present amount of eight hundred forty-seven thousand five
hundred fifty Euro (€ 847,550.-) to one million one hundred forty-seven thousand seven hundred Euro (€ 1,147,700.-)
by creation and issue of five thousand nine hundred forty-two (5,942) class O shares (the «O New Shares»), three
thousand nine hundred seventy-seven (3,977) class Y shares (the «Y New Shares») and two thousand eighty-seven (2,087)
class Z shares (the «Z New Shares»), all with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each.
IV. HARBOR BERMUDA, LP., prenamed, LBPOL BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, IPPOCRATE BERMUDA
HOLDINGS, L.P., prenamed, POSEIDON BERMUDA HOLDINGS, LP., prenamed, LINCO BERMUDA HOLDINGS L.P.,
prenamed, WILLIAM BERMUDA HOLDINGS, LP., prenamed, LE PROVENCAL BERMUDA HOLDINGS L.P., prenamed,
SIERRA BIANCA BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, ANGEL CITY BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, DU-
NA BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, WILLIAM II BERMU-
DA HOLDINGS, L.P., prenamed, CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, ZOLIBORZ BERMUDA
HOLDINGS, L.P., prenamed, SEGOVIA BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, SERICO BERMUDA HOLDINGS, L.P.,
prenamed, ADAM BERMUDA HOLDINGS L.P., prenamed, REPE LBREP II LLC., prenamed, FOX BERMUDA HOLDINGS
L.P., prenamed, GRACECHURCH BERMUDA HOLDINGS L.P., prenamed, MC&S BERMUDA HOLDINGS L.P., pre-
named, GOODWATER BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, and LION BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed,
resolve to waive their preferential subscription right in favor of NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, for
the subscription of the O New Shares, in favor of MC&S BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, for the subscription
of the Y New Shares and in favor of FOX BERMUDA HOLDINGS L.P., prenamed, for the subscription of the Z New
Shares.
133523
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
- NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, declared to subscribe for the five thousand nine hundred forty-
two (5,942) O New Shares with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each, and have them fully paid up in the
amount of one hundred forty-eight thousand five hundred fifty Euro (€ 148,550.-), together with a share premium in the
amount of twenty-four Euro (€ 24.-), by contribution in kind in the total amount of one hundred forty-eight thousand
five hundred seventy-four Euro (€ 148,574.-) consisting in the cancellation of the following receivables:
- a receivable in the amount of ten thousand six hundred twenty-five Euro (€ 10,625.-) held by NEPTUNE BERMUDA
HOLDINGS, L.P., prenamed, towards the Company, by virtue of an interest free loan agreement executed between
NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, and the Company on July 12th, 2007, with effect as of June, 8th,
2006, whereby NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, LP., prenamed, granted a loan in the amount often thousand six
hundred twenty-five Euro (€ 10,625.-) to the Company;
- a receivable in the amount of one hundred thousand eighty-six British Pound and ninety-one pence (GBP 100,086.91)
held by NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, towards the Company, by virtue of an interest free loan
agreement executed between NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, and the Company on July 12th, 2007,
with effect as of February 20, 2007, whereby NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, granted a loan in the
amount of one hundred thousand eighty-six British Pound and ninety-one pence (GBP 100,086.91) to the Company;
- a receivable in the amount of sixteen British Pound and seventeen pence (GBP 16.17) held by NEPTUNE BERMUDA
HOLDINGS, L.P., prenamed, towards the Company, by virtue of an interest free loan agreement executed between
NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, and the Company on July 12th, 2007, with effect as of February 20,
2007, whereby NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, granted a loan in the amount of sixteen British Pound
and seventeen pence (GBP 16.17) to the Company.
Proof of the existence and value of such receivables has been given to the undersigned notary by a copy of the three
(3) interest free loan agreements executed between NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, and the Com-
pany.
- MC&S BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, declared to subscribe for the three thousand nine hundred seventy-
seven (3,977) Y New Shares with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each, and have them fully paid up in the
amount of ninety-nine thousand four hundred twenty-five Euro (€ 99,425.-), together with a share premium in the amount
of ten Euro (€ 10.-), by contribution in kind in the total amount of ninety-nine thousand four hundred thirty-five Euro (€
99,435.-) consisting in the cancellation of a portion in the same amount of a receivable in the amount of six hundred sixty-
two thousand eight hundred eighty-five Euro (€ 662,885.-) held by MC&S BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed,
towards the Company, by virtue of an interest free loan agreement executed between MC&S BERMUDA HOLDINGS,
L.P., prenamed, and the Company, on March 16th, 2007, whereby MC&S BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, granted
a loan in the amount of six hundred sixty-two thousand eight hundred eighty-five Euro (€ 662,885.-) to the Company.
Proof of the existence and value of such receivable has been given to the undersigned notary by a copy of the loan
agreement executed between MC&S BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, and the Company on March 16th, 2007.
- FOX BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, declared to subscribe for the two thousand eighty seven (2,087) Z
New Shares with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each, and have them fully paid up in the amount of fifty two
thousand one hundred seventy-five Euro (€ 52,175.-), together with a share premium in the amount of fourteen Euro
and eight Euro cents (€ 14.08), by contribution in kind in the total amount of fifty-two thousand one hundred eighty nine
Euro and eight Euro cents (€ 52,189.08) consisting in the cancellation of a portion in the same amount of a receivable
held by FOX BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, towards the Company, by virtue of draw downs made under a
loan facility agreement executed between FOX BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, and the Company, on August
3, 2007, whereby FOX BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, granted a loan facility up to four million five hundred
thirty-nine thousand five hundred Euro (€ 4,539,500.-) to the Company.
Proof of the existence and value of such receivable has been given to the undersigned notary by a copy of the loan
facility agreement executed between FOX BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, and the Company on August 3, 2007.
V. The shareholders resolve to decrease the Company's share capital from one million one hundred forty-seven
thousand seven hundred Euro (€ 1,147,700.-) to one million one hundred eleven thousand twenty five Euro (€ 1,111,025.-)
by an amount of thirty six thousand six hundred seventy-five Euro (€ 36,675.-) through the cancellation of:
- one hundred sixty-three (163) class P ordinary shares, all with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each,
having an aggregate value of four thousand seventy-five Euro (€ 4,075.-), by reimbursement to CANNON BRIDGE
BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, of the amount of four thousand seventy-five Euro (€ 4,075.-) together with an
amount of nineteen Euro cents (€ 0.19) from the premium account;
- one thousand three hundred four (1,304) class T ordinary shares, all with a nominal value of twenty-five Euro (€
25.-) each, having an aggregate value of thirty-two thousand six hundred Euro (€ 32,600.-), by reimbursement to DUNA
BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, of the amount of thirty-two thousand six hundred Euro (€ 32,600.-).
VI. Pursuant to the above increase and decrease of capital, article 5, first paragraph of the Company's articles of
association is amended and shall henceforth read as follows:
133524
« Art. 5. First paragraph. The issued capital of the Company is set at one million one hundred eleven thousand twenty-
five Euro (€ 1,111,025.-) divided into six hundred fifty-five (655) class A ordinary shares, six hundred and three (603)
class B ordinary shares, seven thousand one hundred and seventy-nine (7,179) class C ordinary shares, three thousand
five hundred eighty-one (3,581) class D ordinary shares, two hundred and twenty-three (223) class E ordinary shares, six
thousand seventy-five (6,075) class F ordinary shares, one hundred and one (101) class G ordinary shares, six thousand
sixty-one (6,061) class H ordinary shares, forty (40) class I ordinary shares, forty (40) class J ordinary shares, seventy-five
(75) class K ordinary shares, seventy-five (75) class L ordinary shares, three hundred thirty-two (332) class M ordinary
shares, seventy-five (75) class N ordinary shares, six thousand seventeen (6,017) class O ordinary shares, two thousand
seven hundred thirty (2,730) class P ordinary shares, seventy-five (75) class Q ordinary shares, three thousand eight
hundred and forty (3,840) class R ordinary shares, seventy-five (75) class S ordinary shares, seventy-five (75) class T
ordinary shares, seventy-five (75) class U ordinary shares, seventy-five (75) class V ordinary shares, seventy-five (75) class
W ordinary shares, seventy-five (75) class X ordinary shares, four thousand fifty-two (4,052) class Y ordinary shares and
two thousand one hundred sixty-two (2,162) class Z ordinary shares, all with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-)
each.»
VII. The shareholders resolve to amend the appointment of Mr. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on
May 10th, 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brazil), with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New
York, NY 10022, United States of America, as Category A Manager of the Company and to appoint him as Category B
Manager of the Company with immediate effect.
VIII. The shareholders resolve to amend the appointment of Mr. Robert Shaw, Senior Vice President, born on October
5, 1966 in New York (USA), with professional address at 399 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of
America, as Category A Manager of the Company and to appoint him as Category B Manager of the Company with
immediate effect.
IX. The shareholders resolve to amend the appointment of Mr. Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on
March 31st, 1976 in Messancy (Belgium), with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy
of Luxembourg, as Category B Manager of the Company and to appoint him as Category A Manager of the Company
with immediate effect.
X. The shareholders resolve to appoint Mr. Michael Denny, Company Director, born on November 1st, 1977 in
Kilkenny (Ireland), with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, as
new Category A Manager of the Company with immediate effect.
XI. The shareholders acknowledge that further to these changes and appointment, the board of managers of the
Company will be composed as follows:
<i>Category A Managers:i>
- Mr. Benoît Jean J. Bauduin, prenamed.
- Mr. Michael Denny, prenamed.
<i>Category B Managers:i>
- Mr. Rodolpho Amboss, prenamed.
- Mr. Robert Shaw, prenamed.
- Mr. John McCarthy, Company Director, born on the September 6th, 1961 in New York (United States of America),
residing at 120 Regents Park Road, London NW1 8XL, United Kingdom.
XII. The shareholders resolve to amend article 11, third and seventh paragraphs of the Company's articles of association
so that it is read as follows:
« Art. 11. 3rd paragraph. A meeting of the Board of Managers may be convened by the Chairman or by one category
A Manager and one category B Manager.
Art. 11. 7th paragraph. A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority
of Managers holding office with at least the presence or the representation of one Category A Manager and one Category
B Manager. Any decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority including at least the favourable
vote of one Category A Manager and one Category B Manager. The Chairman shall have a casting vote.»
XII. The shareholders resolve to amend article 16 of the Company's articles of association so that it is read as follows:
« Art. 16. Representation of the Company. In dealing with third parties, any Manager shall have the power to act in
the name of the Company in all circumstances and to carry out and authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The Company is bound in all circumstances by the joint signature of one category A Manager and
one category B Manager.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which will be borne to the Company as a result
of the present shareholders' meeting are estimated at approximately at five thousand Euro (€ 5,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
133525
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le premier octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
HARBOR BERMUDA, LP., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton
HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 36.838;
LBPOL BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 36.831;
SERICO BERMUDA HOLDINGS, LP., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 36.987;
IPPOCRATE BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37.035;
POSEIDON BERMUDA HOLDINGS, LP., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37.034;
LINCO BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37.695;
WILLIAM BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37.769;
LE PROVENÇAL BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2
Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37893;
SIERRA BIANCA BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2
Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 36811;
ANGEL CITY BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37771;
WILLIAM II BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 38357;
NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 38628;
CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House,
2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 38644;
ZOLIBORZ BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 38212;
SEGOVIA BERMUDA HOLDINGS, L.P., un exempted partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 39005;
DUNA BERMUDA HOLDINGS, L.P., un exempted partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 39033;
LION BERMUDA HOLDINGS, L.P., un exempted partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 38888;
ADAM BERMUDA HOLDINGS, L.P., un exempted partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 39148;
REPE LBREP II L.L.C., une limited liability company, ayant son siège social à C/O LEHMAN BROTHERS INC, 399 Park
Avenue, New York 10022, USA, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, sous le
numéro 3856984,
FOX BERMUDA HOLDINGS, LP., un exempted partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 39428;
GRACECHURCH BERMUDA HOLDINGS, L.P., un exempted partnership, ayant son siège social à Clarendon House,
2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 39354;
133526
MC&S BERMUDA HOLDINGS, LP., un exempted partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 39682;
GOODWATER BERMUDA HOLDINGS, L.P., un exempted partnership, ayant son siège social à Clarendon House,
2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 39.455.
tous ici représentés par Mademoiselle Stéphanie Colson, employée, ayant son adresse professionnelle à Senningerberg,
L-1450 Luxembourg, en vertu de vingt-trois (23) procurations données le 29 septembre 2007.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-
mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomi-
nation LBREP II EUROPE HOLDINGS S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 106.232, con-
stituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 19 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 600 en date du 22 juin 2005, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois lors d'une
assemblée générale extraordinaire en date du 16 avril 2007, tenue devant le notaire soussigné, publiée au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1515 en date du 20 juillet 2007.
II. Le capital social de la Société est fixé à huit cent quarante-sept mille cinq cent cinquante Euro (€ 847.550,-) divisé
en six cent cinquante-cinq (655) parts sociales ordinaires de classe A, six cent trois (603) parts sociales ordinaires de
classe B, sept mille cent soixante-dix neuf (7.179) parts sociales ordinaires de classe C, trois mille cinq cent quatre-vingt-
un (3.581) parts sociales ordinaires de classe D, deux cent vingt-trois (223) parts sociales ordinaires de classe E, six mille
soixante-quinze (6.075) parts sociales ordinaires de classe F, cent une (101) parts sociales ordinaires de classe G, six mille
soixante et une (6.061) parts sociales ordinaires de classe H, quarante (40) parts sociales ordinaires de classe I, quarante
(40) parts sociales ordinaires de catégorie J, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie K, soixante-quinze
(75) parts sociales ordinaires de catégorie L, trois cent trente-deux (332) parts sociales ordinaires de catégorie M,
soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie N, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie
O, deux mille huit cent quatre-vingt-treize (2.893) parts sociales ordinaires de catégorie P, soixante-quinze (75) parts
sociales ordinaires de catégorie Q, trois mille huit cent quarante (3.840) parts sociales ordinaires de catégorie R, soixante-
quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie S, mille trois cent soixante dix-neuf (1.379) parts sociales ordinaires de
catégorie T, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie U, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires
de catégorie V, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie W, soixante-quinze (75) parts sociales ordi-
naires de catégorie X, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie Y et soixante-quinze (75) parts sociales
ordinaires de catégorie Z, ayant toutes une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.
III. Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trois cent mille cent cinquante
Euro (€ 300.150,-) pour le porter de son montant actuel de huit cent quarante-sept mille cinq cent cinquante Euro (€
847.550,-) à un million cent quarante sept mille sept cents Euro (€ 1.147.700,-) par la création et l'émission de cinq mille
neuf cent quarante-deux (5.942) nouvelles parts sociales ordinaires de classe O (les «Nouvelles Parts O»), trois mille
neuf cent soixante-dix-sept (3.977) nouvelles parts sociales ordinaires de classe Y (les «Nouvelles Parts Y») et deux mille
quatre-vingt-sept (2.087) nouvelles parts sociales ordinaires de classe Z (les «Nouvelles Parts Z»), toutes d'une valeur
nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.
IV. HARBOR BERMUDA, L.P., précité, LBPOL BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, IPPOCRATE BERMUDA HOL-
DINGS, L.P., précité, POSEIDON BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, LINCO BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité,
WILLIAM BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, LE PROVENCAL BERMUDA HOLDINGS L.P., précité, SIERRA BIANCA
BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, ANGEL CITY BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, DUNA BERMUDA HOL-
DINGS, L.P., précité, NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, WILLIAM II BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité,
CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, ZOLIBORZ BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, SEGOVIA
BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, SERICO BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, ADAM BERMUDA HOLDINGS,
L.P., précité, REPE LBREP II L.L.C., précité, FOX BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, GRACECHURCH BERMUDA
HOLDINGS, L.P., précité, MC&S BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, LION BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, et
GOODWATER BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, décident de renoncer à leur droit de souscription préférentiel en
faveur de NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, pour la souscription des Nouvelles Parts O, en faveur de
MC&S BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, pour la souscription des Nouvelles Parts Y et en faveur de FOX BERMUDA
HOLDINGS L.P., précité, pour la souscription des Nouvelles Parts Z.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
- NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, déclare souscrire aux cinq mille neuf cent quarante-deux (5.942)
Nouvelles Parts O de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune et les libérer intégralement pour un montant de cent quarante-
huit mille cinq cent cinquante Euro (€ 148.550,-), ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de vingt-quatre Euro (€
24,-), par un apport en nature d'un montant total de cent quarante-huit mille cinq cent soixante-quatorze Euro (€
148.574,-) consistant en l'annulation des créances suivantes:
- une créance d'un montant de dix mille six cent vingt-cinq Euro (€ 10.625,-) détenue par NEPTUNE BERMUDA
HOLDINGS, L.P., précité, à rencontre de la Société, en vertu d'un contrat de prêt sans intérêt exécuté entre NEPTUNE
133527
BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, et la Société, le 12 juillet 2007, avec effet au 8 juin 2006, par lequel NEPTUNE
BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, a accordé un prêt d'un montant de dix mille six cent vingt-cinq Euro (€ 10.625,-)
à la Société;
- une créance d'un montant de cent mille quatre-vingt-six British Pound et quatre-vingt-onze pence (GBP 100.086,91)
détenue par NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, à rencontre de la Société, en vertu d'un contrat de prêt
sans intérêt exécuté entre NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, et la Société, le 12 juillet 2007, avec effet au
20 février 2007, par lequel NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, a accordé un prêt d'un montant de cent
mille quatre-vingt-six British Pound et quatre-vingt-onze pence (GBP 100.086,91) à la Société;
- une créance d'un montant de seize British Pound et dix-sept pence (GBP 16,17) détenue par NEPTUNE BERMUDA,
HOLDINGS, L.P., précité, à rencontre de la Société, en vertu d'un contrat de prêt sans intérêt exécuté entre NEPTUNE
BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, et la Société, le 12 juillet 2007, avec effet au 20 février 2007, par lequel NEPTUNE
BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, a accordé un prêt d'un montant de seize British Pound et dix-sept pence (GBP
16,17) à la Société.
Preuve de l'existence et de la valeur de ces créance a été donnée au notaire instrumentant par une copie des trois (3)
contrats de prêt sans intérêt exécutés entre NEPTUNE BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, et la Société.
- MC&S BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, déclare souscrire aux trois mille neuf cent soixante-dix-sept (3.977)
Nouvelles Parts Y de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune et les libérer intégralement pour un montant de quatre-vingt-dix-
neuf mille quatre cent vingt-cinq Euro (€ 99.425,-), ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de dix Euro (€ 10,-), par
un apport en nature d'un montant total de quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent trente-cinq Euro (€ 99.435,-) consistant
en l'annulation d'une partie du même montant d'une créance d'un montant de six cent soixante-deux mille huit cent
quatre-vingt-cinq Euro (€ 662.885,-) détenue par MC&S BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité à rencontre de la Société,
en vertu d'un contrat de prêt sans intérêt exécuté entre MC&S BERMUDA HOLDINGS, L.P, précité, et la Société, le 16
mars 2007, par lequel MC&S BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, a accordé à la Société un prêt d'un montant de six
cent soixante-deux mille huit cent quatre-vingt-cinq Euro (€ 662.885,-).
Preuve de l'existence et de la valeur de cette créance a été donnée au notaire instrumentant par une copie du contrat
de prêt sans intérêt exécuté entre MC&S BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, et la Société, le 16 mars 2007.
- FOX BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, déclare souscrire deux mille quatre-vingt-sept (2.087) Nouvelles Parts
Z de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune et les libérer intégralement pour un montant de cinquante-deux mille cent soixante-
quinze Euro (€ 52.175,-), ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de quatorze Euro et huit Euro cents (€ 14,08), par
un apport en nature d'un montant total de cinquante deux mille cent quatre-vingt-neuf Euro et huit Euro cent (€ 52.189,08)
consistant en l'annulation d'une partie du même montant d'une créance détenue par FOX BERMUDA HOLDINGS, L.P.,
précité à rencontre de la Société, en vertu de tirages effectué sur un contrat de facilité de prêt exécuté entre FOX
BERMUDA HOLDINGS, L.P, précité, et la Société, le 3 août 2007, par lequel FOX BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité,
a accordé à la Société une facilité de prêt jusqu'à quatre millions cinq cent trente-neuf mille cinq cents Euro (€ 4.539.500,-).
Preuve de l'existence et de la valeur de cette créance a été donnée au notaire instrumentant par une copie du contrat
de facilité exécuté entre FOX BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, et la Société, le 3 août 2007.
V. Les associés décident de réduire le capital social de un million cent quarante sept mille sept cents Euro (€ 1.147.700,-)
à un million cent onze mille vingt cinq Euro (€ 1.111.025,-) par un montant de trente-six mille six cent soixante quinze
Euro (€36.675,-), par l'annulation de:
- cent soixante-trois (163) parts sociales ordinaires de catégorie P, d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro chacune
(€ 25,-), d'une valeur totale de quatre mille soixante-quinze Euro (€ 4.075,-), par remboursement à CANNON BRIDGE
BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, d'un montant de quatre mille soixante-quinze Euro (€ 4.075,-) ainsi que d'un
montant de dix-neuf Euro cents (€ 0,19) du compte prime d'émission;
- mille trois cent quatre (1.304) parts sociales ordinaires de catégorie T, d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro
chacune (€ 25,-), d'une valeur totale de trente-deux mille six cents Euro (€ 32.600,-), par remboursement à DUNA
BERMUDA HOLDINGS, L.P, précité, d'un montant de trente-deux mille six cents Euro (€ 32.600,-).
VI. Suite à l'augmentation et à la réduction de capital ci-dessus, l'article 5, paragraphe premier des statuts de la Société
est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Paragraphe premier. Le capital social émis de la Société est de un million cent onze mille vingt-cinq Euro (€
1.111.025,-) et est divisé six cent cinquante-cinq (655) parts sociales ordinaires de classe A, six cent trois (603) parts
sociales ordinaires de classe B, sept mille cent soixante-dix neuf (7.179) parts sociales ordinaires de classe C, trois mille
cinq cent quatre-vingt-un (3.581) parts sociales ordinaires de classe D, deux cent vingt-trois (223) parts sociales ordinaires
de classe E, six mille soixante-quinze (6.075) parts sociales ordinaires de classe F, cent une (101) parts sociales ordinaires
de classe G, six mille soixante et une (6.061) parts sociales ordinaires de classe H, quarante (40) parts sociales ordinaires
de classe I, quarante (40) parts sociales ordinaires de catégorie J, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie
K, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie L, trois cent trente-deux (332) parts sociales ordinaires de
catégorie M, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie N, six mille dix-sept (6.017) parts sociales ordi-
naires de catégorie O, deux mille sept cent trente (2.730) parts sociales ordinaires de catégorie P, soixante-quinze (75)
parts sociales ordinaires de catégorie Q, trois mille huit cent quarante (3.840) parts sociales ordinaires de catégorie R,
soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie S, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie
133528
T, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie U, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie
V, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie W, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de caté-
gorie X, quatre mille cinquante-deux(4.052) parts sociales ordinaires de catégorie Y et deux mille cent soixante-deux
(2.162) parts sociales ordinaires de catégorie Z, ayant toutes une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.»
VII. Les associés décident de nommer M. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro
de Itapemirim, E.S. (Brazil), avec adresse professionnelle au 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, Etats-
Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie B au lieu de gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat.
VIII. Les associés décident de nommer M. Robert Shaw, Senior Vice President, né le 5 octobre, 1966 in New York
(USA), avec adresse professionelle au 399 Park Avenue, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique en tant que gérant
de catégorie B au lieu de gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat.
IX. Les associés décident de nommer M. Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, né le 31 mars 1976 in Messancy
(Belgique), avec adresse professionelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, America en tant que gérant de catégorie
A au lieu de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat.
X. Les associés décident de nommer M. Michael Denny, Company Director, né le 1
er
novembre, 1977 in Kilkenny
(Irelande), avec adresse professionelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en tant que gérant de catégorie A de la
Société avec effet immédiat.
XI. Les associés reconnaissent que suite à ces changements et à ces nominations, le conseil de gérance de la Société
sera composé comme suit:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- M. Benoît Jean J. Bauduin, prénommé.
- M. Michael Denny, prénommé.
<i>Gérants de catégorie B:i>
- M. Rodolpho Amboss, prénommé.
- M. Robert Shaw, prénommé.
- M. John McCarthy, Company Director, né le 6 septembre 1961 à New York Etats Unis d'Amérique, résidant au 120
Regents Park Road, London NW1 8XL, Royaume Uni.
XII. Les associés décident de modifier les troisième et septième paragraphes de l'article 11 des statuts de la Société
comme suit:
« Art. 11. 3
ème
paragraphe. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée si le Président ou un gérant
de catégorie A et un gérant de catégorie B le demandent.
Art. 11. 7
ème
paragraphe. Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si une majorité de
gérants est présente ou représentée avec au moins la présence d'un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion avec au moins
le vote favorable d'un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Le Président dispose dune vox prépondérante.»
XIII. Les associés décident de modifier l'article 16 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 16. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, chacun des gérants aura les pouvoirs les plus étendus pour
agir au nom de la Société en toutes circonstances ainsi que pour accomplir et autoriser tous les actes et opérations relatifs
à l'objet social de la Société. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature d'un Gérant de catégorie A
et un gérant de catégorie B.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq mille Euro (€ 5.000,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connue du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, elle a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: S. Colson, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2007, Relation: LAC/2007/29306. — Reçu 3.001,98 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
133529
Luxembourg, le 16 octobre 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007133529/211/448.
(070154867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2007.
Reliability Engineering S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9364 Eppeldorf, Reisermillen.
R.C.S. Luxembourg B 100.479.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Référence de publication: 2007133168/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 6 novembre 2007, réf. DSO-CK00023. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(070154061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
Melrose Resources, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 39.351.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12
août 2007, publié au Mémorial C numéro 989 du 25 septembre 2003; et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 octobre 2007.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Junglinster, le 9 novembre 2007.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Pour J. Seckler
<i>Notaire
i>M. Goeres
Référence de publication: 2007133143/231/17.
(070154200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
L.S. Lux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 9, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 92.117.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007132608/832/12.
Enregistré à Diekirch, le 26 octobre 2007, réf. DSO-CJ00233. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070153407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Firwind Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 48.245.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
133530
Luxembourg, le 9 novembre 2007.
COMPANIES & TRUST PROMOTION S.A.
Signature
Référence de publication: 2007132987/696/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01509. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
Firwind Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 48.245.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2007.
COMPANIES & TRUST PROMOTION S.A.
Signature
Référence de publication: 2007132988/696/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01507. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
Firwind Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 48.245.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2007.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Référence de publication: 2007132990/696/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01504. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
Wintersport Investments Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 51.942.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2007.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Référence de publication: 2007132991/696/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01502. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
INREDE S.A. (International Nippon Real Estate Development & Finance S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 36.485.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
133531
Luxembourg, le 9 novembre 2007.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Référence de publication: 2007132992/696/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01499. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
First Web S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 74.162.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2007.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Référence de publication: 2007132993/696/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01493. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
Paul Thiltges Distributions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 44.025.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007132716/725/12.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10207. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Accord Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 74.948.
<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 27 septembre 2007i>
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants de la société avec effet immédiat:
<i>Administrateurs:i>
- Fabio Mazzoni, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
- Joseph Mayor, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
- Antonio Bosch Clariana, demeurant à 18, Via Idiomi, I-20090 Assago (Milan).
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de renouveler le mandat de WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES en qualité
de Commissaire aux Comptes avec effet immédiat.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.
133532
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007132811/587/24.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ09959. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Groupe Minelis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 55.644.
<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale tenue en date du 12 octobre 2007i>
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Philippe Vanderhoven de son poste d'administrateur de la société avec
effet rétroactif au 30 juin 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée nomme Monsieur José Correia, résidant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, au
poste d'administrateur de la société avec effet rétroactif au 30 juin 2006. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2011.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007132807/587/20.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00896. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
J.B. Investment Company, Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 38.918.
<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 24 septembre 2007i>
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée prend note du transfert de siège social du Commissaire aux Comptes de la Société, à savoir WOOD,
APPLETON, OLIVER EXPERTS-COMPTABLES S.à r.l., du 9b, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg et ce depuis le 24 avril 2006.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007132806/587/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00895. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
World Immo Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 77.758.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 septembre 2007i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 21 septembre 2007 que:
Les membres du Conseil d'administration, délibérant valablement, ont nommé Monsieur François Georges, expert-
comptable, né le 20 mars 1967 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg,
à la fonction d'administrateur-délégué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012, avec pouvoir d'engager
133533
la Société en toutes circonstances par sa seule signature, suivant l'article 6 des statuts de la Société, et ont décidé d'élire
ce dernier en tant que Président du Conseil d'administration.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Luxembourg, le 21 septembre 2007.
<i>WORLD IMMO INVEST S.A.
i>F. Georges
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2007132804/5710/22.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2007, réf. LSO-CJ09742. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070153685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Gai Mattiolo Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 118.165.
Il résulte de deux courriers adressés à la société GAI MATTIOLO HOLDING S.A. que Messieurs Philippe Vanderhoven
et Fabio Mazzoni ont démissionné de leur mandat d'administrateur de la société, respectivement en date du 13 avril 2007
et du 9 octobre 2007.
Il résulte d'un courrier adressé à la société GAI MATTIOLO HOLDING S.A. que la société WOOD APPLETON
OLIVER EXPERTS-COMPTABLES S.à r.l. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société avec
effet au 9 octobre 2007.
A la demande des intéressés
Signature
Référence de publication: 2007132809/587/17.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ09957. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Calibois S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 26.069.
Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Madame Françoise Dumont. Cette dernière
assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.
Fait à Luxembourg, le 2 mai 2007.
Certifié sincère et conforme
<i>CALIBOIS S.A.
i>J.-R. Bartolini / V. Dumont
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007132823/795/17.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2007, réf. LSO-CK00222. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Caam Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 68.806.
<i>Extrait de la Résolution Circulaire du Conseil d'Administration du 20 novembre 2006i>
En date du 20 novembre 2006, le Conseil d'administration de la Société mentionnée ci-dessus (ci-après la «Société»)
a décidé:
- de révoquer le mandat de délégué à la gestion journalière octroyé à Monsieur Philippe Zaouati en qualité de Directeur
Général par décision du Conseil prise le 5 octobre 2001;
133534
- de nommer Monsieur Dominique Couasse, CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, 5, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, en qualité de Directeur Général et de l'autoriser à accomplir tout acte de gestion courante
et à représenter la Société, notamment dans ses rapports avec les prestataires et les autorités de tutelle,
- de nommer Monsieur Philippe Zaouati en qualité d'Administrateur-délégué à la gestion journalière.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>G. Abel
<i>Fondé de Pouvoiri>
Référence de publication: 2007132828/1024/22.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI10330. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070153702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Galux S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 17.771.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 13 septembre 2007 à 15.00 heures à Luxembourgi>
L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat des administrateurs pour une durée de un an, à savoir:
- Monsieur Koen Lozie, Administrateur de sociétés, demeurant 18, rue des Sacrifiés, à Garnich,
- Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant 11, rue de Fischbach à Blaschette,
- COSAFIN SA, Société Anonyme, 23, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg, représentée par Monsieur Jacques
Bordet, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Leurs mandats viendront à échéance lors de la prochaine assemblée ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au
31 décembre 2007.
L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat de EURAUDIT Sàrl en tant que Commissaire aux comptes
pour une nouvelle durée d'un an.
Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine assemblée qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre
2007.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007132837/1172/23.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04418. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Treveria G S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 116.356.
Les comptes annuels pour la période du 18 avril 2006 (date de constitution) au 31 décembre 2006 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007132998/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, réf. LSO-CK01160. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
Ocean Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 93.904.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
133535
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
OCEAN PROPERTIES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur Catégorie A / Administrateur Catégorie Bi>
Référence de publication: 2007133012/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01514. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
Prostar S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 60.649.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PROSTAR S.A.
C. Mathu / O. Oudin
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007133010/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01520. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
S.E.T.I. Société Européenne de Transactions Immobilières S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 30.918.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007133004/677/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00914. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2007.
MH-SH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 68.794.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2007.
<i>MH-SH S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature
Référence de publication: 2007132640/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00607. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070153136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
133536
AB Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.
Accord Investment S.A.
Alcmena
Alicor S.à r.l.
Batima Invest S.A.
Caam Funds
Calibois S.A.
Colyzeo II Development S.à r.l.
CommCapital S.à r.l.
Constructions Métalliques Kremer S.A.
Crédit Agricole Asset Management Luxembourg S.A.
Crown Corporate Services
dfl Luxembourg Two S.à r.l.
D.W.L. Immobilière S.A.
Eastwood S.A.H.
Eclipse Immobilière S.A.
First Web S.A.
Firwind Finance S.A.
Firwind Finance S.A.
Firwind Finance S.A.
Floorings I S.à r.l.
Gai Mattiolo Holding S.A.
Galux S.A.H.
Groupe Minelis S.A.
Herinvest S.A.
Hotel Koener S.à.r.l.
IBR Invest S.A.
ICG-Gemco S.à r.l.
Immo Foyer S.à.r.l.
Immo Foyer S.à.r.l.
INREDE S.A. (International Nippon Real Estate Development & Finance S.A.)
InterFact S.à.r.l.
International Research and Development (Luxembourg) S.A.
J.B. Investment Company
LBC Holdings GP S.à r.l.
LBREP II Europe Holdings S.à r.l.
Loeffler S.à r.l.
LP One Halbergmoos Sàrl
L.S. Lux SA
Marguy Mootz S.à r.l. unipersonnelle
Melrose Resources
MH-SH S.A.
Ocean Properties S.A.
Omnium Européen d'Entreprises O.E.E.
Paul Thiltges Distributions S.à r.l.
Pembroke S.A.
Prostar S.A.
Reliability Engineering S.à.r.l.
Revolia S.à r.l.
S.E.T.I. Société Européenne de Transactions Immobilières S.A.
Société Nouvelle Ernzbach S.A.
Sodefi S.A.
Technolux Holding S.A.
Treveria G S.à r.l.
Wintersport Investments Holding S.A.
World Immo Invest S.A.