logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2741

28 novembre 2007

SOMMAIRE

Altice 5 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131561

Ameco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131567

Apache Luxembourg Holdings II  . . . . . . . .

131564

a_part concept s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131563

Bokay Pictures S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131528

Books and Beans S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

131549

CERATIZIT Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . .

131564

Ceratizit S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131550

Ceratungsten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131549

C. & M. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131565

Conforto Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131564

CORSAIR (Luxembourg) N°15 S.A.  . . . . .

131522

De Herrero Management S.A.  . . . . . . . . . .

131551

Euroholding Fashion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

131548

Euroholding Fashion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

131550

Fek Immobilière SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131533

Floris S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131522

Fondation Nicolas Lanners  . . . . . . . . . . . . . .

131533

Garage Muller-Locations . . . . . . . . . . . . . . . .

131565

Gesco Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131567

Great German Nursing Homes C . . . . . . . .

131541

Great German Nursing Homes D  . . . . . . .

131522

Great German Nursing Homes E  . . . . . . . .

131555

Interstyle Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

131550

Interstyle Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

131565

Jasperus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131548

Lux Cogeba Construction S.à r.l.  . . . . . . . .

131533

Maitland Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

131565

MDS International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131566

Moda Brand Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

131550

Moda Brand Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

131547

M.S.C.V. Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

131563

Patrimoine Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131561

Stelco Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

131562

SYMFONICA Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131529

Trenubel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131563

T.S. Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131549

United Bakeries Luxembourg S.A. . . . . . . .

131564

V2I Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131549

V2I Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131548

Water and Sun S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131534

131521

Floris S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 98.107.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007131294/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ09894. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070151763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

CORSAIR (Luxembourg) N°15 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 95.217.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007131295/1463/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00327. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Great German Nursing Homes D, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 133.033.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the fifteenth day of October.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

PRESIDENTIAL NURSING HOMES HOLDINGS, a société à responsabilité limitée (private limited liability company)

incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2A, rue des
Capucins, L-1313 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123.143,
incorporated by a deed of the notary Paul Decker, on 13 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, C no. 281 on 1 March 2007

here represented by Mr Max Mayer, employee, residing in L-2551 Luxembourg, by virtue of a proxy given in London,

on September 24th, 2007.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle the Articles of which it

has established as follows:

«Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially

the law of August 10th, 1915 on commercial companies such as amended.

Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,

whether furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in
real estate, and those concerning the placement and management of money.

The object of the Company is also to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,

commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any  activities  in  whatsoever  form,  as  well  as  the  management  and  development,  permanently  or  temporarily,  of  the
portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a financial participations company according to
the applicable provisions.

131522

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The private limited liable Company is incorporated under the name of GREAT GERMAN NURSING HOMES

D.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II. Capital - Shares

Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by one hundred

(100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euros (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid
up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Art. 7.  If  there  is  more  than  one  shareholder,  the  transfer  of  shares  to  non-shareholders  is  subject  to  the  prior

unanimous approval of the shareholders. The Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per
share.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each shareholder who so requests.

Title III. Management

Art. 8. Board of managers.
8.1. The Company is managed by at least four managers, appointed by a resolution of the sole shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office of whom two shall be designated as Class A managers
and two shall be designated as Class B managers. The managers do not need to be shareholders.

8.2. The managers may be dismissed ad nutum by an unanimous vote of the board of managers of the sole shareholder

of the Company.

Art. 9. Powers of the board of managers.
9.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and
operations in accordance with the Company's object.

9.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either managers or

not, by any Class A manager and any Class B manager acting jointly.

Art. 10. Procedure.
10.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any manager in

accordance with any joint venture agreement entered into between the Shareholders from time to time.

10.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 72 hours in advance

of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be
set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

10.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers are present or represented at

the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting.
The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each
member of the board of managers.

10.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

10.5 The board of managers can validly deliberate and act only if at least one Class A Manager and one Class B Manager

is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast including
at least one Class A Manager and one Class B Manager. The resolutions of the board of managers will be recorded in
minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

10.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

131523

10.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 11. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of one

Class A Manager and one Class B Manager or by the single or joint signature(s) of any person(s) to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with article 9.2. of these Articles.

Title IV. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The sole shareholder exercises the powers devolved to a meeting of shareholders by the dispositions of the

foresaid law of August 10th, 1915.

12.2. If there is more than one shareholder, each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of Shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile
or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2  Any  shareholders'  decisions  are  only  validly  taken  by  unanimous  vote  of  the  board  of  managers  of  the  sole

shareholder of the Company.

Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 14. The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of the same year.

Art. 15. Each year, on the thirty-first day of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal

reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason
whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual contribution shall be
resumed until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole shareholder or distributed among the shareholders if there is more than one.

However, the sole shareholder or, as the case may be, a meeting of shareholders may decide, at the majority vote
determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.

Title VI. Dissolution

Art. 16. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a shareholder.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole shareholder or by a general meeting of shareholders.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole shareholder or, as the case may be, distributed

to the shareholders proportionally to the shares they hold.

Title VII. General provisions

Art. 17. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the shareholders shall refer to the

law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.»

<i>Subscription and payment

All the shares have been entirely subscribed by the private liable company PRESIDENTIAL NURSING HOMES HOLD-

INGS, prenamed. They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred euros (EUR 12,500.-) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned
notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitory Provision

The first financial year shall begin on the day of incorporation and finish on 31 December 2008.

131524

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed

capital, acting as foresaid, has passed the following resolutions:

1) The following are appointed managers of the Company for an unlimited period:
(i) Claudia Daxelhoffer, residing in CH-8942 Oberrieden, Feldstrasse 8, as A Manager;
(ii) Isaac Schapira, born on 16 December 1952 in Jerusalem, Israel, business man, residing at 2, Danescroft Gardens,

London NW4 2ND, as A Manager;

(iii) Andrew Pettit, lawyer, born on 7 March 1968 in Cleethorpes, United Kingdom, having its professional address at

20 Balderton Street, London W1K 6TL, United Kingdom as B Manager; and

(iv)  Matthias  Wilke,  banker,  born  on  23  April  1972  in  Diez/Lahn,  Germany,  having  its  professional  address  at  20

Balderton Street, London W1K 6TL, United Kingdom, as B Manager.

2) Mrs Claudia Daxelhoffer, prenamed, is authorised to sign all Bank transactions by her sole signature.
3) The Company shall have its registered office at L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins.

<i>Estimate of cost

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 1,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation. Upon request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahr zweitausendundsieben, den fünfzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

PRESIDENTIAL NURSING HOMES HOLDINGS, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wirksam gegründet und

bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 2A, rue des Capucins in L-1313 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg unter Sektion B, Nummer
123.143, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den Notar Paul Decker, am 13. Dezember 2006, veröffentlicht
im Mémorial C, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg vom 1. März 2007, Nummer 281

hier vertreten durch Herrn Max Mayer, Angestellter, wohnhaft in L-2551 Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht

gegeben in London am 24. September 2007.

Diese Vollmacht soll nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den instrumentierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit ihr einregistriert zu werden.

Diese Komparentin, vertreten wie vorgenannt, beabsichtigt, eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung

zu gründen, die folgende Satzung haben soll:

«Titel I. Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) errichtet, welche

durch geltendes Gesetzesrecht, insbesondere durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in
der jeweils geltenden Fassung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Weiterentwicklung, der Verkauf und die Vermietung

von jeglichen Immobilien, seien sie möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Immobiliengeschäfte, mit Ausnahme
derjenigen, welche einem Immobilienhändler vorbehalten sind und derjenigen, welche die Platzierung von Geld und die
Vermögensverwaltung betreffen.

Zweck der Gesellschaft ist es außerdem, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle industriellen, kommerziellen,

finanziellen, privaten oder immobilienbezogenen Transaktionen, egal welcher Form, vorzunehmen, die in direktem Zu-
sammenhang stehen mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung, egal welcher Form, von jeglichen Unternehmen
und Gesellschaften, welche die Ausführung von jeglichen Geschäften in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftszweck,
sowie die dauerhafte oder vorübergehende Verwaltung und Entwicklung des Portfolios, welches zu diesem Zweck ge-
schaffen ist, zum Zweck haben. Die Gesellschaft soll als Beteiligungsgesellschaft (Société de Participation Financière) gemäß
den einschlägigen Bestimmungen betrachtet werden. Die Gesellschaft kann sich in jeder Form beteiligen an Geschäften,
Unternehmen und Gesellschaften, welche einen mit dem Gesellschaftszweck identischen, ähnlichen oder verbundenen
Zweck verfolgen oder welche die Entwicklung oder Ausweitung ihrer Tätigkeit fördern.

131525

Art. 3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung besteht unter dem Namen GREAT GERMAN NURSING HOMES

D.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Er kann in jede andere Ortschaft des Großherzogtum Lu-

xemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.

Titel II. Kapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert

(100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), alle voll gezeichnet und vollens
eingezahlt.

Jeder Anteil gewährt das Recht an einem Bruchteil des Vermögens und des Gewinns der Gesellschaft proportional

zur bestehenden Anzahl der Anteile.

Art. 7. Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind Anteilsübertragungen an Nichtgesellschafter nur mit dem vorherigen,

einstimmigen Einverständnis der Gesellschafter möglich.

Die Anteile sind unteilbar, da nur ein Eigentümer pro Anteil anerkannt wird. Eine Anteilsübertragung ist für die Ge-

sellschaft oder Dritte erst rechtsverbindlich nach Eingang an oder Annahme durch die Gesellschaft gemäß den Bestim-
mungen des Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches (Code Civil)

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wird am Sitz der Gesellschaft ein Gesellschafter-Register geführt, in welches

jeder Gesellschafter auf Verlangen Einsicht nehmen kann.

Titel III. Geschäftsführung

Art. 8. Verwaltungsrat.
8.1. Die Gesellschaft wird durch mindestens vier Verwaltungsratsmitglieder verwaltet, welche durch Beschluss des

Alleingesellschafters, oder der Generalversammlung der Gesellschafter, der gleichzeitig die Amtsdauer festsetzt, ernannt
werden; zwei werden als Kategorie A Verwaltungsratsmitglieder bezeichnet und zwei als Kategorie B Verwaltungsrats-
mitglieder. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen nicht Gesellschafter sein.

8.2. Die Verwaltungsratsmitglieder können ad nutum durch einstimmigen Beschluss des Verwaltungsrats des Allein-

gesellschafters von ihrem Posten enthoben werden.

Art. 9. Aufgaben des Verwaltungsrats.
9.1. Jegliche Aufgaben, welche nicht gemäß dem Gesetz, oder den Bestimmungen der vorliegenden Satzung der Ge-

sellschafterversammlung  vorbehalten  sind,  fallen  in  den  Kompetenzbereich  des  Verwaltungsrats,  welcher  befugt  ist,
jegliche Geschäfte im Rahmen des Geschäftszweckes auszuführen und zu bewilligen.

9.2. Jedes Kategorie A Verwaltungsratmitglied und jedes Kategorie B Verwaltungsratmitglied, jeweils gemeinsam han-

delnd, können für bestimmte Fälle eine umfänglich begrenzte Sondervollmacht an ein Verwaltungsratsmitglied oder an
einen Dritten erteilen.

Art. 10. Verfahren.
10.1. Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen, wie die Interessen der Gesellschaft es verlangen, oder auf Wunsch

jedes Verwaltungsratsmitgliedes gemäß den Bestimmungen möglicher, von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern
eingegangener Gemeinschaftsunternehmensabkommen.

10.2. Die schriftliche Anzeige einer Verwaltungsratskonferenz muss wenigstens 72 Stunden vor dem Datum der Kon-

ferenz an alle Verwaltungsratsmitglieder geschickt werden, außer im Notfall, in welchem Fall der Notfall im Einberu-
fungsschreiben beschrieben werden muss.

10.3 Ein solches Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder

vertreten sind und bestätigen, eingehend informiert gewesen zu sein sowie die Tagesordnung zu kennen. Jedes Verwal-
tungsratsmitglied kann schriftlich auf das Einberufungsschreiben verzichten, sei es per Originalschreiben, per Telegramm,
Telex, Faxschreiben oder E-Mail.

10.4. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf einer Konferenz Handlungen vornehmen, indem es ein anderes Verwal-

tungsratsmitglied schriftlich zu seinem Stellvertreter benennt.

10.5. Der Verwaltungsrat kann nur wirksam beraten und handeln, wenn jeweils mindestens ein Kategorie A Mitglied

und ein Mitglied der Kategorie B anwesend oder vertreten sind. Verwaltungsratsbeschlüsse werden mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, wobei jeweils ein Kategorie A Mitglied und ein Kategorie B Mitglied zustimmen müssen.
Die Verwaltungsratsbeschlüsse werden in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, das von allen anwesenden oder vertre-
tenen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet wird.

10.6. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung per Telefon- oder Videokonferenz oder

einem anderen gleichwertigen Kommunikationsmittel, welches es den Teilnehmern erlaubt, einander zu verstehen und
miteinander zu sprechen, teilnehmen. Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung mit ebensolchen Kommunikati-
onsmitteln wird wie eine persönliche Teilnahme des Verwaltungsratsmitgliedes an einer Verwaltungsratssitzung angese-
hen.

131526

10.7. Umlaufbeschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind, sind gültig und verbindlich

wie Beschlüsse, welche im Laufe einer einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung getroffen wurden. Die
Unterschriften können sich in einem einzigen Dokument oder in mehreren identischen Kopien des Umlaufbeschlusses
befinden und können durch Telefax oder Brief nachgewiesen werden.

Art. 11. Vertretung. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten rechtskräftig verpflichtet durch die gemeinschaftliche

Unterschrift jeweils eines Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A und eines Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B
oder durch die alleinige oder gemeinschaftliche Unterschrift der Person oder der Personen, an welche Vertretungsmacht
gemäß den Bestimmungen von Artikel 9.2. der vorliegenden Satzung übertragen wurde.

Titel IV. Entscheidungen des Alleingesellschafters -

Gemeinsame Entscheidungen mehrerer Gesellschafter

Art. 12. Befugnisse und Stimmrechte.
12.1 Der Alleingesellschafter übt die Befugnisse aus, die gemäß den Bestimmungen des oben genannten Gesetzes vom

10. August 1915 der Gesellschafterversammlung übertragen sind.

12.2 Falls es mehrere Gesellschafter gibt, hat jeder von ihnen Stimmrechte proportional zu den von ihm gehaltenen

Gesellschaftsanteilen.

12.3 Jeder Gesellschafter kann jede natürliche oder juristische Person zu seinem Bevollmächtigten zur Vertretung bei

Generalversammlungen ernennen, und zwar durch schriftliche Vollmacht in Form eines Briefes, Telegramms, Telex, Te-
lefax oder einer E-Mail.

Art. 13. Form - Quorum - Mehrheit.
13.1 Falls die Anzahl der Gesellschafter 25 oder weniger beträgt können Gesellschafterbeschlüsse durch Umlaufbe-

schluss gefasst werden, deren Text allen Gesellschaftern schriftlich, sei es als Original oder per Telegramm, Telex, Telefax
oder E-Mail, gesendet sein muss. Die Gesellschafter geben ihre Stimme ab, indem sie den Umlaufbeschluss unterzeichnen.
Die Unterschriften der Gesellschafter können sich in einem einzigen Dokument oder in mehreren identischen Kopien
des Umlaufbeschlusses befinden und können durch Telefax oder Brief nachgewiesen werden.

13.2 Gesellschafterbeschlüsse können nur durch einstimmigen Beschluss des Verwaltungsrats des Alleingesellschafters

gefasst werden.

Titel V. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des gleichen Jahres.

Art. 15. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per einunddreißigsten Dezember, werden ein Bericht über die der

Aktiva und Passiva der Gesellschaft und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt. Der Saldo der Gewinn- und Ver-
lustrechnung, abzüglich Aufwendungen, Kosten, Belastungen Abschreibungen und Rückstellungen ist der Nettogewinn
der Gesellschaft.

Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft der gesetzlichen Reserve der Ge-

sellschaft zugeführt, solange bis die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt
aus welchem Grunde auch immer die gesetzliche Reserve unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals fallen, so muss die
jährliche Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden bis das Ein-Zehntel-Verhältnis wieder hergestellt ist.

Der Überschuss wird dem Alleingesellschafter zugeteilt oder, falls mehrere Gesellschafter vorhanden sind, unter diesen

verteilt. Dieser bzw. diese können jedoch durch Mehrheitsentscheidung gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen  entscheiden,  dass  der  Gewinn,  nach  Abzug  jeglicher  Reserven,  auf  das  folgende  Jahr  übertragen  oder  einer
außergesetzlichen Reserve zugeführt wird.

Titel VI. Auflösung

Art. 16. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die Insolvenz, die gerichtliche Entmündigung oder die

Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters aufgelöst.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation vom oder von den Verwaltungsratsmitglied(ern) im

Amt oder, in Ermangelung dessen, von einem oder mehreren Liquidatoren, vom Alleingesellschafter oder von der Ge-
neralversammlung der Gesellschafter ernannt, ausgeführt. Der oder die Liquidator(en) ist bzw. sind mit umfassenden
Vollmachten zur Realisierung der Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.

Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, dem Alleingesellschafter zugeteilt, oder gegebenenfalls

unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile aufgeteilt.

Titel VII. Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Auf alle Angelegenheiten, die in der vorliegenden Satzung nicht geregelt sind, finden die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.»

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle Anteile wurden gezeichnet durch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRESIDENTIAL NURSING HOMES

HOLDINGS, vorgenannt, und vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von zwölftau-

131527

sendfiinfhundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde,
der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt zum Gründungszeitpunkt und endet am 31. Dezember 2008.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der Alleingesellschafter welcher das Gesamtkapital vertritt, folgende Be-

schlüsse gefasst:

1) Es werden zu Verwaltungsratsmitgliedern auf unbestimmte Zeit ernannt:
(i) Frau Claudia Daxelhoffer, wohnhaft in CH-8942 Oberrieden, Feldstrasse, 8, zum Verwaltungsratsmitglied der Ka-

tegorie A,

(ii) Herrn Isaac Schapira, Kaufmann, geboren am 16. Dezember 1952 in Jerusalem, Israel, wohnhaft in 2, Danescroft

Gardens, London NW4 2ND, Großbritannien, zum Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A,

(iii) Herrn Andrew Pettit, Anwalt, geboren am 7. Mai 1968 in Cleethorpes, England, mit beruflichem Sitz in 20 Baiderton

Street, London W1K 6TL, Großbritannien, zum Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B,

(iv) Herrn Matthias Wilke, Bänker, geboren am 23. April 1972 in Diez/Lahn, Deutschland, mit beruflichem Sitz in 20

Baiderton Street, London W1K 6TL, Großbritannien, zum Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B.

2) Frau Claudia Daxelhoffer, vorbenannt, ist autorisiert alle Bankabwicklungen durch ihre alleinige Unterschrift zu

tätigen.

3) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1313 Luxemburg, 2a, rue des Capucins.

<i>Kostenschätzung

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Gebühren, Vergütungen und Auslagen in welcher Form auch immer, welche

die Gesellschafrt aus Anlass dieser Urkunde zu tragen hat, oder welche ihr im Zusammenhang mit ihr auferlegt werden,
beläuft sich auf ungefähr 1.500,- EUR.

Der unterzeichnete Notar, welcher englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass der Text der vorliegenden

Satzung auf Wunsch der Erschienenen in englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, dass es der Wunsch der Erschienenen ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text der englische Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung und Erklärung an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Mayer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2007, LAC/2007/31205. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Jungers.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 25. Oktober 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007131879/206/340.
(070151982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Bokay Pictures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 5, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 95.750.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BOKAY PICTURES SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2007131599/514/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07080. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

131528

SYMFONICA Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 133.061.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und sieben den neunten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1.- Die ADAGIO STIFTUNG unter dem Recht des Fürstentums Liechtenstein, mit Sitz in FL-9490 Vaduz, Aeulestrasse

5,

2.- Lic.iur. Christoph Langenauer, Hinterwies 42, 9042 Speicher, Schweiz,
beide vertreten durch
Herrn Patrick Römer, Privatbeamter, mit Berufsadresse in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy
aufgrund einer Vollmachten unter Privatschrift vom 18. September 2007.
Welche Komparentinnen, vertreten wie eingangs erwähnt, beschlossen haben zwischen ihnen eine Aktiengesellschaft

zu gründen mit folgenden Statuten:

Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck,- Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Form, Name der Gesellschaft. Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, welche

Inhaber der Anteile werden, welche hiermit geschaffen werden, wird eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesell-
schaft (die «Gesellschaft») gegründet. Diese Aktiengesellschaft unterliegt der Gesetzgebung des Großherzogtums Lu-
xemburg («Luxemburg») und den Bestimmungen dieser Satzung.

Die Aktiengesellschaft trägt den Namen SYMFONICA HOLDING.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt

werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art

eingetreten sind oder bevorstehen, welche die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung
zwischen  dem  Gesellschaftssitz  und  dem  Ausland  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Verwaltungsrat  den  Gesell-
schaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegen. Diese provisorischen Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Staats-
zugehörigkeit  der  Gesellschaft,  welche,  unbeschadet  dieser  provisorischen  Verlegung  des  Gesellschaftssitzes,  die
Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einer der Personen, die mit der täglichen Geschäftsfüh-

rung betraut sind, auszuführen und bekannt zu geben.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung in jeder möglichen Form an anderen lu-

xemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann vor allem auf dem Wege von Einlagen, Zeichnungen, Optionen, Kauf und jeder anderen Weise Werte jederzeit

erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder anders realisieren und verwerten.

Die Gesellschaft kann Patente und alle mit diesen Patenten verbundenen Rechte erwerben und verwalten.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen an denen ein direktes und substantielles Interesse besteht, jederzeit jede

Hilfeleistung, Darlehen, Vorauszahlungen oder Garantien gewähren.

Sie kann alle Maßnahmen vornehmen, um ihre Rechte zu garantieren, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen

oder ihn fördern.

Art. 4. Dauer der Gesellschaft. Die Dauer der Geseilschaft ist unbeschränkt.
Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch die Aktionärs Versammlung im Rahmen eines Beschlusses gemäss Artikel 67-1

des Gesetzes über die Handelsgesellschaften aufgelöst werden.

Kapitel II. - Kapital, Aktien

Art. 5. Kapital. Das gezeichnete Kapital beträgt einunddressig-tausend Euro (31.000,- EUR) und ist eingeteilt in ein-

hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je hundert Euro (310,- EUR).

Art. 6. Form der Aktien. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.

Kapitel III. - Verwaltungsrat

Art. 7. Verwaltungsrat. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern,

welche nicht Gesellschafter sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Aktionärsversammlung ge-
wählt, welche die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder festlegt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine Höchst-

131529

dauer von sechs Jahren ernannt und bleiben im Amt bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Verwaltungsratsmitglieder sind
wiederwählbar und können jederzeit von der Aktionärsversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Art. 8. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Er kann ebenfalls einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der für die Sit-

zungsprotokolle der Aktionärsversammlung und der Verwaltungsratssitzungen zuständig ist.

Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung des Vorsitzenden und ebenso jedes mal dann, wenn zwei Ver-

waltungsratsmitglieder die Einberufung verlangen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz der Aktionärsversammlungen und der Verwaltungsratssitzungen;

in seiner Abwesenheit wird die Aktionärsversammlung oder der Verwaltungsrat mit einer Mehrheit der Stimmen ein
anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen, welches den Vorsitz der Versammlung führen wird.

Die schriftliche Einberufung aller Verwaltungsratssitzungen muss mindestens eine Woche vor der Sitzung an alle Ver-

waltungsratsmitglieder verschickt werden, mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen oder im Falle des Einverständnisses
aller Personen, die an der Sitzung teilnehmen können.

Die Einberufung gibt den Ort, die Zeit und die Tagesordnung der Sitzung an.
Durch schriftliches Einverständnis aller Verwaltungsratsmitglieder per Telekopie oder durch jede Art von Fernmel-

detechnik kann auf die Einberufung verzichtet werden.

Es bedingt keiner speziellen Einberufung für Sitzungen, für welche das Datum und der Ort vorab durch Beschluss des

Verwaltungsrates festgelegt worden sind.

Jede Verwaltungsratssitzung findet in Luxemburg statt oder an einem anderen Ort, welcher von Zeit zu Zeit vom

Verwaltungsrat bestimmt werden kann.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Telefax oder durch jede Art von Fernmeldetechnik

Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratssitzung erteilen.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsrats-

mitglieder erschienen oder vertreten ist.

Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.
In Dringlichkeitsfällen ist ein von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschriebener schriftlicher Beschluss genauso

gültig und rechtsverbindlich gefasst wie ein solcher der von einer rechtmäßig einberufenen und gültig beratenden Ver-
waltungsratssitzung gefasst wurde.

Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt beurkundet werden.

Jedes Dokument ist von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben.

Art. 9. Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen. Die Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen werden

vom Vorsitzenden der Versammlung unterschrieben. Die Vollmachten sind den Protokollen beizufügen. Die Abschriften
und Auszüge von Protokollen, welche vor Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Verwaltungsratsvorsit-
zenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.

Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, welche zur

Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder zweckdienlich ist.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbe-

halten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates.

Art. 11. Übertragung von Vollmachten. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie

die Vertretung derselben in bezug auf die tägliche Geschäftsführung an eines oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder
sowie an geschäftsführende Direktoren, Bevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen, welche nicht
Gesellschafter sein müssen aber Gesellschafter sein können. Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten oder
Vollmachten erteilen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen an Personen oder Beauftragte seiner Wahl
übergeben.

Falls  die  tägliche  Geschäftsführung  an  ein  Mitglied  des  Verwaltungsrates  übertragen  wird,  ist  hierzu  die  vorherige

Genehmigung der Gesellschafterversammlung nötig.

Art. 12. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten rechtsverbindlich verpflichtet durch die

gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, oder durch die einzelne Unterschrift der Person,
die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wurde, im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung, oder durch die
gemeinsame oder einzelne Unterschrift von allen Personen, auf die der Verwaltungsrat solche Unterschriftsbefiignisse
übertragen hat, aber nur im Rahmen dieser Unterschriftsbefugnisse.

Art. 13. Kommissare.  Die  Aufsicht  der  Gesellschaft  obliegt  einem  oder  mehreren  Kommissaren,  Aktionäre  oder

Nichtaktionäre.

Die Kommissare werden durch die Aktionärsversammlung, welche ihre Zahl bestimmt, für eine Höchstdauer von

sechs Jahren ernannt und bleiben auf ihrem Posten bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Sie sind wiederwählbar; die Gesell-
schafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit mit oder ohne Grund widerrufen.

131530

Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung

Art. 14. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Die Aktionärsversammlung, welche ordnungsgemäß zusammen-

gekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Sie hat alle Befugnisse, welche das Gesetz und gegenwärtige Satzung ihr erteilen.

Art. 15. Jährliche Aktionärsversammlung. Die jährliche Aktionärsversammlung tritt zusammen am zweiten Dienstag

des Monats Februar eines jeden Jahres um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort, welcher in der
Einberufung angegeben ist.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die jährliche Gesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag

abgehalten.

Art. 16. Andere Gesellschafterversammlungen. Der Verwaltungsrat kann andere Aktionärsversammlungen einberufen.

Diese Versammlungen müssen auf Anfrage von Aktionären abgehalten werden, die mindestens ein Zehntel (1/10) des
Gesellschaftskapitals vertreten.

Wenn Fälle von höherer Gewalt eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat abgewägt werden, können

die Aktionärs-Versammlungen, inbegriffen auch die jährliche Aktionärsversammlung, im Ausland abgehalten werden.

Art. 17. Prozedur, Wahl. Die Aktionärsversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von den Kommissaren in

der vom Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen.

Die Einberufung beinhaltet die Tagesordnung der Aktionärsversammlung.
Falls sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, die der Versammlung vorgelegte Tagesordnung

zu kennen, kann eine Aktionärsversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden.

Jeder Aktionär kann einen Bevollmächtigten, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, durch Telekopie oder durch jede

Art von Fernmeldetechnik zu seiner Vertretung und zur Abstimmung bei einer Aktionärsversammlung ernennen.

Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der Aktionärsversammlung festzulegen.
Außer im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes werden die Beschlüsse, unbeschadet der Zahl der auf

der Aktionärsversammlung vertretenen Aktien, mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

Die Änderung der Satzung gemäss Artikel 67-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften verlangt die Präsenz oder

die Vertretung von wenigstens fünfzig (50%) Prozent des Gesellschaftskapitals und eine Zweidrittel (2/3) Mehrheit der
anwesenden oder vertretenen Aktien.

Jede Aktie gibt Anrecht auf ein Stimmrecht.
Die  Abschriften  oder  Auszüge  der  Versammlungsprotokolle,  welche  bei  Gericht  oder  anderswo  vorzulegen  sind,

werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Kapitel V. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats September und endet mit dem

letzten Tag des Monats August des darauffolgenden Jahres.

Der  Verwaltungsrat  bereitet  die  Jahresrechnung  entsprechend  den  luxemburgischen  Rechtsvorschriften  und  den

Buchhaltungsregeln vor.

Art. 19. Gewinnausschüttung. Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn sind 5% abzuziehen zur Speisung

des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfallt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel
des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Auf Empfehlung des Verwaltungsrates wird die Aktionärsversammlung über die Ausschüttung des Saldos des Reinge-

winnes entscheiden.

Die Aktionärsversammlung kann beschließen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve- oder

Provisionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Gesellschafter als Dividende zu verteilen.

Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen eine Anzahlung auf Dividende vornehmen.
Der Verwaltungsrat beschließt den Betrag und das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen wird.
Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurück-

kaufen.

Kapitel VI. - Auflösung, Liquidation

Art. 20. Auflösung, Liquidation. Die Aktionärsversammlung kann zu jeder Zeit unter denselben Bedingungen hinsichtlich

der  Beschlussfähigkeit  und  der  Mehrheit  wie  die,  die  für  eine  Satzungsänderung  erforderlich  sind,  die  Auflösung  der
Gesellschaft entscheiden, außer bei anderslautenden Gesetzesbestimmungen.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die

Aktionärsversammlung, welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

131531

Kapitel VII. - Geltendes Recht

Art. 21. Geltendes Recht. Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen

sich die Parteien auf das Gesetz vom 15. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungs-
gesetze.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und wird am letzten Tag des Monats

August 2008 enden.

2.- Die erste Generalversammlung wird mithin im Jahre 2009 stattfinden.

<i>Zeichnung und Zahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Statuten durch die Komparenten, vertreten wie eingangs erwähnt, werden die Aktien

wie folgt gezeichnet:

Aktien

1.- die ADAGIO STIFTUNG, vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Lic.iur. Christoph Langenauer, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Alle Aktien sind voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von einunddressigtausend Euro

(31.000,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Erklärung

Der  amtierende  Notar  erklärt,  dass  die  in  Artikel  26  des  abgeänderten  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die

Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Kosten

Die Auslagen, Kosten und Honorare jedweder Art welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Gründung er-

wachsen, werden abgeschätzt auf 1.900,- EUR.

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung

Die Komparenten, vertreten wie eingangs erwähnt, welche das gesamte Kapital vertreten und welche sich als rechts-

gültig einberufen erklären, haben sich in einer außergewöhnlichen Generalversammlung zusammengefunden.

Nachdem sie festgestellt haben, dass die Versammlung rechtsgültig einberufen wurde, haben sie einstimmig nachfol-

gende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt und folgende Mitglieder werden ernannt:
a) Herr Lic.iur. Christoph Langenauer, geboren in Rehetobel (Schweiz) am 31. März 1951, wohnhaft in CH-9042

Speicher, Schweiz, Hinterwies 42,

b) Herr Roger Frick, Wirtschaftsprüfer, geboren in Vaduz (Fürstentum Liechtenstein), am 7. August 1962, wohnhaft

in FL-9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, Aeulestrasse 5,

c) Herr Ronald Weber, Wirtschaftsprüfer, geboren in Maastricht (Niederlande), am 2. August 1953, berufsansässig in

L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy.

2. Die Zahl der Kommissare wird auf eins (1) festgesetzt und wird ernannt:
die  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  PKF  ABAX  AUDIT,  mit  Sitz  in  L-2212  Luxemburg,  6,  Place  de  Nancy,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 27.761.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars erlöschen mit dem Abschluss der jährlichen Aktio-

närsversammlung des Jahres 2010.

3. Der Gesellschaftssitz ist in L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem unterzeichneten Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Roemer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, LAC/2007/30596. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

131532

Luxemburg-Eich, den 25. Oktober 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007131540/206/216.
(070152336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Lux Cogeba Construction S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 7, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 60.332.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 24 octobre 2007.

<i>Pour LUX COGEBA CONSTRUCTION S.A R.L.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L
Signature

Référence de publication: 2007131538/1345/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08415. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070152257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Fek Immobilière SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5969 Itzig, 83, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 81.070.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 24 octobre 2007.

FEK IMMOBILIERE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007131537/1345/14.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08420. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Fondation Nicolas Lanners, Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.

R.C.S. Luxembourg G 116.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2006

<i>Actif

<i>Passif

EUR

EUR

Titres ayant le caractère d'immobilisations

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289.407,81

Dotation initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185.920,14

Avoirs en banques, CCP et encaisse . . . .

136.317,99

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235.492,04

Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . .

4.313,42

425.725,80

425.725,60

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2006

<i>Débit

<i>Crédit

EUR

EUR

Dépenses de la fondation . . . . . . . . . . . . .

27.340,-

Intérêts créditeurs sur dépôts à terme

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.607,59

Autres intérêts et charges assimilées . . . .

26,17

Dividendes obtenus . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.072,-

Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . .

4.313,42

Dons obtenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.000,-

31.679,59

31.679,59

<i>Dépenses de la fondation

Olympiade des mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000,-

131533

Concours informatique (CIL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500,-

ASSOC. DES JEUNES SCIENTIFIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500,-

Fraunhofer IKTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.340,-

PARTENARIAT UKRAINE DEUX LUXEMBOURG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,-

27.340,-

Référence de publication: 2007131675/1100/34.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09681. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Water and Sun S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 133.058.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the sixteenth day of October.
Before Us Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared the following:

LEGNOR TRADING S.A., having its registered office at Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
here represented by Mrs Cristina Floroiu with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Panama City on 2nd October 2007.
The said proxy, signed ne varietur by the party appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the Articles

of Association of a public limited liability company (société anonyme), which they form between themselves:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares

hereafter created a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg especially the law of May 11th, 2007 of private family assets management companies (sociétés de gestion
de patrimoine familial), and by the present Articles of Incorporation.

The private family assets management company under form of a public limited liability company will exist under the

name of WATER AND SUN S.A.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality by a resolution of the board of

directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the
ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures will
have no effect on to nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a Luxembourg Company.

Art. 3. Object. The object of the company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, without interfering in the management or the control of these companies.

The company may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The company may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary

thereto.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct

and substantial interest.

The company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development

of its purposes, always remaining however within the limits established by the law of May 11th, 2007 of private family
assets management companies (sociétés de gestion de patrimoine familial).

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

131534

The Company may be dissolved at any moment by a decision of the general meeting of shareholders resolving in the

same manner as for the amendment of these articles of incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The Company has an issued capital of thirty-five thousand euro (EUR 35,000.-), divided into

three hundred and fifty (350) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) per share fully paid-in.

Art. 6. Shares. The shares will be either in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of

shareholders, with the exception of those shares for which the law prescribes the registered form.

The Company may issue multiple share certificates.

Chapter III. Board of directors, Statutory auditor

Art. 7. Board of Directors. The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three

members who need not be shareholders.

The directors shall be elected by the shareholders' meeting, which shall determine their number, for a period not

exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting
of the shareholders ratifies the election at its next meeting.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors elects from among its members a chairman. It may

as well appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings
of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two

directors so require.

The chairman shall preside at all general meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence

the general meeting or the board of directors will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the
majority present at such meeting.

Written notices of any meeting of the board of directors will be given by letter or by telex to all directors at least 48

hours in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such
circumstances will be set forth in the notice of meeting. The notice indicates the place and agenda for the meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax of each director. No separate

notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, a written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content, each signed by one or several director(s).

Art. 9. Minutes of the Meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors will

be signed by the chairman of the meeting and by any other director. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman of the board of directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all

acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the
present articles of incorporation to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

The board of directors may decide to set up one or more committees whose members may but need not be directors.

In that case the board of directors shall appoint the members of such committee(s) and determine its powers.

Art. 11. Delegation of Powers. The board of directors may delegate the daily management of the Company and the

representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees
or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined
permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Art. 12. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of

any two directors or by the individual signature of the person to whom the daily management of the Company has been
delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom signatory
power has been delegated by the board but only within the limits of such power.

131535

Art. 13. Statutory Auditor. The Company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be share-

holders.

The statutory auditors shall be elected by the shareholders' meeting, which shall determine their number, for a period

not exceeding 6 years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

Chapter IV. General meeting of shareholders

Art. 14. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company

represents the entire body of shareholders. Subject to the provisions of article 10 above, it has the broadest powers to
order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 15. Annual General Meeting. The annual general meeting shall be held at the registered office of the Company or

at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the third Friday of April each year at 3.30
p.m.

If such day is a public holiday or a Sunday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. Other General Meetings. The board of directors or the statutory auditor may convene other general meetings.

Such meetings must be convened if shareholders representing at least one tenth of the Company's capital so require.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board of

directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 17. Procedure, Vote. Shareholders' meetings are convened by notice made in compliance with the provisions of

law.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax

as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders'

meeting.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by

a simple majority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman of the board or by any two directors.

Chapter V. Fiscal year, Allocation of profits

Art. 18. Fiscal Year. The Company's accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents, together

with a report on the operations of the Company, at least one month before the date of the annual general meeting to
the statutory auditor who will make a report containing his comments on such documents.

Art. 19. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) will be allocated to

the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the annual net profits will be disposed of It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or
to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as
dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board

of directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the

same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, either anticipatively or by expiration of its term, the liquidation will be carried out

by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and
their compensation.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 21. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance

with the law of 10th August 1915 governing commercial companies and law of May 11, 2007 of private family assets
management companies (sociétés de gestion de patrimoine familial), as amended.

131536

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the December

31st, 2008.

The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2009.

<i>Subscription

The articles of association of the Company having thus been established, the appearing parties declares to subscribe

all the three hundred and fifty (350) shares.

All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of thirty-five thousand euro (EUR 35,000.-)

is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand one hundred Euro
(€ 2,100.-)

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
The number of directors is fixed at three (3) and the number of statutory auditors at one (1).
The following are appointed directors:
1) M 

e

 Natacha Steuermann, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

2) M 

e

 Dominique Leonard, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

3) Ms Ingrid Lafond, residing professionally in Luxembourg,
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2013,
Has been appointed as chairman of the board of directors:
- M 

e

 Dominique Leonard, prenamed.

Has been appointed statutory auditor:
- FIDALPHA S.A. with registered office at 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.
Their term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2013.
The registered office of the Company is established in L-1840 Luxembourg, 11b, boulevard Joseph II.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing parties the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Eich.
The document having been read to the person appearing, the said person signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

LEGNOR TRADING S.A., ayant son siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands
ici représentée par Madame Cristina Floroiu, demeurant professionnellement à Luxembourg
en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Panama City, le 2 octobre 2007,
laquelle procuration, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis du notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une

société anonyme qu'il va constituer par les présentes:

Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront

propriétaires des actions ci-après créées une Société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-

131537

Duché de Luxembourg, de la loi du 11 mai 2007, sur les sociétés de gestion de patrimoine familial et par les présents
statuts.

La société de gestion de patrimoine familial sous forme de Société Anonyme adopte la dénomination WATER AND

SUN S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg-Ville.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la commune par une résolution du conseil d'adminis-

tration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce
siège ou entre ce siège et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré temporai-
rement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera une société luxem-
bourgeoise.

Art. 3. Objet. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

de capitaux luxembourgeoises ou étrangères, sans s'immiscer dans la gestion ou le contrôle de ces sociétés.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de
gestion de patrimoine familial.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans

les mêmes conditions que pour la modification des présents statuts.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital Social. La Société a un capital social émis de trente-cinq mille euros (35.000,- EUR), divisé en trois cent

cinquante (350) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action, entièrement libérées.

Art. 6. Actions. Les actions sont soit nominatives soit au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception des actions

pour lesquelles la loi prévoit la forme nominative.

La Société pourra émettre des certificats d'actions multiples.

Chapitre III. Conseil d'administration, Commissaire aux comptes

Art. 7. Conseil d'Administration. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres

au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause, il sera

pourvu  à  leur  remplacement  par  les  administrateurs  restants  conformément  aux  dispositions  de  la  loi.  Dans  ce  cas,
l'assemblée générale des actionnaires ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. Réunions du Conseil d'Administration. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Il pourra

également nommer un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur, qui sera responsable de la tenue des procès-
verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si

deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du conseil d'adminis-

tration, mais en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera à la majorité des membres
présents un autre administrateur pour présider la réunion.

Convocation écrite de toute réunion du conseil d'administration sera donné par lettre ou télex à tous les adminis-

trateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette
urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu et l'ordre du jour de
la réunion.

131538

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit ou par câble, télégramme, télex ou

télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une
date et à un endroit déterminés dans une annexe préalablement adoptée par une résolution du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d'urgence, une décision écrite, signée par l'ensemble des administrateurs, est régulière et valable comme si elle

avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs
administrateurs.

Art. 9. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil

d'administration seront signés par le président de la réunion et par tout autre administrateur. Les procurations resteront
annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du

conseil d'administration.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expres-
sément  à  l'assemblée  générale  des  actionnaires  par  la  loi  ou  les  présents  statuts  sont  de  la  compétence  du  conseil
d'administration.

Le conseil d'administration peut décider de constituer un ou plusieurs comités dont les membres seront administra-

teurs  ou  non.  En  pareille  hypothèse  le  conseil  d'administration  devra  nommer  les  membres  de  ce(s)  comité(s)  et
déterminer leurs pouvoirs.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoirs, employés ou autres personnes qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la société, ou conférer
des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions spécifiques permanentes ou temporaires à des personnes ou agents
de son choix.

Art. 12. Représentation de la Société. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux

administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée,
dans le cadre de cette gestion journalière, ou par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Commissaire aux Comptes. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, action-

naires ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils
peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans motif par l'assemblée générale.

Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société

régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité,
elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la Société.

Art. 15. Assemblée Générale Annuelle. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel

autre endroit indiqué dans les avis de convocations le troisième vendredi du mois d'avril chaque année à 15.30.

Si ce jour est un jour férié légal ou un dimanche l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Autres Assemblées Générales. Le conseil d'administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer

d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins
un dixième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.

Art. 17. Procédure, Vote. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de

l'assemblée générale, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées générales en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex

ou télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

131539

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les résolutions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la

majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée générale à produire en justice ou ailleurs sont signés par le

président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de

décembre de chaque année.

Le  conseil  d'administration  établit  le  bilan  et  le  compte  de  profits  et  pertes.  Au  moins  un  mois  avant  la  date  de

l'assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la Société, au
commissaire aux comptes qui établira son rapport contenant son commentaire sur ces documents.

Art. 19. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette
réserve légale atteindra le dixième (10%) du capital social souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des

bénéfices annuels nets restant. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de
réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme
dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la

loi. Le conseil d'administration déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant aux

mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification de ces statuts, sauf dispositions
contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit à l'échéance du terme, la liquidation s'effectuera par les

soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nominés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs
et leurs émoluments.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 21. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés

de gestion de patrimoine familial, telle que modifiée trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les
présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et sera clos au 31 décembre 2008.
La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en 2009.

<i>Souscription

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, la comparante déclare souscrire toutes les trois cent cinquante (350)

actions.

Toutes les actions ont été intégralement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de trente-cinq mille

euros (€ 35.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est estimé à environ deux mille cent Euros (€ 2.100,-)

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris a l'unanimité des voix les

résolutions suivantes:

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires aux comptes à un (1).
Sont nommés administrateurs:
1) M 

e

 Natacha Steuermann, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

131540

2) M 

e

 Dominique Leonard, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.

3) Mademoiselle Ingrid Lafond, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Leur mandat prendra fin lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2013.
Est nommé président du conseil d'administration:
- M 

e

 Dominique Leonard, prénommé.

Est nommé commissaire aux comptes:
- FIDALPHA S.A. ayant son siège social au 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2013.
Le siège social de la société est fixé à L-1840 Luxembourg, 11b, boulevard Joseph II
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu par nom, prénom état et demeure par le notaire

instrumentant celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Floroiu, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2007, LAC/2007/31549. — Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 25 octobre 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007131865/206/394.
(070152304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Great German Nursing Homes C, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 133.059.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the fifteenth day of October.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

PRESIDENTIAL NURSING HOMES HOLDINGS, a société à responsabilité limitée (private limited liability company)

incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2A, rue des
Capucins, L-1313 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123.143,
incorporated by a deed of the notary Paul Decker, on 13 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, C no. 281 on 1 March 2007

here represented by Mr Max Mayer, employee, residing in L-2551 Luxembourg, by virtue of a proxy given in London,

on September 24th, 2007.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it

has established as follows:

«Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially

the law of August 10th, 1915 on commercial companies such as amended.

Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,

whether furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in
real estate, and those concerning the placement and management of money.

The object of the Company is also to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,

commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any  activities  in  whatsoever  form,  as  well  as  the  management  and  development,  permanently  or  temporarily,  of  the
portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a financial participations company according to
the applicable provisions.

131541

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The private limited liable Company is incorporated under the name of GREAT GERMAN NURSING HOMES

C.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II. Capital - shares

Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by one hundred

(100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euros (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid
up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Art. 7.  If  there  is  more  than  one  shareholder,  the  transfer  of  shares  to  non-shareholders  is  subject  to  the  prior

unanimous approval of the shareholders. The Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per
share.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each shareholder who so requests.

Title III. Management

Art. 8. Board of managers.
8.1. The Company is managed by at least four managers, appointed by a resolution of the sole shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office of whom two shall be designated as Class A managers
and two shall be designated as Class B managers. The managers do not need to be shareholders.

8.2. The managers may be dismissed ad nutum by an unanimous vote of the board of managers of the sole shareholder

of the Company.

Art. 9. Powers of the board of managers.
9.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and
operations in accordance with the Company's object.

9.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either managers or

not, by any Class A manager and any Class B manager acting jointly.

Art. 10. Procedure.
10.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any manager in

accordance with any joint venture agreement entered into between the Shareholders from time to time.

10.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 72 hours in advance

of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be
set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

10.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers are present or represented at

the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting.
The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each
member of the board of managers.

10.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

10.5 The board of managers can validly deliberate and act only if at least one Class A Manager and one Class B Manager

is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast including
at least one Class A Manager and one Class B Manager. The resolutions of the board of managers will be recorded in
minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

10.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

131542

10.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 11. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of one

Class A Manager and one Class B Manager or by the single or joint signature(s) of any person(s) to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with article 9.2. of these Articles.

Title IV. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The sole shareholder exercises the powers devolved to a meeting of shareholders by the dispositions of the

foresaid law of August 10th, 1915.

12.2. If there is more than one shareholder, each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of Shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile
or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2  Any  shareholders'  decisions  are  only  validly  taken  by  unanimous  vote  of  the  board  of  managers  of  the  sole

shareholder of the Company.

Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 14. The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of the same year.

Art. 15. Each year, on the thirty-first day of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal

reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason
whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual contribution shall be
resumed until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole shareholder or distributed among the shareholders if there is more than one.

However, the sole shareholder or, as the case may be, a meeting of shareholders may decide, at the majority vote
determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.

Title VI. Dissolution

Art. 16. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a shareholder.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole shareholder or by a general meeting of shareholders.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts. The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole shareholder or, as the case may be,
distributed to the shareholders proportionally to the shares they hold.

Title VII. General provisions

Art. 17. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the shareholders shall refer to the

law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.»

<i>Subscription and Payment

All the shares have been entirely subscribed by the private liable company PRESIDENTIAL NURSING HOMES HOLD-

INGS, prenamed. They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred euros (EUR 12,500.-) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned
notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitory Provision

The first financial year shall begin on the day of incorporation and finish on 31 December 2008.

131543

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed

capital, acting as foresaid, has passed the following resolutions:

1) The following are appointed managers of the Company for an unlimited period:
(i) Claudia Daxelhoffer, residing in CH-8942 Oberrieden, Feldstrasse 8, as A Manager;
(ii) Isaac Schapira, born on 16 December 1952 in Jerusalem, Israel, business man, residing at 2, Danescroft Gardens,

London NW4 2ND, as A Manager;

(iii) Andrew Pettit, lawyer, born on 07 March 1968 in Cleethorpes, United Kingdom, having its professional address

at 20 Balderton Street, London W1K 6TL, United Kingdom as B Manager; and

(iv)  Matthias  Wilke,  banker,  born  on  23  April  1972  in  Diez/Lahn,  Germany,  having  its  professional  address  at  20

Balderton Street, London W1K 6TL, United Kingdom, as B Manager.

2) Mrs Claudia Daxelhoffer, prenamed, is authorised to sign all Bank transactions by her sole signature.
3) The Company shall have its registered office at L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins.

<i>Estimate of cost

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 1,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation. Upon request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahr zweitausendundsieben, den fünfzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

PRESIDENTIAL NURSING HOMES HOLDINGS, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wirksam gegründet und

bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 2A, rue des Capucins in L-1313 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg unter Sektion B, Nummer
123.143, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den Notar Paul Decker, am 13. Dezember 2006, veröffentlicht
im Mémorial C, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg vom 1. März 2007, Nummer 281

hier vertreten durch Herrn Max Mayer, Angestellter, wohnhaft in L-2551 Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht

gegeben in London am 24. September 2007.

Diese Vollmacht soll nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den instrumentierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit ihr einregistriert zu werden.

Diese Komparentin, vertreten wie vorgenannt, beabsichtigt, eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung

zu gründen, die folgende Satzung haben soll:

«Titel I. Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) errichtet, welche

durch geltendes Gesetzesrecht, insbesondere durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in
der jeweils geltenden Fassung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Weiterentwicklung, der Verkauf und die Vermietung

von jeglichen Immobilien, seien sie möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Immobiliengeschäfte, mit Ausnahme
derjenigen, welche einem Immobilienhändler vorbehalten sind und derjenigen, welche die Platzierung von Geld und die
Vermögensverwaltung betreffen.

Zweck der Gesellschaft ist es außerdem, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle industriellen, kommerziellen,

finanziellen, privaten oder immobilienbezogenen Transaktionen, egal welcher Form, vorzunehmen, die in direktem Zu-
sammenhang stehen mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung, egal welcher Form, von jeglichen Unternehmen
und Gesellschaften, welche die Ausführung von jeglichen Geschäften in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftszweck,
sowie die dauerhafte oder vorübergehende Verwaltung und Entwicklung des Portfolios, welches zu diesem Zweck ge-
schaffen ist, zum Zweck haben. Die Gesellschaft soll als Beteiligungsgesellschaft (Société de Participation Financière) gemäß
den einschlägigen Bestimmungen betrachtet werden. Die Gesellschaft kann sich in jeder Form beteiligen an Geschäften,
Unternehmen und Gesellschaften, welche einen mit dem Gesellschaftszweck identischen, ähnlichen oder verbundenen
Zweck verfolgen oder welche die Entwicklung oder Ausweitung ihrer Tätigkeit fördern.

131544

Art. 3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung besteht unter dem Namen GREAT GERMAN NURSING HOMES

C.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Er kann in jede andere Ortschaft des Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.

Titel II. Kapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert

(100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), alle voll gezeichnet und vollens
eingezahlt.

Jeder Anteil gewährt das Recht an einem Bruchteil des Vermögens und des Gewinns der Gesellschaft proportional

zur bestehenden Anzahl der Anteile.

Art. 7. Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind Anteilsübertragungen an Nichtgesellschafter nur mit dem vorherigen,

einstimmigen Einverständnis der Gesellschafter möglich.

Die Anteile sind unteilbar, da nur ein Eigentümer pro Anteil anerkannt wird. Eine Anteilsübertragung ist für die Ge-

sellschaft oder Dritte erst rechtsverbindlich nach Eingang an oder Annahme durch die Gesellschaft gemäß den Bestim-
mungen des Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches (Code Civil)

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wird am Sitz der Gesellschaft ein Gesellschafter-Register geführt, in welches

jeder Gesellschafter auf Verlangen Einsicht nehmen kann.

Titel III. Geschäftsführung

Art. 8. Verwaltungsrat.
8.1. Die Gesellschaft wird durch mindestens vier Verwaltungsratsmitglieder verwaltet, welche durch Beschluss des

Alleingesellschafters, oder der Generalversammlung der Gesellschafter, der gleichzeitig die Amtsdauer festsetzt, ernannt
werden; zwei werden als Kategorie A Verwaltungsratsmitglieder bezeichnet und zwei als Kategorie B Verwaltungsrats-
mitglieder. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen nicht Gesellschafter sein.

8.2. Die Verwaltungsratsmitglieder können ad nutum durch einstimmigen Beschluss des Verwaltungsrats des Allein-

gesellschafters von ihrem Posten enthoben werden.

Art. 9. Aufgaben des Verwaltungsrats.
9.1. Jegliche Aufgaben, welche nicht gemäß dem Gesetz, oder den Bestimmungen der vorliegenden Satzung der Ge-

sellschafterversammlung  vorbehalten  sind,  fallen  in  den  Kompetenzbereich  des  Verwaltungsrats,  welcher  befugt  ist  ,
jegliche Geschäfte im Rahmen des Geschäftszweckes auszuführen und zu bewilligen.

9.2. Jedes Kategorie A Verwaltungsratmitglied und jedes Kategorie B Verwaltungsratmitglied, jeweils gemeinsam han-

delnd, können für bestimmte Fälle eine umfänglich begrenzte Sondervollmacht an ein Verwaltungsratsmitglied oder an
einen Dritten erteilen.

Art. 10. Verfahren.
10.1. Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen, wie die Interessen der Gesellschaft es verlangen, oder auf Wunsch

jedes Verwaltungsratsmitgliedes gemäß den Bestimmungen möglicher, von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern
eingegangener Gemeinschaftsunternehmensabkommen.

10.2. Die schriftliche Anzeige einer Verwaltungsratskonferenz muss wenigstens 72 Stunden vor dem Datum der Kon-

ferenz an alle Verwaltungsratsmitglieder geschickt werden, außer im Notfall, in welchem Fall der Notfall im Einberu-
fungsschreiben beschrieben werden muss.

10.3 Ein solches Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder

vertreten sind und bestätigen, eingehend informiert gewesen zu sein sowie die Tagesordnung zu kennen. Jedes Verwal-
tungsratsmitglied kann schriftlich auf das Einberufungsschreiben verzichten, sei es per Originalschreiben, per Telegramm,
Telex, Faxschreiben oder E-Mail.

10.4. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf einer Konferenz Handlungen vornehmen, indem es ein anderes Verwal-

tungsratsmitglied schriftlich zu seinem Stellvertreter benennt.

10.5. Der Verwaltungsrat kann nur wirksam beraten und handeln, wenn jeweils mindestens ein Kategorie A Mitglied

und ein Mitglied der Kategorie B anwesend oder vertreten sind. Verwaltungsratsbeschlüsse werden mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, wobei jeweils ein Kategorie A Mitglied und ein Kategorie B Mitglied zustimmen müssen.
Die Verwaltungsratsbeschlüsse werden in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, das von allen anwesenden oder vertre-
tenen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet wird.

10.6. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung per Telefon- oder Videokonferenz oder

einem anderen gleichwertigen Kommunikationsmittel, welches es den Teilnehmern erlaubt, einander zu verstehen und
miteinander zu sprechen, teilnehmen. Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung mit ebensolchen Kommunikati-
onsmitteln wird wie eine persönliche Teilnahme des Verwaltungsratsmitgliedes an einer Verwaltungsratssitzung angese-
hen.

131545

10.7. Umlaufbeschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind, sind gültig und verbindlich

wie Beschlüsse, welche im Laufe einer einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung getroffen wurden. Die
Unterschriften können sich in einem einzigen Dokument oder in mehreren identischen Kopien des Umlaufbeschlusses
befinden und können durch Telefax oder Brief nachgewiesen werden.

Art. 11. Vertretung. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten rechtskräftig verpflichtet durch die gemeinschaftliche

Unterschrift jeweils eines Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A und eines Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B
oder durch die alleinige oder gemeinschaftliche Unterschrift der Person oder der Personen, an welche Vertretungsmacht
gemäß den Bestimmungen von Artikel 9.2. der vorliegenden Satzung übertragen wurde.

Titel IV. Entscheidungen des Alleingesellschafters

Gemeinsame Entscheidungen mehrerer Gesellschafter

Art. 12. Befugnisse und Stimmrechte.
12.1 Der Alleingesellschafter übt die Befugnisse aus, die gemäß den Bestimmungen des oben genannten Gesetzes vom

10. August 1915 der Gesellschafterversammlung übertragen sind.

12.2 Falls es mehrere Gesellschafter gibt, hat jeder von ihnen Stimmrechte proportional zu den von ihm gehaltenen

Gesellschaftsanteilen.

12.3 Jeder Gesellschafter kann jede natürliche oder juristische Person zu seinem Bevollmächtigten zur Vertretung bei

Generalversammlungen ernennen, und zwar durch schriftliche Vollmacht in Form eines Briefes, Telegramms, Telex, Te-
lefax oder einer E-Mail.

Art. 13 Form - Quorum - Mehrheit.
13.1 Falls die Anzahl der Gesellschafter 25 oder weniger beträgt können Gesellschafterbeschlüsse durch Umlaufbe-

schluss gefasst werden, deren Text allen Gesellschaftern schriftlich, sei es als Original oder per Telegramm, Telex, Telefax
oder E-Mail, gesendet sein muss. Die Gesellschafter geben ihre Stimme ab, indem sie den Umlaufbeschluss unterzeichnen.
Die Unterschriften der Gesellschafter können sich in einem einzigen Dokument oder in mehreren identischen Kopien
des Umlaufbeschlusses befinden und können durch Telefax oder Brief nachgewiesen werden.

13.2 Gesellschafterbeschlüsse können nur durch einstimmigen Beschluss des Verwaltungsrats des Alleingesellschafters

gefasst werden.

Titel V. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des gleichen Jahres.

Art. 15. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per einunddreißigsten Dezember, werden ein Bericht über die der

Aktiva und Passiva der Gesellschaft und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Der  Saldo  der  Gewinn-  und  Verlustrechnung,  abzüglich  Aufwendungen,  Kosten,  Belastungen  Abschreibungen  und

Rückstellungen ist der Nettogewinn der Gesellschaft.

Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft der gesetzlichen Reserve der Ge-

sellschaft zugeführt, solange bis die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt
aus welchem Grunde auch immer die gesetzliche Reserve unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals fallen, so muss die
jährliche Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden bis das Ein-Zehntel-Verhältnis wieder hergestellt ist.

Der Überschuss wird dem Alleingesellschafter zugeteilt oder, falls mehrere Gesellschafter vorhanden sind, unter diesen

verteilt. Dieser bzw. diese können jedoch durch Mehrheitsentscheidung gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen  entscheiden,  dass  der  Gewinn,  nach  Abzug  jeglicher  Reserven,  auf  das  folgende  Jahr  übertragen  oder  einer
außergesetzlichen Reserve zugeführt wird.

Titel VI. Auflösung

Art. 16. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die Insolvenz, die gerichtliche Entmündigung oder die

Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters aufgelöst.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation vom oder von den Verwaltungsratsmitglied(ern) im

Amt oder, in Ermangelung dessen, von einem oder mehreren Liquidatoren, vom Alleingesellschafter oder von der Ge-
neralversammlung der Gesellschafter ernannt, ausgeführt. Der oder die Liquidator(en) ist bzw. sind mit umfassenden
Vollmachten zur Realisierung der Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.

Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, dem Alleingesellschafter zugeteilt, oder gegebenenfalls

unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile aufgeteilt.

Titel VII. Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Auf alle Angelegenheiten, die in der vorliegenden Satzung nicht geregelt sind, finden die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.»

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle Anteile wurden gezeichnet durch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRESIDENTIAL NURSING HOMES

HOLDINGS, vorgenannt, und vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von zwölftau-

131546

sendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfugung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde,
der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt zum Gründungszeitpunkt und endet am 31. Dezember 2008.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der Alleingesellschafter welcher das Gesamtkapital vertritt, folgende Be-

schlüsse gefasst:

1) Es werden zu Verwaltungsratsmitgliedern auf unbestimmte Zeit ernannt:
(i) Frau Claudia Daxelhoffer, wohnhaft in CH-8942 Oberrieden, Feldstrasse, 8, zum Verwaltungsratsmitglied der Ka-

tegorie A,

(ii) Herrn Isaac Schapira, Kaufmann, geboren am 16. Dezember 1952 in Jerusalem, Israel, wohnhaft in 2, Danescroft

Gardens, London NW4 2ND, Großbritannien, zum Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A,

(iii) Herrn Andrew Pettit, Anwalt, geboren am 7. Mai 1968 in Cleethorpes, England, mit beruflichem Sitz in 20 Baiderton

Street, London W1K 6TL, Großbritannien, zum Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B,

(iv) Herrn Matthias Wilke, Bänker, geboren am 23. April 1972 in Diez/Lahn, Deutschland, mit beruflichem Sitz in 20

Baiderton Street, London W1K 6TL, Großbritannien, zum Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B.

2) Frau Claudia Daxelhoffer, vorbenannt, ist autorisiert alle Bankabwicklungen durch ihre alleinige Unterschrift zu

tätigen.

3) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1313 Luxemburg, 2a, rue des Capucins.

<i>Kostenschätzung

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Gebühren, Vergütungen und Auslagen in welcher Form auch immer, welche

die Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde zu tragen hat, oder welche ihr im Zusammenhang mit ihr auferlegt werden,
beläuft sich auf ungefähr 1.500,- EUR.

Der unterzeichnete Notar, welcher englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass der Text der vorliegenden

Satzung auf Wunsch der Erschienenen in englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, dass es der Wunsch der Erschienenen ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text der englische Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung und Erklärung an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Mayer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2007, LAC/2007/31205. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Jungers.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 25. Oktober 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007131864/206/339.
(070152307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Moda Brand Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 66.431.

Le bilan de la société au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007131595/5387/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ03950. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

131547

Euroholding Fashion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 42.772.

Le bilan de la société au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007131587/5387/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ03902. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070151915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

V2I Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 65.378.

Le bilan de la société au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007131585/5387/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ03921. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Jasperus, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 129.814.

RECTIFICATIF

Il s'est avéré qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la version française de l'acte de constitution de la société

anonyme JASPERUS, ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, qui a été signé le 3 juillet 2007,
concernant la conclusion du rapport du réviseur d'entreprises HRT REVISION Sàrl,

Laquelle se lit en version anglaise:

<i>«Conclusion

Based on the work performed and described above, we have no comments on the value of the contribution in kind

which corresponds at least in number and nominal value to the 1,239 shares with a nominal value of EUR 1.000.- each to
be issued».

Et en version française:

<i>«Conclusion

Based on the work performed and described above, we have no comments on the value of the contribution in kind

which corresponds at least in number and nominal value to the 417 shares with a nominal value of EUR 1.000,- each to
be issued.»

A savoir qu'en lieu et place des «417 shares» en la version française il y a lieu de lire «1,239 shares».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 2 octobre 2007.

P. Bettingen
<i>Le notaire

Référence de publication: 2007131552/202/26.
(070151983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

131548

T.S. Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4385 Ehlerange, Zare Ilôt Est.

R.C.S. Luxembourg B 46.051.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour T.S. LUX SA
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2007131580/514/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07065. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070151903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Books and Beans S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 81.004.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BOOKS AND BEANS SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2007131581/514/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07034. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

V2I Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 65.378.

Le bilan de la société au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007131583/5387/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ03914. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Ceratungsten, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4578 Niedercorn, 21, Zone Industrielle Hâneboesch.

R.C.S. Luxembourg B 24.496.

Le bilan au 28 février 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007131561/1100/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09398. - Reçu 48 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

131549

Moda Brand Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 66.431.

Le bilan de la société au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007131594/5387/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ03949. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070151926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Interstyle Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 40.556.

Le bilan de la société au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007131591/5387/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ03935. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Euroholding Fashion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 42.772.

Le bilan de la société au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007131589/5387/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ03894. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Ceratizit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.

R.C.S. Luxembourg B 4.610.

Le bilan au 28 février 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007131564/1100/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09402C. - Reçu 60 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

131550

De Herrero Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 133.039.

STATUTS

L'an deux mille sept, le seize octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Luciano Pinelli, homme d'affaires, né le 6 avril 1948 à Sassuolo (MO) Italie, demeurant à 11000 Prague

(République  Tchèque),  Konvitska  5/263,  ci-après  représenté  par  Monsieur  Antonio  Fernandes,  employé  privé,  avec
adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé
donnée à Luxembourg le 18 septembre 2007;

2) Monsieur Mario Pinelli, dirigeant de sociétés, né le 14 mars 1977 à Modena (MO) Italie, demeurant à Via Radici, 3,

I-41043  Corlo  Di  Formigine  (MO)  Italie,  ci-après  représenté  par  Monsieur  Antonio  Fernandes,  employé  privé,  avec
adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé
donnée à Luxembourg le 18 septembre 2007;

3) Monsieur Francesco Pinelli, dirigeant de sociétés. né le 16 décembre 1979 à Modena (MO) Italie, demeurant à Via

Radici, 3, I-41043 Corlo Di Formigine (MO) Italie, ci-après représenté par Monsieur Antonio Fernandes, employé privé,
avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, agissant en vertu d'une procuration sous seing
privé donnée à Luxembourg le 18 septembre 2007.

Les procurations susmentionnées resteront annexées au présent acte afin d'être soumises en même temps à la for-

malité de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: DE HERRERO MANAGEMENT S.A. société ano-
nyme.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale

des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d'adminis-

tration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra même
être transféré à l'étranger, sur simple décision du conseil d'administration, lorsque des événements extraordinaires d'or-
dre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient
imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-

bourgeoise.

En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité

étrangère ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime de tous les associés et de tous les obligataires réunis en
assemblée générale extraordinaire et plénière.

La Société peut décider sa transformation de société anonyme en société européenne (S.E.) de droit luxembourgeois.
La  Société  peut,  par  décision  du  conseil  d'administration,  créer,  tant  dans  le  Grand-Duché  de  Luxembourg  qu'à

l'étranger, des filiales, sièges secondaires, succursales, agences et bureaux.

Art. 4. La Société a principalement pour objet d'effectuer, contre rémunérations et comme prestataire, tous services

de gestion à un fonds d'investissement spécial agréé, existant selon le droit luxembourgeois constitué à Luxembourg par
acte notarié reçu en date du 16 octobre 2007 par M 

e

 Martine Schaeffer de Luxembourg, conformément aux dispositions

de la loi modifiée du 13 février 2007 sur les fonds d'investissements spécialisés et les lois sur les sociétés, et dont les
statuts sont en cours de publication.

En vue de l'accomplissement de son objet social la Société peut effectuer toutes opérations et prester tous services

et concours nécessaires ou utiles à cette gestion, dans le cadre des conventions valablement conclues avec le fonds.

Dans le cadre de l'accomplissement de son objet social, la Société peut d'une manière générale effectuer toutes opé-

rations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et prester tous services, tant au Grand-Duché
de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet
social.

131551

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix)

actions d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Les actions sont émises soit au porteur soit sous la forme nominative, au choix de l'actionnaire.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
La Société peut exister avec un seul actionnaire

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus.
Les administrateurs seront de deux catégories, à savoir des administrateurs de catégorie A et des administrateurs de

catégorie B.

L'assemblée générale détermine le nombre des administrateurs de catégorie A et le nombre des administrateurs de

catégorie B. Le nombre total des administrateurs, catégories A et B confondues, devra toujours être de trois au mois et
de neuf au plus.

Dans les réunions du conseil d'administration tous les administrateurs, qu'il soit de catégorie A ou de catégorie B, ont

les mêmes prérogatives, notamment de vote.

Tous les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en

son sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale

devient vacant, les mandats de tous les administrateurs prennent automatiquement et immédiatement fin, sans possibilité
de pourvoir provisoirement à un remplacement par voie de cooptation. Dans un tel cas, l'assemblée générale devra être
convoquée sans délai par les administrateurs restants d'après les délais et modalités prévues dans la loi, et afin que, lors
de cette réunion, l'assemblée générale procède à la recomposition complète du conseil d'administration.

Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions

du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-
même.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette

mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il repré-
sente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité

que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes,

sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la
société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des
cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux
sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir

tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de
ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective d'au moins un administrateur de la catégorie A et d'au

moins un administrateur de la catégorie B, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil
d'administration.

Au fins de clarifier la paragraphe qui précède il est précisé que la Société ne se trouve pas engagée par des signatures

conjointes d'administrateurs de catégorie A seuls, ni par des signatures cointes d'administrateurs de catégorie B seuls.

Tout administrateur peut prendre connaissance de toutes les informations qui sont transmises au conseil d'adminis-

tration.

La  délégation  des  pouvoirs  de  la  gestion  journalière  à  un  membre  du  conseil  d'administration  ou  l'attribution  de

pouvoirs spéciaux à un tel membre impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale
ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué ou à ces autres administrateurs.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, représentée

par son conseil d'administration.

131552

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent. Il est convoqué par

son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter dans les réunions du conseil d'administration par un de ses collègues.

Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n'a

pas de voix prépondérante.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d'administration peut délibérer au moyen d'un réseau de visioconférences. La délibération est mise en réseau

à partir du siège social. Le procès-verbal des délibérations arrêtées par visioconférence est rédigé au siège social par le
secrétaire du conseil d'administration.

Il est envoyé aux membres du conseil d'administration endéans les quinze jours de la réunion. Ceux-ci feront connaître

par écrit au secrétaire leur approbation ou leurs objections.

Si au cours d'une délibération par visioconférence une dissidence substantielle entre les membres du conseil d'admi-

nistration devait naître, tout administrateur est en droit de demander le renvoi du sujet qui en est à l'origine à une
prochaine réunion du conseil d'administration qui se tiendra endéans les 30 jours à Luxembourg, les membres étant
physiquement présents ou dûment représentés. Le premier alinéa de cet article est d'application.

A défaut d'autres dispositions plus restrictives prévues dans le règlement intérieur sont réputés présents pour le calcul

du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration par visioconférence
ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéris-
tiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises
de façon continue.

Toute réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.
La Société peut à son choix établir un règlement intérieur contraignant pour tous les administrateurs, qui arrête toutes

autres mesures complémentaires relatives aux réunions qui se tiennent à distance.

Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont

dans ce cas transmises par écrit aux membres du conseil d'administration qui font connaître leurs décisions en retour et
par écrit. Les décisions sont considérées prises si une majorité d'administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d'administration. Les extraits des décisions du conseil d'adminis-

tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour

un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et un

décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d'administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l'annexe aux comptes annuels.

Art. 12. Le conseil d'administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale quand

ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque
des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du
jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour.
L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander

l'inscription d'un ou de plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est
adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.

Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d'ad-

ministration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d'administration peut subordonner l'admission des propriétaires d'actions au porteur au dépôt

préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit à
une voix.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2 

ème

 vendredi du mois de juin à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la

décharge des organes sociaux.

131553

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)

pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le
dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration est autorisé à procéder en cours d'exercice au versement d'acomptes sur dividendes aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire et ratifier tous les actes qui intéressent la

Société.

Sauf pour les cas où la loi requiert un quorum ou une majorité plus strictes, les assemblées générales modificatives

des statuts ne pourront valablement adopter des résolutions que lorsqu'au moins une majoritaire des deux tiers de tous
les actionnaires est présente ou valablement représentée en première convocation, respectivement qu'une majorité d'au
moins cinquante et un pourcent de tous les actionnaires est présente ou valablement représentée lorsque l'assemblée
est appelé à délibérer en deuxième convocation. Les résolutions des assemblées modificatives des statuts sont valablement
adoptés à la majorité des deux tiers de toua les actionnaires présents ou représentés, que l'assemblée modificative des
statuts délibère en première ou en seconde convocation.

Art. 16. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2007.
La première assemblée générale annuelle se réunit en 2008.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Actions

1.- Monsieur Luciano Pinelli, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

304

2.- Monsieur Francesco Pinelli, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

3.- Monsieur Mario Pinelli, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

310

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en
a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales

et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à 2.000,- EUR (deux mille euros ).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l'unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre total des administrateurs, catégories A et B confondues, est fixé à 3 (trois).
Le nombre des administrateurs de catégorie A est fixé à 1 (un)
Le nombre des administrateurs de catégorie B est fixé à 2 (deux).
Est nommés aux fonctions d'administrateurs de catégorie A:
Monsieur Luciano Pinelli, homme d'affaires, né le 6 avril 1948 à Sassuolo (MO) Italie, demeurant à 11000 Prague

(République Tchèque), Konvitska 5/263.

Sont nommés aux fonctions d'administrateur de catégorie B:
1) Monsieur Mario Pinelli, dirigeant de sociétés, né le 14 mars 1977 à Modena (MO) Italie, demeurant à Via Radici, 3,

I-41043 Corlo Di Formigine (MO) Italie;

2) Monsieur Francesco Pinelli, dirigeant de sociétés, né le 16 décembre 1979 à Modena (MO) Italie, demeurant à Via

Radici, 3, I-41043 Corlo Di Formigine (MO) Italie.

131554

<i>Deuxième résolution

Le nombre des commissaires est comptes est fixé à 1 (un).
Est nommé commissaire aux comptes:
La société anonyme EUROPEAN ADMINISTRATIVE SERVICES AND INFORMATION TECHNOLOGY S.A. (EASIT

S.A.), avec siège social à L-8805 Rambrouch, 33, rue Principale.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

statutaire qui se tiendra en 2013.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg. Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Fernandes, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007, LAC/2007/32218. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007131871/5770/237.
(070151994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Great German Nursing Homes E, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 133.030.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the fifteenth day of October.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

PRESIDENTIAL NURSING HOMES HOLDINGS, a société à responsabilité limitée (private limited liability company)

incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2A, rue des
Capucins, L-1313 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123.143,
incorporated by a deed of the notary Paul Decker, on 13 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, C no. 281 on 1 March 2007

here represented by Mr Max Mayer, employee, residing in L-2551 Luxembourg, by virtue of a proxy given in London,

on September 24th, 2007.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it

has established as follows:

«Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially

the law of August 10th, 1915 on commercial companies such as amended.

Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,

whether furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in
real estate, and those concerning the placement and management of money.

The object of the Company is also to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,

commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any  activities  in  whatsoever  form,  as  well  as  the  management  and  development,  permanently  or  temporarily,  of  the
portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a financial participations company according to
the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The private limited liable Company is incorporated under the name of GREAT GERMAN NURSING HOMES

E.

131555

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II. Capital - shares

Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by one hundred

(100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euros (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid
up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Art. 7.  If  there  is  more  than  one  shareholder,  the  transfer  of  shares  to  non-shareholders  is  subject  to  the  prior

unanimous approval of the shareholders. The Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per
share.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each shareholder who so requests.

Title III. Management

Art. 8. Board of managers.
8.1. The Company is managed by at least four managers, appointed by a resolution of the sole shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office of whom two shall be designated as Class A managers
and two shall be designated as Class B managers. The managers do not need to be shareholders.

8.2. The managers may be dismissed ad nutum by an unanimous vote of the board of managers of the sole shareholder

of the Company.

Art. 9. Powers of the board of managers.
9.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and
operations in accordance with the Company's object.

9.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either managers or

not, by any Class A manager and any Class B manager acting jointly.

Art. 10. Procedure.
10.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any manager in

accordance with any joint venture agreement entered into between the Shareholders from time to time.

10.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 72 hours in advance

of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be
set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

10.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers are present or represented at

the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting.
The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each
member of the board of managers.

10.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

10.5 The board of managers can validly deliberate and act only if at least one Class A Manager and one Class B Manager

is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast including
at least one Class A Manager and one Class B Manager. The resolutions of the board of managers will be recorded in
minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

10.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

10.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 11. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of one

Class A Manager and one Class B Manager or by the single or joint signature(s) of any person(s) to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with article 9.2. of these Articles.

131556

Title IV. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The sole shareholder exercises the powers devolved to a meeting of shareholders by the dispositions of the

foresaid law of August 10th, 1915.

12.2. If there is more than one shareholder, each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of Shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile
or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2  Any  shareholders'  decisions  are  only  validly  taken  by  unanimous  vote  of  the  board  of  managers  of  the  sole

shareholder of the Company.

Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 14. The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of the same year.

Art. 15. Each year, on the thirty-first day of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal

reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason
whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual contribution shall be
resumed until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole shareholder or distributed among the shareholders if there is more than one.

However, the sole shareholder or, as the case may be, a meeting of shareholders may decide, at the majority vote
determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.

Title VI. Dissolution

Art. 16. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a shareholder. In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager
or managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole shareholder or by a general meeting
of shareholders. The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets
and the payment of debts. The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole shareholder or, as
the case may be, distributed to the shareholders proportionally to the shares they hold.

Title VII. General provisions

Art. 17. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the shareholders shall refer to the

law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.»

<i>Subscription and Payment

All the shares have been entirely subscribed by the private liable company PRESIDENTIAL NURSING HOMES HOLD-

INGS, prenamed. They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred euros (EUR 12,500.-) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned
notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitory Provision

The first financial year shall begin on the day of incorporation and finish on 31 December 2008.

<i>Resolutions of the Sole Shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed

capital, acting as foresaid, has passed the following resolutions:

1) The following are appointed managers of the Company for an unlimited period:
(i) Claudia Daxelhoffer, residing in CH-8942 Oberrieden, Feldstrasse 8, as A Manager;
(ii) Isaac Schapira, born on 16 December 1952 in Jerusalem, Israel, business man, residing at 2, Danescroft Gardens,

London NW4 2ND, as A Manager;

(iii) Andrew Pettit, lawyer, born on 07 March 1968 in Cleethorpes, United Kingdom, having its professional address

at 20 Balderton Street, London W1K 6TL, United Kingdom as B Manager; and

131557

(iv)  Matthias  Wilke,  banker,  born  on  23  April  1972  in  Diez/Lahn,  Germany,  having  its  professional  address  at  20

Balderton Street, London W1K 6TL, United Kingdom, as B Manager.

2) Mrs Claudia Daxelhoffer, prenamed, is authorised to sign all Bank transactions by her sole signature.
3) The Company shall have its registered office at L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins.

<i>Estimate of cost

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 1,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation. Upon request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahr zweitausendundsieben, den fünfzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

PRESIDENTIAL NURSING HOMES HOLDINGS, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wirksam gegründet und

bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 2A, rue des Capucins in L-1313 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg unter Sektion B, Nummer
123.143, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den Notar Paul Decker, am 13. Dezember 2006, veröffentlicht
im Mémorial C, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg vom 1. März 2007, Nummer 281

hier vertreten durch Herrn Max Mayer, Angestellter, wohnhaft in L-2551 Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht

gegeben in London am 24. September 2007.

Diese Vollmacht soll nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den instrumentierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit ihr einregistriert zu werden.

Diese Komparentin, vertreten wie vorgenannt, beabsichtigt, eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung

zu gründen, die folgende Satzung haben soll:

«Titel I. Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) errichtet, welche

durch geltendes Gesetzesrecht, insbesondere durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in
der jeweils geltenden Fassung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Weiterentwicklung, der Verkauf und die Vermietung

von jeglichen Immobilien, seien sie möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Immobiliengeschäfte, mit Ausnahme
derjenigen, welche einem Immobilienhändler vorbehalten sind und derjenigen, welche die Platzierung von Geld und die
Vermögensverwaltung betreffen.

Zweck der Gesellschaft ist es außerdem, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle industriellen, kommerziellen,

finanziellen, privaten oder immobilienbezogenen Transaktionen, egal welcher Form, vorzunehmen, die in direktem Zu-
sammenhang stehen mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung, egal welcher Form, von jeglichen Unternehmen
und Gesellschaften, welche die Ausführung von jeglichen Geschäften in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftszweck,
sowie die dauerhafte oder vorübergehende Verwaltung und Entwicklung des Portfolios, welches zu diesem Zweck ge-
schaffen ist, zum Zweck haben. Die Gesellschaft soll als Beteiligungsgesellschaft (Société de Participation Financière) gemäß
den einschlägigen Bestimmungen betrachtet werden. Die Gesellschaft kann sich in jeder Form beteiligen an Geschäften,
Unternehmen und Gesellschaften, welche einen mit dem Gesellschaftszweck identischen, ähnlichen oder verbundenen
Zweck verfolgen oder welche die Entwicklung oder Ausweitung ihrer Tätigkeit fördern.

Art. 3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung besteht unter dem Namen GREAT GERMAN NURSING HOMES

E.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Er kann in jede andere Ortschaft des Großherzogtum Lu-

xemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.

Titel II. Kapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert

(100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), alle voll gezeichnet und vollens
eingezahlt.

131558

Jeder Anteil gewährt das Recht an einem Bruchteil des Vermögens und des Gewinns der Gesellschaft proportional

zur bestehenden Anzahl der Anteile.

Art. 7. Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind Anteilsübertragungen an Nichtgesellschafter nur mit dem vorherigen,

einstimmigen Einverständnis der Gesellschafter möglich.

Die Anteile sind unteilbar, da nur ein Eigentümer pro Anteil anerkannt wird. Eine Anteilsübertragung ist für die Ge-

sellschaft oder Dritte erst rechtsverbindlich nach Eingang an oder Annahme durch die Gesellschaft gemäß den Bestim-
mungen des Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches (Code Civil)

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wird am Sitz der Gesellschaft ein Gesellschafter-Register geführt, in welches

jeder Gesellschafter auf Verlangen Einsicht nehmen kann.

Titel III. Geschäftsführung

Art. 8. Verwaltungsrat.
8.1. Die Gesellschaft wird durch mindestens vier Verwaltungsratsmitglieder verwaltet, welche durch Beschluss des

Alleingesellschafters, oder der Generalversammlung der Gesellschafter, der gleichzeitig die Amtsdauer festsetzt, ernannt
werden; zwei werden als Kategorie A Verwaltungsratsmitglieder bezeichnet und zwei als Kategorie B Verwaltungsrats-
mitglieder. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen nicht Gesellschafter sein.

8.2. Die Verwaltungsratsmitglieder können ad nutum durch einstimmigen Beschluss des Verwaltungsrats des Allein-

gesellschafters von ihrem Posten enthoben werden.

Art. 9. Aufgaben des Verwaltungsrats.
9.1. Jegliche Aufgaben, welche nicht gemäß dem Gesetz, oder den Bestimmungen der vorliegenden Satzung der Ge-

sellschafterversammlung  vorbehalten  sind,  fallen  in  den  Kompetenzbereich  des  Verwaltungsrats,  welcher  befugt  ist,
jegliche Geschäfte im Rahmen des Geschäftszweckes auszuführen und zu bewilligen.

9.2. Jedes Kategorie A Verwaltungsratmitglied und jedes Kategorie B Verwaltungsratmitglied, jeweils gemeinsam han-

delnd, können für bestimmte Fälle eine umfänglich begrenzte Sondervollmacht an ein Verwaltungsratsmitglied oder an
einen Dritten erteilen.

Art. 10. Verfahren.
10.1. Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen, wie die Interessen der Gesellschaft es verlangen, oder auf Wunsch

jedes Verwaltungsratsmitgliedes gemäß den Bestimmungen möglicher, von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern
eingegangener Gemeinschaftsunternehmensabkommen.

10.2. Die schriftliche Anzeige einer Verwaltungsratskonferenz muss wenigstens 72 Stunden vor dem Datum der Kon-

ferenz an alle Verwaltungsratsmitglieder geschickt werden, außer im Notfall, in welchem Fall der Notfall im Einberu-
fungsschreiben beschrieben werden muss.

10.3 Ein solches Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder

vertreten sind und bestätigen, eingehend informiert gewesen zu sein sowie die Tagesordnung zu kennen. Jedes Verwal-
tungsratsmitglied kann schriftlich auf das Einberufungsschreiben verzichten, sei es per Originalschreiben, per Telegramm,
Telex, Faxschreiben oder E-Mail.

10.4. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf einer Konferenz Handlungen vornehmen, indem es ein anderes Verwal-

tungsratsmitglied schriftlich zu seinem Stellvertreter benennt.

10.5. Der Verwaltungsrat kann nur wirksam beraten und handeln, wenn jeweils mindestens ein Kategorie A Mitglied

und ein Mitglied der Kategorie B anwesend oder vertreten sind. Verwaltungsratsbeschlüsse werden mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, wobei jeweils ein Kategorie A Mitglied und ein Kategorie B Mitglied zustimmen müssen.
Die Verwaltungsratsbeschlüsse werden in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, das von allen anwesenden oder vertre-
tenen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet wird.

10.6. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung per Telefon- oder Videokonferenz oder

einem anderen gleichwertigen Kommunikationsmittel, welches es den Teilnehmern erlaubt, einander zu verstehen und
miteinander zu sprechen, teilnehmen. Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung mit ebensolchen Kommunikati-
onsmitteln wird wie eine persönliche Teilnahme des Verwaltungsratsmitgliedes an einer Verwaltungsratssitzung angese-
hen.

10.7. Umlaufbeschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind, sind gültig und verbindlich

wie Beschlüsse, welche im Laufe einer einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsratssitzung getroffen wurden. Die
Unterschriften können sich in einem einzigen Dokument oder in mehreren identischen Kopien des Umlaufbeschlusses
befinden und können durch Telefax oder Brief nachgewiesen werden.

Art. 11. Vertretung. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten rechtskräftig verpflichtet durch die gemeinschaftliche

Unterschrift jeweils eines Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A und eines Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B
oder durch die alleinige oder gemeinschaftliche Unterschrift der Person oder der Personen, an welche Vertretungsmacht
gemäß den Bestimmungen von Artikel 9.2. der vorliegenden Satzung übertragen wurde.

131559

Titel IV. Entscheidungen des Alleingesellschafters -

Gemeinsame Entscheidungen mehrerer Gesellschafter

Art. 12. Befugnisse und Stimmrechte.
12.1 Der Alleingesellschafter übt die Befugnisse aus, die gemäß den Bestimmungen des oben genannten Gesetzes vom

10. August 1915 der Gesellschafterversammlung übertragen sind.

12.2 Falls es mehrere Gesellschafter gibt, hat jeder von ihnen Stimmrechte proportional zu den von ihm gehaltenen

Gesellschaftsanteilen.

12.3 Jeder Gesellschafter kann jede natürliche oder juristische Person zu seinem Bevollmächtigten zur Vertretung bei

Generalversammlungen ernennen, und zwar durch schriftliche Vollmacht in Form eines Briefes, Telegramms, Telex, Te-
lefax oder einer E-Mail.

Art. 13. Form - Quorum - Mehrheit.
13.1 Falls die Anzahl der Gesellschafter 25 oder weniger beträgt können Gesellschafterbeschlüsse durch Umlaufbe-

schluss gefasst werden, deren Text allen Gesellschaftern schriftlich, sei es als Original oder per Telegramm, Telex, Telefax
oder E-Mail, gesendet sein muss. Die Gesellschafter geben ihre Stimme ab, indem sie den Umlaufbeschluss unterzeichnen.
Die Unterschriften der Gesellschafter können sich in einem einzigen Dokument oder in mehreren identischen Kopien
des Umlaufbeschlusses befinden und können durch Telefax oder Brief nachgewiesen werden.

13.2 Gesellschafterbeschlüsse können nur durch einstimmigen Beschluss des Verwaltungsrats des Alleingesellschafters

gefasst werden.

Titel V. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des gleichen Jahres.

Art. 15. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per einunddreißigsten Dezember, werden ein Bericht über die der

Aktiva und Passiva der Gesellschaft und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Der  Saldo  der  Gewinn-  und  Verlustrechnung,  abzüglich  Aufwendungen,  Kosten,  Belastungen  Abschreibungen  und

Rückstellungen ist der Nettogewinn der Gesellschaft.

Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft der gesetzlichen Reserve der Ge-

sellschaft zugeführt, solange bis die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt
aus welchem Grunde auch immer die gesetzliche Reserve unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals fallen, so muss die
jährliche Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden bis das Ein-Zehntel-Verhältnis wieder hergestellt ist.

Der Überschuss wird dem Alleingesellschafter zugeteilt oder, falls mehrere Gesellschafter vorhanden sind, unter diesen

verteilt. Dieser bzw. diese können jedoch durch Mehrheitsentscheidung gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen  entscheiden,  dass  der  Gewinn,  nach  Abzug  jeglicher  Reserven,  auf  das  folgende  Jahr  übertragen  oder  einer
außergesetzlichen Reserve zugeführt wird.

Titel VI. Auflösung

Art. 16. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die Insolvenz, die gerichtliche Entmündigung oder die

Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters aufgelöst.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation vom oder von den Verwaltungsratsmitglied(ern) im

Amt oder, in Ermangelung dessen, von einem oder mehreren Liquidatoren, vom Alleingesellschafter oder von der Ge-
neralversammlung der Gesellschafter ernannt, ausgeführt. Der oder die Liquidator(en) ist bzw. sind mit umfassenden
Vollmachten zur Realisierung der Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.

Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, dem Alleingesellschafter zugeteilt, oder gegebenenfalls

unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile aufgeteilt.

Titel VII. Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Auf alle Angelegenheiten, die in der vorliegenden Satzung nicht geregelt sind, finden die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.»

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle Anteile wurden gezeichnet durch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRESIDENTIAL NURSING HOMES

HOLDINGS, vorgenannt, und vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von zwölftau-
sendflinfhundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfugung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde,
der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt zum Gründungszeitpunkt und endet am 31. Dezember 2008.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der Alleingesellschafter welcher das Gesamtkapital vertritt, folgende Be-

schlüsse gefasst:

1) Es werden zu Verwaltungsratsmitgliedern auf unbestimmte Zeit ernannt:

131560

(i) Frau Claudia Daxelhoffer, wohnhaft in CH-8942 Oberrieden, Feldstrasse, 8, zum Verwaltungsratsmitglied der Ka-

tegorie A,

(ii) Herrn Isaac Schapira, Kaufmann, geboren am 16. Dezember 1952 in Jerusalem, Israel, wohnhaft in 2, Danescroft

Gardens, London NW4 2ND, Großbritannien, zum Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A,

(iii) Herrn Andrew Pettit, Anwalt, geboren am 7. Mai 1968 in Cleethorpes, England, mit beruflichem Sitz in 20 Baiderton

Street, London W1K 6TL, Großbritannien, zum Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B,

(iv) Herrn Matthias Wilke, Bänker, geboren am 23. April 1972 in Diez/Lahn, Deutschland, mit beruflichem Sitz in 20

Baiderton Street, London W1K 6TL, Großbritannien, zum Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B.

2) Frau Claudia Daxelhoffer, vorbenannt, ist autorisiert alle Bankabwicklungen durch ihre alleinige Unterschrift zu

tätigen.

3) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1313 Luxemburg, 2a, rue des Capucins.

<i>Kostenschätzung

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Gebühren, Vergütungen und Auslagen in welcher Form auch immer, welche

die Gesellschafrt aus Anlass dieser Urkunde zu tragen hat, oder welche ihr im Zusammenhang mit ihr auferlegt werden,
beläuft sich auf ungefähr 1.500,- EUR.

Der unterzeichnete Notar, welcher englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass der Text der vorliegenden

Satzung auf Wunsch der Erschienenen in englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, dass es der Wunsch der Erschienenen ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text der englische Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung und Erklärung an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Mayer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2007, LAC/2007/31207. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Jungers.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 25. Oktober 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007131876/206/338.
(070151975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Patrimoine Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 43.209.

<i>Extrait de la résolution du Conseil d'Administration du 31 août 2005

En date du 31 août 2005, le Conseil d'Administration de la société mentionnée ci-dessus (ci-après la «Société»), décide

du transférer du siège social de CAIS-BL au 5, allée Scheffer, L-5250 Luxembourg; la date précise de ce transfert n'est
pas encore arrêtée, mais le Conseil accepte d'ores et déjà que le siège social de la Société, actuellement localisé au 39,
allée Scheffer, L-2520 soit automatiquement déplacé à la nouvelle adresse de CAIS-BL au jour du transfert du siège social
de la banque et instruit CAIS-BL d'engager le moment venu les formalités de publication requises dans ce cadre.

Fait au Luxembourg, le 31 août 2005.

Pour extrait sincère et conforme
Pour le Conseil d'Administration
G. Abel

Référence de publication: 2007131496/1024/19.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2007, réf. LSO-CJ03275. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Altice 5 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 131.334.

ALTICE PARTICIPATIONS GENERAL PARTNER LIMITED ayant son siège social à 1, Le Marchant Street, St Peter

Port, Guernesey, agissant en qualité de General Partner et pour le compte de ALTICE PARTICIPATIONS L.P., ayant son
siège social à 1, Le Marchant Street, St Peter Port, Guernesey, dûment représentée par Monsieur Patrick Drahi, dûment

131561

habilité en qualité de directeur, a été nommée, en qualité de président du conseil d'administration de la Société suivant
résolutions prises en date du 24 août 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007131503/280/16.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2007, réf. LSO-CJ02767. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Stelco Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg, 2, rue Walram.

R.C.S. Luxembourg B 37.524.

L'an deux mille sept, le neuf octobre,
Par devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STELCO IMMOBILIERE S.A.,

avec siège social à L-2715 Luxembourg, 2, rue Walram, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de
résidence à Luxembourg, en date du 17 juillet 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
23 du 23 janvier 1992, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le
numéro 37.524.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jeannot Philipp, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Marie-France Pastore, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Micael Da Silva, employé privé, demeurant à Esch-sur-AIzette.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des trois cents (300) actions existantes.
2.  Constatation  de  la  conversion  de  la  devise  du  capital  social  de  trois  millions  de  francs  luxembourgeois  (LUF

3.000.000,-) en soixante quatorze mille trois cent soixante-huit euros et six cents (EUR 74.368,06), représenté par trois
cents (300) actions sans désignation de valeur nominale.

3. Modification du premier alinéa de l'article cinq des statuts:
« Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt vierundsiebzigtausenddreihundertachtundsechzig Komma null sechs

Euro  (EUR  74.368,06),  eingeteilt  in  dreihundert  (300)  Aktien  ohne  Angabe  des  Nennwertes,  welche  in  voller  Höhe
eingezaht sind.»

4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des trois cents (300) actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale constate que, par suite du basculement de la devise du capital social en euros, avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital social, jusque-là de trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), est actuellement

de soixante quatorze mille trois cent soixante-huit euros et six cents (EUR 74.368,06).

<i>Troisième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des

statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

131562

«  Art. 5. (premier alinéa).  Das  gezeichnete  Aktienkapital  beträgt  vierundsiebzigtausenddreihundertachtundsechzig

Komma null sechs Euro (EUR 74.368,06), eingeteilt in dreihundert (300) Aktien ohne Angabe des Nennwertes, welche
in voller Höhe eingezaht sind.»

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: J. Philipp, M.-F. Pastore, M. Da Silva, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, LAC / 2007 / 30623. — Reçu 12 euros.

<i>Pour le Receveur F. Sandt (signé): C. Frising.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2007.

E. Schlesser.

Référence de publication: 2007131506/227/62.
(070152041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

M.S.C.V. Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3396 Roeser, 10, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 84.212.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007131525/8216/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08189. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Trenubel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 48.444.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 2 octobre 2007

Conformément à l'article 51, alinéa 4 de la loi Fondamentale sur les sociétés commerciales, les Administrateurs restants

procèdent à la nomination par voie de cooptation de Monsieur Norbert Schmitz, résidant au 3, avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg, au titre d'Administrateur provisoire en remplacement de Monsieur Jean Bintner, démissionnaire.

Cette nomination sera soumise à la prochaine Assemblée Générale aux fins d'élection définitive.

<i>TRENUBEL S.A.
S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Référence de publication: 2007131494/1023/18.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2007, réf. LSO-CJ06161. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

a_part concept s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 1, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 99.213.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

131563

<i>Pour a_part concept S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2007131597/514/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07071. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Apache Luxembourg Holdings II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 165.000,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 115.956.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MERCURIA SERVICES
Signature

Référence de publication: 2007131574/1005/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00672. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

United Bakeries Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 107.217.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

UNITED BANKERIES LUXEMBOURG S.A.
A. J. P. Scholtes
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2007131665/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2007, réf. LSO-CK00216. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

CERATIZIT Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.

R.C.S. Luxembourg B 17.122.

Le bilan au 28 février 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007131565/1100/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09407. - Reçu 52 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Conforto Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 6.465.

L'adresse du commissaire aux comptes, MONTBRUN REVISION S.àr.l. est transférée à:
2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

131564

Luxembourg, le 23 octobre 2007.

Pour avis
Signature

Référence de publication: 2007131690/534/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2007, réf. LSO-CJ09857. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Maitland Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 88.645.

Le bilan au 30 avril 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007131568/631/14.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04097. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Interstyle Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 40.556.

Le bilan de la société au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007131592/5387/14.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ03940. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070151923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

C. &amp; M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 45.391.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007131528/8216/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08479. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Garage Muller-Locations, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 23.620.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

131565

Itzig, le 24 octobre 2007.

<i>Pour GARAGE MULLER-LOCATIONS
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L
Signature

Référence de publication: 2007131547/1345/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08410. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

MDS International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 92.148.

L'an deux mille sept, le treize septembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Christos Kostakis, gérant de sociétés, né à Hasselt, le 27 mai 1977, demeurant à B-3600 Genk, Verbin-

dingslaan, 80, et

2.- L'associé/gérant Monsieur Jos Beckers, gérant de sociétés, né à Sint-Truiden, le 4 janvier 1966, demeurant actuel-

lement à B-3440 Budingen, Hogenstraats.

tous deux ici représentés par Monsieur Max Mayer, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich,
lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant resteront annexés aux présentes.

Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, agissant en leur qualité d'associés représentant l'intégralité du

capital social, de la société à responsabilité limitée MDS INTERNATIONAL avec siège social à L-6550 Berdorf, 42, rue
de Echternach

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 février 2003, publié au Mémorial C Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 385 du 9 avril 2003,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 92.148;
Que suivant deux cessions de parts sous seing privé signé en date du 28 février 2006, Monsieur Quitos Kostakis,

prénommé, est devenue propriétaire de 31 parts sociales appartenant à Monsieur Goofy Neureuther, et Monsieur Jos
Beckers, prénommé est devenue propriétaire de 32 parts sociales appartenant à Monsieur Claude Petit.

Les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions

suivantes:

L'associé unique a ensuite requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré vers L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy et en conséquence de modifier le premier

alinéa de l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«  Art. 2. (1 

er

 alinéa).  Le siège de la société est établi dans la Ville de Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

Les associés acceptent la démission de Monsieur Claude Petit en sa qualité de gérant et nomment en remplacement

pour une durée indéterminée Monsieur Jos Beckers, prénommé, lequel aura tous pouvoirs d'engager et représenter la
société par sa seule signature.

<i>Acceptation

Monsieur Jos Beckers, prénommé, représenté en vertu de la même procuration repris ci-dessus, en sa qualité de gérant

de la société, déclare accepter ladite cession, au nom de la société conformément à l'article 1690 nouveau du Code Civil.

Il déclare qu'il n'a entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l'effet de la susdite cession.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 900,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. Mayer, P. Decker.

131566

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2007, Relation: LAC/2007/26853. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 26 septembre 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007131534/206/53.
(070151869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Ameco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7759 Roost/Bissen, 1, route de Bissen.

R.C.S. Luxembourg B 11.671.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 24 octobre 2007.

<i>Pour AMECO S.A R.L.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L
Signature

Référence de publication: 2007131533/1345/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08424. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070152249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Gesco Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 60.317.

L'an deux mille sept, le neuf octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GESCO HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 60 317, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors
notaire de résidence à Luxembourg, le 30 juillet 1997, publié au Mémorial C numéro 621 du 7 novembre 1997, et dont
les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch,
en date du 2 octobre 2002, publié au Mémorial C numéro 173 du 18 février 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Katia Roti, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les soixante-douze mille (72.000) actions représentant l'intégralité

du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen aux Iles Vierges Britanniques, Geneva Place,

Waterfront Drive, Road Town, Tortola, et adoption par la société de la nationalité des Iles Vierges Britanniques.

2.- Démission des administrateurs actuellement en fonction et décharge leur est accordée pour l'exécution de leur

mandat jusqu'à ce jour.

131567

3.- Démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge lui accordée pour l'exercice de son

mandat jusqu'à ce jour.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 août 2007 et de transférer le siège

social, administratif et le siège de direction effective avec effet à la date de ce jour du Grand-Duché de Luxembourg,
L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal aux Iles Vierges Britanniques, Geneva Place, 3rd Floor, Waterfront Drive, Road
Town, Tortola, et de faire adopter par la société la nationalité des Iles Vierges Britanniques, sans toutefois que ce chan-
gement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne
juridique nouvelle.

L'assemblée constate que cette résolution a été prise en conformité de l'article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur

les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs actuellement en fonction et de leur accorder décharge

pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction et de lui accorder

décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Madame Luisella Moreschi, licenciée en

sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, avec tous pouvoirs de substitution et de délégation, à l'effet
d'accomplir,  individuellement ou conjointement, toutes  les  formalités  administratives  nécessaires  à  l'inscription  de la
société à Road Town, Tortola et d'enregistrer la Société aux Iles Vierges Britanniques, de signer tous actes et documents
y afférents et de faire toutes les démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.

L'assemblée décide de renoncer à l'établissement de statuts conformément aux lois des Iles Vierges Britanniques,

lesquels seront établis au moment où le transfert deviendra effectif.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide que tous les documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg seront conservés

pendant une période de cinq ans à l'ancien siège de la société.

<i>Condition suspensive

Les résolutions ci-dessus sont prises sous la condition suspensive de l'inscription de la Société par les autorités des

Iles Vierges Britanniques compétentes.

Tous pouvoirs sont conférés à Madame Luisella Moreschi, prénommée, pour faire constater par-devant notaire la

réalisation de la condition suspensive.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi, S. Wolter-Schieres, K. Roti, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2007, Relation: LAC/2007/31563. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007131476/242/79.

(070152250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

131568


Document Outline

Altice 5 S.A.

Ameco

Apache Luxembourg Holdings II

a_part concept s.à r.l.

Bokay Pictures S.à r.l.

Books and Beans S.à r.l.

CERATIZIT Luxembourg S.à r.l.

Ceratizit S.A.

Ceratungsten

C. &amp; M. S.A.

Conforto Holding S.A.

CORSAIR (Luxembourg) N°15 S.A.

De Herrero Management S.A.

Euroholding Fashion S.A.

Euroholding Fashion S.A.

Fek Immobilière SA

Floris S.A.

Fondation Nicolas Lanners

Garage Muller-Locations

Gesco Holding S.A.

Great German Nursing Homes C

Great German Nursing Homes D

Great German Nursing Homes E

Interstyle Holding S.A.

Interstyle Holding S.A.

Jasperus

Lux Cogeba Construction S.à r.l.

Maitland Europe S.à r.l.

MDS International

Moda Brand Holding S.A.

Moda Brand Holding S.A.

M.S.C.V. Consulting S.à r.l.

Patrimoine Invest

Stelco Immobilière S.A.

SYMFONICA Holding

Trenubel S.A.

T.S. Lux S.A.

United Bakeries Luxembourg S.A.

V2I Holding S.A.

V2I Holding S.A.

Water and Sun S.A.