This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2676
22 novembre 2007
SOMMAIRE
Akemis Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128438
All-Sport International Holding S.A. . . . . .
128404
Almafin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128405
Automotive Components Europe S.A. . . .
128402
Bahnhof Holdings A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128444
Berenberg Euro Strategie Aktien Fonds VI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128408
Blacksmith Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
128409
Blacksmith Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
128409
Caesar Finance 2000 S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
128446
Camberwell S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128429
Captiva Capital Partners II S.C.A. . . . . . . .
128448
CIFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128446
Docu Group (Lux 3) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
128446
EcoLive S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128441
Europarticipations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128437
Fime S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128445
Fingroup S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128445
Fontanina Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128405
Gef Real Estate Holding . . . . . . . . . . . . . . . .
128403
Globus Consulting And Management Ser-
vices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128448
Immo-Lux Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128447
Infrastructure Creation Company S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128438
Kalchesbrück NewCo S.A. . . . . . . . . . . . . . .
128424
Kalchesbruck S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128413
Kass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128447
Le Palmier S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128428
Logistic Strategies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128447
Media Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
128404
Mena Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128403
Millenium Diamond Holdings S.A. . . . . . . .
128440
Millenium Diamond Services Investments
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128438
Nol S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128446
Oakwood Global Finance S.C.A. . . . . . . . . .
128406
Oeko-Service Luxemburg (O.S.L.) S.A. . .
128447
PET Packaging S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128445
Polaris Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128433
Sia World S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128444
Skype Communications . . . . . . . . . . . . . . . . .
128437
Société Immobilière Le Domicile S.A. . . .
128443
Sports Group Development S.A. . . . . . . . .
128404
TDS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128430
The Modern Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128405
TONDELINOX Production de pièces inox,
unipersonnelle LDA, succursale de Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128436
Toxon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128444
United Minds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128441
Viking River Cruises S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
128445
Vilient Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128448
128401
Automotive Components Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 118.130.
An ORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company will be held extraordinarily at the registered office of the Company, 82, route d'Arlon,
L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on <i>December 14, 2007i> at 12.00 a.m. Central European time («CET»)
(the «Meeting») for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Opening;
2. Election of the chairman of the Meeting:
3. Election of the scrutineer(s) of the Meeting;
4. Acknowledgement of the resignation of WOOD APPLETON OLIVER & Co as statutory auditor of the Company,
effective as of July 27, 2007 and discharge of their liabilities from their mandate for the period up to their resignation;
5. Appointment of FIDUCIAIRE FIBETRUST Sciv. as statutory auditor of the Company, its mandate to expire at the
annual general meeting of shareholders to approve the accounts for the year ended December 31, 2012;
6. Appointment of DELOITTE SA as independent auditor of the Company to audit the consolidated and stand alone
accounts of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to approve the
accounts of the Company for the year ended December 31, 2007;
7. Approval of the remuneration of the non-executive directors as approved by the board of directors of the Company
on October 16, 2007; and
8. Closing.
VOTING
Items 1 to 8 of the Agenda as mentioned above may be passed without a quorum, by a simple majority of the votes
cast thereon at the Meeting.
VOTING ARRANGEMENTS
Shareholders holding bearer shares not already admitted for listing and tradingon the Warsaw Stock Exchange (the
«WSE»)
The owners of bearer shares should deposit their shares at the registered office of the Company by December 8,
2007 at 11.59 p.m. CET.
The shares so deposited will remain blocked until the day after the Meeting or any adjournment thereof.
Shareholders holding their shares through NDS and already admitted for listing and trading on the WSE
Shareholders holding their shares through the clearing and settlement system of NDS who wish to take part in the
Meeting need to arrange with their respective financial intermediary holding the shares on their accounts for the Certi-
ficate certifying the number of shares recorded in the relevant account in the name of the relevant shareholder to be
issued for the purpose of participating and voting at the Meeting to be valid until December 14, 2007, inclusive (the
«Certificate»). The Certificate duly completed and signed needs to be sent directly to the registered office of the Company
or to EBCC (referred as the «Agent») and shall be received no later than December 8, 2007 at 11.59 p.m. CET.
The Certificate so deposited will block the shares until the day after the Meeting or any adjournment thereof.
Please note that any shareholder whose Certificate has not been received by December 8, 2007 will not be eligible to
participate in the Meeting. Subject to delivery of the Certificate, shareholders may participate and vote in the Meeting in
person, by proxy or by correspondence.
- Shareholders who wish to attend the Meeting in person, by proxy or vote by correspondence need to download the
form indicating their attendance in person or by proxy or the form for voting by correspondence from the Company
website www.acegroup.lu or directly at the registered office of the Company upon request.
- Shareholders who wish to attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed attendance
form, together with the Certificate to the registered office of the Company or to the Agent, to arrive no later than
December 8, 2007 at 11.59 p.m. CET.
- Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form
together with the Certificate, to the registered office of the Company or to the Agent, to arrive no later than December
8, 2007 at 11.59 p.m. CET.
A person appointed as proxy needs not be a holder of shares of the Company. Lodging of a proxy form will not prevent
a shareholder from attending the Meeting if he decides to do so.
128402
- Shareholders who cannot attend the Meeting in person or by proxy, are invited to send a duly completed and signed
voting form, together with the Certificate to the registered office or to the Agent to arrive no later than December 8,
2007 at 11.59 p.m. CET.
MISCELLANEOUS
- The articles of association of the Company are available on the Company's website www.acegroup.lu and at the
registered office of the Company.
November 22, 2007
<i>The Board of Directorsi> .
The Agent
EBCC Sp.Z.o.o.
54-215 Wroclaw
ul. Bystrzycka 89
Poland
Référence de publication: 2007130587/6449/68.
Gef Real Estate Holding, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 21.066.
The shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on Monday <i>10th December 2007i> at 11.30 a.m. at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg with
the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Cancellation of the decision taken at the Annual General Meeting held on June 26, 2006, to appoint DELOITTE as
independent external auditor and termination of their mandate with immediate effect.
2. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and the Commissaire for the accounting year
ended December 31, 2006.
3. Presentation and approval of the unaudited annual accounts for the year ended December 31, 2006.
4. Allocation of the results.
5. Discharge of the Board of Directors and the Commissaire for the accounting year ended December 31, 2006.
6. Election of the Directors and the Commissaire.
7. Ratification by the shareholders of the purchase by the company of 1,040,000 of its own shares at USD 5.- per
share appearing on the balance sheet at December 31, 2006 and authorisation to the Board to buy and sell the
shares of the Company on the following conditions:
- Quantity: up to 10% of the issued shares
- Price per share: minimum USD 4.- and maximum USD 6.-
- Duration: 18 months from December 31, 2006.
8. Miscellaneous.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2007131891/581/27.
Mena Holdings S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 8.273.
The shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on Monday <i>10th December 2007i> at 12.00 a.m. at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg with
the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Cancellation of the decision taken at the Annual General Meeting held on June 22, 2006, to appoint DELOITTE as
independent external auditor and termination of their mandate with immediate effect.
2. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and the Commissaire for the accounting year
ended December 31, 2006.
3. Presentation and approval of the unaudited annual accounts for the year ended December 31, 2006.
128403
4. Allocation of the results.
5. Discharge of the Board of Directors and the Commissaire for the accounting year ended December 31, 2006.
6. Election of the Directors and Commissaire.
7. Approval of the delegation to the Chairman of the powers to represent the Company and conduct its daily ma-
nagement and affairs.
8. Miscellaneous.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2007131892/581/23.
Sports Group Development S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 59.579.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>31 décembre 2007i> à 10.00 heures à l'étude de Maître Joëlle Baden avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport du Commissaire à la Liquidation, la FIDUCIAIRE GLACIS,
- Décharge au Liquidateur et au Commissaire à la Liquidation,
- Clôture de la Liquidation,
- Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007132108/755/17.
Media Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 61.257.
The shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on Monday <i>10th December 2007i> at 11.00 a.m. at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg with
the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the report of the Statutory Auditor for the financial year ended December 31, 2006;
2. Presentation and approval of the annual accounts for the financial year ended December 31, 2006;
3. Allocation of the results;
4. Discharge of the members of the Board of Directors and Statutory Auditor for the financial year ended December
31, 2006;
5. Continuation of activities in reference to Art. 100 of the law on commercial companies;
6. Statutory elections;
7. Miscellaneous.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2007132292/581/20.
All-Sport International Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 39.673.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
128404
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 décembre 2007i> à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2007,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants,
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur
démission,
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007132944/795/18.
Almafin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 43.749.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE
qui aura lieu le <i>10 décembre 2007i> à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006,
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur,
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
5. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant,
6. Décharge spéciale à l'Administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission,
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007132946/795/18.
Fontanina Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 22.881.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>11 décembre 2007i> à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2007,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants,
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur
démission,
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007132948/795/18.
The Modern Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 67.545.
The Shareholders are invited to attend the
128405
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders (the «Meeting») of THE MODERN FUNDS (the «Company») which will be held in Luxembourg, at
the registered office of the Company on <i>November 30, 2007i> at 10.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
a. Acknowledgment of the resignation of the Board of Directors,
b. Acknowledgment of the resignation of the conducting persons,
c. Appointment of following directors as successor to the previous Board of Directors:
- Steen Bryde,
- Henrik Juul,
- Michael Elmgren,
- Ulrika Nathhorst Jener,
d. Various.
Shareholders who wish to participate at the extraordinary general meeting shall:
- have their names entered in the register of shareholders maintained by BANQUE INVIK S.A. or by BANQUE INVIK
LUXEMBOURG FILIAL on Monday 26th November 2007;
- notify the Company of their intention to participate by no later than 3.00 p.m. on Monday 26th November 2007.
Proxy forms are available at the registered office of the Company. Proxy forms duly signed should be returned by mail
to the registered office of the Company, for the attention of Mr Gaston Colbach or alternatively by fax to (+352) 27 751
270 by 3.00 p.m. on Monday 26th November 2007 at the latest.
Please note that the resolutions on the above-mentioned agenda will require no quorum and the resolutions will be
passed by a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2007129999/755/29.
Oakwood Global Finance S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 122.047.
In the year two thousand and seven, on the twenty-second of October.
Before Us, M
e
Jean Seckler, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
- Mr Christian Dostert, private employee, professionally residing in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,
acting in his capacity as a special proxy-holder of the General Partner of the corporate partnership limited by shares
(«société en commandite par actions») OAKWOOD GLOBAL FINANCE S.C.A., (hereinafter referred to as the «Ab-
sorbing Company»), with registered office in L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II, inscribed in the Trade and Companies'
Register of Luxembourg, section B, under the number 122,047,
pursuant to circular resolutions made by the Board of Directors of the General Partner of the Absorbing Company
with effect as of October 22, 2007, and pursuant to a proxy given in Luxembourg on October 22, 2007.
A copy of these circular Board resolutions as well as the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-
holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
The Absorbing Company has been incorporated under the denomination of OAKWOOD FINANCIAL INVEST-
MENTS S.C.A. pursuant to a deed of M
e
André-Jean-Joseph Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, (Grand-
Duchy of Luxembourg), on November 16, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(«Mémorial C») number 3 of the 4th of January 2007,
and the articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of M
e
Joëlle
Baden, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), on April 20, 2007, published in the Mémorial C,
number 1471 of the 17th of July 2007, containing the change of the Company's denomination into OAKWOOD GLOBAL
FINANCE S.C.A.
This appearing party, through its proxy-holder, has declared and requested the notary to state that:
1. The Absorbing Company holds one hundred percent (100%) of the shares of the private limited liability company
OAKWOOD FINANCIAL FUND S.à r.l., with registered office in L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II, inscribed in the
Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 110,440, (hereinafter the «Absorbed Com-
pany»).
2. The Board of Directors of the General Partner of the Absorbing Company as well as the Board of Managers of the
Absorbed Company (together the «Merging Companies») have adopted, pursuant to a deed of the undersigned notary
dated September 10th, 2007, a merger project, which has been published pursuant to article 262 of the law of August
128406
10th, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law») in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 2050 of the 21st of September, 2007.
3. The documents, provided for by article 267, paragraph 1, a), b), and c) of the Law (i.e. the merger project, the annual
accounts and annual reports of the Merging Companies for the last three financial years, an accounting statement not
older than three months in reference to the date of the merger project), were put at the disposal of the shareholders of
the Merging Companies at their registered office one month prior to the date of this meeting.
4. No objections to the merger were received between the date of publication of the merger project and the date of
this meeting.
5. The Board of Directors of the General Partner of the Absorbing Company has acknowledged the effect of the
merger.
6. The merger takes effect as of today with accounting effect starting on January 1st, 2007.
7. The Absorbed Company is merged into the Absorbing Company by contribution of all its assets and liabilities to
the Absorbing Company without any restriction or limitation.
8. As a result of the merger, the Absorbed Company ceases to exist by dissolution without liquidation as of the date
of the present deed.
9. Full and complete discharge is granted to the members of the Board of Managers of the Absorbed Company for the
proper performance of their duties until today.
10. The accounting books and documents of the Absorbed Company will be kept during a period of five (5) years at
least at the registered office of the Absorbing Company.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at seven hundred and fifty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Junglinster, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder, acting as said before, known to the notary by his name, first name,
civil status and residence, the said proxy-holder signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-deux octobre.
Par-devant Nous, Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
- Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Lu-
xembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de l'Associé Commandité de la société en commandite par actions OAK-
WOOD GLOBAL FINANCE S.C.A., (ci-après la «Société Absorbante»), avec siège social à L-2340 Luxembourg, 6, rue
Philippe II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 122.047,
en vertu d'un pouvoir lui ayant été conféré sur base des résolutions circulaires prises par le Conseil d'Administration
de l'Associé Commandité de la Société Absorbante avec effet au 22 octobre 2007, et conformément à une procuration
délivrée à Luxembourg le 22 octobre 2007.
Une copie de ces résolutions circulaires du Conseil d'Administration ainsi que la prédite procuration, après avoir été
signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enre-
gistrées avec lui.
La Société Absorbante a été constituée originairement sous la dénomination sociale de OAKWOOD FINANCIAL
INVESTMENTS S.C.A., suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Lu-
xembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 16 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations («Mémorial C») numéro 3 du 4 janvier 2007,
et les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joëlle Baden,
notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 20 avril 2007, publié au Mémorial C
numéro 1471 du 17 juillet 2007, contenant le changement de la dénomination de la Société en OAKWOOD GLOBAL
FINANCE S.C.A.
Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter que:
1. La Société Absorbante détient cent pour-cent (100%) des actions de la société à responsabilité limitée OAKWOOD
FINANCIAL FUND S.à r.l., avec siège social à L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 110.440, (ci-après la «Société Absorbée»).
128407
2. Le Conseil d'Administration de l'Associé Commandité de la Société Absorbante ainsi que le Conseil de Gérance de
la Société Absorbée (ensemble les «Sociétés Fusionnantes») ont adopté, suivant acte reçu par le notaire instrumentant
daté du 10 septembre 2007, un projet de fusion, qui a été publié conformément aux dispositions de l'article 262 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 2050 du 21 septembre 2007.
3. Les documents requis par l'article 267, paragraphe 1, a), b), et c) de la Loi (c.-à-d. le projet de fusion, les comptes
annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices sociaux des Sociétés Fusionnantes, et un état comptable
ne datant pas de plus de trois mois en référence à la date du projet de fusion), ont été tenus à disposition des actionnaires
des Sociétés Fusionnantes à leur siège social durant un mois précédant la date de cette assemblée.
4. Aucune objection à l'encontre de la fusion n'a été communiquée entre la date de publication du projet de fusion et
la date de cette assemblée.
5. Le Conseil d'Administration de l'Associé Commandité de la Société Absorbante a constaté l'effet de la fusion.
6. La fusion prend effet à la date d'aujourd'hui avec effet comptable au 1
er
janvier 2007.
7. La Société Absorbée est absorbée par la Société Absorbante par apport de tous ses actifs et passifs à la Société
Absorbante, sans aucune restriction ni limitation.
8. Comme conséquence de la fusion, le Société Absorbée cesse d'exister par dissolution sans liquidation à partir de
la date du présent acte.
9. Décharge pleine et entière est accordée aux membres du Conseil de Gérance de la Société Absorbée pour l'exercice
de leurs mandats jusqu'à aujourd'hui.
10. Les documents et pièces comptables relatifs à la Société Absorbée resteront conservés pendant une période de
cinq (5) ans au moins au siège social de la Société Absorbante.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à sept cent cinquante euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, le présent acte a été passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par son nom, prénom,
état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 octobre 2007, Relation GRE/2007/4849. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 novembre 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007127906/231/127.
(070152998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.
Berenberg Euro Strategie Aktien Fonds VI, Fonds Commun de Placement.
Aufgrund der gesamten Rücknahme der Anteile des Fonds hat der Verwaltungsrat der BERENBERG LUX INVEST S.A.
(«die Verwaltungsgesellschaft»), mit Sitz in L-1118 Luxemburg, 23, rue Aldringen, beschlossen den Fonds mit Wirkung
zum 14. November 2007 auszulösen.
Die Verwaltungsgesellschaft wird einen Liquidationsbericht erstellen, welcher von DR. WOLLERT - DR. ELMEN-
DORFF S.à r.l., Wirtschaftsprüfer des Fonds, geprüft wird.
Die Gesellschäftsbücher und sonstige Unterlagen des Fonds werden mindestens 5 Jahre am Gesellschaftssitz der Ver-
waltungsgesellschaft archiviert.
BERENBERG LUX INVEST S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
Référence de publication: 2007132951/584/13.
128408
Blacksmith Holding S.A., Société Anonyme,
(anc. Blacksmith Holding S.à r.l.).
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 104.230.
Im Jahre zweitausendundsechs, den zwanzigsten Dezember, vor dem Unterzeichneten, Maître Joseph Elvinger, Notar
mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Grossherzogtum Luxemburg).
Fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter von BLACKSMITH HOLDING S.àr.l (die «Gesell-
schaft»), mit Gesellschaftssitz in L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund, gegründet durch notarielle Urkunde von
Maître Joseph Elvinger, Notar, am 11. November 2004, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das
«Mémorial») vom 3. Februar 2005, Nummer 99, veröffentlicht wurde, statt.
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch den Notar Joseph Elvinger
am 21. November 2006, noch nicht im Mérmorial C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht.
Die Versammlung fand unter dem Vorsitz von M
e
Philippe Prussen, Rechtsanwalt, mit professioneller Adresse in
Luxemburg, 2 place Winston Churchill, statt.
Der Vorsitzende bestimmte M
e
Kathrin Kraemer, maître en droit, mit professioneller Adresse in Luxemburg, 2 place
Winston Churchill, zur Protokollführerin.
Die Versammlung bestimmte M
e
Kathrin Kraemer, maître en droit, mit professioneller Adresse in Luxemburg, 2 place
Winston Churchill, zur Wahlprüferin.
Nachdem der Vorstand der Versammlung auf diese Weise gebildet wurde, erklärte und beauftragte der Vorsitzende
den Notar folgendes festzustellen:
I. Die anwesenden und vertretenen Gesellschafter, die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter und die Anzahl
ihrer Anteile sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, die von den Gesellschaftern, von den
Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter, vom Vorstand der Versammlung und vom unterzeichneten Notar un-
terzeichnet wurde, wird der vorliegenden notariellen Urkunde als Anlage beigelegt.
Die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter werden der vorliegenden notariellen Urkunde ebenfalls als Anlage
beigefügt.
II. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Kenntnisnahme und Berücksichtigung des Bewertungsberichts des WIRTSCHAFTSPRÜFERS KPMG und Umwand-
lung der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft (société anonyme) und Neuformulierung der Satzung
2. Bestätigung der Verwaltungsratsmitgelieder und Entschluss den Abschlussprüfer zu einem späteren Zeitpunkt zu
Ernennen.
III. Wie aus der zuvor genannten Anwesenheitsliste hervorgeht, ist das gesamte im Umlauf befindliche Grundkapital in
Höhe von zweihundertachtundvierzigtausendsechshundert Euro (EUR 248.600,-) unterteilt in neunhundertvierzig (940)
Klasse A-2 Geschäftsanteile, viertausendfünfhundertzwanzig (4.520) Klasse B-Geschäftsanteile, zweitausendzweihundert-
sechzig (2.260) Klasse C-Geschäftsanteile und zweitausendzweihundertsechzig (2.260) Klasse D-Geschäftsanteile mit je
einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) bei dieser außerordentlichen Hauptversammlung anwesend oder
vertreten. Alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, ordnungsgemäss geladen und über die Tagesord-
nung informiert worden zu sein, weshalb auf eine formelle Einberufung verzichtet wurde.
IV. Diese Hauptversammlung, die das gesamte Grundkapital vertritt, wurde ordnungsgemäss einberufen und kann
wirksam über alle Tagesordnungspunkte beschliessen.
Nach eingehender Beratung fasste die Versammlung den nachfolgenden Beschluss.
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen einstimmig, nach Durchsicht des Bewertungsberichts des Wirtschaftsprüfers, welcher
die folgende Schlussfolgerung enthält: «Based on the verification carried out as described above, we have no observation
to make on the value of the Net Assets which corresponds at least to the number and nominal value of the ordinary
shares in issue.» die Umwandlung der Gesellschaftsform in eine Aktiengesellschaft (société anonyme) und Neuformulie-
rung der Satzung wie folgt:
« Art. 1. Form, Name. Zwischen den an diesem Tag Anwesenden und allen Personen, die Eigentümer der nachfolgend
benannten Aktien werden, wird hiermit eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) unter dem Namen
BLACKSMITH HOLDING S.A. (die «Gesellschaft») gegründet, die den luxemburgischen Gesetzen (die «Gesetze») und
den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die «Satzung») unterliegen.
Art. 2. Zweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder Form in luxemburgischen und aus-
ländischen Gesellschaften oder anderen Handelsunternehmen, der Erwerb von Aktien, Obligationen, Schuldverschrei-
128409
bungen, Schuldscheinen und sonstigen Wertpapieren durch Kauf, Zeichnung oder in sonstiger Weise sowie deren
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in sonstiger Weise, sowie der Besitz, die Verwaltung, die Entwicklung und die
Betreuung ihrer Beteiligungen und Wertpapiere. Die Gesellschaft kann sich auch an Teilhaberschaften beteiligen und ihre
Geschäfte mittels Zweigniederlassungen in Luxemburg oder im Ausland tätigen.
Die Gesellschaft kann Darlehen jeder Art aufnehmen sowie Obligationen und Schuldverschreibungen begeben.
Die Gesellschaft kann Hilfeleistungen (in Form von Darlehen, Krediten, Garantien und Bürgschaften, Sicherheiten oder
in sonstiger Weise) an Gesellschaften oder Unternehmen leisten, an denen die Gesellschaft beteiligt ist oder die der
gleichen Gruppe von Gesellschaften wie die Gesellschaft angehören. Die Gesellschaft kann ferner Kontroll- oder
Überwachungsmaßnahmen jeglicher Art ergreifen und alle Maßnahmen durchführen, die ihr zur Erfüllung und Entwicklung
des Gesellschaftszwecks zweckmäßig erscheinen.
Die Gesellschaft kann außerdem alle geschäftlichen, technischen, finanziellen sowie sonstigen Tätigkeiten durchführen,
die direkt oder indirekt die Erfüllung und Entwicklung des Gesellschaftszwecks erleichtern können.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Sitz. Der Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch satzungsändernden
Beschluss der Aktionäre an einen beliebigen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Die Adresse des Geschäftssitzes kann innerhalb der Gemeinde Luxemburg durch Beschluss des Verwaltungsrats verlegt
werden.
Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder bevorstehen, die nach Mei-
nung des Verwaltungsrats die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur
Beendigung dieser außergewöhnlichen Ereignisse ins Ausland verlegt werden; diese vorläufigen Maßnahmen haben jedoch
keinerlei Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes wei-
terhin luxemburgisch bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden durch den Verwaltungsrat ergriffen und
sämtlichen Betroffenen angezeigt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das gezeichnete Gesellschaftskapital wird auf zweihundertachtundvierigtausendsechshun-
dert Euro (€ 248.600,-) festgelegt, eingeteilt in vier Anteilsklassen: zweiundzwanzigtausendsechshundert (22.600) Klasse
A-2 Aktien, hundertdreizehntausend (113.000) Klasse B Aktien, sechsundfünfzigtausendfünfhundert (56.500) Klasse C
Aktien und sechsundfünfzigtausendfünfhundert (56.500) Klasse D. Alle Aktien gleich welcher Klasse haben die gleichen
Rechte. Das Gesellschaftskapital kann durch satzungsändernden Beschluss erhöht oder herabgesetzt werden. Soweit
gesetzlich zulässig, kann die Gesellschaft eigene Geschäftsanteile zurückkaufen.
Art. 6. Verkauf von Aktien.
(1) Der Verkauf, die Übertragung, die Belastung sowie jede andere Verfügung über Aktien bedürfen der vorherigen
Zustimmung durch Beschluss der Aktionärsversammlung. Dasselbe gilt für den Verkauf, die Übertragung, die Belastung
oder andere Verfügungen über einzelne einer Aktie innewohnende oder aus einer Aktie folgende Rechte sowie für die
Begründung einer Unterbeteiligung, einer Treuhand oder eines Stimmpools, von Stimmrechtsbindungen oder ähnlichen
Vereinbarungen bezüglich eines Geschäftsanteils (jede dieser vorstehend genannten Maßnahmen hiernach eine «Verfü-
gung»).
(2) Der eine Verfügung begehrende Aktionär ist berechtigt, an der Beschlussfassung mitzuwirken. Vorbehaltlich ab-
weichender Vereinbarungen zwischen den Aktionären steht die Zustimmung im freien Belieben der Aktionäre. Die
Zustimmung kann nur erteilt werden, wenn der die Verfügung begehrende Aktionär den Aktionären den schriftlichen
Nachweis erbracht hat, dass der Erwerber, Rechtsnachfolger oder Pfandgläubiger der zwischen sämtlichen Aktionären
getroffenen Aktionärsvereinbarung (sofern vorhanden) beigetreten ist oder anderweitig an die Verpflichtungen des ver-
fügenden Aktionärs nach Maßgabe der Aktionärsvereinbarung gebunden ist.
(3) Falls die Aktionäre die Zustimmung zu einer Verfügung nicht erteilen, können die betroffenen Aktien durch einen
Beschluss gegen Gewährung einer Gegenleistung, die der Gegenleistung wertmäßig entspricht, zu welcher der
veräußerungswillige Aktionäre die Anteile hätte veräußern können, eingezogen werden. Bestand die dem veräußerungs-
willigen Aktionär angebotene Gegenleistung nicht (ausschließlich) in einer Barzahlung, können die Aktien - unter
Nichtberücksichtigung der nicht in Geld schätzbaren Nebenleistungen - gegen eine gleichwertige Barzahlung eingezogen
werden. Diese wird durch einen Sachverständigen bestimmt, der von dem Verwaltungsrat innerhalb einer Frist von 14
Tagen nach der Aktionärsversammlung, die den Vorschlag der Verfügung abgelehnt hat, ernannt wird. Falls dies nicht
innerhalb einer Periode von einem (1) Monat erfolgt und kein anderer Aktionär die innerhalb dieser Periode die Aktien
zu dem vom Sachverständigen bestimmten Preis kauft, darf der betreffende Aktionär die Verfügung gemäss den, dem
Verwaltungsrat mitgeteilten Bedingungen vornehmen.
(4) Jede Verfügung über eine Mehrheit der Aktien an einem Aktionär oder über einer Mehrheit dieser Aktien zuge-
hörige oder daraus folgende Rechte oder die Begründung einer Unterbeteiligung, eines Stimmpools, von Stimmrechts-
bindungen oder ähnlichen Vereinbarungen bezüglich einer Mehrheit der Aktien an einem Aktionär gelten als Verfügung,
die der vorherigen Zustimmung der Aktionäre der Gesellschaft bedarf; dies gilt nicht für Verfügungen über eine Mehrheit
der Aktien an Aktionären, die von KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & Co. L.P. (hiernach KKR L.P.) oder einem mit KKR
128410
L.P. verbundenen Unternehmen gehalten werden. Jede nach Satz 1 zustimmungspflichtige Verfügung über Aktien an einem
Aktionär berechtigt die mit KKR L.P. verbundenen Aktionär zur Ausübung eines Vorerwerbsrechts an sämtlichen von
dem betroffenen Aktionär gehaltenen Aktien an der Gesellschaft zu den Bedingungen, die in einer zwischen sämtlichen
Aktionären geschlossenen Aktionärsvereinbarung (sofern vorhanden) vereinbart sind. Bis zur Erteilung der nach Satz 1
erforderlichen Zustimmung stehen dem betroffenen Aktionär keine Rechte aus den von ihm gehaltenen Aktien an der
Gesellschaft zu.
Art. 7. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird vom Verwaltungsrat geführt, der aus nicht weniger als drei (3) Mitgliedern
besteht, die nicht unbedingt Aktionäre der Gesellschaft sein müssen (die «Verwaltungsratsmitglieder»).
Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher Kapitalmehrheit
bestellt und abberufen. Die Dauer des Amtes beträgt einen Zeitraum von nicht mehr als sechs Jahren oder bis ihre
Nachfolger gewählt wurden. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.
Der Verwaltungsrat kann einen Sekretär wählen, welcher kein Verwaltungsratmitgelied sein muss.
Die Verwaltungsratsitzungen werden durch den Vorstandsvorsitzenden, den Sekretär oder zwei Verwaltungsratmit-
geliedern einberufen.
Eine schriftliche Einberufung jeder Verwaltungsratssitzung ist den Verwaltungsratsmitgliedern wenigstens 24 Stunden
im voraus zuzuschicken, ausser es handelt sich um eine dringliche Angelegenheit, deren Umstände in der schriftlichen
Einberufung genannt werden müssen.
Die schriftliche Einberufung entfällt, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder schriftlich oder per Fax, Telegramm oder
ähnliche Kommunikationsmittel, darauf verzichten. Eine schriftliche Einberufung ist nicht nötig, wenn eine Verwaltungs-
ratssitzung, deren Datum und Ort in einem vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates bestimmt hat.
Der Verwaltungsrat kann in gültiger Weise beraten und Beschlüsse fassen ohne vorherige Einberufung, wenn alle
Verwaltungsratmitgelieder anwesend oder vertreten sind. Die Anzahl der Vollmachten, die ein Verwaltungsratmitgelied
annehmen und aufgrund derer er Stimmrechte ausüben kann, ist unbeschränkt.
Der Verwaltungsrat kann nur in gültiger Weise beraten und Beschlüsse fassen wenn mindestens zwei Verwaltungs-
ratmitgelieder anwesend oder durch Vollmachten vertreten sind. Sämtliche Entscheidungen des Verwaltungsrates
bedürfen der einfachen Mehrheit. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende oder der von ihm bevollmächtigte Vertreter
eine zweite Stimme.
Jedes Verwaltungsratmitgelied kann an jeder Verwaltungsratssitzung mittels Telefon-Konferenz oder mittels anderer
ähnlicher Kommunikationsmitteln, die es allen Verwaltungsratmitgliedern ermöglichen, einander zu hören und miteinan-
der zu kommunizieren, teilnehmen. Eine Verwaltungsratssitzung kann auch ausschließlich mittels Telefon-Konferenz
abgehalten werden. Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung sowie die Abhaltung einer Verwaltungsratssitzung in
solcher Weise ist einer persönlichen Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung bzw. einer Abhaltung einer Verwal-
tungsratssitzung unter Anwesenheit sämtlicher Verwaltungsratmitglieder gleichwertig. Der Verwaltungsrat kann seine
Beschlüsse auch einstimmig auf einem Dokument oder mehreren ähnlichen Dokumenten mittels Rundschreiben schriftlich
per Brief, Telegramm oder Fax oder ähnlicher Kommunikationsmittel fassen. Die verschiedenen Dokumente bilden ge-
meinsam das rechtsgültig unterschriebene Rundschreiben, das den Beschluss beweist.
Die beweiskräftige Beglaubigung sowie die Ausstellung von Auszügen über Beschlüsse der Verwaltungsratmitgelieder
erfolgt durch die Unterschrift des Vorstandsvorsitzenden oder von denen die von dem betroffenen Beschluss dazu be-
vollmächtigt wurden.
Gegenüber Dritten haben die Verwaltungsratmitgelieder unter allen Umständen die weitestgehenden Befugnisse, um
für die Gesellschaft zu handeln und um alle die Gesellschaft betreffenden Handlungen und Transaktionen zu tätigen, zu
erlauben und ihnen zuzustimmen. Jedes Verwaltungsratmitgelied ist einzelvertretungsbefugt. Jedes Verwaltungsratmitge-
lied ist befugt, Dritte im Umfang seiner Vertretungsbefugnis zu bevollmächtigen.
Art. 8. Keine persönliche Haftung. Die Verwaltungsratmitgelieder haften nicht persönlich für Verbindlichkeiten der
Gesellschaft. Die Verwaltungsratmitgelieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewis-
senhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Sie sind der Gesellschaft zum Ersatz des aus der Verletzung ihrer Pflichten
entstehenden Schadens verpflichtet.
Art. 9. Hauptversammlungsbeschlüsse.
(1) Jeder Aktionär kann sich an den gemeinsamen Beschlüssen beteiligen. Die Anzahl der Stimmrechte entspricht der
Anzahl der Aktien, die er besitzt. Jeder Aktionär kann sich in Hauptversammlungen rechtsgültig durch einen anderen
Aktionär vertreten lassen; die Vollmacht bedarf der Schriftform; die Anzahl der Vollmachten, die ein Aktionär annehmen
und aufgrund derer er Stimmrechte ausüben kann, ist unbeschränkt.
(2) Jeder Aktionär kann einer Aktionärsversammlung auch mittels Visio-konferenz oder ähnlichen Kommunikations-
mitteln welche eine Identifizierung ermöglichen beiwohnen und gilt dann als anwesend.
(3) Jeder Aktionär kann auch bei einer Aktionärsversammlung mittels Formular wählen. Ein solches Formular muss
folgende Vermerkungen enthalten: (i) Name des Aktionärs, (ii) Anzahl der Aktien, (iii) jeder Punkt der Tagesordnung der
Aktionärsversammlung mit dem Vermerk ob für oder gegen den Punkt gestimmt wird. Ein solches Formular muss vor
der Aktionärsversammlung, gegebenfalls noch am gleichen Tag, der Gesellschaft zukommen.
128411
(4) Soweit nicht Entscheidungen und die Zuständigkeit zur Entscheidung an ein anderes Organ übertragen worden
sind, werden Entscheidungen der Aktionäre durch Hauptversammlungsbeschluss getroffen. Sämtliche Entscheidungen und
Erklärungen, die durch die Aktionäre nach Maßgabe einer zwischen sämtlichen Aktionären getroffenen Aktionärsverein-
barung (sofern vorhanden) zu treffen bzw. abzugeben sind, werden durch Aktionärsbeschluss getroffen.
Art. 10. Aktionärsbeirat. Sämtliche Entscheidungen und Bestimmungen, die durch die Aktionäre nach Maßgabe einer
zwischen sämtlichen Aktionären getroffenen Aktionärsvereinbarung (sofern vorhanden) getroffen werden müssen, kön-
nen, soweit gesetzlich zulässig, durch Beschluss des Verwaltungsrates mit Genehmigung der Aktionärsversammlung an
einen Aktionärsbeirat (der «Beirat») der Gesellschaft übertragen werden, deren Mitglieder und Funktionsweise durch
Hauptversammlungsbeschluss bestimmt werden.
Art. 11. Freistellungsberechtigte. Soweit gesetzlich zulässig, stellt die Gesellschaft sämtliche Personen, einschließlich
von Direktoren und Organmitgliedern der Gesellschaft, die berechtigt für einen Aktionär handeln, (jeweils ein «Freistel-
lungsberechtigter») von sämtlichen Verbindlichkeiten, Haftungen, Schadensersatzansprüchen und dergleichen, die sich aus
Handlungen oder Unterlassungen der Freistellungsberechtigten bei der Wahrnehmung bestimmter Funktionen in der
Gesellschaft oder mit der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar verbundenen Unternehmen ergeben, sei es als Organ-
mitglied, sei es in einem Ausschuss oder Beirat oder in vergleichbarer Funktion, frei. Diese Freistellung gilt nicht für den
Fall, dass die Verbindlichkeiten, Haftungen, Schadensersatzansprüche oder dergleichen auf einem vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Verstoß gegen vertragliche oder gesetzliche Pflichten beruhen.
Art. 12. Hauptversammlungen. Beschlüsse der Aktionäre werden mit den durch das Luxemburgische Gesetz über
Handelsgesellschaften vorgesehenen Mehrheiten gefasst. Beschlüsse der Hauptversammlung werden in Versammlungen,
einschließlich Versammlungen mittels Video-Konferenz oder anderen Kommunikationsmitteln, die es sämtlichen an der
Versammlung teilnehmenden Aktionäre ermöglichen, einander zu hören und miteinander zu kommunizieren, gefasst; die
Teilnahme an einer Versammlung in solcher Weise ist einer persönlichen Teilnahme am Versammlungsort gleichwertig.
Jeder in einer rechtsgültig einberufenen Hauptversammlung der Gesellschaft rechtsgültig gefasste Beschluss sowie jeder
rechtsgültige schriftliche Beschluss bindet die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft.
Versammlungen werden mindestens acht (8) Tage vor dem Versammlungstag mittels einer an sämtliche Aktionäre per
Einschreiben versandten Einberufungsmitteilung einberufen; die Einberufungsmitteilungen sind an die in dem von der
Gesellschaft geführten Gesellschafterregister aufgeführten Adressen zu versenden. Ist das gesamte Gesellschaftskapital
bei einer Hauptversammlung vertreten, kann die Versammlung ohne vorherige Mitteilung abgehalten werden.
Soweit nicht in dieser Satzung oder gesetzlich anders bestimmt, bedürfen Beschlüsse der Hauptversammlung der
Mehrheit des Gesellschaftskapitals. Beschlüsse betreffend die Genehmigung von Verfügungen über Aktien bedürfen einer
Mehrheit von drei viertel des Gesellschaftskapitals in diesem Fall bedürfen die Beschlüsse nur der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen ohne Rücksicht auf den Kapitalanteil. Satzungsändernde Beschlüsse (einschließlich von Beschlüssen über
die Auflösung, Umwandlung oder Spaltung der Gesellschaft) bedürfen einer Mehrheit von drei Viertel des Gesellschafts-
kapitals. Beschlüsse über die Änderung der Nationalität der Gesellschaft bedürfen der Zustimmung sämtlicher Aktionäre.
Die alljährliche Hauptversammlung wird am zweiten Montag des Monats Mai um 14.00 Uhr abgehalten. Sollte dieser
Tag kein Werktag sein, wird die Hauptversammlung am unmittelbar darauffolgenden Werktag abgehalten.
Art. 13. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben
Jahres.
Art. 14. Buchführung. Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Buchführung der Gesellschaft zu
sorgen. Die Verwaltungsratsmitglieder haben den Jahresabschluss innerhalb der gesetzlichen Fristen zeitnah aufzustellen.
Art. 15. Rechnungslegung. Die Überwachung der Gesellschaftstätigkeit unterliegt einem oder mehreren Abschluss-
prüfern, welche von der Hauptversammlung ernannt werden, die auch ihre Amtszeit bestimmt. Die wiederholte
Ernennung von Abschlussprüfern ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig.
Art. 16. Rücklagen. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent der gesetzlichen Rücklage zuzu-
führen; eine Zuführung ist nicht erforderlich, solange und soweit die Rücklage zehn Prozent des ausgegebenen Kapitals
der Gesellschaft übersteigt.
Die Aktionäre können beschließen, Interimsdividenden auszuzahlen, wenn eine von dem Verwaltungsrat aufgestellte
Zwischenbilanz ausweist, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende
Betrag nicht die Gewinne übersteigen darf, die seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres erzielt wurden, zuzüglich des
Gewinnvortrags und der Entnahmen aus hierfür verfügbaren Rücklagen, jedoch vermindert um die Verluste aus früheren
Geschäftsjahren und die Beträge, die einer gesetzlichen Rücklage zugeführt werden müssen. Die vom Verwaltungsrat
erstellte Zwischenbilanz muss gemäss Artikel 72-2 des Luxemburger Gesetzes über Handelsgesellschaften von dem
Der Rechnungssaldo kann auf Beschluss der Aktionäre an die Aktionäre ausgeschüttet werden.
Etwaige Agios können an die Aktionäre auf Beschluss der Aktionäre ausgeschüttet werden. Die Aktionäre können
außerdem beschließen, etwaige Agios ganz oder teilweise dem gesetzlichen Rücklagenkonto zuzuführen.
128412
Art. 17. Auflösung der Gesellschaft. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen Liqui-
dator oder mehrere Liquidatoren, die nicht Aktionäre sein müssen, und die von der Hauptversammlung ernannt werden.
Die Hauptversammlung legt auch die Befugnisse und die Vergütung der Liquidatoren fest.
Art. 18. Einzelaktionär. Für den Fall dass und so lange wie ein Aktionär alle Aktien hält, besteht die Gesellschaft als
Gesellschaft eines Alleingesellschafters gemäß Artikel 23 des Gesetzes über Handelsgesellschaften.
Art. 19. Sonstiges. Soweit diese Satzung keine Regelungen enthält, gilt das anwendbare Recht.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die jetzigen Verwaltungsratmitgelieder werden in ihrem Amt bestätigt und es wird der Beschluss gefasst den Abs-
chlussprüfer in einer anschliessenden Generalversammlung zu ernennen.
Da der Versammlung keine weiteren Angelegenheiten vorliegen, wurde diese daraufhin vertagt.
Die Kosten die der Gesellschaft aus Anlass des Gegenwertigen enstehen werden auf ein tausend fünf hundert abge-
schätzt.
Dem Vorgenannten entsprechend wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg am Tag des zu Beginn
genannten Datums erstellt.
Nachdem das Dokument den erschienenen Personen vorgelesen wurde, welche dem Notar durch ihren Namen,
Vornamen, Stand und ihrer Herkunft nach bekannt sind, haben die Mitglieder des Vorstands zusammen mit uns, Notar,
die hier vorliegende Urkunde unterzeichnet, nachdem keine andere Gesellschafter beantragt hatte, dieselbe zu unter-
zeichnen.
Gezeichnet: P. Prussen, K. Kraemer, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 16, case 1. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 31. Januar 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007132178/211/252.
(070156404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2007.
Kalchesbruck S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 76.354.
In the year two thousand and seven, on the fifteenth day of October.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the company KALCHESBRÜCK S.A., (hereafter the «Company»), a société
anonyme with registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered with the Luxembourg Reister of
Trade and Companies under number B 76.354, incorporated pursuant to a deed of M
e
Emile Schlesser, notary residing
in Luxembourg, dated June 6, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
o
754 of October
13, 2000 and whose articles have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, dated February 26, 2007,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
o
883 of May 15, 2007.
The meeting is chaired by Mr Frank Tölle, with professional address at 4/12 Freyung, A-1010 Vienna, Austria.
The chairman appoints as secretary Mr Matthias Voß, with professional address at Hower Brack 43, D-21037 Hamburg,
Germany.
The meeting elects as scrutineer Mr Michael Liebe, with professional address at Benrather Strasse 18-20, Düsseldorf,
Germany.
The chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholder present or represented and the number of its shares are shown on an attendance list, signed by
the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be registered
with these minutes.
II. As appears from the said attendance list, all shares in circulation representing the whole share capital of the Company,
presently fixed at one hundred thousand Euro (EUR 100,000) are present or represented at this general meeting.
III. The shareholder declares having been informed in advance of the agenda of the meeting and waived all convening
requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the items
of the agenda.
IV. The meeting has been called for with the following agenda:
1) Presentation of the merger project of the Company.
128413
2) Approval of the merger project and decision to realise the merger according to article 259 of the law of August 10,
1915 on commercial companies by the transfer of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of KAL-
CHESBRÜCK NewCo S.A., a société anonyme, having its registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 125.180)
(KALCHESBRÜCK NewCo S.A.), to the Company, followed by the dissolution without liquidation of KALCHESBRÜCK
NewCo S.A.
3) Issuance in favour of the sole shareholder of KALCHESBRÜCK NewCo S.A. of three hundred ten (310) shares
with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100) each in consideration for the transfer of any and all assets, liabilities,
rights, obligations and contracts of KALCHESBRÜCK NewCo S.A. to the Company and cancellation of one thousand
(1,000) shares of the Company with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100) each previously held by KALCHES-
BRÜCK NewCo S.A.
4) Acknowledgement of the effective date of the merger.
5) Complete restatement of the articles of association of the Company.
6) Appointment of two additional directors of the Company.
7) Miscellaneous.
V. The provisions of the law of 10th August 1915 on commercial companies (the «Law») regarding the merger have
been fulfilled:
1) Publication on September 14, 2007 of the merger project in the Mémorial C, number 1981, one month before the
date of the general meetings convened to decide on the merger project.
2) Drawing up of a written report by the director of each of the merging companies explaining the merger project
and in particular the share exchange ratio.
3) Drawing up of a report by an independent expert, Mr. Jean-Bernard Zeimet, Réviseur d'Entreprises, residing at 67,
rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, appointed at the joint request of KALCHESBRÜCK NewCo S.A. and the Com-
pany by the judge of the «tribunal d'arrondissement» in accordance with article 266 of the Law.
4) Deposit of the documents required by article 267 of the Law at the registered office of the Company one month
before the date of the general meetings of the merging companies.
A copy of the reports mentioned at point 2) and 3) will be annexed to the present deed.
After having approved the above, the general meeting took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting declares that it has knowledge of the merger project and the proposed acquisition of KALCHES-
BRÜCK NewCo S.A by the Company. The merger will be implemented by the contribution of any and all assets liabilities,
rights, obligations and contracts of KALCHESBRÜCK NewCo S.A., without exception and reserves, to the Company.
The meeting notes that the merger project has been executed by the director of the Company and KALCHESBRÜCK
NewCo S.A on August 28, 2007 and has been published in the Mémorial C, number 1981 of September 14, 2007, in
accordance with article 262 of the Law.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to approve the merger project of the Company as published in the Mémorial C, number
1981 of September 14, 2007 in all its provisions and in its entirety, without exception and reserves.
The general meeting further resolves to realise the merger of the Company by the acquisition of KALCHESBRÜCK
NewCo S.A. In this respect, the general meeting resolved to approve the allocation of any and all assets, liabilities, rights,
obligations and contracts of KALCHESBRÜCK NewCo S.A. to the Company and the issue and conditions of issue of new
shares, all in accordance with the exchange ratio as published in the Mémorial C, number 1981 of September 14, 2007
as well as in accordance with the balance sheet annexed to the merger project.
The new shares of the Company shall carry the right to participate in any distribution of profits of the Company as
from March 1, 2007. The new shares will be in registered form and their inscription in the shareholders' register of the
Company will occur on the day of the present deed.
According to article 266 of the Law, Mr Jean-Bernard Zeimet, Réviseur d'Entreprises, residing at 67, rue Michel Welter,
L-2730 Luxembourg acting as independent expert for the Company and the Absorbing Company, appointed at the joint
request of KaLCHESBRÜCK NewCo S.A. and the Company by the judge of the «tribunal d'arrondissement» in accordance
with article 266 of the Law examined in its written report the merger project and share exchange ratio being three
hundred ten (310) new shares in the Company in exchange for three hundred ten (310) shares of KALCHESBRÜCK
NewCo S.A.
The independent expert's report states the following:
«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe
that the share exchange ratio defined in the merger plan is not reasonable and relevant and that the evaluation methods
used to determine the exchange ratio are not adequate and justified in the circumstances.»
The report is annexed to the present deed.
128414
<i>Third resolutioni>
After careful consideration, the general meeting resolves to issue three hundred ten (310) new shares with a nominal
value of one hundred Euro (EUR 100) each (the «New Shares») in consideration for the transfer of any and all assets,
liabilities, rights, obligations and contracts of KALCHESBRÜCK NewCo S.A. to the Company. Considering that pursuant
to such transfer the Company becomes the owner of its current one thousand (1,000) shares with a nominal value of
one hundred Euro (EUR 100), since these were previously held at 100% by KALCHESBRÜCK NewCo S.A., the general
meeting resolves that these one thousand (1,000) own shares shall be cancelled.
The general meeting acknowledged that the New Shares are subscribed as follows:
- SIGNA PROPERTY FUNDS DEUTSCHLAND AG, with registered office at Benrather Straße 18-20, D-40213 Düs-
seldorf, and registered with the Handelsregister B Düsseldorf under HRB no. 51018, sole shareholder of KALCHES-
BRÜCK NewCo S.A., declares to subscribe to three hundred ten shares (310) with a nominal value of one hundred Euro
(EUR 100) each.
The Company moreover declares that the contribution in kind of all assets and liabilities by way of merger between
two Luxembourg companies qualifies for the capital duty exemption according to article 4-1 of the law of 29th December
1971 as amended.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting notes that the merger is effective, from an accounting and fiscal point of view, as from March 1,
2007 without prejudice to the provisions of article 273 of the Law regarding the effects of the merger towards third
parties.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting resolves to amend and to restate the articles of association of the Company and SIGNA PROP-
ERTY FUNDS DEUTSCHLAND AG, aforementioned, as new shareholder of the Company, declares having been
informed in advance on this item of the agenda and waives all convening formalities. The general meeting thus resolves
that the articles of association of the Company shall henceforth read as follows:
« Art. 1. There exists a joint stock company (hereafter the «Company»), which will be governed by the laws pertaining
to such an entity and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the
«Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).
Art. 2. The Company's purpose is the acquisition of real estate, the exploitation and administration of acquired real
estate and the offering of investments or participations in such real estate by domestic or foreign companies or businesses.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt securities. The Company may lend funds including the proceeds of any
borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies. It may also give guarantees and grant
securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries and affiliated companies
or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or
over some of its assets and shall open bank accounts in its name.
The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or real estate transactions with respect to movables or im-
movables, which are directly or indirectly connected with the Company's purpose.
It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may
take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose.
Art. 3 . The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company has the name KALCHESBRÜCK S.A.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg (Municipality of Luxembourg).
The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in compliance with the articles of association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
The decisions in Article 5 have to be taken by unanimous resolution.
Art. 6. The share capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) represented by three hundred ten (310)
shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100) each.
The shares are nominal or bearer shares.
128415
The Company can redeem its own shares according to the provisions of the Law. This decision has to be taken by
unanimous resolution.
Art. 7. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the
shareholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles. This decision has to be taken by unanimous resolution.
Art. 8. The Company is managed by a board of directors composed of at least three members who do not need to
be shareholders. If the company is incorporated by one sole shareholder or if at a general meeting it is noticed that the
Company has one sole shareholder, the board of directors can be composed by one sole director until the ordinary
general meeting which takes place after it has been determined the existence of more than one shareholder, unless
another shareholder acquires at least one (1) share in the framework of the merger of KALCHESBRÜCK S.A. In this
case, immediately after the transfer of ownership to the new shareholder, or immediately after the merger, an extraor-
dinary general meeting would have to be called in order to elect a new board of directors consisting of three members,
for which the shareholder belonging to the SIGNA Group or the HSH REAL ESTATE Group can propose one of the
directors and the shareholder belonging to the HSH REAL ESTATE Group can propose the third director.
The directors are appointed by the general meeting for a period not exceeding six years. They may be dismissed ad
nutum. The appointment and dismissal of the directors have to be decided by unanimous resolution of all shareholders
or, in case of a sole shareholder, by decision of the sole shareholder.
In the event of a vacancy of an appointed director,
- an extraordinary general meeting has to be convened which elects a new director, or
- the remaining directors can preliminary fill in the vacancy. In this case the definitive appointment of the new director
is decided by the next general meeting.
The company will pay the directors any expenses they have incurred in relation to their mandate as director.
Art. 9. The board of directors elects a chairman under its members. In case of the absence of the chairman, a director
which is designated by the board of directors takes over his function.
The board of directors is convened by the chairman or upon demand of any directors.
The board of directors can validly deliberate if the majority of its members is present or represented; a director can
only represent one director. In case the board of directors is composed of one sole member, this director has the function
of the board of directors.
The members of the board of directors can vote in writing, by telex or by telefax. Telegrams and Telefax have to be
confirmed in writing.
Any director may participate in any meeting of the board of directors to be held in Luxembourg by telephone or video
conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear
one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The above provisions are not valid in the case of a sole director.
Art. 10. The resolutions of the board of directors shall be adopted by the majority of directors present or represented
at the meeting or in case of a sole director by this sole director, provided that the present Articles do not foresee another
quorum or unanimous vote. In case of equality of votes the vote of the chairman is preponderant.
Art. 11. The minutes of the board of directors' meetings are signed by the directors present at the meeting.
The certification of copies or extracts is done by a director or by a representative.
Art. 12. In dealing with third parties, the board of directors will have all powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and
provided the terms of this article shall have been complied with. All powers not expressly reserved by law or the present
Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may only perform the following acts with the approval of the general meeting of the share-
holders. Approval can only be granted by unanimous resolution of the general meeting.
1. Conclusion, amendments or termination of contracts with
- shareholders,
- affiliated companies of shareholders,
- the financing banks,
- the tenants DELOITTE and NORDEA BANK or,
- employees, service providers appointed by the Company or directors employed by the Company.
2. Any business affair causing costs of more than EUR 50,000 as well as the granting of proxies or power of procuration.
Art. 13. The board of directors may sub-delegate to its members or to a third party who does not need to be a
shareholder, his power for the management of the daily business of the Company. The transfer to a member of the board
of directors requires the prior approval by the general meeting and is limited to one financial year.
128416
Art. 14. The Company shall be validly committed towards third parties by the joint signature of two directors, or in
case of a sole director, by the signature of the sole director or by the sole signature of a delegate of the board of directors
acting in conformity with the powers granted to him.
Art. 15. The activity of the Company is controlled by one or more statutory auditors, who do not need to be share-
holders, to be appointed by unanimous decision of the general meeting which determines its number and its remuneration.
This does not apply to the case where another shareholder acquires at least one (1) share in the framework of the
merger of KALCHESBRÜCK S.A. In this case, the extraordinary general meeting called immediately after the transfer of
ownership to the new shareholder or immediately after the merger may elect one or more new auditors, for which both,
the shareholder belonging to the SIGNA Group and the one belonging to the HSH REAL ESTATE Group can propose
one of the auditors.
The duration of the mandate of the statutory auditor is determined by the general meeting. However, it cannot exceed
six years.
Art. 16. The general meeting of shareholders represents all shareholders. It has the largest powers to decide on the
affairs of the Company unless the present Articles state otherwise. The general meeting decides about the amendment
of the articles of association as well as further items foreseen by the present Articles by unanimous resolution unless
these provide for another quorum.
The general meeting is convened according to the provisions of the Law.
Art. 17. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at registered office or at
the place specified in the convening notices on the first Monday of the month of June at 10 a.m.
In case the above mentioned day is a public holiday, the meeting will take place on the first business day following
thereafter.
Art. 18. The board of directors or the statutory auditor(s) can convene a general meeting. It has to be convened upon
request of shareholders, who represent less than 10% of the share capital.
Art. 19. Each share entitles to one vote. The Company will recognize only one owner per share. If there are several
owners of a share, the Company shall be entitled to suspend the exercise of the rights attached thereto until one person
is designated as being the owner vis-à-vis the Company.
Art. 20. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the
same year.
Art. 21. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the board of directors
prepares an inventory of the assets and liabilities of the company, the balance sheet and the profit and loss account, in
accordance with the Law.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company upon the adoption of a resolution of the board of managers proposing the dividend distribution and upon the
adoption of a shareholders' resolution deciding the dividend distribution.
Art. 23. The director, or in case of plurality of directors, the board of directors may resolve to pay interim dividends
before the end of the current financial year, excluding the first financial year, under following conditions:
The director or the board of directors has to establish an interim balance sheet showing that sufficient funds are
available for distribution. Any director may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet be reviewed
by an independent auditor at the Company's expense.
The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, if any, increased
by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be
established according to the Law or the Articles.
Art. 24. The dissolution and the liquidation of the Company must be decided by unanimous resolution of the extra-
ordinary shareholders meeting in front of a Luxembourg notary. The shareholders belonging to the SIGNA Group or
the HSH REAL ESTATE Group both have the right to denominate one liquidator each who proceeds with the liquidation
of the Company. The general meeting of shareholders or the sole shareholder, as the case may be, shall appoint one or
more liquidators that will carry out the liquidation, shall specify the powers of such liquidator(s) and determine his/their
remuneration. When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company, if any, shall be
attributed to the shareholders proportionally to the shares they hold.
128417
Art. 25. All legal acts (transfer, encumbrances, material amendments and other dispositions) are subject to prior
approval of the general meeting, except for the disposition about one (1) share in favour of the newly joining shareholder
in relation to the merger of the Company.
Art. 26. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.»
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting resolves to appoint with effect as of the date of the present deed the following persons as
additional directors of the Company, their mandate expiring at the ordinary general meeting approving the annual accounts
as at December 31, 2012:
- Mr Matthias Voß, born on September 12, 1970 in Kiel, Germany, residing at Hower Brack 43, 21037 Hamburg,
Germany;
- Mr Ernst-Willhelm Münster, born on July 2nd, 1949 in Schleswig, Germany; residing c/o HSH NORDBANK PRIVATE
BANKING S.A., 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary states the existence and the legality of the deeds and formalities executed by the Company
and KALCHESBRÜCK S.A. in view of the merger.
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this merger are estimated at approximately one thousand and nine hundred Euro (1,900 EUR).
There being nothing further on the agenda the meeting is closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Munsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all known to the notary, by their surnames, first names,
civil status and residence, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundsieben, am fünfzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Jean Seckler, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Findet die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft KALCHESBRUCK S.A., (hiernach die «Gesell-
schaft») statt, einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister
Luxemburg, Sektion B, Nr. 76.354, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch Maître Emile Schlesser, Notar mit
Amtssitz in Luxemburg, am 6. Juni 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr 754 vom
13 Oktober 2000. Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeich-
neten Notar, am 26. Februar 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 883 vom 15.
Mai 2007.
Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Franck Tölle, mit beruflicher Anschrift in 4/12 Freyung, A-1010 Wien,
Österreich.
Der Vorsitzende bestellt Herrn Matthias Voß, mit beruflicher Anschrift in Hower Brack 43, D-21037, Hamburg,
Deutschland, zum Schriftführer.
Die Generalversammlung ernennt Herrn Michael Liebe, mit beruflicher Anschrift in Benrather Strasse 18-20, Düssel-
dorf, Deutschland.
Der Vorsitzende bittet den Notar folgendes festzuhalten:
I. Der bei der Generalversammlung anwesende oder vertretene Aktionär, sowie die Anzahl der von ihm gehaltenen
Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste eingetragen, die vom Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmenzähler und
dem unterzeichneten Notar unterschrieben wird. Diese Liste sowie die Vollmacht bleiben der gegenwärtigen Urkunde
zwecks Einregistrierung beigefügt.
II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft von einhunderttausend
Euro (EUR 100.000) bei dieser außerordentlichen Generalversammlung vertreten ist.
III. Der Aktionär erklärt, vorab über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden zu sein und verzichtet
auf die Einhaltung der Einberufungsformalitäten. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengetreten und kann
wirksam über die Tagesordnungspunkte entscheiden.
IV. Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung der Versammlung:
1) Vorstellung des Verschmelzungsplans der Gesellschaft.
128418
2) Genehmigung des Verschmelzungsplans und Entscheidung, die Verschmelzung gemäß Art. 259 des Gesetzes vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaften durch die Übertragung aller Aktiva, Verbindlichkeiten, Rechte, Verpflichtun-
gen und Verträge der KALCHESBRÜCK NewCo S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 560, rue de Neudorf, L-2220
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 125.1809
(KALCHESBRÜCK NewCo S.A.) an die Gesellschaft vorzunehmen, gefolgt von der anschließenden Auflösung ohne Li-
quidation der KALCHESBRÜCK NewCo S.A.
3) Ausgabe von dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100) an den einzigen
Aktionär von KALCHESBRÜCK NewCo S.A. als Gegenleistung für die Übertragung aller Aktiva, Verbindlichkeiten,
Rechte, Verpflichtungen und Verträge der KALCHESBRÜCK NewCo S.A an die Gesellschaft und Annullierung von ein-
tausend (1.000) Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100), die alle zuvor von
KALCHESBRÜCK NewCo S.A. gehalten wurden.
4) Anerkennung des Wirksamkeitsdatums der Verschmelzung.
5) Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft.
6) Ernennung von zwei weiteren Verwaltungsratsmitgliedern.
7) Verschiedenes.
V. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das «Gesetz») bezüglich Ver-
schmelzungen wurden eingehalten:
1) Veröffentlichung des Verschmelzungsplans am 14.September 2007 im Mémorial C, Nummer 1981, einen Monat vor
dem Stattfinden der Generalversammlungen, die zur Abstimmung über den Verschmelzungsplan einberufen worden sind.
2) Abfassung eines schriftlichen Berichts durch den Verwaltungsrat jeder verschmelzenden Gesellschaft, der den Ver-
schmelzungsplan und im Besonderen das Austauschverhältnis der Anteile erläutert.
3) Abfassung eines Berichts durch einen unabhängigen Prüfer, Herrn Jean-Bernard Zeimet, Réviseur d'Entreprises,
wohnhaft in 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxemburg, ernannt auf gemeinsamen Antrag von KALCHESBRÜCK NewCo
S.A. und der Gesellschaft durch den Richter des «tribunal d'arrondissement» in Übereinstimmung mit Art. 266 des Ge-
setzes.
4) Hinterlegung der Unterlagen gemäß Art. 267 des Gesetzes am Gesellschaftssitz der Gesellschaft einen Monat vor
dem Stattfinden der Generalversammlungen der fusionierenden Gesellschaften.
Eine Kopie der unter Punkt 2) und 3) erwähnten Berichte wird dieser Urkunde als Anlage beigefügt.
Nach Feststellung des obigen, fasst die Generalversammlung die folgenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung erklärt Kenntnis von dem Verschmelzungsplan und von dem vorgeschlagenen Erwerb der
KALCHESBRÜCK NewCo S.A. durch die Gesellschaft zu haben. Die Verschmelzung wird umgesetzt durch die Einbrin-
gung aller Aktiva, Verbindlichkeiten, Rechte, Verpflichtungen und Verträge der KALCHESBRÜCK NewCo S.A., ohne
Ausnahmen und Vorbehalte, in die Gesellschaft. Die Versammlung stellt fest, dass der Verschmelzungsplan durch den
Verwaltungsrat der Gesellschaft und KALCHESBRÜCK NewCo S.A. am 28. August 2007 unterzeichnet und im Mémorial
C, Nummer 1981 vom 14. September 2007 veröffentlicht wurde, gemäß Art. 262 des Gesetzes.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, den Verschmelzungsplan der Gesellschaft, wie er im Mémorial C, Nummer 1981
vom 14. September 2007 veröffentlicht wurde, vollständig und ohne Ausnahmen und Vorbehalte zu genehmigen.
Die Generalversammlung beschließt außerdem, die Verschmelzung der Gesellschaft durch den Erwerb der KAL-
CHESBRÜCK NewCo S.A. durchzuführen. In dieser Hinsicht beschließt die Generalversammlung die Zuordnung aller
Aktiva, Verbindlichkeiten, Rechte, Verpflichtungen und Verträge der KALCHESBRÜCK NewCo S.a. an die Gesellschaft
und die Ausgabe und die Bedingungen der Ausgabe von neuen Aktien, in Übereinstimmung mit dem Austauschverhältnis,
wie es im Mémorial C, Nummer 1981 vom 14. September 2007 veröffentlicht wurde und in Übereinstimmung mit der
Bilanz, die dem Verschmelzungsplan beigefügt ist, zu genehmigen.
Den neuen Aktien der Gesellschaft soll das Recht zur Beteiligung an der Ausschüttung von Gewinnen der Gesellschaft
ab dem 1. März 2007 zustehen. Die neuen Aktien werden die Form von Inhaberaktien haben und ihre Eintragung in das
Aktionärsregister der Gesellschaft wird am Tag der vorliegenden Urkunde erfolgen.
Gemäß Art. 266 des Gesetzes hat Herr Jean-Bernard Zeimet, Réviseur d'Entreprises, wohnhaft in 67, rue Michel
Welter, L-2730 Luxemburg, ernannt auf gemeinsamen Antrag von KALCHESBRÜCK NewCo S.A. und der Gesellschaft
durch den Richter des «tribunal d'arrondissement» in Übereinstimmung mit Art. 266 des Gesetzes, in seinem schriftlichen
Bericht den Verschmelzungsplan und das Austauschverhälntis von dreihundertzehn (310) neuen Aktien in der Gesellschaft
im Austausch für dreihundertzehn (310) Aktien in KALCHESBRÜCK NewCo S.A. untersucht.
Der Bericht des unabhängigen Prüfers kommt zu folgender Schlussfolgerung:
«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe
that the share exchange ratio defined in the merger plan is not reasonable and relevant and that the evaluation methods
used to determine the exchange ratio are not adequate and justified in the circumstances.»
128419
Der Bericht wird dieser Urkunde als Anlage beigefügt.
<i>Dritter Beschlussi>
Nach eingehender Überlegung beschließt die Generalversammlung, dreihundertzehn (310) neue Aktien mit einem
Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100) (die «Neuen Aktien») als Gegenleistung für die Übertragung aller Aktiva,
Verbindlichkeiten, Rechte, Verpflichtungen und Verträge von KALCHESBRÜCK NewCo S.A. an die Gesellschaft auszu-
geben. In Anbetracht der Tatsache, dass aufgrund dieser Übertragung die Gesellschaft die Eigentümerin der von ihr
ausgegebenen eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100) wird, da diese bisher
zu 100% durch KALCHESBRÜCK NewCo S.A. gehalten wurden, beschließt die Generalversammlung, dass diese eintau-
send (1.000) eigenen Aktien annulliert werden sollen.
Die Generalversammlung erkennt an, dass die Neuen Aktien wie folgt gezeichnet werden:
- SIGNA PROPERTY FUNDS DEUTSCHLAND AG, mit Sitz in Benrather Straße 18-20, D-40213 Düsseldorf, regist-
riert beim Handelsregister B Düsseldorf unter Nummer HRB 51018, einzige Aktionärin von KALCHESBRÜCK NewCo
S.A., erklärt, dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100) zu zeichnen.
Die Gesellschaft erklärt außerdem, dass die Einbringung aller Aktiva und Passiva durch Verschmelzung zweier luxem-
burgischer Gesellschaften unter die Befreiung von der Einlagepflicht gemäß Art. 4-1 des Gesetzes vom 29. Dezember
1971, wie abgeändert, fällt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung stellt fest, dass die Verschmelzung aus buchhalterischer und steuerlicher Sicht ab dem 1.
März 2007 wirksam ist, unbeschadet der Vorschriften von Art. 273 des Gesetzes hinsichtlich der Wirksamkeit der Ver-
schmelzung gegenüber Dritten.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, die Satzung abzuändern und neuzufassen und SIGNA PROPERTY FUNDS
DEUTSCHLAND AG, als neuer Aktionär, erklärt im Vorfeld von der Tagesordnung der Versammlung informiert worden
zu sein und auf alle Einberufungsformalitäten zu verzichten. Die Generalversammlung beschließt somit, dass die Satzung
der Gesellschaft fortan folgenden Wortlaut haben soll:
« Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft (nachfolgend die «Gesellschaft»), die dem auf eine solche Gesellschaft
anwendbaren Recht unterliegt und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in
seiner derzeit geltenden Fassung (nachfolgend das «Gesetz») und dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag (der «Gesell-
schaftsvertrag»).
Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist der Ankauf von Immobilien, die Verwertung und Verwaltung von Immobilien,
die durch die Gesellschaft erworben werden, sowie das Anbieten von Investitionen oder Beteiligungen durch inländische
oder ausländische Gesellschaften und Unternehmen oder Privatpersonen an solchen Immobilien.
Die Gesellschaft kann jedwede Form von Krediten aufnehmen, außer durch öffentliche Platzierung. Die Gesellschaft
kann Darlehen einschließlich der Erlöse aus Krediten und/oder Emissionen von Schuldtiteln an ihre Tochtergesellschaft
oder an verbundene Unternehmen weitergeben. Des weiteren kann die Gesellschaft einen Teil ihres Vermögens oder
ihr gesamtes Vermögen verpfänden, abtreten oder belasten und in ihrem Namen Bankkonten eröffnen.
Die Gesellschaft kann im Allgemeinen jede Maßnahme oder jedes Mittel anwenden, das in Zusammenhang mit Inves-
titionen zum Zwecke der effizienten Verwaltung steht. Darin eingeschlossen sind Maßnahmen und Mittel, die die
Gesellschaft gegen Darlehens-, Währungskurs-, Zins- und andere Risiken absichern sollen.
Die Gesellschaft kann jedes Handels-, Finanz- oder Immobiliengeschäft in Bezug auf bewegliche oder unbewegliche
Güter tätigen, das direkt oder indirekt mit dem Gegenstand der Gesellschaft zusammenhängt.
Sie kann jede gewerbliche Tätigkeit ausüben und ein der Öffentlichkeit zugängliches gewerbliches Unternehmen führen.
Im Allgemeinen kann sie jedwede Maßnahme zur Kontrolle und Aufsicht ergreifen und jede Handlung vornehmen, die sie
zur Ausführung und Entwicklung ihres Gegenstandes als nützlich erachtet.
Art. 3. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist KALCHESBRUCK S.A.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Gebiet der Stadt Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, der unter
Einhaltung der im Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Bestimmungen gefasst wird, an jeden anderen Ort innerhalb des
Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Der Gesellschaftssitz kann innerhalb des Stadtgebietes an jeden anderen Ort durch Beschluss des Verwaltungsrates
verlegt werden.
Die Gesellschaft kann innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder in anderen Ländern Tochtergesellschaften oder
Zweigniederlassungen gründen.
Die Beschlüsse in Artikel 5 müssen einstimmig gefasst werden.
128420
Art. 6. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000), eingeteilt in
dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von je hundert Euro (EUR 100).
Die Aktien haben die Form von Namens- oder Inhaberaktien.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
erwerben. Ein Beschluss hierüber muss einstimmig gefasst werden.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluss des alleinigen Aktionärs oder der Generalver-
sammlung, in Übereinstimmung mit Artikel 16 des Gesellschaftsvertrages abgeändert werden. Der Beschluss ist einstim-
mig zu fassen.
Art. 8 . Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen. Sofern die Gesellschaft mit einem Aktionär gegründet wird oder sofern anlässlich einer
Generalversammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, kann sich der Verwaltungsrat aus
einem einzigen Mitglied zusammensetzen und zwar bis zur ordentlichen Generalversammlung, die stattfindet, nachdem
die Existenz von mehr als einem Aktionär festgestellt wurde, es sei denn, es erwirbt ein weiterer Aktionär in zeitlichem
oder sachlichem Zusammenhang mit einer Verschmelzung auf die KALCHESBRUCK S.A. mindestens eine (1) Aktie. In
diesem Fall ist unverzüglich nach Begründung der neuen Aktieninhaberschaft oder unverzüglich nach der Verschmelzung
eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen und ein neuer, aus drei Mitgliedern bestehender Verwaltungsrat
von den Aktionären zu wählen, wobei der oder die Aktionäre, die der SIGNA Gruppe sowie der HSH REAL ESTATE
Gruppe zuzurechnen sind, jeweils einen Verwaltungsrat vorschlagen können und der Aktionär, der zur HSH REAL ES-
TATE Gruppe gehört, das dritte Verwaltungsratsmitglied vorschlagen kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können jederzeit von der Generalversammlung abberufen werden. Die Ernennung und Abberufung
der Verwaltungsratsmitglieder muss durch einstimmigen Beschluss aller Aktionäre oder, im Falle eines einzelnen Aktio-
närs, durch den alleinigen Aktionär erfolgen.
Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitgliedes frei, ist
- entweder eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen, auf der ein neues von der Generalversammlung
zu wählendes Verwaltungsratsmitglied einstimmig zu wählen ist oder,
- das frei gewordene Amt von den verbleibenden Verwaltungsratsmitgliedern vorläufig zu besetzen. In diesem Fall
erfolgt die endgültige Wahl des neuen Verwaltungsratsmitglieds durch die nächste Generalversammlung.
Die Gesellschaft ersetzt den Verwaltungsratsmitgliedern die Kosten, die im Zusammenhang mit der Ausübung ihres
Mandats entstanden sind.
Art. 9. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsit-
zenden übernimmt ein vom Verwaltungsrat einstimmig zu bestimmendes Mitglied dessen Aufgabe.
Der Verwaltungsrat kann vom Vorsitzenden oder von jedem einzelnen Verwaltungsratsmitglied einberufen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind, wobei ein Verwal-
tungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Sofern der Verwaltungsrat aus einem einzelnen Mitglied
besteht, nimmt dieses die Funktionen des Verwaltungsrates wahr.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax
abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer in Luxemburg abgehaltenen Verwaltungsratssitzung per Telefon oder
Videokonferenz oder mit vergleichbaren Mitteln der Telekommunikation, die es den Verwaltungsratsmitgliedern erlau-
ben, sich gegenseitig zu hören, teilnehmen. Die Teilnahme unter diesen Umständen ist gleichwertig zur Teilnahme in
Person.
Die oberen Vorschriften gelten nicht im Falle eines einzelnen Verwaltungsratsmitglieds.
Art. 10. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit und, im Falle eines einzelnen
Verwaltungsratsmitglieds, durch dieses, getroffen, sofern in diesem Vertrag oder im Gesetz kein anderes Quorum bzw.
keine Einstimmigkeit geregelt ist.
Art. 11. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 12. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch
das Gesetz oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag der Generalversammlung vorbehalten ist.
Der Verwaltungsrat darf folgende Rechtsgeschäfte nur mit Einwilligung der Generalversammlung vornehmen. Eine
Einwilligung liegt nur vor, wenn die Generalversammlung hierüber einstimmig beschlossen hat.
1. Abschluss, Änderung oder Beendigung von Verträgen mit
128421
- Aktionären,
- verbundenen Unternehmen von Aktionären,
- der finanzierenden Bank,
- den Mietern DELOITTE und NORDEA BANK oder
- Arbeitnehmern, von der Gesellschaft beauftragten Dienstleistern oder von der Gesellschaft angestellten Verwal-
tungsräten.
2. Jegliche Geschäftsführungsmaßnahme, die Kosten von mehr als EUR 50.000 verursacht, sowie die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren.
Art. 13. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung, die einstimmig zu erfolgen hat und nur mit einer Befristung von
einem Geschäftsjahr vorgenommen werden darf.
Art. 14. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet
- durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder
- im Falle eines einzigen Verwaltungsratsmitgliedes, durch die Unterschrift dieses Verwaltungsratsmitgliedes, oder
- durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwal-
tungsrates.
Art. 15. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird, vorbehaltlich Satz 2, durch einen oder mehrere von der Generalver-
sammlung durch einstimmigen Beschluss ernannte Kommissare kontrolliert, welche nicht Aktionäre sein müssen, der ihre
Anzahl und ihre Vergütung festlegt und die Ernennung wieder aufheben kann.
Etwas anderes gilt, sofern ein weiterer Aktionär in zeitlichem oder sachlichem Zusammenhang mit einer Verschmelzung
auf die Gesellschaft mindestens eine (1) Aktie der Gesellschaft erwirbt. In diesem Fall können auf der unverzüglich nach
Begründung der neuen Aktieninhaberschaft, oder unverzüglich nach der Verschmelzung einzuberufenden außerordentli-
chen Generalversammlung ein oder mehrere neue Kommissare von der Generalversammlung ernannt werden, wobei
der oder die Aktionäre, die der SIGNA Gruppe sowie der HSH REAL ESTATE Gruppe zuzurechnen sind, jeweils einen
Kommissar vorschlagen dürfen.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Art. 16. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, um über die Ange-
legenheiten der Gesellschaft zu befinden, es sei denn, in diesem Vertrag ist etwas Abweichendes geregelt. Die General-
versammlung entscheidet über die Änderung des Gesellschaftsvertrages sowie über weitere, in diesem Gesellschaftsver-
trag festgelegte Gegenstände durch einstimmigen Beschluss, es sei denn, in diesem Gesellschaftsvertrag ist ein anderes
Quorum geregelt.
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages sowie des
Gesetzes.
Art. 17. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-
schreiben genannten Ort zusammen und zwar jedes Jahr am ersten Montag des Monats Juni um 10 Uhr am Gesellschafts-
sitz oder an jedem anderen Ort, der in der Einberufung der Aktionäre festgelegt wird.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.
Art. 18. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung ein-
berufen. Sie ist auch einzuberufen, falls ein einzelner Aktionär, der weniger als 10% des Gesellschaftskapitals repräsentiert,
einen derartigen Antrag stellt.
Art. 19. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen;
für den Fall, dass eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungs-
rechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger
Eigentümer ernannt wird.
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am einunddreißigsten Tag des Monats
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 21. Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats Dezember werden die Bücher geschlossen und der Verwaltungsrat
erstellt ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, in Über-
einstimmung mit dem Gesetz.
Jeder Aktionär hat das Recht, das genannte Inventar und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einzusehen.
Art. 22. Der Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug von allgemeinen Kosten, Abschreibungen und Rück-
stellungen stellt den Reingewinn des Geschäftsjahres dar.
128422
Fünf Prozent (5%) des Reingewinns werden abgezogen und den gesetzlichen Rücklagen zugewiesen. Die Verpflichtung,
diese Zuweisung vorzunehmen, besteht dann nicht mehr, wenn die gesetzlichen Rücklagen die Höhe von zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht haben.
Der verbleibende Gewinn kann an die Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung ausgeschüttet werden, aufgrund eines
Vorschlags der Generalversammlung, die eine solche Ausschüttung vorschlägt und aufgrund eines Verwaltungsratsbe-
schlusses, der eine solche Ausschüttung vorschlägt.
Art. 23. Der Verwaltungsrat kann beschließen, vor Ende des laufenden Geschäftsjahres, mit Ausnahme des ersten
Geschäftsjahres, eine Zwischendividende auszuschütten. Der Beschluss muss einstimmig erfolgen. Die Bedingungen sind
wie folgt:
Der Verwaltungsrat muss eine Zwischenbilanz erstellen, die ausweist, dass genügend Finanzmittel für eine Ausschüt-
tung vorhanden sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied hat die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen und auf Kosten der
Gesellschaft diese Zwischenbilanz von einem unabhängigen Prüfer prüfen zu lassen.
Der auszuschüttende Betrag darf den am Geschäftsjahresende realisierten Gewinn (wenn vorhanden) zuzüglich des
Gewinnvortrages und Rücklagen und abzüglich des Verlustvortrages und Beträge, die laut Gesetz oder Gesellschafter-
vertrag den Rücklagen zugeführt werden müssen, nicht übersteigen.
Art. 24. Die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft muss durch einstimmigen Beschluss der Generalversammlung
vor einem Luxemburgischen Notar beschlossen werden. Aktionäre, die der SIGNA Gruppe oder der HSH REAL ESTATE
Gruppe zuzurechnen sind, ernennen jeweils einen Liquidator, der die Liquidation durchführt. Die Befugnisse und die
Entschädigung werden von der Generalversammlung festgelegt. Ein Beschluss hierüber muss einstimmig erfolgen. Wenn
die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen wird, steht der Liquidationserlös den Aktionären im Verhältnis ihrer Anteile
zu.
Art. 25. Sämtliche Verfügungen (Übertragungen, Belastungen, inhaltliche Änderungen oder sonstige Verfügungen) be-
dürfen der Zustimmung der Generalversammlung, mit Ausnahme der Verfügung über eine (1) Aktie zu Gunsten des neu
beitretenden Aktionärs im Zusammenhang mit einer Verschmelzung auf die Gesellschaft.
Art. 26. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag geregelt sind, werden nach
den anwendbaren Gesetzen bestimmt.»
<i>Sechster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt mit Wirkung ab dem Datum der gegenwärtigen Urkunde, die folgenden Personen
als weitere Verwaltungsratsmitglieder zu ernennen; ihr Mandat soll bei der ordentlichen Generalversammlung enden, die
die Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2012 feststellt:
- Herr Matthias Voß, geboren am 12. September 1970 in Kiel, Deutschland, wohnhaft in Hower Brack 43, 21037
Hamburg, Deutschland;
- Herr Ernst-Willhelm Münster, geboren am 2. Juli 1949, in Schleswig, Deutschland, wohnhaft C/O HSH NORDBANK
PRIVATE BANKING S.A., 2, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxemburg.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar stellt die Existenz und die Rechtmäßigkeit der Urkunden und der Formalitäten, die durch
die Gesellschaft und die KALCHESBRUCK S.A im Hinblick auf die Verschmelzung unterzeichnet worden sind, fest.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der Verschmel-
zung entstehen, werden auf ungefähr eintausendsiebenhundert Euro (1.700 EUR) geschätzt.
Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, wird die Versammlung geschlossen.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt, dass die vorliegende Urkunde auf
Verlangen der erschienenen Personen auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Wunsch
derselben erschienenen Personen undi m Falle einer Abweichung zwischen der englischen und der deutschen Fassung,
hat die englische Fassung Vorrang.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Munsbach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: F. Tölle, M. Voß, M. Liebe, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 octobre 2007, Relation: GRE/2007/4715. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
128423
Junglinster, le 5 novembre 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007127908/231/581.
(070152814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.
Kalchesbrück NewCo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 125.180.
In the year two thousand and seven, on the fifteenth day of October.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the company KALCHESBRÜCK NewCo S.A., (hereafter «the Company»),
a société anonyme with registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Company register under number B 125.180, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated
February 26, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no 879 of May 15, 2007 and which
articles have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, dated February 28, 2007, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no 946 of May 22, 2007 and pursuant to a deed of the undersigned
notary, dated February 28, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no 1726 of August
28, 2007.
The meeting is chaired by Mr Frank Tölle, with professional address at 4/12 Freyung, A-1010 Vienna, Austria.
The chairman appoints as secretary Mr Matthias Voß, with professional address at Hower Brack 43, D-21037 Hamburg,
Germany.
The meeting elects as scrutineer Mr Michael Liebe, with professional address at Benrather Strasse 18-20, Düsseldorf,
Germany.
The chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholder present or represented and the number of its shares are shown on an attendance list, signed by
the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be registered
with these minutes.
II. As appears from the said attendance list, all shares in circulation representing the whole share capital of the Company,
presently fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) are present or represented at this general meeting.
III. The shareholder declares having been informed in advance of the agenda of the meeting and waived all convening
requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the items
of the agenda.
IV. The director of the Company has decided by resolutions dated August 28, 2007 to propose to the shareholder of
the Company to merge the Company into KALCHESBRUCK S.A., a société anonyme having its registered office at 560,
rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number
B 76.354, (hereafter the KALCHESBRUCK S.A.).
V. The merger project has been executed on August 28, 2007, published on September 14, 2007 in the Mémorial C,
number 1981.
VI. The agenda of the meeting is the following:
1) Presentation of the merger project of the Company.
2) Approval of the merger project and decision to realise the merger of the Company, according to article 259 of the
law of 10th August 1915 on commercial companies by the transfer, following its dissolution without liquidation, of any
and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Company to KALCHESBRUCK S.A, followed by the
dissolution without liquidation of the Company.
3) Transfer of all and any assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Company to KALCHESBRUCK S.A.
in consideration for the issue of three hundred ten (310) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-)
each of KALCHESBRUCK S.A. (the «New Shares») to the shareholder of the Company.
4) Acknowledgement of the dissolution without liquidation of the Company.
5) Acknowledgement of the effective date of the merger.
6) Miscellaneous.
VII. The provisions of the law of 10th August 1915 on commercial companies (the «Law») regarding the merger have
been fulfilled:
1) Publication on September 14, 2007 of the merger project in the Mémorial C, number 1981, one month before the
date of the general meetings convened to decide on the merger project.
2) Drawing up of a written report by the director of each of the merging companies explaining the merger project
and in particular the share exchange ratio.
128424
3) Drawing up of a report by an independent expert, Mr. Jean-Bernard Zeimet, Réviseur d'Entreprises, residing at 67,
rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, appointed at the joint request of KALCHESBRUCK S.A. and the Company by
the judge of the «tribunal d'arrondissement» in accordance with article 266 of the Law.
4) Deposit of the documents required by article 267 of the Law at the registered office of the Company one month
before the date of the general meetings of the merging companies.
A copy of the reports mentioned at point 2) and 3) will be annexed to the present deed.
After having approved the above, the general meeting takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting declares that it has knowledge of the merger project and the proposed acquisition of the Company
by KALCHESBRUCK S.A. The merger will be implemented by the contribution of any and all assets liabilities, rights,
obligations and contracts of the Company, without exception and reserves, to KALCHESBRUCK S.A. The general meeting
notes that the merger project has been executed by the director of the Company on August 28, 2007 and has been
published in the Mémorial C, number 1981 of September 14, 2007, in accordance with article 262 of the Law.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to approve the merger project of the Company as published in the Mémorial C, number
1981 of September 14, 2007 in all its provisions and in its entirety, without exception and reserves.
The general meeting further resolved to realise the merger by the acquisition of the Company by KALCHESBRUCK
S.A.
The general meeting resolves to approve the allocation of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts
of the Company to KALCHESBRUCK S.A. and the issue and conditions of issue of the New Shares to its shareholder,
all in accordance with the exchange ratio mentioned in the merger project published in the Mémorial C, number 1981
of September 14, 2007 as well as in accordance with the balance sheet annexed to the merger project.
The New Shares of KALCHESBRUCK S.A. shall be vested with the right to participate in any distribution of profits of
KALCHESBRUCK S.A. as from March 1, 2007.
The shareholders' register of KALCHESBRUCK S.A. will be updated in order to reflect the shares issued to the
Company in the framework of the merger.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to transfer to KALCHESBRUCK S.A. any and all assets, liabilities, rights, obligations and
contracts of the Company in the framework of the merger in consideration for the issue of three hundred ten (310)
shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each of KALCHESBRUCK S.A. to the shareholder of the
Company
According to article 266 of the Law, Mr. Jean-Bernard Zeimet, Réviseur d'Entreprises, residing at 67, rue Michel Welter,
L-2730 Luxembourg acting as independent expert for the Company and KALCHESBRUCK S.A., appointed at the joint
request of the Absorbing Company and the Company by the judge of the «tribunal d'arrondissement» in accordance with
article 266 of the Law, examined in his written report the merger project and share exchange ratio being three hundred
ten (310) shares in the Company in exchange for three hundred ten (310) new shares of KALCHESBRUCK S.A.
The independent expert's report stated the following:
«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe
that the share exchange ratio defined in the merger plan is not reasonable and relevant and that the evaluation methods
used to determine the exchange ratio are not adequate and justified in the circumstances.»
Such report is annexed to the present deed.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting states that without prejudice of the approval of the merger project by KALCHESBRUCK S.A.,
the Company will be dissolved without liquidation and will cease to exist pursuant to article 274 of the Law from the day
of the present deed.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting notes that the merger is effective, from an accounting and fiscal point of view, as from March 1,
2007 without prejudice to the provisions of article 273 of the Law regarding the effects of the merger towards third
parties.
Discharge is granted to the director of the Company and to HRT REVISION S.à r.l., as statutory auditor of the
Company, for the accomplishment of their mandate until today.
<i>Statementi>
The undersigned notary states the existence and the legality of the deeds and formalities executed by the Company
and KALCHESBRUCK S.A. in view of the merger.
128425
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this merger are estimated at approximately one thousand and seven hundred Euro (1,700.- EUR).
There being nothing further on the agenda the meeting is closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Munsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all known to the notary, by their surnames, first names,
civil status and residence, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundsieben, am fünfzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Jean Seckler, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Findet die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft KALCHESBRÜCK NewCo S.A., (hiernach die
«Gesellschaft») statt, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, eingetragen im Han-
delsregister Luxemburg, Sektion B, Nr 125.180, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten
Notar, am 26. Februar 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr 879 vom 15. Mai
2007. Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar,
am 28. Februar 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nr 946 vom 22. Mai 2007 und
gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 28. Februar 2007, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nr 1726 vom 28. August 2007.
Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Franck Tölle, mit beruflicher Anschrift in 4/12 Freyung, A-1010 Wien,
Österreich.
Der Vorsitzende bestellt Herrn Matthias Voß, mit beruflicher Anschrift in Hower Brack 43, D-21037, Hamburg,
Deutschland, zum Schriftführer.
Die Generalversammlung ernennt Herrn Michael Liebe, mit beruflicher Anschrift in Benrather Strasse 18-20, Düssel-
dorf, Deutschland, zum Stimmenzähler.
Der Vorsitzende bittet den Notar folgendes festzuhalten:
I. Der bei der Generalversammlung anwesende oder vertretene Aktionär, sowie die Anzahl der von ihm gehaltenen
Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste eingetragen, die vom Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmenzähler und
dem unterzeichneten Notar unterschrieben wird. Diese Liste sowie die Vollmacht bleiben der gegenwärtigen Urkunde
zwecks Einregistrierung beigefügt.
II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft von einunddreissigtausend
Euro (EUR 31.000,-) bei dieser außerordentlichen Generalversammlung vertreten ist.
III. Der Aktionär erklärt, vorab über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden zu sein und verzichtet
auf die Einhaltung der Einberufungsformalitäten. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengetreten und kann
wirksam über die Tagesordnungspunkte entscheiden.
IV. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat am 28. August 2007 beschlossen, dem Aktionär die Verschmelzung der
Gesellschaft mit KALCHESBRUCK S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg,
eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 76.354 (hiernach KALCHESBRUCK S.A.) vorzu-
schlagen.
V. Der Verschmelzungsplan wurde unterzeichnet am 28. August und am 14. September 2007 im Mémorial C, Nummer
1981 veröffentlicht.
VI. Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung der Versammlung:
1) Vorstellung des Verschmelzungsplans der Gesellschaft.
2) Genehmigung des Verschmelzungsplans und Entscheidung, die Verschmelzung gemäß Art. 259 des Gesetzes vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaften durch die Übertragung aller Aktiva, Verbindlichkeiten, Rechte, Verpflichtun-
gen und Verträge der Gesellschaft an KALCHESBRUCK S.A. vorzunehmen, gefolgt von der anschließenden Auflösung
ohne Liquidation der Gesellschaft.
3) Übertragung aller Aktiva, Verbindlichkeiten, Rechte, Verpflichtungen und Verträge der Gesellschaft an KALCHES-
BRUCK S.A. in Gegenleistung für die Ausgabe von dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert
Euro (EUR 100,-) von KALCHESBRUCK S.A. (die «Neuen Aktien») an den Aktionär der Gesellschaft.
4) Anerkennung der Auflösung ohne Liquidation der Gesellschaft.
5) Anerkennung des Wirksamkeitsdatums der Verschmelzung.
6) Verschiedenes.
128426
VII. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das «Gesetz») bezüglich Ver-
schmelzungen wurden eingehalten:
1) Veröffentlichung des Verschmelzungsplans am 14. September 2007 im Mémorial C, Nummer 1981, einen Monat
vor dem Stattfinden der Generalversammlungen, die zur Abstimmung über den Verschmelzungsplan einberufen worden
sind.
2) Abfassung eines schriftlichen Berichts durch den Verwaltungsrat jeder verschmelzenden Gesellschaft, der den Ver-
schmelzungsplan und im Besonderen das Austauschverhältnis der Anteile erläutert.
3) Abfassung eines Berichts durch einen unabhängigen Prüfer, Herrn Jean-Bernard Zeimet, Réviseur d'Entreprises,
wohnhaft in 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxemburg, ernannt auf gemeinsamen Antrag von KALCHESBRUCK S.A. und
der Gesellschaft durch den Richter des «tribunal d'arrondissement» in Übereinstimmung mit Art. 266 des Gesetzes.
4) Hinterlegung der Unterlagen gemäß Art. 267 des Gesetzes am Gesellschaftssitz der Gesellschaft einen Monat vor
dem Stattfinden der Generalversammlungen der fusionierenden Gesellschaften.
Eine Kopie der unter Punkt 2) und 3) erwähnten Berichte wird dieser Urkunde als Anlage beigefügt.
Nach Feststellung des obigen, fasst die Generalversammlung die folgenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung erklärt Kenntnis von dem Verschmelzungsplans und von dem vorgeschlagenen Erwerb der
Gesellschaft durch die KALCHESBRUCK S.A. zu haben. Die Verschmelzung wird umgesetzt durch die Einbringung aller
Aktiva, Verbindlichkeiten, Rechte, Verpflichtungen und Verträge der Gesellschaft, ohne Ausnahmen und Vorbehalte, an
die KALCHESBRUCK S.A. Die Versammlung stellt fest, dass der Verschmelzungsplan durch den Verwaltungsrat der
Gesellschaft am 28.August 2007 unterzeichnet und im Mémorial C, Nummer 1981 vom 14. September 2007 veröffentlicht
wurde, gemäß Art. 262 des Gesetzes.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, den Verschmelzungsplan der Gesellschaft, wie er im Mémorial C, Nummer 1981
vom 14. September 2007 veröffentlicht wurde, vollständig und ohne Ausnahmen und Vorbehalte zu genehmigen.
Die Generalversammlung beschließt außerdem, die Verschmelzung der Gesellschaft durch den Erwerb der Gesellschaft
durch KALCHESBRUCK S.A. durchzuführen.
Die Generalversammlung beschließt, die Zuordnung aller Aktiva, Verbindlichkeiten, Rechte, Verpflichtungen und Ver-
träge der Gesellschaft an die KALCHESBRUCK S.A. und die Ausgabe und die Bedingungen der Ausgabe von neuen Aktien,
in Übereinstimmung mit dem Austauschverhältnis, wie es im Mémorial C, Nummer 1981 vom 14. September 2007 ver-
öffentlicht wurde und in Übereinstimmung mit der Bilanz, die dem Verschmelzungsplan beigefügt ist, zu genehmigen.
Den Neuen Aktien der Gesellschaft soll das Recht zur Teilnahme an der Ausschüttung von Gewinnen der Gesellschaft
ab dem 1. März 2007 zustehen.
Das Aktionärsregister der KALCHESBRUCK S.A. wird aktualisiert, um die im Rahmen der Verschmelzung erfolgte
Ausgabe der Aktien an die Gesellschaft wiederzuspiegeln.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, im Rahmen der Verschmelzung alle Aktiva, Verbindlichkeiten, Rechte, Verpflich-
tungen und Verträge der Gesellschaft an die KALCHESBRUCK S.A. zu übertragen, als Gegenleistung für die Ausgabe von
dreihundertzehn (310) neuen Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) in der KALCHESBRUCK
S.A. an den Aktionär der Gesellschaft.
Gemäß Art. 266 des Gesetzes hat Herr Jean-Bernard Zeimet, Réviseur d'Entreprises, wohnhaft in 67, rue Michel
Welter, L-2730 Luxemburg, ernannt auf gemeinsamen Antrag von KALCHESBRÜCK S.A. und der Gesellschaft durch den
Richter des «tribunal d'arrondissement» in Übereinstimmung mit Art. 266 des Gesetzes, in seinem schriftlichen Bericht
den Verschmelzungsplan und das Austauschverhälntis von dreihundertzehn (310) Aktien in der Gesellschaft im Austausch
für dreihundertzehn (310) neue Aktien in der KALCHESBRUCK S.A. untersucht.
Der Bericht des unabhängigen Prüfers kommt zu folgender Schlussfolgerung:
«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe
that the share exchange ratio defined in the merger plan is not reasonable and relevant and that the evaluation methods
used to determine the exchange ratio are not adequate and justified in the circumstances.»
Der Bericht wird dieser Urkunde als Anlage beigefügt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung hat festgestellt, dass, ungeachtet der Genehmigung des Verschmelzungsplans durch KAL-
CHESBRUCK S.A., die Gesellschaft ohne Liquidation aufgelöst wird und gemäß Art. 274 des Gesetzes ab dem Tag der
gegenwärtigen Urkunde aufhört, zu existieren.
128427
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung stellt fest, dass die Verschmelzung aus buchhalterischer und steuerlicher Sicht ab dem 1.
März 2007 wirksam ist, unbeschadet der Vorschriften von Art. 273 des Gesetzes hinsichtlich der Wirksamkeit der Ver-
schmelzung gegenüber Dritten.
Dem Verwaltungsrat der Gesellschaft und HRT REVISION S.à r.l., als Rechnungskommissar der Gesellschaft, wird für
die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tage Entlastung erteilt.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar stellt die Existenz und die Rechtmäßigkeit der Urkunden und der Formalitäten, die durch
die Gesellschaft und die KALCHESBRUCK S.A im Hinblick auf die Verschmelzung unterzeichnet worden sind, fest.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der Verschmel-
zung entstehen, werden auf ungefähr eintausendsiebenhundert Euro (1.700,- EUR) geschätzt.
Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, wird die Versammlung geschlossen.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt, dass die vorliegende Urkunde auf
Verlangen der erschienenen Personen auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Wunsch
derselben erschienenen Personen und im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und der deutschen Fassung,
hat die englische Fassung Vorrang.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Munsbach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: F. Tölle, M. Voß, M. Liebe, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 octobre 2007, Relation GRE/2007/4714. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 5 novembre 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007127911/231/245.
(070152811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2007.
Le Palmier S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 63.200.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juillet 2007i>
<i>Résolution n° 1i>
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination en qualité
d'administrateur et administrateur-délégué de Monsieur M'hamed Laghouati né le 16 novembre 1972 à Hayange (France)
et demeurant à F-57290 Fameck, avenue Jeanne d'Arc, 177.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.
<i>Résolution n° 2i>
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination en qualité
d'administrateur et administrateur-délégué de Monsieur Mehdi Laghouati né le 12 mai 1979 à Fameck (France) et de-
meurant à F-57100 Thionville, rue du Souvenir Français, 3.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.
<i>Résolution n° 3i>
Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la démission en qualité d'ad-
ministrateur et administrateur délégué de Monsieur Djamel Demigha né le 10 juin 1971 à Constantine (Algérie) et
demeurant Constantine, rue du 19 juin 1965, 27.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.
128428
Esch-sur-Alzette, le 27 juillet 2007.
Pour extrait sincère et conforme à l'original
FIDUCIAIRE C.G.S.
Signature
Référence de publication: 2007127693/1549/29.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2007, réf. LSO-CH09537. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070147635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2007.
Camberwell S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 127.149.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale tenue en date du 10 octobre 2007 que, ont été nommés Gérants de Catégorie A:
- M. William Lafayette, né le 28 janvier 1971 en Californie, Etats-Unis, ayant son adresse au 200, Glasgow Circle,
Danville, CA 94526, Etats-Unis;
- Mme Melissa Ma, née le 17 juin 1970 au Mississipi, Etats-Unis, ayant son adresse au 2345, Lake Street, San Francisco,
CA 94121, Etats-Unis;
- Mme Laure Wang, née le 14 janvier 1971 à New-York, Etats-Unis, ayant son adresse à Branksome Grande 9B, 3
Tregunter Path, Hong Kong, Chine; et
- Mme Rebecca Xu, née le 2 octobre 1968 à Heilongjiang, Chine, ayant son adresse à The Repulse, 109, Repulse Bay
Road, Hong Kong, Chine.
et Gérants de Catégorie B:
- M. Marcel Stephany, né le 4 septembre 1951, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse
professionnelle au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange;
- M. Luc Sunnen, né le 22 décembre 1961, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse profes-
sionnelle au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg; et
- M. Christophe Fender, né le 10 juillet 1965, à Strasbourg, France, ayant son adresse professionnelle au 62, avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
avec effet à la date de ladite assemblée, en remplacement du gérant suivant, démissionnaire:
- La société CONSEIL & MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.897
Le mandat des nouveaux gérants est à durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
- M. William Lafayette, gérant de catégorie A;
- Mme Melissa Ma, gérant de catégorie A;
- Mme Laure Wang, gérant de catégorie A;
- Mme Rebecca Xu, gérant de catégorie A;
- M. Marcel Stephany, gérant de catégorie B;
- M. Luc Sunnen, gérant de catégorie B; et
- M. Christophe Fender, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 2007.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007127692/799/44.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07612. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070147614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2007.
128429
TDS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 132.695.
STATUTS
L'an deux mille sept, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, lequel aura la garde de la présente minute.
Ont comparu:
1) La société anonyme OFFICE DEVELOPPEMENT S.A., ayant son siège social à 4000 Liège (Belgique), rue de l'hip-
podrome, 186.
2) Monsieur Jean-Marie Onclin, administrateur de sociétés, demeurant à B-4000 Liège (Belgique), 39/51 boulevard
Frère Orban.
Ici représentés par Monsieur Fons Mangen, réviseur d'entreprises, demeurant à Ettelbruck, en vertu de deux procu-
rations sous seing privé lui délivrées
Les dites procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps que lui.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une
société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination.
1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents
statuts.
1.2. La société adopte la dénomination TDS S.A.
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à la Ville de Luxembourg.
Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur du Grand Duché de Luxembourg.
2.2. La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.
2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre
l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'admi-
nistration.
Art. 3. Objet.
3.1 La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour elle-même ou pour le compte
de tiers ou en participation avec des tiers, toutes opérations financières, commerciales, se rapportant a la construction,
la rénovation, l'aménagement de bâtiments de toute nature, et travaux publics et privés.
3.2 La société a également pour objet le commerce de tous métaux et alliages, ainsi que de toutes opérations ou
entreprises commerciales, financières ou immobilières se rapportant directement ou, indirectement à son objet social
ou susceptibles de favoriser ou de développer son industrie ou son commerce.
3.3 Sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, elle pourra acquérir, exploiter, céder tous brevets ou licences;
créer, acquérir, prendre et donner à bail; exploiter et conserver, aliéner de toutes manières tous biens meubles et
immeubles; faire tous contrats de participation, de fusion ou d'alliances avec toutes autres sociétés ou entreprises simi-
laires ou non, sous quelque forme que ce soit; le tout à condition que le but de l'opération soit conforme à l'objet social
ou susceptible de constituer, pour la société, une source, un débouché ou un moyen de se couvrir de ses droits.
3.4 Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou im-
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
3.5 La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser, même indirectement, le développement de son entre-
prise
3.6 L'assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts, a qualité pour interpréter l'étendue
de l'objet social.
3.7 L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du Code des Sociétés, étendre ou modifier l'objet
social.
128430
Art. 4. Durée.
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises pour
une modification statutaire.
Titre II. Capital
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.100,- (trente et un mille cent Euros), divisé en 311
(trois cent onze) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. Nature des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
Art. 7. Cession d'actions. Les parts sociales sont librement cessibles entre actionnaires.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-actionnaire ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné
par décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires statuant à la majorité qualifiée prescrite à l'article 15 ci-après.
Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou un acte sous seing privé.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Titre III. Administration, Direction, Surveillance
Art. 8. Conseil d'administration.
8.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
8.2. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six
ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.
8.3. En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission
ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à
la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Art. 9. Réunions du conseil d'administration
9.1. Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé
par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
9.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
9.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion est prépondérante.
9.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
9.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, ou tout autre moyen de communications électroniques, les
deux derniers étant à confirmer par écrit.
9.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux
séances.
9.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.
Art. 10. Pouvoirs généraux du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus
étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la
loi et les présents statuts à l'assemblée générale.
Art. 11. Délégation de pouvoirs.
11.1. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens
le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
11.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblé générale.
11.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Représentation de la société.
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux
administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.
Art. 13. Commissaire aux comptes.
13.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.
13.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six
années.
Titre IV. Assemblée générale
Art. 14. Pouvoirs de l'assemblée générale.
128431
14.1. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales.
14.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Art. 15. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année à
Liège, à l'endroit indiqué dans les convocations le dernier vendredi de juin à 17.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tient de droit, le premier jour ouvrable suivant à la même heure
Art. 16. Autres assemblées générales. Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assem-
blées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Votes. Chaque action donne droit à une voix.
Titre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 18. Année sociale.
18.1. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
18.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.
Art. 19. Répartition de bénéfices.
19.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
19.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des
bénéfices nets.
19.3. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 20. Dissolution, liquidation.
20.1. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que
celles prévues pour la modification des statuts.
20.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l'assemblée générale des actionnaires.
Titre VII. Disposition générale
Art. 21. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2007.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 311 (trois cent
onze) actions comme suit:
1.- OFFICE DEVELOPPEMENT S.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions
2.- Jean-Marie Onclin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR
31.100,- (trente et un mille cent Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille huit cents Euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:
128432
1.- L'adresse de la société est fixée au L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle de 2013:
a) Monsieur Jean-Marie Onclin, administrateur de sociétés, demeurant à B-4000 Liège (Belgique), 39/51, boulevard
Frère Orban.
b) Monsieur Pierre Dispa, assureur, demeurant à B- 4052 Chaudfontaine (Belgique), 4, allée Léonard Legros.
c) Monsieur Pierre Galand, Ingénieur civil, demeurant à L-1160 Luxembourg, 12, boulevard d'Avranches.
d) Monsieur Jean-François Vryens, administrateur de sociétés, demeurant à B-1200 Woluwe-Saint-Lambert (Belgique),
25/b5, avenue Chapelle-aux-Champs.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
- Monsieur Fons Mangen, réviseur d'entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken.
4.- Est appelé aux fonctions de Président du Conseil d'Administration:
- Monsieur Pierre Galand, Ingénieur civil, demeurant à L-1160 Luxembourg,12, boulevard d'Avranches.
5.- Est appelé Administrateur-Délégué, chargé de la gestion journalière des affaires de la société:
- Monsieur Jean-Marie Onclin, administrateur de sociétés, demeurant à B-4000 Liège (Belgique), 39/51, boulevard Frère
Orban.
6.- L'assemblée autorise le conseil d'administration à attribuer la gestion journalière des affaires de la société à un
directeur.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Mangen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, Relation: LAC/2007/27574. — Reçu 311 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007127545/211/187.
(070146771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
Polaris Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 132.696.
STATUTS
L'an deux mille sept, le treize septembre,
Par devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
A Comparu:
Monsieur Jean-Marc Benker, administrateur de sociétés, né le 5 septembre 1963 à Köln-Ehrenfeld, demeurant à B-1180
Bruxelles, Oude Dieweg 42,
ici représenté par Maître Catherine L'Hote-Tissier, avocat à la Cour, demeurant à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard
Royal, en vertu d'une procuration sous seing privé du 12 septembre 2007, la procuration pré-mentionnée, après avoir
été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte avec lequel elle sera
soumise aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme précisé ci-avant, a requis le notaire de constituer par le présent acte une «société
anonyme» et d'établir ses statuts comme suit:
Titre 1
er
- Dénomination, siège social, objet, durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société anonyme (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, de même que par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).
Art. 2. La dénomination de la Société est POLARIS CONSULTING S.A.
Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par le biais d'une résolution de ses actionnaires délibérant selon la manière déterminée
pour la modification des Statuts.
Le siège social pourra être transféré au sein de la même commune par décision du Conseil d'Administration.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité nor-
male du siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
128433
anormales. Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la Société. Pareille déclaration de transfert
du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.
Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. La Société a pour objet au Luxembourg ou à l'étranger, le conseil aux organisations marchandes et/ou non
marchandes dans les domaines de la gestion qu'elle soit stratégique, tactique, financière, des ressources humaines ou
autres. Ceci comprend, de façon non-exhaustive et à titre d'exemple, les activités telles que le coaching, l'audit social, la
gestion des flux et process des ressources etc.
La Société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales,
des sociétés affiliées ou toute société appartenant au même groupe de sociétés ou dans laquelle elle s'intéresse directe-
ment ou indirectement.
La Société peut emprunter sous toutes les formes.
La Société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement et le développement de son objet.
Titre II.- Capital, actions
Art. 6. Le capital social souscrit lors de la constitution de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,00 €)
divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur de cent euros (100,00 €) chacune.
Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-
sentant deux ou plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres
actions.
Titre III.- Administration
Art. 7. La Société pourra être administrée par un seul administrateur à sa seule discrétion, et ce, tant qu'elle aura un
seul actionnaire.
Dans l'hypothèse où la Société a plusieurs actionnaires, elle sera administrée par trois administrateurs au moins nom-
més par l'assemblée générale. Si plusieurs administrateurs ont été nommés, ils constitueront un conseil d'administration.
Les administrateurs, actionnaires ou non, sont nommés par l'assemblée générale pour un terme ne pouvant dépasser
six années et en tout temps révocables par elle.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des
actionnaires.
Art. 8. Le conseil d'administration choisira un président parmi ses membres.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il
doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Chaque administrateur de la Société peut agir à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique, un autre membre du conseil
d'administration comme son mandataire.
Le conseil d'administration ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est
présente en personne ou par mandataire.
Tout membre du conseil d'administration qui participe à une réunion du conseil d'administration via un moyen de
communication (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du conseil d'adminis-
tration présents à cette réunion (soit en personne, soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication)
d'entendre à tout moment ce membre et permettant à ce membre d'entendre à tout moment les autres membres sera
considéré comme étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé
à voter sur les matières traitées à cette réunion.
Les membres du conseil d'administration qui participent à une réunion du conseil d'administration via un tel moyen
de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du procès-verbal de cette réunion.
128434
Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne,
soit par mandataire à une telle réunion.
Les résolutions circulaires signées par tous les membres du conseil d'administration seront considérées comme étant
valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être ap-
posées sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique.
Art. 9. L'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration est investi des
pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la
Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents Statuts à l'assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Le conseil d'administration est autorisé à payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.
Art. 10. La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature de son administrateur unique ou, en
cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins que des décisions spéciales
concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le conseil d'administration
conformément à l'article 11 des présents Statuts.
Art. 11. L'administrateur unique ou, selon le cas, le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la
Société à un ou plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.
Ils peuvent aussi confier la gestion d'une branche spéciale de la Société à un ou plusieurs directeurs, et donner des
pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses propres
membres ou non, actionnaires ou non.
Art. 12. Tous les litiges dans lesquels la Société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités
au nom de la Société par l'administrateur unique ou, selon le cas, par le conseil d'administration, représenté par son
président ou par l'administrateur délégué à cet effet.
Titre IV.- Surveillance
Art. 13. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale annuelle se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit spécifié dans les
convocations le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale se tiendra
le premier jour ouvrable suivant.
L'administrateur unique ou, selon le cas, le conseil d'administration, pourra, à chaque fois qu'il le jugera utile, convoquer
une assemblée générale extraordinaire.
Art. 15. L'actionnaire unique pourra exercer tous les pouvoirs dont l'assemblée générale des actionnaires est investie
conformément à la section IV paragraphe 5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Toutes décisions prises par le seul actionnaire devront être écrites et consignées dans des procès-verbaux. Elles
devront être conservées dans un registre spécial.
Titre VI.- Année sociale, répartition des bénéfices
Art. 16. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la Société et des amortissements,
constitue le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélè-
vement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son
cours si, à un moment quelconque, pour une cause quelconque, ladite réserve tombe en dessous de dix pour cent (10%)
du capital social.
Le solde du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, liquidation
Art. 18. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la Société est dissoute,
la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale
des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 19. Pour tous les points non réglés par les présents Statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et ses lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commencera à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2007.
128435
<i>Souscription - libérationi>
Les Statuts ayant ainsi été adoptés, la personne ayant comparu déclare souscrire à l'entièreté du capital comme suit:
Monsieur Jean-Marc Benker pré-mentionné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions
Total: trois cent dix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions
Les actions ont été entièrement libérées par un apport en espèces de trente et un mille euros (31.000,00 €) et ce
montant est par conséquent à la disposition de la Société à partir de ce moment, tel qu'il a été certifié au notaire instru-
mentaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée ultérieurement ont été observées.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ 1.600,00 €.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L'actionnaire pré-mentionné, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué
s'est ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, il a pris à l'unanimité les résolutions
suivantes:
1) Le siège social de la Société est fixé au L-2557 Luxembourg, 7a, rue Robert Stümper.
2) La Société sera administrée par un administrateur unique. A été nommé comme administrateur:
- Monsieur Jean-Marc Benker, administrateur de sociétés, né le 5 septembre 1963 à Köln-Ehrenfeld, demeurant à
B-1180 Bruxelles, Oude Dieweg 42,
3) Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un (1). A été nommé comme commissaire aux comptes:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, réviseur d'entreprises, demeurant à L-5429 Greiveldange, 1, Hettermillen.
4) Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes se termineront lors de l'assemblée générale
annuelle statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2010.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,
état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. L'Hote-Tissier, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2007. LAC/2007/26602. Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 18 octobre 2007.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007127546/212/174.
(070146772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
TONDELINOX Production de pièces inox, unipersonnelle LDA, succursale de Luxembourg, Succursale
d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-9753 Heinerscheid, 1, Cité Hueserknapp.
R.C.S. Luxembourg B 132.769.
OUVERTURE DE SUCCURSALE
Décisions de l'associé
<i>Ordre du jouri>
Décision de l'ouverture d'une succursale au Luxembourg
<i>Première résolutioni>
L'associé unique de la société TONDELINOX PRODUCTION DE PIECES INOX, UNIPERSONNELLE LDA société
de droit portugais, avec siège à Canas de Santa Maria (P), décide de créer une succursale au Luxembourg. Cette succursale
reprendra les caractéristiques suivantes:
1. Dénomination de la succursale: TONDELINOX PRODUCTION DE PIECES INOX, UNIPERSONNELLE LDA,
succursale de Luxembourg.
128436
2. Adresse de la succursale: L-9753 Heinerscheid, Cité Hueserknapp 1
3. Indication des activités de la succursale: La succursale aura comme activités: la commercialisation et installation de
pièces en inox et autres matériaux.
4. Nom et adresse de la personne responsable de la succursale: Monsieur Armando Cabral Pinheiro, demeurant au
Portugal à Canas de Santa Maria - Tondela, Largo da Fareleira, 82
5. Est nommé: Gérant Administratif Monsieur Gomes De Figueiredo Luis Manuel, né à Tondela le 9 novembre 1971,
demeurant à L-9753 Heinerscheid, Cité Hueserknapp 1.
6. Date d'ouverture de la succursale: 1
er
novembre 2007
<i>TONDELINOX - PRODUÇÃO DE PEÇAS INOX, UNIPESSOAL, LDA
i>A. Cabral Pinheiro
<i>A Gerênciai>
Reconheço a assinatura no présente documento, escrito em lingua francesa, cujo conteúdo entendo, de Armando
Cabral Pinheiro, feita pelo próprio na minha presença, pessoa cuja identidade verifiquei pela exibição do B.l. n.° 2458530
de 16.041998, emitido pelos SIC de Lisboa, na qualidade de sócio e gerente da sociedade TONDELINOX - PRODUÇÃO
DE PEÇAS INOX, UNIPESSOAL, LDA, com sede no Largo da Fareleira, 82, Canas de Santa Maria, Tondela, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Tondela sob o número único de matricula e de pessoa colectiva 506 992 640,
com poderes para o acto, conforme certidão permanente, que visualizei hoje, pelas 12h.
Tondela e Cartório Notarial de Maria Manuela De Figueiredo Almeida, 19 de Outubro de 2007.
O Colaborador da notária, devidamente autorizado para este acto, João Agostinho Barros De Jesus,
Signature
Conta registada sob o n° 2924
Référence de publication: 2007128181/591/41.
Enregistré à Diekirch, le 24 octobre 2007, réf. DSO-CJ00181. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070147870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2007.
Europarticipations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 42.226.
En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé
au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007128165/8202/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08385. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070148166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2007.
Skype Communications, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 100.468.
EXTRAIT
Il résulte de la lettre de M. Niklas Zennström en date du 28 septembre 2007, que M. Niklas Zennström a donné
démission de son mandat de gérant de la Société avec effet au 28 septembre 2007.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
128437
Luxembourg, le 19 octobre 2007.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007127690/1092/18.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07259. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070147556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2007.
Infrastructure Creation Company S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 66.992.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 octobre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007127921/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2007, réf. LSO-CJ05863. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070147341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2007.
Akemis Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 132.126.
EXTRAIT
Il résulte de la décision prise par le gérant de la Société en date du 5 octobre 2007 que le siège social de la Société est
fixé au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
En outre l'adresse professionnelle du gérant unique de la Société a été transférée au 1, rue des Glacis, L-1628 Lu-
xembourg.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007127445/2460/18.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2007, réf. LSO-CJ06340. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070146697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2007.
Millenium Diamond Services Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 66.566.
DISSOLUTION
In the year two thousand and seven, on the twenty-eighth of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appeared:
Mr Pierre-Yves Champagnon, employee, residing professionally in Luxembourg;
«the proxy»
acting as a special proxy of the company MILLENIUM DIAMOND HOLDINGS S.A., with registered office in L-1520
Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, RCS Luxembourg B 66.565;
«the mandator»
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and
the undersigned notary, will be registered with this minute.
The proxy declared and requested the notary to act:
128438
I.- That the société anonyme MILLENIUM DIAMOND SERVICES INVESTMENTS S.A., having its head office in L-1520
Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B
number 66.566, has been incorporated by deed enacted on the 24th of September 1998, published in the Mémorial C
number 904 of the 15th of December 1998.
II.- That the subscribed share capital of the société anonyme MILLENIUM DIAMOND SERVICES INVESTMENTS S.A.
amounts currently to USD 240,000.- (two hundred forty thousand US Dollars) represented by 24,000 (twenty-four
thousand) shares with no par value, fully paid up in cash.
III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of
MILLENIUM DIAMOND SERVICES INVESTMENTS S.A.
IV.- That the mandator acquired all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares
explicitly to proceed with the dissolution of the said company.
V.- That the mandatory, as liquidator, declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets,
liabilities and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is
terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.
VI.- That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
VII.- That the mandator fully discharges the board of directors, statutory auditor and managers for their mandate up
to this date.
VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of MAITLAND
LUXEMBOURG S.A., with registered office in L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read, the above mentioned proxy holder signed with Us, the notary, the present
original deed.
Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text
will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte
anglais fait foi:
L'an deux mille sept, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Pierre-Yves Champagnon, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg;
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société MILLENIUM DIAMOND HOLDINGS S.A., ayant son siège
social à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, RCS Luxembourg B 66.565;
«le mandant»
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que la société anonyme MILLENIUM DIAMOND SERVICES INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1520
Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous
le numéro 66.566, a été constituée suivant acte reçu le 24 septembre 1998, publié au Mémorial C numéro 904 du 15
décembre 1998.
II.- Que le capital social de la société anonyme MILLENIUM DIAMOND SERVICES INVESTMENTS S.A., prédésignée,
s'élève actuellement à USD 240.000,- (deux cent quarante mille US Dollars), représentés par 24.000 (vingt-quatre mille)
actions sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées en numéraire.
III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société
MILLENIUM DIAMOND SERVICES INVESTMENTS S.A.
IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire
unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend
à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation
de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs
de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
128439
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux MAITLAND
LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P-Y. Champagnon, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2007, Relation: LAC/2007/29277. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007130304/211/83.
(070150593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.
Millenium Diamond Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 66.565.
DISSOLUTION
In the year two thousand and seven, on the twenty-eighth of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appeared:
Mr Pierre-Yves Champagnon, employee, residing professionally in Luxembourg;
«the proxy»
acting as a special proxy of the company MDS GROUP HOLDINGS LIMITED, with registered office at 9 Columbus
Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands and registered under 263 473 towards the
Registrar of Companies of the British Virgin Islands;
«the mandator»
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and
the undersigned notary, will be registered with this minute.
The proxy declared and requested the notary to act:
I.- That the société anonyme MILLENIUM DIAMOND HOLDINGS S.A., having its head office in L-1520 Luxembourg,
6, rue Adolphe Fischer, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 66.565,
has been incorporated by deed enacted on the 24th of September 1998, published in the Mémorial C number 902 of the
14th of December 1998.
II.- That the subscribed share capital of the société anonyme MILLENIUM DIAMOND HOLDINGS S.A. amounts
currently to USD 840,000.- (eight hundred forty thousand US Dollars) represented by 84,000 (eighty-four thousand)
shares with no par value, fully paid up in cash.
III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of
MILLENIUM DIAMOND HOLDINGS S.A.
IV.- That the mandator acquired all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares
explicitly to proceed with the dissolution of the said company.
V.- That the mandatory, as liquidator, declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets,
liabilities and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is
terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.
VI.- That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
VII.- That the mandator fully discharges the board of directors, statutory auditor and managers for their mandate up
to this date.
VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of MAITLAND
LUXEMBOURG S.A., with registered office in L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read, the above mentioned proxy holder signed with Us, the notary, the present
original deed.
Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text
will prevail.
128440
Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte
anglais fait foi:
L'an deux mille sept, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Pierre-Yves Champagnon, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg;
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société MDS GROUP HOLDINGS LIMITED, ayant son siege social
à 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands et enregistrée sous le numéro
263 473 au «Registrar of Companies of the British Virgin Islands»;
«le mandant»
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que la société anonyme MILLENIUM DIAMOND HOLDINGS S.A., ayant son siège social à L-1520 Luxembourg,
6, rue Adolphe Fischer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro
66.565, a été constituée suivant acte reçu le 24 septembre 1998, publié au Mémorial C numéro 902 du 14 décembre
1998.
II.- Que le capital social de la société anonyme MILLENIUM DIAMOND HOLDINGS S.A., prédésignée, s'élève ac-
tuellement à USD 840.000,- (huit cent quarante mille US Dollars), représentés par 84.000 (quatre-vingt-quatre mille)
actions sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées en numéraire.
III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société
MILLENIUM DIAMOND HOLDINGS S.A.
IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire
unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend
à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation
de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation, du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs
de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux MAITLAND
LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P.-Y. Champagnon, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2007, Relation: LAC/2007/29278. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007130307/211/85.
(070150597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.
EcoLive S.A., Société Anonyme,
(anc. United Minds).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.909.
In the year two thousand seven, on the twelfth of October.
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg.
Was held:
an extraordinary general meeting of shareholders of UNITED MINDS, a société anonyme having its registered office
in L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register
under number B 123.909, incorporated pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen, then notary residing in Lux-
128441
embourg, on December 22, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 523 of April
3, 2007.
The articles of incorporation of the company have been amended for the last time pursuant to a deed of the same
notary dated March 30, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1284 of June
27, 2007.
The meeting is opened at 9.30 a.m. with Mr Noël Didier, private employee, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
in the chair,
who appointed as secretary Mrs Claire Adam, private employee, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Jacques Bonnier, private employee, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requests the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
- Modification of the name of the company into EcoLive S.A. and related amendment of article 1 of the Articles of
Association.
II.- That the present or represented shareholders, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxy holders of the represented share-
holders and by the board of the meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
The proxies of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been initialled
ne varietur by the persons appearing.
III.- That the whole share capital being present or represented at the present meeting, no convening notices were
necessary, the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the
agenda prior to this meeting.
IV.- That the present meeting representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolution:
<i>Resolutioni>
The general meeting resolves to change the company's name into EcoLive S.A.
As a consequence, article 1 of the articles of incorporation will henceforth read as follows:
« Art. 1. Name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of EcoLive S.A. (the
Company).»
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at one thousand euro (EUR 1,000.-).
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, at the registered office of company, at the date named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearers and in case of divergences
between the English and the French texts, the English text will prevail.
After reading and interpretation to the appearers, the said appearers signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le douze octobre.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNITED MINDS, ayant son siège social
à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 123909, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 22 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 523 du
3 avril 2007.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu par le même notaire en date du 30 mars 2007,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1284 du 27 juin 2007.
L'assemblée est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, 10, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg,
128442
qui désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Lu-
xembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
- Changement de la dénomination de la société en EcoLive S.A. et modification subséquente de l'article 1
er
des statuts
de la société.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en EcoLive S.A.
En conséquence, l'article 1
er
des statuts de la société aura désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société anonyme sous la dénomination de EcoLive S.A. (la Société).».
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ mille euros (EUR 1.000,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: N. Didier, C. Adam, J. Bonnier, J. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, LAC/2007/31722. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Sandt.
Pour expédition conforme délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2007.
J. Baden.
Référence de publication: 2007130285/7241/108.
(070150430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.
Société Immobilière Le Domicile S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 128, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 38.324.
<i>Protokoll über eine außerordentliche Gesellschafterversammlung am 16. Oktober 2007i>
<i>in 6, rue J.P. Ledure L-5620 Mondorf-Les-Bains um 14.00 Uhri>
Unter Verzicht auf alle Frist- und Formschriften versammelten sich die Gesellschafter Herr H.C. Paquet und Herr J.
Hongisto, beide zusammen vertreten 100% der Gesellschaftsanteile der LE DOMICILE S.A. zu einer Sitzung.
Zum Vorsitzenden wurde Herr Juha Hongisto und zum Sekretär Herr H.C. Paquet gewählt.
Es wurden folgendes beschlossen:
128443
Der Sitz der Firma SOCIETE IMMOBILIERE LE DOMICILE S.A. wird von 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-
Hamm nach 128, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg geändert.
Neue Adresse der Firma
LE DOMICILE S.A. ist also 128, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
Da keine weiteren Tagesordnungspunkte vorhanden waren, schloss der Vorsitzender Herr Juha Hongisto die Sitzung
um 14.30 Uhr.
Luxemburg, den 16. Oktober 2007.
Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzender / Sekretäri>
Référence de publication: 2007129676/5895/24.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10216. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070149852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
Toxon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 67.116.
Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signature
Référence de publication: 2007129609/805/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09219. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070149394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
Sia World S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 86.638.
Le bilan au 31 décembre 2006 et les annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007129588/317/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2007, réf. LSO-CJ09654. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070149427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
Bahnhof Holdings A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 36.278.
Le bilan au 31 décembre 2006 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007129587/317/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09266. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070149425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
128444
Fingroup S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 24.860.
Le bilan et annexes au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007129586/317/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09272. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070149423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
Viking River Cruises S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 56.479.
Le bilan au 31 décembre 2006 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007129585/317/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09265. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070149422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
PET Packaging S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 145.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 119.812.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
B. Zech.
Référence de publication: 2007129582/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09522. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070149419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
Fime S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 82.753.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIME S.A.
Signature
Référence de publication: 2007129580/724/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09519. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070149417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
128445
CIFI, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 12.867.
Le bilan au 31 décembre 2006 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007129590/317/13.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2007, réf. LSO-CJ09656. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070149430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
Nol S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 106.388.
Le bilan au 31 août 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2007.
<i>Pour NOL S.à r.l.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Référence de publication: 2007129592/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08125. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070149434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
Caesar Finance 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 75.583.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2007.
<i>Pour CAESAR FINANCE 2000 S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Référence de publication: 2007129593/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08128. - Reçu 46 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070149435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
Docu Group (Lux 3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.102.300,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 106.711.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
128446
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007129579/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09518. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070149416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
L.S. S.A., Logistic Strategies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 90.433.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2007.
<i>Pour LOGISTIC STRATEGIES S.A. (L.S. S.A.)
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Référence de publication: 2007129595/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08131. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070149436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
Oeko-Service Luxemburg (O.S.L.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7738 Colmar-Berg, Piret Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 34.560.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007129578/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08660. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070149597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
Kass, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 4, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 90.733.
Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2007.
Référence de publication: 2007129577/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08750. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070149596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
Immo-Lux Transport, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
R.C.S. Luxembourg B 61.610.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
128447
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007129576/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ03781. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070149595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
Captiva Capital Partners II S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 110.556.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2007.
M. Torbick
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007129597/710/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2007, réf. LSO-CG11113. - Reçu 44 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070149439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
Globus-CMS S.A., Globus Consulting And Management Services, Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 38.260.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007129574/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08709. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070149593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
Vilient Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 103.235.
Les comptes annuels au 30 juin 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2007.
<i>VILIENT CONSULTING S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature
Référence de publication: 2007129572/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2007, réf. LSO-CJ03889. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070149613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
128448
Akemis Holding S.à.r.l.
All-Sport International Holding S.A.
Almafin S.A.
Automotive Components Europe S.A.
Bahnhof Holdings A.G.
Berenberg Euro Strategie Aktien Fonds VI
Blacksmith Holding S.A.
Blacksmith Holding S.à r.l.
Caesar Finance 2000 S.A.
Camberwell S.à r.l.
Captiva Capital Partners II S.C.A.
CIFI
Docu Group (Lux 3) S.à r.l.
EcoLive S.A.
Europarticipations S.A.
Fime S.A.
Fingroup S.A.
Fontanina Holding S.A.
Gef Real Estate Holding
Globus Consulting And Management Services
Immo-Lux Transport
Infrastructure Creation Company S.à.r.l.
Kalchesbrück NewCo S.A.
Kalchesbruck S.A.
Kass
Le Palmier S.A.
Logistic Strategies S.A.
Media Management S.A.
Mena Holdings S.A.
Millenium Diamond Holdings S.A.
Millenium Diamond Services Investments S.A.
Nol S.à r.l.
Oakwood Global Finance S.C.A.
Oeko-Service Luxemburg (O.S.L.) S.A.
PET Packaging S.à r.l.
Polaris Consulting S.A.
Sia World S.A.
Skype Communications
Société Immobilière Le Domicile S.A.
Sports Group Development S.A.
TDS S.A.
The Modern Funds
TONDELINOX Production de pièces inox, unipersonnelle LDA, succursale de Luxembourg
Toxon S.A.
United Minds
Viking River Cruises S.A.
Vilient Consulting S.A.