logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2490

2 novembre 2007

SOMMAIRE

Advent Mango 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119506

Arrecife S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119478

Articvision S.A. Holding  . . . . . . . . . . . . . . . .

119478

Ausilco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119482

Balbo Investment Holding S.A.  . . . . . . . . . .

119484

Barbican S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119479

BC International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119482

Binola S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119487

Bluesky Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119479

Bond Capital Partners (Luxembourg) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119488

Bordeaux Participations  . . . . . . . . . . . . . . . .

119481

CACEIS Bank Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

119486

Cemex Capital Investments S.à r.l.  . . . . . .

119487

Compagnie de Promotion des Investisse-

ments Européens S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

119479

Compagnie Financière de l'Occitanie  . . . .

119480

D-Sign Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119485

EHAG European Industrial Holding A.G.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119476

Electro-Stugalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119482

Ernst August Carree II S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

119486

Ernst August Carree S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

119498

Ernst August Carree S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

119486

Estaima S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119477

Even Germany Zwei S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

119508

Finbourg Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119474

Fiparind  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119487

FO DBH S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119481

France Outlet Mall Holding (No.2) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119474

Frank's Mexico Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . .

119500

Gerinter S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119478

Gerthoma Number Two S.A.  . . . . . . . . . . .

119480

Glenbrook S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119475

G.M. Aviation Services . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119475

Great American Stores B  . . . . . . . . . . . . . . .

119486

Haddington S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119476

Hazel Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119477

Helvoet Pharma International S.A.  . . . . . .

119519

HLC S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119484

H.N.L. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119483

Hosei Gijuku Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .

119483

Hydromot Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119476

Jourdain S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119475

Karat S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119485

Limpertsberg Real Estate Company S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119474

Louisiane S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119477

Maddiston S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119485

Massilia Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119479

Masthead  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119483

Rheinisch-Luxemburger Immobilien A.G.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119477

Rheinlanddamm II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

119487

Rubia S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119481

Sibelga S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119476

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka I Al-

pha S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119485

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka III

Gamma S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119481

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka IV

Delta S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119484

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka IV

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119484

Sivry S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119478

Société Financière de Nolay S.A.  . . . . . . . .

119474

Société Internationale d'Investissements

Financiers Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119480

Sprumex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119475

Strategy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119520

Stryker Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

119480

Unity Media S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119500

Unity Media S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119515

Virgilate Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119487

119473

Finbourg Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 56.512.

EXTRAIT

L'adresse professionnelle de Monsieur Armand Haas, administrateur de la société FINBOURG FINANCE S.A., a été

transférée  au,  2,  avenue  Charles  De  Gaulle,  Espace  Pétrusse,  «Le  Dôme»,  L-1653  Luxembourg  et  ce,  à  partir  du  3
septembre 2007.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2007118492/635/16.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2007, réf. LSO-CI09290. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070135754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Société Financière de Nolay S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 38.408.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007118613/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2007, réf. LSO-CJ00937. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Limpertsberg Real Estate Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 35.078.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007118615/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2007, réf. LSO-CJ00935. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

France Outlet Mall Holding (No.2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M.Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 104.661.

Les comptes annuels au 31 mars 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FRANCE OUTLET MALL HOLDING (NO.2) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007118629/267/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2007, réf. LSO-CI01158. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

119474

Sprumex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 40.666.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007118616/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2007, réf. LSO-CJ00934. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070135630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Jourdain S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 4, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 73.026.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Référence de publication: 2007118657/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 3 octobre 2007, réf. DSO-CJ00027. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070135873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Glenbrook S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 125.184.

EXTRAIT

En date du 20 septembre 2007, l'Associé unique a pris la résolution suivante:
- Melle Sandra Calvaruso, avec adresse professionnelle au 65, avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg, est élue nouveau

gérant de la société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2007118926/724/17.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI10006. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070136560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

G.M. Aviation Services, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 33.610.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007118618/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2007, réf. LSO-CJ00928. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

119475

Sibelga S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 23.151.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007118620/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2007, réf. LSO-CJ00922. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070135621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

EHAG European Industrial Holding A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 98.656.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007118617/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2007, réf. LSO-CJ00932. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Hydromot Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 14.680.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Référence de publication: 2007118658/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 3 octobre 2007, réf. DSO-CJ00026. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070135872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Haddington S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 125.176.

EXTRAIT

En date du 20 septembre 2007, l'Associé unique a pris la résolution suivante:
- Melle Sandra Calvaruso, avec adresse professionnelle au 65, avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg, est élue nouveau

gérant de la société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2007118954/724/17.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI10011. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070136573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

119476

Rheinisch-Luxemburger Immobilien A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 67.152.

Le bilan au 30 novembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2007.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007118635/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2007, réf. LSO-CI06412. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070135686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Louisiane S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 20.626.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007118622/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2007, réf. LSO-CJ00917. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Hazel Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 79.207.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2007.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Référence de publication: 2007118655/696/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2007, réf. LSO-CJ02051. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Estaima S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 4.559.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2007.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007118662/550/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI10211. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

119477

Gerinter S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 8.759.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2007.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007118664/550/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI10215. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070135903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Sivry S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 18.252.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007118623/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2007, réf. LSO-CJ00915. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Articvision S.A. Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 98.836.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2007.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007118663/550/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI10216. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Arrecife S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 94.457.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2007.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007118665/550/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI10207. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

119478

Massilia Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 82.366.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2007118678/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2007, réf. LSO-CJ02010. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070135551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Compagnie de Promotion des Investissements Européens S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 34.188.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2007.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007118666/550/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI10189. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Barbican S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 56.731.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2007.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007118667/550/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI10191. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Bluesky Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 24.800.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007118624/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2007, réf. LSO-CJ00912. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

119479

Gerthoma Number Two S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 58.358.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007118625/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2007, réf. LSO-CJ00910. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070135611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Compagnie Financière de l'Occitanie, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 20.715.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007118626/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2007, réf. LSO-CJ00909. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Société Internationale d'Investissements Financiers Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 39.052.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>SOCIETE INTERNATIONALE D'INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.à.r.l., Société à responsabilité limitée
Le Conseil de gérance
N. Rehm / A. Robillard
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2007118630/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2007, réf. LSO-CJ01897. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Stryker Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 109.153.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>STRYKER LUXEMBOURG S.à R.L.
Signature / Signature
<i>Gérant de Cat A / Gérant de Cat B

Référence de publication: 2007118640/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2007, réf. LSO-CJ01394. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

119480

FO DBH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4772 Pétange, 41B, rue de la Piscine.

R.C.S. Luxembourg B 81.822.

Le bilan au 30 avril 2002 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007119210/317/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2007, réf. LSO-CJ00575. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070136305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka III Gamma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 120.512.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007119130/8019/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2007, réf. LSO-CI08539. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070137216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Rubia S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 86.579.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2007118679/50/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2007, réf. LSO-CJ02003. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Bordeaux Participations, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 50.734.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2007118681/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2007, réf. LSO-CJ01996. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

119481

BC International, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 90.201.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 juillet 2007

Est nommée administrateur,
- Monsieur Carlos Pereira, banquier d'affaires, demeurant à 39, Chemin Charles-Poluzzi, CH-1227Carouge.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 26 juillet 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007118701/534/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2007, réf. LSO-CH02912. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070135866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Electro-Stugalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 82.240.

<i>Extrait des délibérations du Conseil d'administration tenu le 17 juillet 2007

Le Conseil d'administration décide de nommer Monsieur Fernand Hemmen, né le 14 octobre 1958 à Luxembourg,

demeurant 19, rue des Violettes à L-8023 Strassen comme Président du Conseil d'administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007119040/280/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2007, réf. LSO-CI08804. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070136849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Ausilco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 51.312.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 7 août 2007

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2007 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

Mme Silvana Lucchini, directrice de sociétés, demeurant à Brescia (Italie), président et administrateur-délégué;
MM Augusto Mensi, administrateur de sociétés, demeurant à Brescia (Italie), administrateur.

Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A. 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conformé
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007118725/24/24.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2007, réf. LSO-CI09346. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070136135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

119482

Hosei Gijuku Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 74.824.

Constituée par-devant M 

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, et maintenant à Luxembourg en date

du 17 février 2000, acte publié au Mémorial C n 

o

 474 du 5 juillet 2000. Modifiée par-devant le même notaire en

date du 29 mars 2001, acte publié au Mémorial C n 

o

 1042 du 21 novembre 2001, en date du 21 août 2001, acte

publié au Mémorial C n 

o

 196 du 5 février 2002, et en date du 1 

er

 décembre 2006, acte publié au Mémorial C n 

o

172 du 13 février 2007.

Le bilan au 31 mars 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour HOSEI GIJUKU LUXEMBOURG S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007119377/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2007, réf. LSO-CJ01097. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070136378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Masthead, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 94.108.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2007118680/50/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2007, réf. LSO-CJ02001. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070135546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

H.N.L. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 38.888.

Constituée par-devant M 

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 12 décembre 1991, acte publié

au Mémorial C n 

o

 218 du 23 mai 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 juin 1994, acte publié

au Mémorial C n 

o

 435 du 5 novembre 1994 et en date du 14 janvier 1998, acte publié au Mémorial C n 

o

 486 du

2 juillet 1998. Le capital a été converti en Euros par acte sous seing privé le 21 décembre 2001, publié par extrait
au Mémorial C n 

o

 749 du 16 mai 2002. Les statuts ont été modifiés par-devant M 

e

 Henri Hellinckx, notaire de

résidence à Mersch, en date du 26 mars 2003, acte publié au Mémorial C n 

o

 443 du 23 avril 2003.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour H.N.L. S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007119361/29/20.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2007, réf. LSO-CJ01070. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070136408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

119483

HLC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 107.702.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2007118682/50/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2007, réf. LSO-CJ01994. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070135543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 120.509.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007119133/8019/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2007, réf. LSO-CI08536. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070137203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka IV Delta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 120.513.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007119134/8019/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2007, réf. LSO-CI08534. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070137197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Balbo Investment Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 78.638.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2007.

<i>Pour BALBO INVESTMENT HOLDING SA
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007119155/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2007, réf. LSO-CJ01489. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070136817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

119484

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka I Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 120.510.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007119136/8019/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2007, réf. LSO-CI08559. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070137191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

D-Sign Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, Zone Artisanale Economique Régionale Op der Hei.

R.C.S. Luxembourg B 81.475.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 5 septembre 2007, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Capellen, le 13 septembre 2007.

C. Mines
<i>Notaire

Référence de publication: 2007119154/225/12.
(070128673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Karat S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.500,00.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 80.634.

Die Bilanz per 31. Dezember 2006 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Oktober 2007.

Unterschrift.

Référence de publication: 2007119219/534/13.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2007, réf. LSO-CJ00232. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070136269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Maddiston S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 125.183.

EXTRAIT

En date du 20 septembre 2007, l'Associé unique a pris la résolution suivante:
- Melle Sandra Calvaruso, avec adresse professionnelle au 65, avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg, est élue nouveau

gérant de la société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2007118970/724/17.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI10016. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070136650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

119485

Ernst August Carree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 130.430.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2007.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2007119191/5770/12.
(070137183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

CACEIS Bank Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 91.985.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 8 mars 2007

Le Conseil d'Administration qui s'est réuni à la date du 8 mars 2007 décide de nommer le Cabinet ERNST &amp; YOUNG

en tant réviseur de l'entreprise au titre de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 9 mars 2007.

Pour extrait conforme
J.-P. Valentini
<i>Secrétaire Général

Référence de publication: 2007119037/1024/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2007, réf. LSO-CI09608. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070136941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Ernst August Carree II S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 130.064.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2007.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2007119194/5770/12.
(070136923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Great American Stores B, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 122.663.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
PKF WEBER ET BONTEMPS
Signatures

Référence de publication: 2007120116/592/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2007, réf. LSO-CJ02807. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070137296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

119486

Fiparind, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 101.376.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007119196/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2007, réf. LSO-CJ00223. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070136255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Rheinlanddamm II S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 130.575.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2007.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2007119197/5770/12.
(070136921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Binola S.A., Société Anonyme Soparfi,

(anc. Virgilate Holding S.A.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 35.402.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 28 septembre 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007119232/239/13.
(070136736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Cemex Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 115.772.340,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 96.895.

Le siège social du gérant de la Société, la société CEMEX LUXEMBOUG HOLDINGS Sàrl a été transféré, avec effet

au 2 août 2007, du L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, au L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

Le siège social du commissaire aux comptes, OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL Sàrl a été transféré, avec effet

au 1 

er

 juin 2007, du L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, au L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au Registre de Commerce

et des Sociétés.

Luxembourg, le 18 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007119043/280/17.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2007, réf. LSO-CI08798. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070136839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

119487

Bond Capital Partners (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 132.224.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the twenty-second day of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appear:

BOND CAPITAL PARTNERS I LIMITED, a company incorporated under the laws of Bermuda, having its registered

office at Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton, here duly represented by Hubert Janssen, jurist, residing profes-
sionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to this present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party in the capacity of which it acts has requested the notary to draw up the following articles of

incorporation (the «Articles») of a «société anonyme» which such party declares to incorporate.

Name - purpose - registered office - duration

Art. 1. There is hereby formed a «société anonyme», public company limited by shares (the «Company») governed

by the Articles and by the current Luxembourg laws (the «Law»), in particular the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended.

Art. 2. The Company's name is BOND CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A.

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations,
contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company which belong to the same group of companies than the Company any assistance, loans, advances or guarantees;
to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg, by decision of the board of directors.
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case
may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

The Company may have offices and branches (whether or not within a permanent establishment), both in Luxembourg

and abroad.

In the event that the board of directors should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of directors of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or the sole shareholder.

Capital - shares

Art. 7. The Company's issued share capital is set at EUR 32,000.- (thirty-two thousand euros), represented by 3,200

(three thousand two hundred) shares with a nominal value of EUR 10.- (ten euros) each.

119488

The amount of the issued share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general

meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amend-
ment of the Articles.

The authorised share capital of the Company is set at EUR 132,000.- (one hundred thirty-two thousand euros), rep-

resented by 13,200 (thirteen thousand two hundred) shares with a nominal value of EUR 10.- (ten euros) each.

The  board  of  directors  is  authorized,  during  a  period  expiring  5  (five)  years  after  the  publication  of  the  deed  of

incorporation of the Company in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to increase in one or several
times the share capital as long as the issued share capital resulting from such increases remains equal or inferior to this
threshold of EUR 132,000.- (one hundred thirty-two thousand euros).

Such increased amount of capital may be subscribed for and issued against payment in cash or contribution in kind by

observing the then applicable legal requirements or by way of allocation of available reserves, profit carried forward or
share premium and into the share capital, in each case at an issue price determined by the board of directors from time
to time.

The board of directors may delegate to any authorized director or officer of the Company or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the shares representing part or all of
such increased amount of capital.

Upon each increase of the share capital of the Company by the board of directors within the limits of the authorized

capital, the first paragraph of article seven of the articles of association shall be amended accordingly and the board of
directors shall take or authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and
publication of such amendment.

Shares to be subscribed for in cash shall be offered on a pre-emptive basis to shareholders in the proportion of the

capital represented by their shares.

If several class of shares have been issued and the shares issued belong to one class only, the general shareholder

meeting may restrict the preemption right to the holder of such class only or grant the preemptive right to the holders
of shares of other class only after that right has been exercised by the holders of the shares of the class in which the new
shares are issued.

Within the limits of the authorized share capital the board of directors may decide to withdraw or limit the preemption

rights of the shareholders.

Art. 8. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his share-

holding.

Art. 9. The shares are freely transferable.
The shares shall be in registered form only. A register of shareholders shall be kept by the Company and shall contain,

at least, the precise identification of each shareholder, the number of his shares and, if applicable, their transfer and the
date of transfer.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

Art. 10. The Company shall have power to redeem its own shares under the conditions stated in the Law.

Management - supervision

Art. 11. The Company will be managed by a board of directors composed of at least three directors. In such a case,

the Board of Directors is composed by at least one class A director and at least one class B director.

However, when all the shares of the Company are held by a sole shareholder, the board of directors may be formed

with a single director under the conditions stated in the Law. The director(s) need not be shareholders of the Company.

When a legal person is appointed as a member of the board of directors, such legal person shall inform the Company

of the name of the individual that it has appointed to serve as its permanent representative in the exercise of its mandate
of director of the Company.

The director(s) shall be appointed, and his/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of

shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration
of the director(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The director(s) are re-eligible.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum,

remove and replace any director.

In case of vacancy in the office of director by reason of death or resignation of a director or otherwise, the remaining

directors may, by way of cooptation, elect another director to fill such vacancy until the next shareholders meeting in
accordance with the Law.

The term of the office of the director(s) which shall not exceed six years, is fixed by the general meeting of the

shareholders or by the decision of the sole shareholder.

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the Company's purpose. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of share-
holders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of directors.

119489

In dealing with third parties, the board of directors will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose and provided
the terms of these Articles shall have been complied with.

The day-to-day management of the business of the Company and the power to represent the Company with respect

thereto may be delegated to one or more directors, officers, managers, and/or agents, who need not be shareholders of
the Company. The delegation in favour of a member of the board of directors is subject to the prior authorization of the
general meeting of shareholders.

The Company will be bound by the joint signatures of any class A director and class B director, should the Board of

the Company be composed of at least 3 directors or by the single signature of the Company's single director.

The board of directors may from time to time sub-delegate its/his powers for specific tasks to one or several ad hoc

agent(s) who need not be shareholder(s) or director(s) of the Company.

The board of directors will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the

period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 12. The board of directors shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not

have a casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of directors. In case of absence of the chairman,
the board of directors shall be chaired by a director present and appointed for that purpose. The board of directors may
also appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings
of the board of directors or for other matters as may be specified by the board of directors.

The board of directors shall meet when convened by one director.
Notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least 2 (two) days in advance of the

time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the
meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each director by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram or telex, electronic means or by any

other suitable communication means, of each director.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic

means another director as his proxy.

A director may represent more than one director.
Any meeting of the board of directors shall take place in the Grand Duchy of Luxembourg and shall require at least

the presence of half of the directors, either present in person or by representative, which shall form a quorum.

According to article 64bis (3) of the Law, the directors may participate in a meeting of the board of directors by phone,

videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing for their identification.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the directors.
Decisions of the board of directors are taken by the majority of directors participating to the meeting or duly repre-

sented thereto.

The deliberations of the board of directors shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or, if applicable, by his substitute, or by two directors present at the meeting. The proxies will remain attached to the
board minutes. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two directors.

In case of emergency, a resolution in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as a

resolution passed at a meeting of the board of directors.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents

having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other

suitable telecommunication means.

When the board of directors is composed of a single director, resolutions are taken by the single director at such

time and place determined upon its sole discretion and shall be recorded in a written document signed by it.

Art. 13. Any director does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the execution
of his mandate.

119490

General meetings of shareholder(s)

Art. 14. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken by a general meeting of the

shareholders. One general meeting shall be held annually at the registered office of the Company on the second Monday
of June at 2p.m.. If such a day is a public holiday, the general meeting shall be held the following business day at the same
time. Other general meetings of shareholders shall be held in the place, on the day and at the time specified in the notice
of the meeting.

Art. 15. General meetings of shareholders or the sole shareholder are convened by the board of directors, failing

which by shareholders representing one tenth or more of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

be sent by registered letters to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general
meeting for which the notice shall be sent by registered letter at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the
meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on

the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

The directors may attend and speak in general meetings of shareholders.
General meetings of shareholders deliberate at the quorum and majority vote determined by the Law.
Minutes shall be signed by the bureau of the meeting and by the shareholders who request to do so.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.

Financial year - balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, with effect as of the 31st of December, the board of directors will draw up the balance sheet which

will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an
annex containing a summary of all its commitments and the debts of the director(s) and statutory auditor(s) towards the
Company, if any.

At the same time the board of directors will prepare a profit and loss account which will be transmitted, at least one

month before the date of the annual general meeting of shareholders together with a report on the operations of the
Company, to the statutory auditors that shall draft a report.

Art. 18. 15 (fifteen) days before the annual general meeting of shareholders, each shareholder may inspect at the head

office the balance sheet, the profit and loss account, the report of the statutory auditors and any document in accordance
with Article 73 of the Law.

Supervision of the company

Art. 19. The supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux

comptes), who may not be shareholder(s). Each statutory auditor shall be appointed for a period not exceeding six years
by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder, which may remove them at any time.

The term of the office of the statutory auditor(s) and his/their remuneration, if any, are fixed by the general meeting

of the shareholders or by the sole shareholder. At the end of this period, the statutory auditor(s) may be renewed in his/
their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or by the sole shareholder.

Where the thresholds of Article 215 of the Law are met, the Company shall have its annual accounts audited by one

or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or by the sole
shareholder amongst the members of the «Institut des réviseurs d'entreprises».

Dividend - reserves

Art. 20. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,

as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.

The general meeting of shareholders, at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder, may decide

that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.

119491

Interim dividend

Art. 21. The board of directors may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, in

accordance with the Law.

Dissolution - liquidation

Art. 22. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles may resolve

the dissolution of the Company.

Art. 23. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders or by the sole shareholder which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders

proportionally to the shares they hold.

Applicable law

Art. 24. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2007.

<i>Payment - contributions

- 3,200 (three thousand two hundred) shares have been subscribed by BOND CAPITAL PARTNERS I LIMITED, named

above, and fully paid up in cash, proof of which has been duly given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about two thousand Euros.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately  after  the  incorporation  of  the  Company,  the  above-named  persons,  representing  the  entirety  of  the

subscribed capital, held a general meeting of shareholders, and acknowledging being validly convened, passed the following
resolutions

1) The number of directors is set at 3 and that of the statutory auditor (commissaire aux comptes) at 1.
2) Are appointed as:

<i>Class A directors:

- Mr  Anthony  Yick Kin  Huang, born in Shanghai  (China)  on  September  10,  1949  with  professional  address  at 21

Arlington Street, London, SW1A 1RN, UK;

- Mr James Oswald Jacoby Jr, born in Texas (USA) on November 15, 1962 with professional address at 100 Morgan

Keegan Drive, Suite 500, Little Rock, Arkansas 72202, U.S.A..

<i>Class B director:

- Mr Xavier Pauwels, born in Bruxelles (Belgium) on December 21, 1971 with professional address at 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

In accordance with article 12 of its articles of association, the Company shall be bound by the joint signature of any

class A director and any class B director.

The directors shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders which will be

held in June 2008 and will approve the annual accounts as at December 31, 2007.

3) Is elected as statutory auditor (commissaire aux comptes): EUROFID S.à r.l., a company having its registered office

at 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg.

In accordance with article 19 of the Articles, the statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the

annual general meeting of shareholders which will be held in June 2008 and will approve the annual accounts as at De-
cember 31, 2007.

4) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Mersch, on the day named at the beginning of

this document.

119492

The document having been read to the proxies holders, said persons signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

soussigné.

Comparait:

BOND CAPITAL PARTNERS I LIMITED, une société constituée selon le droit des Bermudes, ayant son siège social

sis à Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton, ici représentée par Hubert Janssen, juriste, demeurant profession-
nellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, en qualité par laquelle elle agit, a requis du notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif

d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts (les «Statuts») comme suit:

Dénomination - objet - siège - durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par cet acte une société anonyme (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les

lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée.

Art. 2. La dénomination de la Société sera BOND CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A.

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes

sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la
société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en
partie, pour le prix que la société jurera adapté et en particulier pour les actions ou titres de toute société les acquérant;
de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute
société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la société ou toute société participant
au même groupe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil d'adminis-

tration.

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger

par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas) adoptée
selon les conditions requises pour la modification des Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert provisoire du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le conseil d'administration.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des actionnaires ne pourront pour quelque motif que

ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées des actionnaires ou de l'actionnaire unique.

Capital social - actions

Art. 7. Le capital social est fixé à EUR 32.000,- (trente deux milles euros), représenté par 3.200 (trois mille deux cents)

actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

119493

Le montant du capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée générale des

actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des
Statuts.

Le capital autorisé de la Société est fixé à EUR 132.000,- (cent trente-deux milles euros), représenté par 13.200 (dix

milles) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période expirant 5 (cinq) années après la publication de l'acte

constitutif de la Société au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou plusieurs fois le
capital social tant que le capital social émis résultant de ces augmentations demeure égal ou inférieur au seuil de EUR
132.000,- (cent trente-deux milles euros).

Il peut être souscrit à ces augmentations de capital social contre paiement en numéraire ou apport en nature en

observant alors les prescriptions légales applicables ou par incorporation de réserves disponibles, profits reportés ou
prime d'émission au capital social, dans chaque cas à un prix d'émission déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer à tout administrateur autorisé ou fondé de pouvoir de la Société ou à toute

autre personne dûment autorisée, le droit d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement des actions représentant
tout ou partie du montant d'une telle augmentation de capital.

A chaque augmentation de capital social de la Société par le conseil d'administration dans les limites du capital autorisé,

le premier paragraphe de l'article sept des statuts sera modifié en conséquence et le conseil d'administration prendra ou
autorisera toute personne à faire toutes les démarches nécessaires en vue de l'exécution et de la publication de ladite
modification.

Les actions à souscrire en numéraire doivent être proposées par préférence aux actionnaires en proportion du capital

représenté par leurs actions.

Si plusieurs classes d'actions ont été émises et que ces actions dépendent de la même classe, l'assemblée générale des

actionnaires pourra alors réserver le droit préférentiel de souscription aux détenteurs de cette classe d'actions unique-
ment ou attribuer le droit préférentiel de souscription aux détenteurs des autres classes uniquement après que ce droit
ait été exercé par les détenteurs d'actions de la classe pour laquelle les actions ont été émises.

Le conseil de gérance pourra dans les limites du capital autorisé décider de supprimer ou de réduire le droit préférentiel

de souscription des actionnaires.

Art. 8. Chaque action confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque actionnaire a un

nombre de droit de vote proportionnel aux nombres d'actions qu'il détient.

Art. 9. Les actions sont librement cessibles.
Les actions auront la forme d'actions nominatives uniquement. Un registre des actionnaires sera tenu par la Société

et mentionnera, au moins, l'identification précise de chaque actionnaire, le nombre d'actions qu'il détient et, le cas échéant,
leur transfert et la date de ce transfert.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Art. 10. La Société est autorisée à racheter ses propres actions sous les conditions requises par la Loi.

Administration

Art. 11. La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs. Dans pareil

cas, le conseil d'administration sera composé d'au moins un administrateur de classe A et d'au moins un administrateur
de classe B. Toutefois, lorsque toutes les actions sont détenues par un actionnaire unique, le conseil d'administration peut
être composé d'un seul administrateur dans les conditions prévues par la Loi. L'/Les administrateur(s) ne doit/doivent
pas être obligatoirement actionnaire(s) de la Société.

Lorsqu'une personne morale est nommée en tant que membre du conseil d'administration, elle devra informer la

Société du nom de la personne physique qu'elle a nommé pour agir en tant que son représentant permanent dans l'exercice
de son mandat d'administrateur de la Société.

L'/Les administrateur(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale

des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas) prise à la majorité simple des voix. La rémunération de(s)
l'administrateur(s) peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité. L'/Les administrateur
(s) est/sont rééligible(s).

L'/Les administrateur(s) peut/peuvent être révoqué(s) et remplacé(s) à tout moment, avec ou sans justification, par

une résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas).

En cas de vacance d'un poste d'administrateur en raison du décès ou de la démission d'un administrateur ou pour

toute autre raison, les autres administrateurs peuvent, par voie de cooptation, élire un nouvel administrateur pour pour-
voir à cette vacance jusqu'à l'assemblée générale suivante selon les dispositions de la Loi.

La  durée  du  mandat  de(s)  l'administrateur(s)  qui  n'excédera  pas  6  années,  est  fixée  par  l'assemblée  générale  des

actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles

pour l'accomplissement de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale

119494

des actionnaires ou à l'actionnaire unique (selon le cas) par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil
d'administration.

Vis-à-vis des tiers, le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société

et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec l'objet social et dans la mesure où les termes de ces
Statuts auront été respectés.

La gestion journalière des affaires de la Société et le pouvoir de représenter la Société dans ce cadre peut être déléguée

à un ou plusieurs directeurs, administrateurs, qui peut / peuvent ne pas être actionnaires de la Société. La délégation en
faveur d'un membre du conseil d'administration est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des ac-
tionnaires.

La Société sera engagée par la signature conjointe d'au moins un administrateur de classe A et un administrateur de

classe lorsque le conseil d'administration est composé d'au moins 3 administrateurs ou par la seule signature du seul
administrateur.

Le conseil d'administration peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques

à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne doivent pas être nécessairement actionnaires ou administrateurs de la Société.

Le conseil d'administration détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ces agents, la durée de

leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 12. Le conseil d'administration désignera parmi ses membres un président qui, en cas d'égalité des voix, n'aura

pas voix prépondérante. Le président présidera à toutes les réunions du conseil d'administration. En cas d'absence du
président, le conseil d'administration sera présidé par un administrateur présent et nommé à cet effet. Le conseil d'ad-
ministration peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement administrateur, qui sera responsable
de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil d'administration ou de l'exécution de toute autre tâche
spécifiée par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunira suite à la convocation faite par un administrateur.
Pour chaque conseil d'administration, des convocations devront être établies et envoyées à chaque administrateur au

moins 2 (deux) jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le
procès verbal de la réunion du conseil d'administration.

Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des affaires à traiter.
Les convocations peuvent être faites aux administrateurs oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex,

moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque administrateur peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens

électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les réunions du conseil d'administration se tiendront valablement sans convocation si tous les administrateurs sont

présents ou représentés.

Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil d'administration tenues à l'heure et au lieu

précisé précédemment lors d'une résolution du conseil d'administration.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par téléfax,

câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre administrateur pour le représenter.

Un administrateur peut représenter plusieurs autres administrateurs.
Les réunions du conseil d'administration se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg et requerront la présence de

la moitié des directeurs en personne ou représentés, laquelle sera constitutive du quorum.

Conformément à l'article 64bis (3) de la Loi, les administrateurs peuvent assister à une réunion du conseil d'adminis-

tration par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant leur identifi-
cation.

Une telle participation à une réunion du conseil d'administration est réputée équivalente à une présence physique à la

réunion.

Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des voix des administrateurs participant à la

réunion ou qui y sont valablement représentés.

Les délibérations du conseil d'administration sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou,

si cela est applicable, par son remplaçant ou par deux directeurs présents à l'assemblée. Les procurations resteront
annexées au procès-verbal. Toute copie ou extrait de ce procès-verbal sera signé par le président ou deux directeurs.

En cas d'urgence, une résolution écrite approuvée et signée par tous les administrateurs auront le même effet qu'une

résolution prise lors d'une réunion du conseil d'administration.

Dans un tel cas, les résolutions écrites peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs

documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire fax, câble, télégramme, moyens électroniques ou

tout autre moyen de communication approprié.

119495

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un directeur unique, les décisions sont prises par le directeur unique,

aux moments et lieux qu'il déterminera, par résolutions écrites qu'il signera.

Art. 13. Un administrateur ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son
mandat.

Assemblées générales des actionnaires

Art. 14. En cas de pluralité d'actionnaires, les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale des ac-

tionnaires. Une assemblée générale annuelle est tenue au siège de la Société le deuxième lundi de juin à 14.00 heures. Si
ce jour est un jour férié, l'assemblée générale des actionnaires se tiendra le jour ouvrable suivant à la même heure. Toute
autre assemblée générale des actionnaires se tient au lieu, à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

Art. 15. Les assemblées générales des actionnaires ou de l'actionnaire unique sont convoquées par le conseil d'admi-

nistration ou, à défaut, par des actionnaires représentant plus du dixième du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque actionnaire au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour
laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours par courrier recommandé avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés

de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui ne doit pas
être nécessairement actionnaire.

Les administrateurs peuvent assister et prendre la parole aux assemblées générales des actionnaires.
Les assemblées générales des actionnaires délibèrent aux conditions de quorum et de majorité requises par la Loi.
Les procès-verbaux des assemblées sont signés par le bureau de l'assemblée et par les actionnaires qui en font la

demande.

L'actionnaire unique exerce seul les pouvoirs dévolus par la Loi à l'assemblée des actionnaires.

Exercice social - comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, le conseil d'administration établira le bilan qui contiendra l'inventaire

des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que
les engagements et les dettes des administrateurs et du/des commissaire(s) envers la Société.

Dans le même temps, le conseil d'administration préparera un compte de profits et pertes qui sera transmis au moins

un mois avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou de l'actionnaire unique avec un rapport sur les opérations
de la Société, aux commissaires, qui feront un rapport.

Art. 18. 15 (quinze) jours avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires, tout actionnaire peut prendre con-

naissance au siège social de la Société du bilan, du compte de profits et pertes, du rapport des commissaires et de tout
document mentionné dans l'article 73 de la Loi.

Surveillance de la société

Art. 19. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui ne doit/doivent

pas être nécessairement actionnaire(s). Chaque commissaire sera nommé pour une période n'excédant pas six ans par
l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique, qui peut les révoquer à tout moment.

La durée du mandat du/des commissaire(s) et sa/leur rémunération éventuelle sont fixés par l'assemblée générale des

actionnaires ou par l'actionnaire unique. A l'expiration de cette période, le mandat du/des commissaire(s) pourra/pourront
être renouvelé(s) dans ses/leurs fonctions par une nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires ou de
l'actionnaire unique.

Lorsque les seuils de l'article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un

ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou par l'action-
naire unique parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Dividendes - réserves

Art. 20. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel

qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale devient inférieure à ce montant.

119496

L'assemblée générale des actionnaires, à la majorité prévue par la Loi ou l'actionnaire unique, peut décider qu'après

déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les actionnaires au titre de dividendes au prorata de leur
participation dans le capital social de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dividendes intérimaires

Art. 21. Le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice

social dans les conditions prévues dans la Loi.

Dissolution - liquidation

Art. 22. L'assemblée générale des actionnaires peut décider de la dissolution de la Société dans les conditions requises

pour la modification des statuts.

Art. 23. La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,

nommés par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique qui détermine leurs pouvoirs et leur ré-
munération.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux actionnaires au prorata de leur participation dans

le capital social de la Société.

<i>Loi applicable

Art. 24. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne

contiennent aucune disposition spécifique.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2007.

<i>Libération - apports

- 3,200 (trois mille deux cents) actions ont été souscrites par BOND CAPITAL PARTNERS I LIMITED, nommé ci-

dessus, et entièrement libérées par apport en numéraire, preuve en ayant été donnée au notaire.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille euros.

<i>Décisions de l'actionnaire unique

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, a

tenu  une  assemblée  générale  d'actionnaires  et,  reconnaissant  avoir  été  valablement  convoqué,  a  pris  les  résolutions
suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont nommés:

<i>Administrateurs de classe A:

- M. Anthony Yick Kin Huang, né à Shanghai (Chine) le 10 septembre, 1949, avec adresse professionnelle au 21 Arlington

Street, London, SW1A 1RN, UK;

- M. James Oswald Jacoby Jr, né au Texas (USA) le 15 novembre, 1962, avec adresse professionnelle au 100 Morgan

Keegan Drive, Suite 500, Little Rock, Arkansas 72202, U.S.A..

<i>Administrateur de classe B:

- M. Xavier Pauwels, né à Bruxelles (Belgique) le décembre, 1971, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Conformément à l'article 12 de ses statuts, la Société est engagée par la signature conjointe d'au moins un adminis-

trateur de classe A et d'au moins un administrateur de classe B.

Les administrateurs sont nommés pour une durée expirant le jour de l'assemblée générale des actionnaires qui se

tiendra au mois de juin 2008, pour approuver les comptes annuels au 31 décembre 2007.

3) EUROFID S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg est nommée comme com-

missaire aux comptes.

Conformément à l'article 19 des Statuts, le commissaire au compte est nommé pour une durée expirant le jour de

l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra au mois de juin 2008, pour approuver les comptes annuels au 31
décembre 2007.

4) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes com-

parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

119497

Dont acte, fait et passé à Luxembourg date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2007. Relation: LAC/2007/23868. — Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007120234/211/553.
(070137660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2007.

Ernst August Carree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.636.400,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 130.430.

In the year two thousand and seven, on the tenth of August.
Before Us, Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ING REI WAREHOUSE (UK) BV, having its registered office in NL-2595 AS The Hague, 65, Schenkkade, here repre-

sented by Mrs Corinne Petit, employee, with professional address in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by
virtue of a proxy given in The Hague on August 9th, 2007.

The said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present

deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in her capacity as the sole partner, has requested the undersigned notary to enact the

following:

The appearing party is the sole partner of ERNST AUGUST CARREE S. à r.l., a limited liability corporation with

registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, incorporated by deed of the notary Martine Schaeffer,
residing in Luxembourg, on June 28th, 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
These Articles of Association have not yet been amended.

The capital of the company is fixed at twelve thousand four hundred euro (12,400.- EUR) represented by one hundred

and twenty-four (124) parts, with a nominal value of one hundred euro (100.- EUR) each, entirely paid in.

The appearing party takes the following resolutions:

<i>First resolution

The partner resolves to increase the corporate capital by an amount of two million six hundred and twenty-four

thousand euro (2,624,000.- EUR), so as to raise it from its present amount of twelve thousand four hundred euro (12,400.-
EUR) to two million six hundred and thirty-six thousand four hundred euro (2,636,400.- EUR), by issuing twenty-six
thousand two hundred and forty (2,240) new parts with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, having the
same rights and obligations as the existing parts.

<i>Subscription and liberation

The appearing partner ING REI WAREHOUSE (UK) BV declares to subscribe the twenty-six thousand two hundred

and forty (26,240) new parts and to pay them up, fully in cash, at its par value of one hundred euro (100.- EUR), so that
the amount of two million six hundred and twenty-four thousand euro (2,624,000.- EUR) is at the free disposal of the
Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The appearing partner resolves to amend article 6 of the articles of incorporation, so as to reflect the increase of

capital, which shall henceforth have the following wording:

« Art. 6. The capital is set at two million six hundred and thirty-six thousand four hundred euro (2,636,400.- EUR)

represented by twenty-six thousand three hundred and sixty-four (26,364) parts of a par value of one hundred euro
(100.- EUR) each.»

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party,

this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.

119498

The document having been read and translated to the appearing persons, the appearing persons signed together with

the notary the present original deed.

Suit la version française:

L'an deux mille sept, le dix août.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ING REI WAREHOUSE (UK) BV, ayant son siège social à NL-2595 AS La Haye, 65, Schenkkade, ici représentée par

Mademoiselle Corinne Petit, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une
procuration délivrée à La Haye, le 9 août 2007.

Laquelle  procuration,  après  avoir  été  signée  ne  varietur  par  les  comparantes  et  le  notaire  instrumentant,  restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associée unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui

suit:

La société comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée ERNST AUGUST CARREE S. à r. I.,

avec  siège  social  à  L-2453  Luxembourg,  5,  rue  Eugène  Ruppert,  constituée  suivant  acte  reçu  par  le  notaire  Martine
Schaeffer, de résidence à Luxembourg, en date du 28 juin 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis.

Le capital social de la société est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent vingt-quatre

(124) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

L'associée prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de deux millions six cent vingt-quatre mille

euros (2.624.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) à deux
millions six cent trente-six mille quatre cents euros (2.636.400,- EUR), par l'émission de vingt-six mille deux cent quarante
(26.240) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et
obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription et libération

Et à l'instant, les vingt-six mille deux cent quarante (26.240) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent

euros (100,- EUR) ont été souscrites par l'associée ING REI WAREHOUSE (UK) BV et entièrement libérée en espèces,
de sorte que le montant de deux millions six cent vingt-quatre mille euros (2.624.000,- EUR) se trouve dès maintenant
à la disposition de la société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

Les associées décident, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à deux millions six cent trente-six mille quatre cents euros (2.636.400,- EUR) repré-

senté par vingt-six mille trois cent soixante-quatre (26.364) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,-
EUR) chacune.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et la
traduction française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par leurs

nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Petit, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2007, LAC/2007/23079. — Reçu 26.240 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007119189/5770/95.
(070137182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

119499

Frank's Mexico Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 115.503.

Constituée par-devant M 

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 mars 2006, acte publié au

Mémorial C n 

o

 1201 du 21 juin 2006. Modification des statuts par-devant le même notaire en date du 8 septembre

2006, acte publié au Mémorial C n 

o

 2152 du 17 novembre 2006.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FRANK'S MEXICO HOLDING S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007119364/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2007, réf. LSO-CJ01078. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070136402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Unity Media S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 108.625.

In the year two thousand and seven, on the nineteenth of April.
Before Us, Ms Martine Schaeffer, notary, residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of

UNITY MEDIA MANAGEMENT S.A., having its registered office in L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin, recorded
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 108.624, itself acting as sole general partner and
manager (the «Manager») of UNITY MEDIA S.C.A., having its registered office in L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph
Hackin, recorded with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 108.625 (the «Company»),
pursuant to a resolution of the board of directors of the Manager dated April 18th, 2007.

An excerpt of the minutes of said meeting, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain

attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state his declarations as follows:
1) The Company, formerly named WESTCHESTER S.C.A., has been incorporated pursuant to a deed of the notary

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, residing in Luxembourg, on June 10th, 2005, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 1145 of 4 November 2005. The articles of incorporation have been last modified
pursuant to a deed of the undersigned notary acting in replacement of the notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen
on April 6th, 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2) The subscribed share capital of the Company was set at six hundred eighty-five thousand nine hundred and ten euro

(EUR 685,910.-) consisting of one hundred thirty-seven thousand one hundred eighty-two (137,182) Class A ordinary
shares with a par value of five euro (EUR 5.-) each.

3) Pursuant to article six of the articles of incorporation, the authorised capital, including the subscribed share capital

of six hundred eighty-five thousand nine hundred ten euro (EUR 685,910.-), is fixed at eight hundred forty-one million
five hundred forty-nine thousand, six hundred ninety-seven euro and fifty-one cents (EUR 841,549,697.51), consisting of
(i)  eight  hundred  forty  million  seven  hundred  fifty  thousand  eight  hundred  fifty-seven  euro  and  sixteen  cents  (EUR
840,750,857.16) for a conversion of CPECs into one hundred sixty-eight million one hundred fifty thousand one hundred
seventy-one point four three two (168,150,171.432) Class A ordinary shares with a par value of five euro (EUR 5.-) each;
(iii) fifty thousand euro (EUR 50,000.-) for the issuance of ten thousand (10,000) Class A ordinary shares, and (iii) sixty-
two thousand nine hundred thirty euro and thirty-five cents (EUR 62,930.35) for the issuance of twelve thousand five
hundred eighty-six point zero, seven, zero (12,586.070) Class B shares with a par value of five euro (EUR 5.-) each.

The  Manager  is  authorised  to  issue  shares  without  reserving  for  the  existing  shareholders  a  preferential  right  to

subscribe to the shares issued.

4) On April 18th, 2007, the Manager of the Company decided to increase the capital up to seven hundred thirty-eight

thousand nine hundred fifty-eight euro and eighty-five cents (EUR 738,958.85) through the issuance of ten thousand six
hundred nine point seventy-seven (10,609.77) Class B Shares with a par value of five euro (EUR 5.-) each, through a
contribution in cash of one million sixty-five thousand three hundred seventy nine euro and six cents (EUR 1,065,379.06),

119500

out of which one million twelve thousand three hundred thirty euro and twenty-one cents (EUR 1,012,330.21) have been
allocated to the share premium of the Company and fifty-three thousand forty-eight euro and eighty-five cents (EUR
53,048.85) have been allocated to the share capital of the Company.

In accordance with article six of the articles of incorporation, the Manager has decided to suppress the preferential

right of the existing shareholders to subscribe the newly issued shares.

All the ten thousand six hundred nine point seventy-seven (10,609.77) newly issued Class B Shares have been sub-

scribed as follows:

- Four thousand three hundred and eight point sixty-seven (4,308.67) new class B shares have been subscribed by

TAMITA GbR, an unlimited partnership formed under the laws of Germany, having its registered address at Augusta
Strasse 24, D-53173 Bonn-Bad Godesberg, Germany, for a total price of seven hundred thirty-seven thousand five hundred
sixty-one euro and eighty-eight cents (EUR 737,561.88), out of which seven hundred sixteen thousand eighteen euro and
fifty-three cents (EUR 716,018.53) have been allocated to the share premium of the Company and twenty-one thousand
five hundred forty-three euro and thirty-five cents (EUR 21,543.35) have been allocated to the share capital of the Com-
pany;

- Two thousand fifty-seven point seventy-two (2,057.72) new class B shares have been subscribed by STOMM GbR,

an unlimited partnership formed under the laws of Germany, having its registered address at Spinozastrasse 4, D-30625
Hannover, Germany, for a total price of three hundred six thousand six hundred euro and twenty-eight cents (EUR
306,600.28),  out  of  which  two  hundred  ninety-six  thousand  three  hundred  eleven  euro  and  sixty-eight  cents  (EUR
296,311.68) have been allocated to the share premium of the Company and ten thousand two hundred eighty-eight euro
and sixty cents (10,288.60) have been allocated to the share capital of the Company;

- Nine hundred sixty-eight (968) new class B shares have been subscribed by Mr Christoph Bellmer, having its address

at Lindenberg 137, D-82343 Pocking, Germany, for a total price of four thousand eight hundred forty euro (EUR 4,840.-),
out of which the entirety has been allocated to the share capital of the Company;

- Seven hundred fifty-five (755) new class B shares have been subscribed by Mr Christopher Winfrey, having its address

at Anna Schneider-Steig, 5, D-50678 Köln, Germany, for a total price of three thousand seven hundred seventy five euro
(EUR 3,775.-), out of which the entirety has been allocated to the share capital of the Company;

- Two hundred fifty-nine point twenty-seven (259.27) new class B shares have been subscribed by Mr Colin Buechner,

having its address at Am Kottengroover Maar, D-53913 Swisstal, Germany, for a total price of thousand two hundred
ninety-six euro and thirty-five cents (EUR 1,296.35), out of which the entirety has been allocated to the share capital of
the Company;

- One hundred fifty-five point fifty-seven (155.57) new class B shares have been subscribed by Mr. Kamram Ziaee,

having its address at Schneider-Claus Strasse, 4, D-50858 Köln, Germany, for a total price of seven hundred seventy-
seven euro and eighty-five cents (EUR 777.85), out of which the entirety has been allocated to the share capital of the
Company;

- One hundred fifty-five point fifty-seven (155.57) new class B shares have been subscribed by Mr Christoph Luethe,

having its address at Erbacher Strasse, 24, D-65232 Tannusstein, Germany, for a total price of seven hundred seventy-
seven euro and eighty-five cents (EUR 777.85), out of which the entirety has been allocated to the share capital of the
Company;

- One hundred fifty-five point fifty-seven (155.57) new class B shares have been subscribed by Mr. David Taber, having

its address at Berrenrather Strasse, D-50937 Köln, Germany, for a total price of seven hundred seventy-seven euro and
eighty-five cents (EUR 777.85), out of which the entirety has been allocated to the share capital of the Company;

- Three hundred eight (308) new class B shares have been subscribed by Mr Dejan Jocic, having its address at Prey-

singstrasse, 25, D-81667 Munich, Germany, for a total price of thousand five hundred forty euro (EUR 1,540.-), out of
which the entirety has been allocated to the share capital of the Company;

- Two hundred five point seventy-six (205.76) new class B shares have been subscribed by Mr David McGowan, having

its address at Doneraile Street, SW6 6EW London, United Kingdom, for a total price of thousand twenty-eight euro and
eighty cents (EUR 1,028.80), out of which the entirety has been allocated to the share capital of the Company;

- One hundred fifty-five point fifty-seven (155.57) new class B shares have been subscribed by Mr Maik Emmerman,

having its address at Eduart-Kandl-Strasse, 32, D-82211 Hersching, Germany, for a total price of seven hundred seventy-
seven euro and eighty-five cents (EUR 777.85), out of which the entirety has been allocated to the share capital of the
Company;

- One hundred fifty-five point fifty-seven (155.57) new class B shares have been subscribed by Mr Andrew Gill, having

its address at Aachenerstrasse 531, D-50933 Köln, Germany, for a total price of seven hundred seventy-seven euro and
eighty-five cents (EUR 777.85), out of which the entirety has been allocated to the share capital of the Company;

- Seventy-three point ninety (73.90) new class B shares have been subscribed by Mr. Mario Wilhelm, having its address

at Neusser Strasse, 87, D-50670 Köln, Germany, for a total price of three hundred sixty nine euro and fifty cents (EUR
369.50), out of which the entirety has been allocated to the share capital of the Company;

119501

- Seventy-three point ninety (73.90) new class B shares have been subscribed by Mr. Rene Vom Bruch, having its

address at Ehrenfeldgürtel, 161, D-50823 Köln, Germany, for a total price of three hundred sixty-nine euro and fifty cents
(EUR 369.50), out of which the entirety has been allocated to the share capital of the Company;

- Seventy-three point ninety (73.90) new class B shares have been subscribed by Mrs Laura Krastins, having its address

at Ottostrasse, 8, D-50823 Köln, Germany, for a total price of three hundred sixty nine euro and fifty cents (EUR 369.50),
out of which the entirety has been allocated to the share capital of the Company;

- Seventy-three point ninety (73.90) new class B shares have been subscribed by Mr. Jens Müller, having its address at

Gerresheimer Strasse, 240b, D-40721 Hilden, Germany, for a total price of three hundred sixty nine euro and fifty cents
(EUR 369.50), out of which the entirety has been allocated to the share capital of the Company;

- Seventy-three point ninety (73.90) new class B shares have been subscribed by Mr. Michael Rabes, having its address

at An der Struth, 25, D-65510 Idstein-Dasbach, Germany, for a total price of three hundred sixty nine euro and fifty cents
(EUR 369.50), out of which the entirety has been allocated to the share capital of the Company;

- One hundred (100) new class B shares have been subscribed by Mr. Michael Kramer, having its address at 1247

Oenoke Ridge, New Canaan, CT 06840, USA, for a total price of five hundred euro (EUR 500.-), out of which the entirety
has been allocated to the share capital of the Company;

- One hundred (100) new class B shares have been subscribed by Mr Eric Zinterhofer, having its address at 9 West

57 Street, 43st Floor, New York, NY 10019, USA, for a total price of five hundred euro (EUR 500.-), out of which the
entirety has been allocated to the share capital of the Company;

- One hundred (100) new class B shares have been subscribed by Mr Michael Block, having its address at 9 West 57

Street, 43st Floor, New York, NY 10019, USA, for a total price of five hundred euro (EUR 500.-), out of which the entirety
has been allocated to the share capital of the Company;

- Fifty (50) new class B shares have been subscribed by BC EUROPEAN CAPITAL VII TOP-UP, with professional

address at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL, for a total price of two hundred fifty euro
(EUR 250.-), out of which the entirety has been allocated to the share capital of the Company;

- Two hundred fifty (250) new class B shares have been subscribed by BC EUROPEAN CAPITAL VII, with professional

address at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL, for a total price of thousand two hundred
fifty euro (EUR 1,250.-), out of which the entirety has been allocated to the share capital of the Company;

All such shares have been entirely paid up so that the total sum of one million sixty-five thousand three hundred seventy

nine euro and six cents (EUR 1,065,379.06) has been put at the disposal of the Company as was justified to the undersigned
notary.

As a consequence of such increase of share capital, article six, of the articles of incorporation is amended and now

reads as follows:

« Art. 6.
(a) Subscribed Capital
The subscribed capital is fixed at seven hundred thirty-eight thousand nine hundred fifty-eight euro and eighty-five

cents (EUR 738,958.85) represented by one hundred thirty-seven thousand one hundred eighty-two (137,182) Class A
ordinary shares with a par value of five euro (EUR 5.-) each and by ten thousand six hundred nine point seventy-seven
(10,609.77) Class B Shares with a par value of five euro (EUR 5.-) each.

The authorised capital, including the subscribed share capital of seven hundred thirty-eight thousand nine hundred

fifty-eight euro and eighty-five cents (EUR 738,958.85) is fixed at eight hundred forty-one million five hundred forty-nine
thousand, six hundred ninety-seven euro and fifty-one cents (EUR 841,549,697.51), consisting of (i) eight hundred forty
million seven hundred fifty thousand eight hundred fifty-seven euro and sixteen cents (EUR 840,750,857.16) for a con-
version of CPECs into one hundred sixty-eight million one hundred fifty thousand one hundred seventy-one point four
three two (168,150,171.432) Class A ordinary shares with a par value of five euro (EUR 5.-) each; and (iii) fifty thousand
euro (EUR 50,000.-) for the issuance of ten thousand (10,000) Class A ordinary shares with a par value of five euro (EUR
5.-) each and (iv) nine thousand eight hundred eighty-one euro and fifty cents (EUR 9,881.50) for the issuance of one
thousand nine hundred seventy-six point three (1,976.3) Class B shares with a par value of five euro (EUR 5.-) each.
During the period of five years, from the date of the publication of the amendment of these articles of association, the
GP be and is hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such
terms as it shall see fit (and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a pref-
erential right to subscribe to the shares issued).

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the

general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association. The
Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

(b) The Class A Ordinary Shares
i. Generally. All Class A ordinary shares shall be identical in all respects. All Class A ordinary shares shall share ratably

in the payment of dividends and in any other distributions with respect to Class A ordinary shares which are allocated
on an aggregate basis to such Class A ordinary shares. All Class A ordinary shares purchased or otherwise acquired by

119502

the Company shall, if the GP so directs, be retired with the effect that the issued number of Class A ordinary shares is
reduced.

ii. Voting Rights. Each Class A ordinary share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which

shareholders have the right to vote.

iii. Redemption; Convertibility. Class A ordinary shares will not be subject to mandatory redemption (except as may

from time to time be approved by the GP and set forth in a separate agreement) and will not be convertible into any
other shares.

(c) The Class B Ordinary Shares
i. Generally. All Class B ordinary shares shall be identical in all respects. All Class B ordinary shares shall participate in

the payment of dividends and in any other distributions with respect to Class B ordinary shares in the manner set forth
herein. All Class B ordinary shares purchased or otherwise acquired by the Company shall, if the GP so directs, be retired
with the effect that the issued number of Class B ordinary shares is reduced.

ii. Voting Rights. Each Class B ordinary share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which

shareholders have the right to vote.

iii. Redemption; Convertibility. Class B ordinary shares will not be subject to mandatory redemption (except as may

from time to time be approved by the GP and set forth in a separate agreement) and will not be convertible into any
other shares.»

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English text and the German text, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this document.
After reading and interpretation to the appearing person, said appearing person signed together with the notary the

present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundsieben, am neunzehnten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, handelnd als Bevollmächtigter des Verwaltungsrates der

Gesellschaft UNITY MEDIA MANAGEMENT S.A. mit Gesellschaftssitz in L-1746 Luxemburg, 2, rue Joseph Hackin, ein-
getragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 108.624, diese ihrerseits handelnd
als einziger Komplementär und Manager von UNITY MEDIA S.C.A. mit Gesellschaftssitz in L-1746 Luxembourg, 2, rue
Joseph Hackin, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg Sektion unter der Nummer B 108.625,
gemäß eines Beschlusses des Verwaltungsrates vom 18. April 2007.

Ein Auszug des Protokolls dieser Sitzung wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den

Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben registriert zu werden.

Der Erschienene, in der obengenannten Eigenschaft handelnd, hat den unterzeichneten Notar gebeten folgende De-

klarationen festzulegen:

1)  Die  Aktiengesellschaft  UNITY  MEDIA  S.C.A.,  vormals  Westchester  S.CA.,  wurde  gemäß  Urkunde  des  Notars

André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg, am 10. Juni 2005 gegründet, welche Urkunde veröffentlicht
wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1145 vom 4. November 2005. Die Satzung wurde
zum letzten Mal abgeändert gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars welcher in Vertretung von Notar André-Jean-
Joseph  Schwachtgen  handelte,  am  6  April  2007,  noch  nicht  veröffentlicht  im  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations.

2) Das gezeichnet Kapital der Gesellschaft war auf sechshundertfünfundachtzigtausendneunhundertzehn Euro (EUR

685.910,-) festgesetzt, aufgeteilt in einhundertsiebenunddreißigtausendeinhundertzweiundachtzig (137.182) Aktien der
Klasse A mit einem Nennwert von jeweils fünf Euro (EUR 5,-) pro Aktie.

3) Gemäß Artikel sechs der Satzung beträgt das genehmigte Aktienkapital, einschließlich des gezeichneten Aktienka-

pitals von sechshundertfünfundachzigtausendneunhundertzehn Euro (EUR 685.910,-), achthunderteinundvierzig Millionen
fünfhundertneunundvierzigtausendsechshundertsiebenundneunzi g Euro und einundfünfzig Cent (EUR 841.549.697,51),
bestehend aus (i) achthundertvierzig Millionen siebenhundertfünfzigtausendachthundertsiebenundfünfzig Euro und sech-
zehn Cent (EUR 840.750.857,16) zur Umwandlung von CPECs in einhundertachtundsechzig Millionen einhundertfünfzig-
tausendeinhunderteinundsiebzig Komma vierhundertzweiunddreißig (168.150.171.432) Klasse A-Stammaktien mit einem
Nennwert von je fünf Euro (EUR 5,-); (iii) fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) zur Ausgabe von zehntausend (10.000)
Klasse  A-Stammaktien,  und  (iii)  zweiundsechzigtausendneunhundertdreißig  Euro  und  fünfunddreißig  Cent  (EUR
62.930,35) zur Ausgabe von zwölftausendfünfhundertsechsundachzig Komma nullsiebennull (12.586.070) Klasse B-Aktien
mit einem Nennwert von je fünf Euro (EUR 5,-). Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Aktien auszustellen ohne den beste-
henden Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen.

119503

4) In seiner Sitzung vom 18. April 2007, hat der Verwaltungsrat beschlossen, das Gesellschaftskapital auf siebenhun-

dertachtunddreißigtausendneunhundertachtundfünfzig  Euro  und  fünfundachtzig  Cents  (EUR  738.958,85)  zu  erhöhen
durch Ausgabe von zehntausendsechshundertneun Komma siebenundsiebzig (10.609,77) neuen Aktien der Klasse B, mit
einem Nennwert von jeweils fünf Euro (EUR 5,-) pro Aktie, bei Erhalt einer Zahlung von jeweils fünf Euro (EUR 5,-) pro
Aktie durch Bareinzahlung von einer Million fünfundsechzigtausenddreihundertneunundsiebzig Euro und sechs Cent (EUR
1.065.379,06), wovon eine Million zwölftausenddreihundertdreißig Euro und einundzwanzig Cents (EUR 1.012.330,21)
dem Ausgabeaufschlag und dreiundfünfzigtausendachtundvierzig Euro und fünfundachtzig Cents (EUR 53.048,85) dem
Aktienkapital zugeteilt wurden.

Gemäß Artikel 6 der Satzung, hat der Verwaltungsrat das Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre in Bezug auf die

neu ausgegebenen Aktien eingestellt.

Alle zehntausendsechshundertneun Komma siebenundsiebzig (10.609,77) neuen Aktien der Klasse B wurden folgend

gezeichnet:

- Viertausenddreihundertacht Komma siebenundsechzig (4.308,67) Aktien der Klasse B wurden durch TAMITA GbR,

ein unlimited partnership Deutschen Rechts, mit Sitz in Augusta Strasse 24, Bonn-Bad Godesberg, D-53173, Deutschland,
zu  einem  Gesamtpreis  von  siebenhundertsiebenunddreißigtausendfünfhunderteinundsechzig  Euro  und  achtundachtzig
Cent (EUR 737.561,88), wovon siebenhundertsechzehntausendachtzehn Euro und dreiundfünfzig Cents (EUR 716.018,53)
dem  Ausgabeaufschlag  der  Gesellschaft  und  einundzwanzigtausendfünfhundertdreiundvierzig  Euro  und  fünfunddreißig
Cents (EUR 21.543,35) dem Aktienkapital der Gesellschaft zugeteilt wurden;

- Zweitausendsiebenundfünfzig Komma zweiundsiebzig (2.057,72) neue Aktien der Klasss B durch STOMM GbR, ein

unlimited partnership Deutschen Rechts, mit Sitz in Spinozastrasse 4, D-30625 Hannover, Deutschland, zu einem Ge-
samtpreis von dreihundertsechstausendsechshundert Euro und achtundzwanzig Cents (EUR 306.600,28), wovon zwei-
hundertsechsundneunzigtausenddreihundertelf Euro und achtundsechzig Cents (EUR 296.311,68) dem Ausgabeaufschlag
der Gesellschaft und -zehntausendzweihundertachtundachtzig Euro und sechzig Cents (EUR 10.288,60) dem Aktienkapital
der Gesellschaft zugeteilt wurden;

- Neunhundertachtundsechzig (968) neue Aktien der Klasse B durch Herrn Christoph Bellmer, mit Wohnsitz in Lin-

denberg,  137,  D-82343  Pöcking,  Deutschland,  für  einen  Gesamtpreis  von  viertausendachthundertvierzig  Euro  (EUR
4.840,-), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde;

- Siebenhundertfünfundfünfzig (755) neue Aktien der Klasse B durch Herrn Christopher Winfrey, mit Wohnsitz in

Anna Schneider-Steig, 5, D-50678 Köln, Deutschland, für einen Gesamtpreis von dreitausendsiebenhundertfünfundsiebzig
Euro (EUR 3.775,-), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde;

- Zweihundertneunundfünfzig Komma siebenundzwanzig (259,27) neue Aktien der Klasse B durch Herrn Colin Bu-

echner, mit Wohnsitz in Kottengroover Maar, D-53913 Swisstal, Deutschland, für einen Gesamtpreis von tausendzwei-
hundertsechsundneunzig  Euro  und  fünfunddreißig  Cents  (EUR  1.296,35),  wovon  die  Gesamtheit  dem  Aktienkapital
zugeteilt wurde;

- Hundertfünfundfünzig Komma siebenundfünfzig (155,57) neue Aktien der Klasse B durch Herrn Kamram Ziaee, mit

Wohnsitz in Schneider-Claus Strasse, 4, D-50858 Köln, Deutschland, für einen Gesamtpreis von siebenhundertsiebe-
nundsiebzig Euro und fünfundachtzig Cents (EUR 777,85), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde;

- Hundertfünfundfünzig Komma siebenundfünfzig (155,57) neue Aktien der Klasse B durch Herrn Christoph Luethe,

mit Wohnsitz in Erbacher Strasse, 24, D-65232 Tannusstein, Deutschland, für einen Gesamtpreis von siebenhundertsie-
benundsiebzig Euro und fünfundachtzig Cents (EUR 777,85), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde;

- Hundertfünfundfünzig Komma siebenundfünfzig (155,57) neue Aktien der Klasse B durch Herrn David Taber, mit

Wohnsitz in Berrenrather Strasse, D-50937 Köln, Deutschland, für einen Gesamtpreis von siebenhundertsiebenundsieb-
zig Euro und fünfundachtzig Cents (EUR 777,85), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde;

- Dreihundertacht (308) neue Aktien der Klasse B durch Herrn Dejan Jocic, mit Wohnsitz in Preysingstrasse, 25,

D-81667 München, Deutschland, für einen Gesamtpreis von tausendfünfhundertvierzig Euro (EUR 1.540,-), wovon die
Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde;

- Zweihundertfünf Komma sechsundsiebzig (205,76) neue Aktien der Klasse B durch Herrn David McGowan, mit

Wohnsitz in Doneraile Street, SW6 6EW London, United Kingdom, für einen Gesamtpreis von tausendachtundzwanzig
Euro und achtzig Cents (EUR 1.028,80), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde;

- Hundertfünfundfünfzig Komma siebenundfünfzig (155,57) neue Aktien der Klasse B durch Herrn Maik Emmermann,

mit Wohnistz in Eduart-Kandl-Strasse, 32, D-82211 Hersching, Deutschland, für einen Gesamtpreis von siebenhundert-
siebenundsiebzig Euro und fünfundachtzig Cents (EUR 777,85), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde;

- Hundertfünfundfünfzig Komma siebenundfünfzig (155,57) neue Aktien der Klasse B durch Herrn Andrew GILL, mit

Wohnistz in Aachenerstrasse 531, D-50933 Köln, Deutschland, für einen Gesamtpreis von siebenhundertsiebenundsiebzig
Euro und fünfundachtzig Cents (EUR 777,85), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde;

- Dreiundsiebzig Komma neunzig (73,90) neue Aktien der Klasse B durch Herrn Mario Wilhelm, mit Wohnsitz in

Neusser Strasse, 87, D-50670 Köln, Deutschland, für einen Gesamtpreis von dreihundertneunundsechzig Euro und fünfzig
Cents (EUR 369,50), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde;

119504

- Dreiundsiebzig Komma neunzig (73,90) neue Aktien der Klasse B durch Herrn Rene Vom Bruch, mit Wohnsitz in

Ehrenfeldgürtel, 161, D-50823 Köln, Deutschland, für einen Gesamtpreis von dreihundertneunundsechzig Euro und fünfzig
Cents (EUR 369,50), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde;

- Dreiundsiebzig Komma neunzig (73,90) neue Aktien der Klasse B durch Frau Laura Krastins, mit Wohnsitz in Ot-

tostrasse, 8, D-50823 Köln, Deutschland, für einen Gesamtpreis von dreihundertneunundsechzig Euro und fünfzig Cents
(EUR 369,50), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde;

- Dreiundsiebzig Komma neunzig (73,90) neue Aktien der Klasse B durch Herrn Jens Müller, mit Wohnsitz in Ge-

rresheimer Strasse, 240b, D-40721 Hilden, Deutschland, für einen Gesamtpreis von dreihundertneunundsechzig Euro
und fünfzig Cents (EUR 369,50), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde;

- Dreiundsiebzig Komma neunzig (73,90) neue Aktien der Klasse B durch Herrn Michael Rabes, mit Wohnsitz in An

der Struth, 25, D-65510 Idstein-Dasbach, Deutschland, für einen Gesamtpreis von dreihundertneunundsechzig Euro und
fünfzig Cents (EUR 369,50), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde;

- Hundert (100) neue Aktien der Klasse B durch Herrn Michael Kramer, mit Wohnistz in 1247 Oenoke Ridge, New

Canaan, CT 06840, USA, für einen Gesamtpreis von fünfhundert Euro (EUR 500,-), wovon die Gesamtheit dem Aktien-
kapital zugeteilt wurde;

- Hundert (100) neue Aktien der Klasse B durch Herrn Eric Zinterhofer, mit Wohnsitz in 9 West 57 Street, 43st Floor,

New  York,  NY  10019,  USA,  für  einen  Gesamtpreis  von  fünfhundert  Euro  (EUR  500,-),  wovon  die  Gesamtheit  dem
Aktienkapital zugeteilt wurde;

- Hundert (100) neue Aktien der Klasse B durch Herrn Michael Block, mit Wohnsitz in 9 West 57 Street, 43st Floor,

New  York,  NY  10019,  USA,  für  einen  Gesamtpreis  von  fünfhundert  Euro  (EUR  500,-),  wovon  die  Gesamtheit  dem
Aktienkapital zugeteilt wurde;

- Fünfzig (50) neue Aktien der Klasse B durch BC EUROPEAN CAPITAL VII TOP-UP, mit Sitz in Trafalgar Court, Les

Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL, für einen Gesamtpreis von zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-), wovon
die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde;

- Zweihundertfünfzig (250) neue Aktien der Klasse B durch BC EUROPEAN CAPITAL VII, mit Sitz in Trafalgar Court,

Les  Banques,  St  Peter  Port,  Guernsey,  GY1  3QL,  für  einen  Gesamtpreis  von  tausendzweihundertfünfzig  Euro  (EUR
1.250,-), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde;

Alle diese Aktien wurden vollständig eingezahlt, so dass die Gesamtsumme von einer Million fünfundsechzigtausendd-

reihundertneunundsiebzig Euro und sechs Cents (EUR 1.065.379,06) zur freien Verfügung der Gesellschaft stehen, wie
dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Folglich der Kapitalerhöhung ist Artikel 6 der Satzung abgeändert und lautet in Zukunft wie folgt:
« Art. 6.
a) Gezeichnetes Aktienkapital
Das gezeichnete Aktienkapital beträgt siebenhundertachtunddreißigtausendneunhundertachtundfünfzig Euro und fünf-

undachtzig  Cents  (EUR  738.958,85)  und  ist  in  einhundertsiebenunddreißigtausendeinhundertzweiundachzig  (137.182)
Klasse A-Stammaktien mit einem Nennwert von je fünf Euro (EUR 5,-) und zehntausendsechshundertneun Komma sie-
benundsiebzig (10.609,77) Klasse B-Stammaktien mit einem Nennwert von je fünf Euro (EUR 5,-) aufgeteilt.

Das  genehmigte  Aktienkapital,  einschließlich  des  gezeichneten  Aktienkapitals  von  siebenhundertachtunddreißigtau-

sendneunhundertachtundfünfzig  Euro  und  fünfundachtzig  Cents  (EUR  738.958,85),  beträgt  achthunderteinundvierzig
Millionen  fünfhundertneunundvierzigtausendsechshundertsiebenundneunzi  g  Euro  und  einundfünfzig  Cent  (EUR
841.549.697,51), bestehend aus (i) achthundertvierzig Millionen siebenhundertfünfzigtausendachthundertsiebenundfünfzig
Euro und sechzehn Cent (EUR 840.750.857,16) zur Umwandlung von CPECs in einhundertachtundsechzig Millionen ein-
hundertfünfzigtausendeinhunderteinundsiebzig Komma vierhundertzweiunddreißig (168.150.171,432) Klasse A-Stamm-
aktien  mit  einem  Nennwert  von  je  fünf  Euro  (EUR  5,-);  (iii)  fünfzigtausend  Euro  (EUR  50.000,-)  zur  Ausgabe  von
zehntausend (10.000) Klasse A-Stammaktien, und (iv) neuntausendachthunderteinundachtzig Euro und fünfzig Cent (EUR
9.881,50)  zur  Ausgabe  von  eintausendneunhundertsechsundsiebzig  Komma  drei  (1.976,3)  Klasse  B-Aktien  mit  einem
Nennwert von je fünf Euro (EUR 5,-). Während eines Zeitraums von fünf Jahren ab der Veröffentlichung dieser Sat-
zungsänderung, ist die GP hiermit zur Ausgabe von Aktien und zur Erteilung von Optionen zur Zeichnung von Aktien
berechtigt, an solche Personen und zu solchen Bedingungen wie sie dies für geeignet hält (Die GP ist in diesem Zusam-
menhang insbesondere dazu berechtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den bestehenden Aktionären Vorzugsrechte
in Bezug auf die Zeichnung der ausgegebenen Aktien einzuräumen).

Das gezeichnete und das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch einen entsprechend den Erfordernissen für

Satzungsänderungen angenommenen Beschluss der Aktionärshauptversammlung erhöht oder herabgesetzt werden. Die
Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

(b) Die Klasse A-Stammaktien
i. Allgemein. Alle Klasse A-Stammaktien sind in jeder Hinsicht identisch. Alle Klasse A-Stammaktien haben anteilmäßig

an der Zahlung von Dividenden und jedweden sonstigen Ausschüttungen in Bezug auf Klasse A-Stammaktien teil, die
diesen Klasse A-Stammaktien als Gesamtbetrag zugeteilt werden. Alle seitens der Gesellschaft gekauften oder anderweitig

119505

erworbenen Klasse A-Stammaktien sind auf Anweisung der GP zurückzuziehen, mit der Folge, dass die ausgegebene
Anzahl an Klasse A-Stammaktien verringert wird.

ii. Stimmrechte. Jede Klasse A-Stammaktie berechtigt ihren Inhaber zur Abgabe einer Stimme im Hinblick auf sämtliche

Angelegenheiten, über die die Aktionäre zur Abstimmung berechtigt sind.

iii Rückkauf; Umwandelbarkeit. Klasse A-Stammaktien unterliegen nicht dem Tilgungsverbot (es sei denn, dies wird

von Zeit zu Zeit von der GP genehmigt und in einer gesonderten Vereinbarung dargelegt) und können in keine anderen
Anteile umgewandelt werden.

c) Die Klasse B-Stammaktien
i.  Allgemein.  Alle  Klasse  B-Stammaktien  sind  in  jeder  Hinsicht  identisch.  Alle  Klasse  B-Stammaktien  haben  an  der

Zahlung von Dividenden und jedweden sonstigen Ausschüttungen in Bezug auf Klasse B-Stammaktien in der hierin be-
schriebenen  Art  und  Weise  teil.  Alle  seitens  der  Gesellschaft  gekauften  oder  anderweitig  erworbenen  Klasse  B-
Stammaktien  sind  auf  Anweisung  der  GP  zurückzuziehen,  mit  der  Folge,  dass  die  ausgegebene  Anzahl  an  Klasse  B-
Stammaktien verringert wird.

ii. Stimmrechte. Jede Klasse B-Stammaktie berechtigt ihren Inhaber zur Abgabe einer Stimme im Hinblick auf sämtliche

Angelegenheiten, über die die Aktionäre zur Abstimmung berechtigt sind.

iii. Rückkauf; Umwandelbarkeit. Klasse B-Stammaktien unterliegen nicht dem Tilgungsverbot (es sei denn, dies wird

von Zeit zu Zeit von der GP genehmigt und in einer gesonderten Vereinbarung dargelegt) und können in keine anderen
Anteile umgewandelt werden.»

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage des Er-

schienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage
des gleichen Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung, wird die
englische Fassung massgebend sein.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Signé: C. Opitz, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 27 avril 2007, REM/2007/941. — Reçu 10.653,79 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 31 mai 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007119214/5770/361.
(070136691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Advent Mango 5, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 115.787.

In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth of June.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-F LIMITED PARTNERSHIP, a partnership organized under

the laws of the Netherlands, with registered office at C/O ADVENT INTERNATIONAL CORPORATION, 75 State
Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, United States,

here represented by Mrs. Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal on 22 June 2007.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of ADVENT MANGO 5, a société à responsabilité limitée, governed by

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, whose registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 115.787,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated April 7, 2006, whose articles of association have been
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated June 29, 2006 number 1256, (the «Mémorial C»),
and whose bylaws have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on 15 May 2006, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated August 2, 2006, number 1478.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

119506

<i>First resolution

The sole partner decides to change the par value of the existing shares from one hundred US dollars (USD 100.-) to

one US dollar (USD 1.-) each so that the share capital is represented by sixty-eight thousand five hundred (68,500) shares
of one US dollar (USD 1.-) each.

<i>Second resolution

The sole partner decides to increase the Company's share capital by an amount of twenty-four thousand seven hundred

and sixty-nine US dollars (USD 24,769.-), so as to raise it from its present amount of sixty-eight thousand five hundred
US dollars (USD 68,500.-) up to ninety-three thousand two hundred and sixty-nine US dollars (USD 93,269.-) by the issue
of twenty-four thousand seven hundred and sixty-nine (24,769) shares, having a par value of one US dollar (USD 1.-) each
(collectively referred as the «New Shares») and having the same rights and obligations as the existing shares.

The twenty-four thousand seven hundred and sixty-nine (24,769) New Shares have been subscribed by ADVENT

LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-F LIMITED PARTNERSHIP, prenamed, paid up by a contribution in cash.

The total contribution of twenty-four thousand seven hundred and sixty-nine US dollars (USD 24,769.-) will be entirely

allocated to the share capital of the Company.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the articles of incorporation of the Company is

amended and now reads as follows:

« Art. 6. The share capital is set at ninety-three thousand two hundred and sixty-nine US dollars (USD 93,269.-)

represented by ninety-three thousand two hundred and sixty-nine (93,269) shares with a par value of one US dollar (USD
1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to two thousand euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- ADVENT LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-F LIMITED PARTNERSHIP, un partnership régi selon les

lois de l'Etat du Delaware, ayant son siége social au C/O ADVENT INTERNATIONAL CORPORATION, 75 State Street,
29th Floor, Boston, MA 02109, Etats Unis,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous

seing privé donnée en date du 22 juin 2007.

La procuration signée ne varietur par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de ADVENT MANGO 5 (ci après la «Société»), une société à res-

ponsabilité limitée ayant son siège social au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.787, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 7 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 29 juin 2006, numéro 1256 et dont
les statuts ont été amendés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 mai 2006, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations du 2 août 2006, numéro 1478.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de changer la valeur nominale des parts sociales existantes de cent US dollars (USD 100,-) à

un US dollar (USD 1,-) chacune, de sorte que le capital social est représenté par soixante-quatre mille neuf cents (64.900)
parts sociales d'un US dollar (USD 1,-) chacune.

119507

<i>Deuxième résolution

L'associé  unique  décide  d'augmenter  le  capital  social  de  la  Société  à  concurrence  de  vingt-quatre  mille  sept  cent

soixante-neuf US dollars (USD 24.769,-), afin de le porter de son montant actuel de soixante-huit mille cinq cents US
dollars (USD 68.500,-) jusqu'à quatre-vingt-treize mille deux cent soixante-neuf US dollars (USD 93.269,-) et ce par la
création et l'émission de vingt-quatre mille sept cent soixante-neuf (24.769) nouvelles parts sociales ayant une valeur
nominale d'un US dollar (USD 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les
«Nouvelles Parts Sociales»).

Les vingt-quatre mille sept cent soixante-neuf (24.769) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par ADVENT LATIN

AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND III-F LIMITED PARTNERSHIP, prénommée, payées par un apport en numéraire.

L'apport de vingt-quatre mille sept cent soixante-neuf US dollars (USD 24.769,-) sera entièrement alloué au capital

social.

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

A la suite des résolutions ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme

suit:

« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quatre-vingt-treize mille deux cent soixante-neuf US dollars (USD

93.269,-) représenté par quatre-vingt-treize mille deux cent soixante-neuf (93.269) parts sociales d'une valeur d'un US
dollar (USD 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.»

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice a la somme de deux mille euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2007. Relation: EAC/2007/7530. — Reçu 184,31 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 10 août 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007119391/239/113.
(070136723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Even Germany Zwei S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 132.181.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the first day of August.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

EVEN GERMANY S.C.A., société en commandite par actions, a company incorporated under the laws of Luxembourg

by a deed of notary Paul Bettingen on November 27th, 2006, published in the Mémorial C, number 185 on February 15th,
2007, having its registered office at 73, Côte dEich, L-1450 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 121.940, here represented
by its manager EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à r.l., which is itself represented by its duly appointed Category
B managers, Mr Camille Paulus and Mr Eric Vanderkerken, who are themselves here represented by Matthias Pons, lawyer,
residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on July 31st, 2007.

Which proxy shall be signed ne varietur by the attorney of the above named person and the undersigned notary and

shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.

The above named party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed

a single member limited liability company and to draw up its Articles of Association as follows:

119508

Title I.- Name - registered office - purpose -duration

Art. 1. There is hereby established a single member limited liability company which will be governed by the laws in

effect and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies, as amended from time to time,
September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on single member limited liability
companies (hereafter the «Law») as well as by the present articles (hereafter the «Articles»).

Art. 2. The name of the company is EVEN GERMANY ZWEI S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place in

the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its participants deliberating in the manner provided for
amendments to the Articles.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of real estate, stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the
possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises  and  may  render  any  assistance  by  way  of  loan,  guarantees  or  otherwise  to  subsidiaries,  affiliated  or  group
companies. The corporation may also establish branches in Luxembourg and abroad. The corporation may borrow in
any form against liquid of fixed assets from related or unrelated companies, it may also proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial Operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The company is established for an unlimited term.

Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants will not put an end to the company.

Title II.- Capital - Parts

Art. 7. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into one

hundred (100) parts of one hundred and twenty-five euro (EUR 125,-) each.

The company shall have an authorised share capital of fifteen million euro (EUR 15,000,000.-) divided into one hundred

and twenty thousand (120,000.-) parts having a nominal value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each.

The board of managers of the company is hereby authorised to issue further parts, with or without issue premium,

so as to bring the total capital of the company up to the amount of the authorised share capital. The board of managers
is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for such parts from time to time, to accept
subscriptions for such parts, and to accept contributions in cash or in kind as payment of the issue price for such parts.

This authorisation is granted for a period of three (3) years from the date of publication of the present articles, for

purposes of financing the acquisition of real estate property mainly in Germany or to discharge any liability incurred in
or amount due as a result of its formation. The period of this authority may be extended by resolution of the sole
participant or, as the case may be, of the general meeting of participants, in the manner required for amendment of these
articles of association.

The board of managers is further authorized to issue convertible bonds or assimilated instruments, bonds with sub-

scription  rights  attached,  or  any  debt  financial  instruments  convertible  into  parts  under  the  conditions  which  it  will
determine, provided however that these bonds or instruments are not to be issued to the public.

When the board of managers effects a whole or partial increase in capital pursuant to the above provisions, it shall be

obliged to take steps to amend this article in order to record the change. The board of managers is hereby authorised
to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment.

Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter

vivos to non-participants may only be made with the prior approval given in general meeting of participants representing
at least three quarters of the share capital of the company.

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the Law.

Art. 9. The heirs, representatives or entitled persons of a participant and creditors of a participant cannot, under any

circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any
way in its administration.

119509

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

Title III.- Management

Art. 10. The company is managed by one or more managers appointed by the participants for an undetermined term.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) may be revoked ad
nutum.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is invested with the broadest powers to

perform all acts necessary or useful for the accomplishment of the corporate purpose of the company, except those
expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of participants.

Any litigation involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by

the manager, or in case of plurality of managers, by the board of managers represented by the manager delegated for this
purpose.

In case of plurality of managers, the company shall be bound by the joint signature of any two members of the board

of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

In case of plurality of managers, the board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of its

members is present either in person or by proxy.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the votes of the managers present either

in person or by proxy.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of

managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device)
to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be
counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.

Title IV.- General meeting of participants

Art. 11. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under

section XII of the law of August 10th, 1915.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall

be in writing and shall be recorded in minutes, kept in a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written

consultation at the instigation of the management. Resolutions shall be validly adopted by the participants representing
more than fifty per cent (50%) of the capital.

However, resolutions to alter the Articles of the company may only be adopted by a quorum of at least fifty per cent

of the existing participants and the affirmative vote of at least three quarters of the company's votes present or repre-
sented at the general meeting amending the Articles, further subject to the provisions of the Law.

All general meetings of participants shall take place in Luxembourg.
Each part carries one vote at all meetings of participants.
Any participant may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a participant, to represent him

at a general meeting of participants and to vote in his name and stead.

Title V.- Financial year - profits - reserves

Art. 12. The financial year of the company starts on the first day of October of each year and ends on the last day of

September of the following year.

Art. 13. Each year on the last day of September an inventory of the assets and the liabilities of the company as well as

a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the pro-

visions and taxes constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory

as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

119510

The remainder of the net profit is at the disposal of the general meeting of participants.

Title VI.- Dissolution - liquidation

Art. 14. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need

not be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law. The
liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse

the contribution made by the participants on the parts of the company.

The final surplus will be distributed to the participants in proportion to their respective participation in the company.

Title VII.- Varia

Art. 15. The parties refer to the existing Law and regulations for all matters not mentioned in the present Articles.

<i>Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the formation of the company and shall end on the 30th day of

September 2008.

<i>Subscription

The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe to the entire capital as follows:

Parts

EVEN GERMANY SCA, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

The parts have been fully paid up to the amount of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) per part by a

contribution in cash of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).

As a result, the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is as of now at the disposal of the company

as has been certified to the notary executing this deed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of its organization, are estimated at approximately EUR 1,500.- (one thousand five hundred Euro).

<i>Extraordinary general meeting

After the Articles have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to hold an

extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is fixed at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;
2) Have been elected managers (gérants) of the company for an undetermined term:

<i>Board of Managers:

a) Erik Vanderkerken, company director, born on January 27th, 1964 in Esch-sur-Alzette, and having his professional

residence at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;

b) Pascal Bruzzese, company director, born on April 7, 1966 in Esch-sur-Alzette, Luxembourg, having his professional

residence at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg; and

c) Michael Levy, company director, born on March 7, 1973 in Geneva, Switzerland, and having his professional residence

at Rue Vautier 17, CH-1227 Carouge, Schweiz.

3) Has been appointed independent auditor PricewaterhouseCoopers, 400, route d'Esch, BP 1443, L- 1014 Luxem-

bourg.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English followed by a German version, on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and German text, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahr zweitausendundsieben, am ersten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen mit Amtswohnsitz in Niederanven.

Erschien folgende Person:

EVEN GERMANY S.C.A., eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, société en commandite par actions, eine nach dem

luxemburgischen Recht durch Urkunde des Notars Paul Bettingen am 27. November 2006, veröffentlicht am 15. Februar
2007 im Mémorial C, Nummer 185, gegründete Gesellschaft, die ihren Sitz in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg, R.C.S.

119511

Luxemburg B 121940 hat, und hier durch ihren Manager EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à r.l. vertreten wird,
welcher wiederum durch seine beiden Kategorie B Geschäftsführer Herrn Camille Paulus und Herrn Eric Vanderkerken
vertreten wird und hier durch Matthias Pons, Jurist, mit Adresse in Luxemburg, im Wege einer am 31. Juli 2007 begebenen
Vollmacht, vertreten wird.

Welche Vollmacht, nachdem sie durch den oben benannten Vertreter und den unterzeichnenden Notar ne varietur

gezeichnet wurde, mit dieser Urkunde verbunden bleiben soll, um zusammen registriert zu werden.

Die oben benannte Partei, vertreten wie oben erwähnt, erklärt ihre Absicht, mit dieser Urkunde eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung mit nur einem Gesellschafter zu gründen und die folgende Satzung aufzuzeichnen:

Titel I.- Firma - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden luxemburgi-

schen  Gesetzen  und  insbesondere  dem  Gesetz  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften  und  dessen
Abänderungen, dem Gesetz vom 18. September 1933 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wie abgeändert, und
dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Gesellschafter Gesellschaft mit beschränkter Haftung (hiernach die
«Gesetze») und der hiernach folgenden Satzung (die «Satzung») unterliegt.

Art. 2. Die Gesellschaft führt die Firma EVEN GERMANY ZWEI S.à r.l.

Art. 3. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg. Er kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach

den gesetzlichen Regelungen, die für eine Satzungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des
Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Im Falle außergewöhnlicher politischer oder wirtschaftlicher Ereignisse, welche auftreten oder sich dringlich ergeben

und die normale Aktivität oder Kommunikation am Gesellschaftssitz mit dem Ausland erschweren, kann der Gesell-
schaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis diese Ereignisse oder Umstände nicht mehr vorhanden sind.

Eine solche Entscheidung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Die Entscheidung wird durch das

Organ der Gesellschaft an Drittparteien bekannt gemacht, welches am besten dafür in der Lage ist.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften,

deren Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Austausch oder
auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Wertpapieren oder
Effekten aller Art sowie der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeglicher finanzieller, industrieller oder kommerzieller

Gesellschaften beteiligen und kann finanzielle Unterstützung im Wege von Darlehen, Garantien oder auf sonstige Weise
geben an verbundene Unternehmen oder Unternehmen derselben Gruppe. Die Gesellschaft kann auch Zweigstellen in
Luxemburg oder im Ausland begründen. Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen gegen flüssige oder
fixe Vermögenswerte von verbundenen oder nicht verbundenen Unternehmen, und kann Schuldinstrumente ausgeben.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen, jede Art finanzieller, beweg-

licher  und  unbeweglicher,  kommerzieller  und  industrieller  Operationen  tätigen,  welche  sie  zur  Verwirklichung  und
Förderung ihres Zweckes für notwendig erachtet.

Art. 5. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.

Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht durch Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Verlust der Geschäftsfähigkeit eines

Gesellschafters aufgelöst.

Titel II.- Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 7. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig euro (EUR 125,-).

Die Gesellschaft hat ein autorisiertes Kapital in Höhe von fünfzehn Millionen euro (EUR 15.000.000,-) eingeteilt in

einhundertzwanzigtausend (120.000) Anteile mit einem Nominalwert von einhundertfünfundzwanzig euro (EUR 125,-).

Die Geschäftsführung ist authorisiert, weitere Anteile auszugeben, mit oder ohne Aktienagio, um das Gesamtkapital

der Gesellschaft bis auf den Wert des authorisierten Kapitals zu erhöhen. Die Geschäftsführung ist authorisiert, die
Bedingungen zu bestimmen, welche mit der Zeichnung solcher neuen Anteile zusammenhängen von Zeit zu Zeit, Zeich-
nungen für diese Anteile zu akzeptieren, und die Einzahlungen in bar oder als Sacheinlage in Höhe des Ausgabepreises
entgegenzunehmen.

Diese Authorisierung ist für eine Zeitperiod von drei (3) Jahren beginnend mit dem Datum der Veröffentlichung dieser

Satzung und nur für die Zwecke der Finanzierung des Aufkaufes von Immobilien und Grundstücken in Deutschland sowie
für die Einlösung von Verpflichtungen der Gesellschaft im Rahmen der Gründung der Gesellschaft. Die Zeitperiode kann
durch den Beschluss des einzigen Gesellschafters oder, im gegebenen Falle, durch Beschluss der Generalversammlung
der Gesellschafter, in der Art und Weise wie für die Änderung der Satzung vorgesehen, verlängert werden.

Die Geschäftsführung ist des Weiteren befugt, Wandelschuldanleihen und sonstige Schuldverschreibungen, mit oder

ohne Zeichnungsrechte oder sonstige Schuldinstrumente, welche in Aktien umwandelbar sind, auszugeben, vorausgesetzt,
diese Instrumente werden nicht öffentlich angeboten.

119512

Sofern die Geschäftsführung eine teilweise oder vollständige Kapitalerhöhung beschließt im Rahmen der oben ausge-

führten Absätze, so ist die Geschäftsführung verpflichtet, alle Schritte zu unternehmen, um diesen Artikel entsprechend
abzuändern. Die Geschäftsführung ist hierbei authorisiert, alle Schritte zu unternehmen, um eine solche Änderung aus-
zuführen und zu veröffentlichen.

Art. 8. Die Anteile können, solange es nur einen Gesellschafter gibt, von diesem Gesellschafter ohne Beschränkungen

übertragen werden.

Im Falle, dass es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Eine Über-

tragung von Anteilen inter vivos an Nichtgesellschafter kann nur nach Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindes-
tens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten, erfolgen.

Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des luxemburgischen Gesetzes über die Handels-

gesellschaften verwiesen.

Art. 9. Ein Gesellschafter, seine Erben, Vertreter, Berechtigten oder Gläubiger können weder einen Antrag auf Sie-

gelanlegung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäftsgang
der Gesellschaft beeinträchtigen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung be-

ziehen.

Titel III.- Geschäftsführung

Art. 10. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche von den Gesellschaftern für eine

unbestimmte Dauer gewählt werden, verwaltet. Sofern mehrere Geschäftsführer gewählt sind, bilden sie einen Vorstand.
Die Geschäftsführer können ohne Angabe von Gründen, ad nutum, abgewählt werden.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand ist mit den größtmöglichen Befugnissen

ausgestattet, um alle Handlungen zur Verwaltung und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesell-
schaftszweck durchführen zu können, wobei ihm alle Befugnisse zustehen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder
diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugeschrieben werden.

Sollte die Gesellschaft als Klägerin oder Beklagte in einem Rechtsstreit auftreten, vertritt der Geschäftsführer, oder

im Falle des Vorstands der vom Vorstand dafür autorisierte Geschäftsführer, die Gesellschaft in ihrem eigenen Namen.

Im Falle der Ernennung mehrere Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei

Mitgliedern des Vorstandes rechtswirksam verpflichtet, wobei eine Unterschrift von einem Kategorie B Geschäftsführer
stammen muss.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand kann seine Zuständigkeiten für spezielle

Aufgaben an Unterbevollmächtigte oder an einen oder mehrere ad hoc Vertreter delegieren.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer kann der Vorstand nur wirksam entscheiden, wenn mindestens die Hälfte seiner

Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse des Vorstandes benötigen eine Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer.
Alle Treffen des Vorstands finden in Luxemburg statt.
Beschlüsse, welche von allen Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnet sind, gelten als genauso wirksam angenommen,

als wenn diese Beschlüsse bei einer korrekt einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung getroffen worden wären.
Die Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren identischen Kopien erscheinen und sie
können durch Brief, Telefax oder ähnliche Kommunikation nachgewiesen werden.

Außerdem soll jedes Vorstandsmitglied - welches an einer Vorstands sitzung im Wege einer Kommunikationshilfe

(einschließlich Telefon) teilnimmt, welche es den (selbst, durch Vollmacht oder ebenfalls durch eine Kommunikationshilfe)
anwesenden Vorstandsmitgliedern erlaubt, das andere Vorstandsmitglied jederzeit während der Sitzung zu hören und
selbst gehört zu werden - als für diese Vorstandssitzung anwesend gelten und soll bei der Aufstellung des Quorums und
mit seiner Stimme bei Abstimmungen während einer solchen Sitzung berücksichtigt werden.

Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst

gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.

Titel IV.- Gesellschafterversammlung

Art. 11. Der einzige Gesellschafter ist mit allen Zuständigkeiten ausgestattet, die der Gesellschafterversammlung nach

Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 eingeräumt werden.

Alle Entscheidungen, welche nicht in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder des Vorstands fallen, können

vom Gesellschafter getroffen werden. Jede solcher Entscheidungen muss schriftlich verfasst, in einem Protokoll festge-
halten und in einem speziellen Register registriert werden.

Sollte mehr als ein Gesellschafter existieren, so werden die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterver-

sammlung gefasst oder durch schriftliche Beratung auf Initiative der Geschäftsführung. Beschlüsse gelten nur als ange-
nommen, wenn Gesellschafter, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.

Beschlüsse zur Abänderung dieser Satzung können mit Blick auf das geltende Gesetz nur wirksam gefasst werden,

wenn ein solcher Beschluss von 2/3 der anwesenden oder vertretenen Stimmrechte gefasst wird, wobei mindestens fünzig

119513

Prozent des existierenden Gesellschaftskapitals bei der Generalversammlung anwesend sein muss, ergänzt durch die
Vorschriften des Gesetzes.

Alle Gesellschafterversammlungen finden in Luxemburg statt.
Jeder Gesellschaftsanteil beinhaltet das Recht zur Abgabe einer Stimme auf jeder Gesellschafterversammlung.
Jeder Gesellschafter kann im Wege einer schriftlichen Vollmacht eine andere Person, die kein Gesellschafter sein muss,

autorisieren, ihn auf einer

Gesellschafterversammlung zu vertreten und in seinem Namen und auf seine Rechnung abzustimmen.

Titel IV.- Geschäftsjahr - Gewinn - Reserven

Art. 12. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober eines Jahres und endet am letzten Septembertag

des darauffolgenden Jahres.

Art. 13. Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats September, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der

Gesellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.

Das Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen und

der Provisionen, stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange ob-

ligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals umfasst. Der Abzug muss allerdings wieder
bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn der Fond, zu welchem Zeitpunkt und
aus welchem Grund auch immer, vermindert wurde.

Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter zur Verfügung.

Titel VI.- Liquidation - Auflösung

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt,

welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung, mit der in Artikel 142 des
Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen Abänderungsgesetzen bestimmten Mehrheit, ernannt werden. Der (die) Li-
quidator(en) verfüg(en) über die weitestgehenden Befugnisse zur Realisierung des existierenden Vermögens und Beglei-
chung der Verpflichtungen.

Der nach der Begleichung aller Kosten, Schulden und Ausgaben, welche aufgrund der Liquidation entstehen, zur Ver-

fügung stehende Betrag soll verwendet werden, um die von den Gesellschaftern auf Gesellschaftsanteile eingezahlten
Beträge zurückzuzahlen.

Der danach noch bestehende Restbetrag wird an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Gesellschaftsbeteiligung aus-

gezahlt.

Titel VII.- Verschiedenes

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetz-

lichen Bestimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. September 2008.

<i>Zeichnung

Nachdem diese Satzung wie obenstehend verfasst wurde, erklärt die erschienene Partei, wie folgt Anteile der Gesell-

schaft zu zeichnen:

Anteile

EVEN GERMANY S.C.A., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Die Anteile wurden vollständig bis zu einem Betrag von einhundert fünfundzwanzig euro (EUR 125,-) je Anteil durch

Barzahlung in Höhe von zwölftausendfünfhundert euro (EUR 12.500,-) eingezahlt.

Als Ergebnis steht ab dem jetzigen Zeitpunkt der Gesellschaft der Betrag von zwölftausendfünfhundert euro (EUR

12.500,-) zur Verfügung, was von dem Notar, welcher diese Urkunde unterzeichnet, bestätigt wird.

<i>Kosten

Die aufgrund dieser Gründung angefallenen Ausgaben, Kosten, Entschädigungen oder Gebühren jeglicher Form, welche

durch die Gesellschaft zu begleichen sind, werden auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-) geschätzt.

<i>Außerordentliche Gesellschaftsversammlung

Nachdem diese Satzung soeben verabschiedet wurde, entscheidet der oben erwähnte einzige Gesellschafter, eine

Gesellschafterversammlung abzuhalten. Nachdem festgestellt wurde, dass die Gesellschafterversammlung wirksam kon-
stitutiert wurde, hat diese die folgenden Beschlüsse gefasst:

1) Der Sitz der Gesellschaft ist in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg;
2) Als Geschäftsführer (gérants) der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer werden folgende Personen ernannt:

119514

<i>Vorstand:

a) Erik Vanderkerken, Direktor, geboren am 27. Januar 1964 in Esch-sur-Alzette, mit professioneller Adresse in 73,

Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg;

b) Pascal Bruzzese, Direktor, geboren am 7. April 1966 in Esch-sur-Alzette, Luxemburg, mit professioneller Adresse

in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg;

c) Michael Levy, Schweizer Staatsbürger, geboren am 7. März 1973 in Genf, Schweiz, Geschäftsführer, mit Wohnsitz

in Rue Vautier 17, CH-1227 Carouge, Schweiz.

3) Wurde als unabhängiger Wirtschaftsprüfer' ernannt, PricewaterhouseCoopers, 400, route d'Esch, BP 1443, L- 1014

Luxemburg.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anweisung

der oben erschienen Partei die vorliegende Satzung in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Version verfasst
ist, und dass auf Hinweis derselben erschienen Partei im Falle von inhaltlichen Unterschieden zwischen den sprachlichen
Versionen, die englische Version massgebend sein soll.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.
Nachdem diese Urkunde der anwesenden Person, welche dem unterzeichneten Notar durch Name, Nachname, Fa-

milienstand und Anschrift bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die anwesende Person zusammen mit dem Notar diese
Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Pons, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2007, LAC/2007/21218. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Kopie, Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 24. September 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007119521/202/373.
(070136766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Unity Media S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 108.625.

In the year two thousand and seven, on the fifth of July.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, civil notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of

UNITY MEDIA MANAGEMENT S.A., having its registered office in L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin, recorded
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 108.624, itself acting as sole general partner and
manager (the «Manager») of UNITY MEDIA S.C.A., having its registered office in L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph
Hackin, recorded with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 108.625 (the «Company»),
pursuant to a resolution of the board of directors of the Manager dated 22 June 2007, here represented by Bob Calmes,
maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given in Luxembourg, on 5th July 2007.

An excerpt of the minutes of said meeting, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain

attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state his declarations as follows:
1) The Company, formerly named WESTCHESTER S.C.A., has been incorporated pursuant to a deed of the under-

signed notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, residing in Luxembourg, on 10 June 2005, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1145 of 4 November 2005. The articles of incorporation have been last
modified pursuant to a deed of the undersigned notary on 19 April 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

2) The subscribed share capital of the Company was set at seven hundred thirty-eight thousand nine hundred fifty-

eight euro and eighty-five cents (EUR 738,958.85) represented by one hundred thirty-seven thousand one hundred eighty-
two (137,182) Class A ordinary shares with a par value of five euro (EUR 5) each and by ten thousand six hundred nine
point seventy-seven (10,609.77) Class B Shares with a par value of five euro (EUR 5.-) each.

3) Pursuant to article six of the articles of incorporation, the authorised capital, including the subscribed share capital

of seven hundred thirty-eight thousand nine hundred fifty-eight euro and eighty-five cents (EUR 738,958.85), is fixed at
eight hundred forty-one million five hundred forty-nine thousand, six hundred ninety-seven euros and fifty-one cents
(EUR 841,549,697.51), consisting of (i) eight hundred forty million seven hundred fifty thousand eight hundred fifty-seven
euros and sixteen cents (EUR 840,750,857.16) for a conversion of CPECs into one hundred sixty-eight million one hundred
fifty thousand one hundred seventy-one point four three two (168,150,171.432) Class A ordinary shares with a par value

119515

of five euro (EUR 5.-) each; (iii) fifty thousand euro (EUR 50,000.-) for the issuance of ten thousand (10,000) Class A
ordinary shares with a par value of five euro (EUR 5.-) each; and (iv) nine thousand eight hundred eighty-one euros and
fifty cents (EUR 9,881.50) for the issuance of one thousand seventy-six point three (1,976.3) Class B shares with a par
value of five euro (EUR 5.-) each.

The  Manager  is  authorised  to  issue  shares  without  reserving  for  the  existing  shareholders  a  preferential  right  to

subscribe to the shares issued.

4) On 22 June 2007, the Manager of the Company decided to increase the capital up to seven hundred forty thousand

four hundred fifty-eight euro and eighty-five cents (EUR 740,458.85) through the issuance of three hundred (300) Class
B Shares with a par value of five euros (EUR 5.-) each, through a contribution in cash of thousand five hundred euro (EUR
1,500.-), out of which the entirety has been allocated to the share capital of the Company.

In accordance with article six of the articles of incorporation, the Manager has decided to suppress the preferential

right of the existing shareholders to subscribe the newly issued shares.

All the three hundred (300) newly issued Class B Shares have been subscribed as follows:
One hundred (100) new class B shares have been subscribed by Mr Jean Luc Allavena, with professional address at 6,

rue Princesse Florestine, 98000 Monaco, Principality of Monaco, for a total price of five hundred euro (EUR 500.-), out
of which the entirety has been allocated to the share capital of the Company;

One hundred (100) new class B shares have been subscribed by Mr Serge Bijnens, with professional address at 3, rue

Munster, L-2160 Luxembourg, for a total price of five hundred euro (EUR 500.-), out of which the entirety has been
allocated to the share capital of the Company;

Thirteen (13) new class B shares have been subscribed by CYRUS EUROPE MASTER FUND LTD, with address at 399

Park Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, for a total price of sixty-five euro (EUR 65.-), out of which the entirety
has been allocated to the share capital of the Company;

Seven (7) new class B shares have been subscribed by CRS FUND LTD, with address at 399 Park Avenue, 39th Floor,

New York, NY 10022, for a total price of thirty-five euro (EUR 35.-), out of which the entirety has been allocated to the
share capital of the Company;

Eighty (80) new class B shares have been subscribed by CYRUS OPPORTUNITIES MASTER FUND II LTD, with address

at 399 Park Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, for a total price of four hundred euro (EUR 400.-), out of which
the entirety has been allocated to the share capital of the Company;

All such shares have been entirely paid up so that the total sum of thousand five hundred euro (EUR 1,500.-) has been

put at the disposal of the Company as was justified to the undersigned notary.

As a consequence of such increase of share capital, article six, of the articles of incorporation is amended and now

reads as follows:

« Art. 6.
(a) Subscribed Capital
The subscribed capital is fixed at seven hundred forty thousand four hundred fifty-eight euro and eighty-five cents

(EUR 740,458.85) represented by one hundred thirty-seven thousand one hundred eighty-two (137,182) Class A ordinary
shares with a par value of five euros (EUR 5.-) each and by ten thousand nine hundred nine point seventy-seven (10,909.77)
Class B Shares with a par value of five euros (EUR 5) each.

The authorised capital, including the subscribed share capital of seven hundred forty thousand four hundred fifty-eight

euro and eighty-five cents (EUR 740,458.85) is fixed at eight hundred forty-one million five hundred forty-nine thousand,
six hundred ninety-seven euros and fifty-one cents (EUR 841,549,697.51), consisting of (i) eight hundred forty million
seven hundred fifty thousand eight hundred fifty-seven euros and sixteen cents (EUR 840,750,857.16) for a conversion
of CPECs into one hundred sixty-eight million one hundred fifty thousand one hundred seventy-one point four three two
(168,150,171.432) Class A ordinary shares with a par value of five euro (EUR 5.-) each; (iii) fifty thousand euros (EUR
50,000.-) for the issuance of ten thousand (10,000) Class A ordinary shares with a par value of five euro (EUR 5.-) each;
and (iv) eight thousand three hundred eighty-one euro and fifty cents (EUR 8,381.5) for the issuance of one thousand six
hundred seventy-six point three (1,676.3) Class B shares with a par value of five euro (EUR 5.-) each. During the period
of five years, from the date of the publication of the amendment of these articles of association, the GP be and is hereby
authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as it shall see
fit (and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe
to the shares issued).

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the

general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association. The
Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

The Class A Ordinary Shares
i. Generally. All Class A ordinary shares shall be identical in all respects. All Class A ordinary shares shall share ratably

in the payment of dividends and in any other distributions with respect to Class A ordinary shares which are allocated
on an aggregate basis to such Class A ordinary shares. All Class A ordinary shares purchased or otherwise acquired by

119516

the Company shall, if the GP so directs, be retired with the effect that the issued number of Class A ordinary shares is
reduced.

ii. Voting Rights. Each Class A ordinary share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which

shareholders have the right to vote.

iii. Redemption; Convertibility. Class A ordinary shares will not be subject to mandatory redemption (except as may

from time to time be approved by the GP and set forth in a separate agreement) and will not be convertible into any
other shares.

(c) The Class B Ordinary Shares
i. Generally. All Class B ordinary shares shall be identical in all respects. All Class B ordinary shares shall participate in

the payment of dividends and in any other distributions with respect to Class B ordinary shares in the manner set forth
herein. All Class B ordinary shares purchased or otherwise acquired by the Company shall, if the GP so directs, be retired
with the effect that the issued number of Class B ordinary shares is reduced.

ii. Voting Rights. Each Class B ordinary share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which

shareholders have the right to vote.

iii. Redemption; Convertibility. Class B ordinary shares will not be subject to mandatory redemption (except as may

from time to time be approved by the GP and set forth in a separate agreement) and will not be convertible into any
other shares.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English text and the German text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearing person, said appearing person signed together with the notary the

present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundsieben, den fünften Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, handelnd als Bevollmächtigter des Verwaltungsrates der

Gesellschaft UNITY MEDIA MANAGEMENT S.A. mit Gesellschaftssitz in L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, einge-
tragen  im  Handels-  und  Gesellschaftsregister  in  Luxemburg  Sektion  unter  der  Nummer  B  108.624,  diese  ihrerseits
handelnd als einziger Komplementär und Manager von UNITY MEDIA S.C.A. mit Gesellschaftssitz in L-1746 Luxembourg,
2, rue Joseph Hackin, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg Sektion unter der Nummer B
108.625, gemäß eines Beschlusses des Verwaltungsrates vom 22. Juni 2007.

Ein Auszug des Protokolls dieser Sitzung wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den

Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben registriert zu werden.

Der Erschienene, in der obengenannten Eigenschaft handelnd, hat den unterzeichneten Notar gebeten folgende De-

klarationen festzulegen:

1) Die Aktiengesellschaft UNITY MEDIA S.C.A., vormals WESTCHESTER S.C.A., wurde gemäß Urkunde des unter-

zeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen am 10. Juni 2005 gegründet, welche Urkunde veröffentlicht wurde im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1145 vom 4. November 2005. Die Satzung wurde zum letzten
Mal abgeändert gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 19. April 2007, noch nicht veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

2) Das gezeichnet Kapital der Gesellschaft war auf siebenhundertachtunddreißigtausendneunhundertachtundfünfzig

Euro und fünfundachtzig Cent (EUR 738.958,85) festgesetzt, aufgeteilt in hundertsiebenunddreißigtausendeinhundert-
zweiundachtzig (137.182) Klasse A Stammaktien und zehntausendsechshundertneun Komma siebenundsiebzig (10.609,77)
Aktien der Klasse B, mit einem Nennwert von jeweils fünf Euro (EUR 5,-) pro Aktie.

3) Gemäß Artikel sechs der Satzung beträgt das genehmigte Aktienkapital, einschließlich des gezeichneten Aktienka-

pitals  von  siebenhundertachtunddreißigtausendneunhundertachtundfünfzig  Euro  und  fünfundachtzig  Cent  (EUR
738.958,85), achthunderteinundvierzig Millionen fünfhundertneunundvierzigtausendsechshundertsiebenundneunzig Euro
und einundfünfzig Cent (EUR 841.549.697,51), bestehend aus (i) achthundertvierzig Millionen siebenhundertfünfzigtau-
sendachthundertsiebenundfünfzig  Euro  und  sechzehn  Cent  (EUR  840.750.857,16)  zur  Umwandlung  von  CPECs  in
einhundertachtundsechzig Millionen einhundertfünfzigtausendeinhunderteinundsiebzig Komma vierhundertzweiunddrei-
ßig (168.150.171,432) Klasse A-Stammaktien mit einem Nennwert von je fünf Euro (EUR 5,-); (iii) fünfzigtausend Euro
(EUR 50.000,-) zur Ausgabe von zehntausend (10.000) Klasse A-Stammaktien, und (iv) neuntausendachthunderteinun-
dachtzig Euro und fünfzig Cent (EUR 9.881,50) zur Ausgabe von eintausendneunhundertsechsundsiebzig Komma dreißig
(1.976,30) Klasse B-Aktien mit einem Nennwert von je fünf Euro (EUR 5,-). Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Aktien
auszustellen ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen.

119517

4) In seiner Sitzung vom 22. April 2007, hat der Verwaltungsrat beschlossen, das Gesellschaftskapital auf siebenhun-

dertvierzigtausendvierhundertachtundfünfzig Euro und fünfundachtzig Cents (EUR 740.458,85) zu erhöhen durch Ausgabe
von dreihundert (300) neuen Aktien der Klasse B, mit einem Nennwert von jeweils fünf Euro (EUR 5,-) pro Aktie, bei
Erhalt einer Zahlung von jeweils fünf Euro (EUR 5,-) pro Aktie durch Bareinzahlung von eintausendfünfhundert (EUR
1.500,-), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde.

Gemäß Artikel 6 der Satzung, hat der Verwaltungsrat das Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre in Bezug auf die

neu ausgegebenen Aktien eingestellt.

Alle dreihundert (300) neuen Aktien der Klasse B wurden folgend gezeichnet:
Einhundert (100) neue Aktien der Klasse B durch Herrn Jean Luc Allavena, mit Wohnsitz in 6, rue Princesse Florestine,

98000 Monaco, zu einem Gesamtpreis von fünfhundert Euro (EUR 500,-), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital
zugeteilt wurde;

Einhundert (100) neue Aktien der Klasse B durch Herrn Serge Bijnens, mit Wohnsitz in 3, rue Munster, L-2160 Lu-

xembourg, zu einem Gesamtpreis von fünfhundert Euro (EUR 500,-), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt
wurde;

Dreizehn (13) neue Aktien der Klasse B durch CYRUS EUROPE MASTER FUND LTD, mit Sitz in 399 Park Avenue,

39th Floor, New York, NY 10022, für einen Gesamtpreis von fünfundsechzig Euro (EUR 65,-), wovon die Gesamtheit
dem Aktienkapital zugeteilt wurde;

Sieben (7) neue Aktien der Klasse B durch CRS FUND LTD, mit Sitz in 399 Park Avenue, 39th Floor, New York, NY

10022, für einen Gesamtpreis von fünfunddreißig Euro (EUR 35,-), wovon die Gesamtheit dem Aktienkapital zugeteilt
wurde;

Achtzig (80) neue Aktien der Klasse B durch CYRUS OPPORTUNITIES MASTER FUND II LTD, mit Sitz in 399 Park

Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, für einen Gesamtpreis von vierhundert Euro (EUR 400,-), wovon die Ge-
samtheit dem Aktienkapital zugeteilt wurde;

Alle diese Aktien wurden vollständig eingezahlt, so dass die Gesamtsumme von eintausendfünfhundert (EUR 1.500,-)

zur freien Verfügung der Gesellschaft stehen, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Folglich der Kapitalerhöhung ist Artikel 6 der Satzung abgeändert und lautet in Zukunft wie folgt:
« Art. 6.
a) Gezeichnetes Aktienkapital
Das gezeichnete Aktienkapital beträgt siebenhundertvierzigtausendvierhundertachtundfünfzig Euro und fünfund achtzig

Cents  (EUR  740.458,85)  und  ist  in  einhundertsiebenunddreißigtausendeinhundertzweiundachtzig  (137.182)  Klasse  A-
Stammaktien mit einem Nennwert von je fünf Euro (EUR 5,-) und zehntausendneunhundertneun Komma siebenundsiebzig
(10.909,77) Klasse B-Stammaktien mit einem Nennwert von je fünf Euro (EUR 5,-) aufgeteilt.

Das genehmigte Aktienkapital, einschließlich des gezeichneten Aktienkapitals von siebenhundertvierzigtausendvier-

hundertachtundfünfzig  Euro  und  fünfundachtzig  Cents  (EUR  740.458,85),  beträgt  achthunderteinundvierzig  Millionen
fünfhundertneunundvierzigtausendsechshundertsiebenundneunzig  Euro  und  einundfünfzig  Cent  (EUR  841.549.697,51),
bestehend aus (i) achthundertvierzig Millionen siebenhundertfünfzigtausendachthundertsiebenundfünfzig Euro und sech-
zehn Cent (EUR 840.750.857,16) zur Umwandlung von CPECs in einhundertachtundsechzig Millionen einhundertfünfzig-
tausendeinhunderteinundsiebzig Komma vierhundertzweiunddreißig (168.150.171,432) Klasse A-Stammaktien mit einem
Nennwert von je fünf Euro (EUR 5,-); (iii) fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) zur Ausgabe von zehntausend (10.000)
Klasse A-Stammaktien, und (iv) achttausenddreihunderteinundachtzig Euro und fünfzig Cent (EUR 8.381,50) zur Ausgabe
von eintausend sechshundertsechsundsiebzig Komma dreißig (1.676,3) Klasse B-Aktien mit einem Nennwert von je fünf
Euro (EUR 5,-). Während eines Zeitraums von fünf Jahren ab der Veröffentlichung dieser Satzungsänderung, ist die GP
hiermit zur Ausgabe von Aktien und zur Erteilung von Optionen zur Zeichnung von Aktien berechtigt, an solche Personen
und  zu solchen  Bedingungen wie  sie  dies  für geeignet  hält  (Die  GP  ist  in  diesem  Zusammenhang  insbesondere  dazu
berechtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den bestehenden Aktionären Vorzugsrechte in Bezug auf die Zeichnung
der ausgegebenen Aktien einzuräumen).

Das gezeichnete und das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch einen entsprechend den Erfordernissen für

Satzungsänderungen angenommenen Beschluss der Aktionärshauptversammlung erhöht oder herabgesetzt werden. Die
Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

(b) Die Klasse A-Stammaktien
i. Allgemein. Alle Klasse A-Stammaktien sind in jeder Hinsicht identisch. Alle Klasse A-Stammaktien haben anteilmäßig

an der Zahlung von Dividenden und jedweden sonstigen Ausschüttungen in Bezug auf Klasse A-Stammaktien teil, die
diesen Klasse A-Stammaktien als Gesamtbetrag zugeteilt werden. Alle seitens der Gesellschaft gekauften oder anderweitig
erworbenen Klasse A-Stammaktien sind auf Anweisung der GP zurückzuziehen, mit der Folge, dass die ausgegebene
Anzahl an Klasse A-Stammaktien verringert wird.

ii. Stimmrechte. Jede Klasse A-Stammaktie berechtigt ihren Inhaber zur Abgabe einer Stimme im Hinblick auf sämtliche

Angelegenheiten, über die die Aktionäre zur Abstimmung berechtigt sind.

119518

iii. Rückkauf: Umwandelbarkeit. Klasse A-Stammaktien unterliegen nicht dem Tilgungsverbot (es sei denn, dies wird

von Zeit zu Zeit von der GP genehmigt und in einer gesonderten Vereinbarung dargelegt) und können in keine anderen
Anteile umgewandelt werden.

c) Die Klasse B-Stammaktien
i.  Allgemein.  Alle  Klasse  B-Stammaktien  sind  in  jeder  Hinsicht  identisch.  Alle  Klasse  B-Stammaktien  haben  an  der

Zahlung von Dividenden und jedweden sonstigen Ausschüttungen in Bezug auf Klasse B-Stammaktien in der hierin be-
schriebenen  Art  und  Weise  teil.  Alle  seitens  der  Gesellschaft  gekauften  oder  anderweitig  erworbenen  Klasse  B-
Stammaktien  sind  auf  Anweisung  der  GP  zurückzuziehen,  mit  der  Folge,  dass  die  ausgegebene  Anzahl  an  Klasse  B-
Stammaktien verringert wird.

ii. Stimmrechte. Jede Klasse B-Stammaktie berechtigt ihren Inhaber zur Abgabe einer Stimme im Hinblick auf sämtliche

Angelegenheiten, über die die Aktionäre zur Abstimmung berechtigt sind.

iii. Rückkauf; Umwandelbarkeit. Klasse B-Stammaktien unterliegen nicht dem Tilgungsverbot (es sei denn, dies wird

von Zeit zu Zeit von der GP genehmigt und in einer gesonderten Vereinbarung dargelegt) und können in keine anderen
Anteile umgewandelt werden.»

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage des Er-

schienenen die gegenwärtige

Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage des gleichen Erschienenen

und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung, wird die englische Fassung massge-
bend sein.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Calmes, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2007, LAC/2007/17793. — Reçu 15 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007119216/5770/235.
(070136695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Helvoet Pharma International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 67.466.

Lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 26 avril 2007, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Pierre L B Wijnen, avec adresse au 212A, Cleynhenslaan, B-3140 Keer-

bergen, Belgique, de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

- Nomination de Monsieur Willy Van de Poel, avec adresse au 40, Duinhoekstraat, B-8660 De Panne, Belgique, en tant

qu'administrateur avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui
statuera sur les comptes annuels de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

- Renouvellement du mandat de Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, en tant qu'administrateur avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'As-
semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007 et qui
se tiendra en 2008.

- Renouvellement du mandat de Monsieur Paul Johann Halg, avec adresse au 31, Gotthardstrasse, CH-6460 Altdorf,

Suisse, en tant qu'administrateur avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale
Annuelle qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

- Renouvellement du mandat de Monsieur Silvio A Magagna, avec adresse au 31, Gotthardstrasse, CH-6460 Altdorf,

Suisse, en tant qu'administrateur avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale
Annuelle qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

- Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg,

en  tant  que  commissaire  avec  effet  immédiat  et  pour  une  période  venant  à  échéance  lors  de  l'Assemblée  Générale
Annuelle qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

119519

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007119046/581/30.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2007, réf. LSO-CI05979. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070136699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Strategy S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 34.993.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le trois octobre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme de droit panaméen dénommée BURNETT HOLDINGS S.A. établie et ayant son siège social à East

53rd Street, Swiss Bank Building, 2nd floor, Panama City, Republique de Panama,

ici représentée par Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2613 Lu-

xembourg, 1, place du Théâtre,

en vertu d'une procuration délivrée en date du 6 novembre 2002.
Laquelle procuration après  avoir été  signée ne  varietur  par  le  comparant  agissant  en  sa  dite  qualité et  le  notaire

instrumentant demeurera annexée aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Lequel mandataire, agissant ès-dite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses décla-

rations et constatations;

I.- Que la société anonyme holding STRATEGY S.A., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph

II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.993, a été constituée suivant
acte reçu Maître Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Dudelange, en date du 4 octobre 1990, publié au Mémorial
C numéro 100 du 4 mars 1991.

II.- Que le capital social de la société anonyme holding STRATEGY S.A., préqualifiée, s'élève actuellement à un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), entièrement libérées.

III.- Que la comparante dûment représentée en sa qualité d'actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance des

statuts et de la situation financière de la susdite société STRATEGY S.A.

IV.- Que la comparante dûment représentée est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société et

qu'en tant qu'actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que la comparante dûment représentée déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'elle prend

à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation
de la société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l'exécution de leurs

mandats jusqu'à ce jour.

VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation des titres au porteur, le tout en présence du notaire instrumentant.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1840 Luxembourg, 39,

boulevard Joseph II.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Bittler, B. Moutrier.
Enregistré à Esch/Al., le 4 octobre 2007, Relation: EAC/2007/12013. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour copie conforme délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007119559/272/47.
(070137244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

119520


Document Outline

Advent Mango 5

Arrecife S.A.

Articvision S.A. Holding

Ausilco S.A.

Balbo Investment Holding S.A.

Barbican S.A.

BC International

Binola S.A.

Bluesky Holding S.A.

Bond Capital Partners (Luxembourg) S.A.

Bordeaux Participations

CACEIS Bank Luxembourg

Cemex Capital Investments S.à r.l.

Compagnie de Promotion des Investissements Européens S.A.

Compagnie Financière de l'Occitanie

D-Sign Group S.A.

EHAG European Industrial Holding A.G.

Electro-Stugalux S.A.

Ernst August Carree II S.à r.l.

Ernst August Carree S.à r.l.

Ernst August Carree S.à r.l.

Estaima S.A.

Even Germany Zwei S.à r.l.

Finbourg Finance S.A.

Fiparind

FO DBH S.A.

France Outlet Mall Holding (No.2) S.à r.l.

Frank's Mexico Holding S.à r.l.

Gerinter S.A.

Gerthoma Number Two S.A.

Glenbrook S.à r.l.

G.M. Aviation Services

Great American Stores B

Haddington S.à r.l.

Hazel Holding S.A.

Helvoet Pharma International S.A.

HLC S.à r.l.

H.N.L. S.à r.l.

Hosei Gijuku Luxembourg S.A.

Hydromot Sàrl

Jourdain S.à.r.l.

Karat S.àr.l.

Limpertsberg Real Estate Company S.A.

Louisiane S.A.

Maddiston S.à r.l.

Massilia Holding S.A.

Masthead

Rheinisch-Luxemburger Immobilien A.G.

Rheinlanddamm II S.à r.l.

Rubia S.àr.l.

Sibelga S.A.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka I Alpha S.à r.l.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka III Gamma S.à r.l.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka IV Delta S.à r.l.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka IV S.à r.l.

Sivry S.A.H.

Société Financière de Nolay S.A.

Société Internationale d'Investissements Financiers Sàrl

Sprumex S.A.

Strategy S.A.

Stryker Luxembourg S.à r.l.

Unity Media S.C.A.

Unity Media S.C.A.

Virgilate Holding S.A.