logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2434

26 octobre 2007

SOMMAIRE

Abowijs International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

116801

Advanced Network Solutions S.à r.l.  . . . . .

116789

Advent Stoco Investment S.à. r.l.  . . . . . . . .

116823

Advent Stoco Investment S.à. r.l.  . . . . . . . .

116810

Arlington Europe Finance S.à r.l.  . . . . . . . .

116813

Art Limited Company S.A. . . . . . . . . . . . . . .

116829

B.E.E.P. (Business Economy Engineering

Projects) Luxembourg, S.àr.l.  . . . . . . . . . .

116822

Benelugap S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116819

Berrak Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116818

CAMPIMOL Société Financière de la Cam-

pine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116810

Capital Target Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . .

116817

CEFIP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116818

CEP II Participations S.à r.l. SICAR  . . . . . .

116817

Communauté d'Exploitation agricole

DENNEWALD-KLENSCH et Cie  . . . . . .

116811

CVI GVF Luxembourg Eighteen S.à r.l.  . .

116790

CVI GVF Luxembourg Nineteen S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116803

Edelweiss Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . .

116819

Entente des Syndicats d'Initiative et de

Tourisme des Communes de Burmeran-
ge, Mondorf-les-Bains, Remich, Schengen
et Wellenstein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116819

Euromachines S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116797

European Retail Income Venture S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116797

Extensity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116802

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.  . . . . .

116790

GEBPF Finance (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

116813

Holding d'Investissement et de Placement

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116818

Lancaster Invest Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

116802

Luxore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116786

Mars Propco 18 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116786

Mars Propco 19 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116786

Mars Propco 23 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116789

Mars Propco 26 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116810

Mars Propco 28 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116789

Mars Propco 32 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116797

Mars Propco 34 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116797

Mars Propco 40 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116787

Metrosphère Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .

116787

MOOR PARK MB 14 Kassel bei Vellmar S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116830

Noe Participations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116818

Poseidon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116811

PPF Banimmo Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . .

116812

PPF Brittany Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

116812

PYTHON Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

116830

PYTHON Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

116830

Red Nova S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116830

RES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116817

Robin Finance Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

116831

Technet Investment Holding  . . . . . . . . . . . .

116811

TriCage Acquisition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116815

116785

Mars Propco 18 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 12.500,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.310.

EXTRAIT

En date du 10 août 2007, le conseil d'administration a décidé de transférer son siège social du 14A, rue des Bains,

L-1212 Luxembourg, au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, avec effet au 13 août 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2007.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007115748/7801/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06591. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070132817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Mars Propco 19 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.311.

EXTRAIT

En date du 10 août 2007, le conseil d'administration a décidé de transférer son siège social du 14A, rue des Bains,

L-1212 Luxembourg, au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, avec effet au 13 août 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2007.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007115749/7801/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06592. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Luxore, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 115.661.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le trente août.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1. Monsieur Pierre Martin, né à Rennes (F), le 20 avril 1952, avec adresse professionnelle à 75, Parc d'activité - L-8308

Capellen, propriétaire de 50 actions.

Ici représenté par son Monsieur Benoît de Bien, consultant, avec adresse professionnelle à L-9515 Wiltz, en vertu

d'une procuration sous seing privé donnée à Cannes, le 31 juillet 2007.

2. Monsieur Shukry Lawrence, né à Jérusalem (Israël), en 1936 avec adresse professionnelle au 75, Parc d'activité -

L-8308 Capellen, propriétaire de 50 actions.

Ici représenté par son Monsieur Benoît de Bien, consultant, avec adresse professionnelle à L-9515 Wiltz, en vertu

d'une procuration sous seing privé donnée à Cannes, le 25 juillet 2007.

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le notaire et le comparant, resteront annexées au

présent acte.

Lesquels comparants, tels que représentés, ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

116786

Que les comparants sont seuls actionnaires de la société anonyme LUXORE, dont le siège social est à L-8308 Capellen

75, Parc d'activité, constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Anja Holtz, soussigné, le 29 mars 2003, publie au
Mémorial C, recueil des sociétés et associations numéro 1236 du 27 juin 2006 inscrite au registre de commerce des
société sous le numéro B 115.661

Que le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-) divisé en cent (100) actions sans valeur nominale.
Que la société ne possède pas d'immeuble, ni de parts d'immeuble.
Que les comparants représentent l'intégralité du capital social, décide de prononcer la dissolution anticipée de la

société LUXORE avec effet au 31 décembre 2006.

Qu'ils déclarent avoir pleine connaissance des statuts et connaître parfaitement la situation financière de la société

LUXORE.

Qu'ils déclarent encore:
- qu'ils sont investis de tout actif, passif et engagement,
- qu'ils prennent à leur charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou

inconnu à ce jour avant tout paiement à leurs personnes.

Que partant, la liquidation de la société est considérée comme faite et clôturée.
Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.
Que les livres et documents de la société sont conservés pendant 5 ans à l'adresse du comparant.
Que tout courrier ou notification des tiers peuvent être adressés au domicile du comparant.

<i>Frais

Le montant des frais incombant au comparant en raison des présentes est estimés à 800,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. de Bien, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 3 septembre 2007, WIL/2007/742. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Pletschette.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Wiltz, le 13 septembre 2007.

A. Holtz.

Référence de publication: 2007115639/2724/51.
(070133229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Mars Propco 40 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.315.550,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.336.

EXTRAIT

En date du 10 août 2007, le conseil d'administration a décidé de transférer son siège social du 14A, rue des Bains,

L-1212 Luxembourg, au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, avec effet au 13 août 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2007.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007115709/7801/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06667. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Metrosphère Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 115.203.

L'an deux mille sept, le vingt-huit août.

116787

Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) METROSPHERE POLAND CORP., une société anonyme, régie par les lois de Canada, avec siège social à 300, Alden

Road, CDN - L3R4C1 Markham, Toronto, Canada, inscrite au Ministère de la Consommation et du Commerce sous le
numéro 1608972,

ici représentée par Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg, en vertu d'une procuration donnée le 20 juillet 2007,

2) 1410248 ONTARIO LIMITED, une société anonyme, régie par les lois de Canada, ayant son siège social à 120,

Adelaide Street West, Suite 2401, CDN - M5H1T1, Toronto, Canada, inscrite au Ministère de la Consommation et du
Commerce sous le numéro 1410248,

ici représentée par Monsieur Pierre Schill, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 20 juillet 2007.
Lesdites procurations signées ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné resteront annexées au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, sont les seules associées de METROSPHERE LUXEMBOURG

S.à r.l (la «Société»), une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous la Section B numéro 115.203, constituée suivant acte notarié, en date du 24 mars 2006, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 16 juin 2006 n° 1173. Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié
en date du 10 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 16 mars 2007 n° 390. Les
comparantes, qui représentent l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associées de la Société décident d'augmenter le capital social à concurrence de trois millions de dollars des Etats-

Unis  d'Amérique  (USD  3.000.000,-)  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  cinquante  mille  dollars  des  Etats-Unis
d'Amérique (USD 50.000,-) à trois millions cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 3.050.000,-) par la
création et l'émission de trente mille (30.000) parts sociales nouvelles, chacune ayant les mêmes droits et obligations que
les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

Les trente mille (30.000) parts sociales nouvelles sont souscrites par la société METROSPHERE POLAND CORP.,

préqualifiée,

représentée comme indiqué ci-avant,
1410248 ONTARIO LIMITED, préqualifiée, renonçant, pour autant que de besoin, à son droit préférentiel de sou-

scription.

Les parts sociales nouvelles sont entièrement libérées par conversion d'une partie d'avances faites en compte courant

que la société METROSPHERE POLAND CORP., préqualifiée, a faite à la Société.

L'apport d'une partie des avances faites en compte courant ci-dessus décrit a fait l'objet d'un rapport établi en date

du 28 août 2007, par FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., Réviseurs d'entreprises, avec siège social à Luxembourg, lequel rapport,
après signature ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent
acte pour être enregistré en même temps.

La valeur de la partie des avances faites en compte courant est constatée par ledit rapport dont la conclusion est la

suivante:

<i>«Conclusion

La valeur effective de l'apport susmentionné s'élève au moins au nombre et à la valeur nominale des 30.000 parts

sociales nouvelles à émettre par METROSPHERE LUXEMBOURG S.à r.l, c'est-à-dire USD 3.000.000,-.»

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à USD 3.050.000,- (trois millions cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique)

représenté par 30.500 (trente mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars des Etats-
Unis d'Amérique) chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital social est évalué à EUR 2.195.377,91.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de EUR 27.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

116788

Et après lecture faite au mandataire des comparantes, connu du notaire instrumentant par son nom et prénoms usuels,

état civil et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Schill, J. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2007, LAC/2007/25258. — Reçu 21.955,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2007.

J. Baden.

Référence de publication: 2007115671/7241/71.
(070133289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Mars Propco 23 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.319.

EXTRAIT

En date du 10 août 2007, le conseil d'administration a décidé de transférer son siège social du 14A, rue des Bains,

L-1212 Luxembourg, au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, avec effet au 13 août 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2007.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007115753/7801/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06605. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Mars Propco 28 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 303.700,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.324.

EXTRAIT

En date du 10 août 2007, le conseil d'administration a décidé de transférer son siège social du 14A, rue des Bains,

L-1212 Luxembourg, au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, avec effet au 13 août 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2007.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007115755/7801/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06628. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Advanced Network Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: A.N.S. Luxembourg S.à r.l..

Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 74.707.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

116789

Junglinster, le 27 septembre 2007.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
M. Goeres
<i>Déléguée par le Notaire J. Seckler

Référence de publication: 2007115956/231/15.
(070133108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 5.524.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 25 septembre 2007.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
M. Goeres
<i>Déléguée par le Notaire J. Seckler

Référence de publication: 2007115968/231/14.
(070133259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

CVI GVF Luxembourg Eighteen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.039.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-third day of August.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies' register under the number B 119.271,

duly represented by Ms. Andrea Hoffmann, private employee, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 16 August

2007.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has drawn up the following articles of incorporation of a

société à responsabilité limitée which it declares organized as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incor-
poration.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and loans and the administration, control
and development of its portfolio.

The Company may act as a general partner and manager of partnerships or similar corporate structures with unlimited

liability for all debts and obligations of such entities.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale, as well the holding, leasing, improving, managing and

mortgaging of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as the management of
all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg
or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or
lease of real estate properties.

116790

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company is incorporated under the name of CVI GVF LUXEMBOURG EIGHTEEN S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means
of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality
may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos,

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.
In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.

The manager(s) is/are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the

term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as
the case may be, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

116791

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute
grave) or wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.

Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Collective decisions of the shareholders - Decisions of the sole shareholder

Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 20. The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's financial year commences on the first of June and ends on the thirty-first of May.

Art. 22. Each year on the thirty-first of May, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole
shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators
shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

116792

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company have been subscribed by CVI GVF (LUX) MASTER

S.à r.l., as aforementioned, paid up by a contribution in cash for an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), entirely allocated to the share capital.

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is

as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 May

2008.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which are to be borne by the Company or

which shall be charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred
Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period of time:
- Mr. Gregor Klaedtke, born on 10 January 1965 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing professionally

at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Mr. Hille-Paul Schut, lawyer, born on 29 September 1977 in 's-Gravenhage, the Netherlands, residing professionally

at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, den dreiundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großherzogtums

Luxemburg, mit Sitz in 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister unter Nummer B 119.271,

hier vertreten durch Andrea Hoffmann, Privatangestellte, wohnhaft in Luxemburg aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 16. August 2007.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société

à responsabilité limitée), die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter  werden, eine  Gesellschaft mit  beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend  die  «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtli-

chen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.

Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf sowie der Besitz, die Vermietung, die Sanierung,

die Verwaltung von und die Gewährung von Hypotheken auf Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland sowie

116793

die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Erwerbs von Beteiligungen in lu-
xemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Zweck der Erwerb, die Verwertung, die Förderung, der Verkauf,
die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung CVI GVF LUXEMBOURG EIGHTEEN S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Be-

schluss der Hauptversammlung der Gesellschafter oder gegebenenfalls des alleinigen Gesellschafters an jeden beliebigen
Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch
einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden. Niederlassungen oder andere
Filialen können entweder in Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in zwölftausendfünf-

hundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-).

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese

Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss, oder gegebenenfalls der Zustimmung des alleinigen Gesellschafters.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die die Miteigentümer gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der

Gesellschaft.

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-

genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern oder gegebenenfalls von dem alleinigen Gesellschafter ernannt.

Die Gesellschafter oder der alleinige Gesellschafter bestimmen auch die Dauer ihres Mandats. Die Geschäftsführer kön-
nen jederzeit, ohne dass ein berechtigter Grund («cause légitime») hierzu bestehen muss, von den Gesellschaftern oder
dem alleinigen Gesellschafter entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers verpflichtet.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Der Geschäftsführerrat wird durch jedes seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort

einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Ge-
schäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden
ernennen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder

116794

durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der
jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern oder von einer vom Geschäftsführerrat bevollmächtigten Person unterzeichnet.

Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-

sellschaft nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer oder jedes Geschäftsführerratsmitglied sowie deren Erben, Nach-

lassverwalter und Verwalter für Ausgaben, die nach vernünftigem Ermessen in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit,
einer Klage oder einem Verfahren, bei dem der Geschäftsführer oder das Geschäftsführerratsmitglied auf Grund seiner
Funktion als gegenwärtiger oder ehemaliger Geschäftsführer oder Geschäftsführerratsmitglied der Gesellschaft oder, auf
Anfrage der Gesellschaft, jeder anderen Körperschaft, von der die Gesellschaft ein Gesellschafter oder Gläubiger ist und
von der er nicht berechtigt ist, Entschädigung zu erhalten, Partei geworden ist, entstanden sind. Dies gilt für Angelegen-
heiten bei denen letztendlich eine schwere Pflichtverletzung (faute grave) oder eine vorsätzliche Pflichtverletzung (faute
intentionnelle) erkannt wurde. Für den Fall einer Vereinbarung soll eine Entschädigung nur für solche Angelegenheiten
gezahlt werden, die von der Vereinbarung gedeckt sind, sofern die Gesellschaft von einem rechtlichen Beistand darüber
informiert wurde, dass die zu entschädigenden Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht auf
Entschädigung soll nicht die Geltendmachung anderer Rechte, zu der die Person berechtigt ist, ausschließen.

Art. 17. Die Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat können sich dazu entschließen, Zwischendividenden auszu-

schütten, und zwar auf Grundlage eines Rechenschaftsberichts, der von einem Geschäftsführer oder dem Geschäftsfüh-
rerrat vorbereitet wird und aufzeigt, dass genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag
nicht die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Rechnungsjahres überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen
Gewinne und der zur Verteilung zur Verfügung stehenden Rücklagen, jedoch abzüglich der übertragenen Verluste und
der Beträge, die einer gesetzlich oder durch die Satzung vorgeschriebenen Kapitalrücklage zugeführt werden.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 19. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel

des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 20. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

E. Geschäftsjahr - Konten- Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Juni und endet am einunddreißigsten Mai.

116795

Art. 22. Am einunddreißigsten Mai eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer

stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder
Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Zwischendividenden werden in Einklang mit den gesetzlich vorgesehen Bedingungen zugeteilt.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung, oder
gegebenenfalls  der  alleinige  Gesellschafter,  legt  die  Befugnisse  und  Vergütungen  der  Liquidatoren  fest.  Insofern  nicht
anderes vorgesehen ist, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der
Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

oder dem alleinigen Gesellschafter im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweist die Erschienene auf die Bestimmungen des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile wurden von CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., vorgenannt,

gezeichnet und durch eine Bareinlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingezahlt, die vollständig
dem Gesellschaftskapital zugewiesen wurde.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass die Gesellschaft über ein Gesellschaftskapital

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) verfügt, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Mai 2008.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

ein tausend drei hundert Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat die oben genannte Person, die das gesamte gezeichnete Gesellschafts-

kapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.
2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern ernannt:
- Herr Gregor Klaedtke geboren am 10. Januar 1965 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in 25B, boulevard Royal, L-2449

Luxemburg; und

- Herr Hille-Paul Schut, Jurist, geboren am 29. September 1977 in ´s-Gravenhage, Niederlande, beruflich wohnhaft in

20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten

Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.

Gezeichnet: A. Hoffmann, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2007, Relation: LAC/2007/24099. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, delivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007116615/211/358.
(070133768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

116796

Mars Propco 32 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 269.175,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.328.

EXTRAIT

En date du 10 août 2007, le conseil d'administration a décidé de transférer son siège social du 14A, rue des Bains,

L-1212 Luxembourg, au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, avec effet au 13 août 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2007.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007115769/7801/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06641. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070132834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Mars Propco 34 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 976.300,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.330.

EXTRAIT

En date du 10 août 2007, le conseil d'administration a décidé de transférer son siège social du 14A, rue des Bains,

L-1212 Luxembourg, au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, avec effet au 13 août 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2007.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007115762/7801/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06657. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Euromachines S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 60.171.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007115860/822/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04548. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

European Retail Income Venture S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 109.566.

In the year two thousand seven, on the fourth day of September,
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg

There appeared:

116797

Mrs Bernardine Vos, employee, residing professionally in Luxembourg,
Acting in her capacity as a special proxyholder of:
EUROPEAN RETAIL VENTURE, a Société à responsabilité limitée, having its registered office at 7, rue de la Chapelle,

L-1325 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 109.637, acting
as general partner (gérant commandité) (the «General Partner») of EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE S.C.A., a
société en commandite par actions, having its registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 109.566 (the «Company»),

by virtue of the authority conferred on her by resolutions adopted by the Board of Managers of the General Partner

of the Company on July 18, 2007.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record the following:
1) The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 14 July 2005, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») on December 7, 2005 and its Articles of Incor-
poration have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on April 18, 2007, published
in the Mémorial C dated 4 July 2007, page 64,980.

2) The issued share capital of the Company is fixed at EUR 6,781,824.- (six million seven hundred eighty-one thousand

eight hundred twenty-four Euros), divided into 59,895 (fifty-nine thousand eight hundred ninety-five) Class A Shares and
4,461,321 (four million four hundred sixty-one thousand three hundred twenty-one) Class B Shares, with a par value of
EUR 1.50 (one Euro fifty cent) each, all fully paid up (by 100%).

3) Pursuant to Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company, the capital maybe increased by an amount

of EUR 143,249,676.- (one hundred forty-three million two hundred forty-nine thousand six hundred seventy-six Euros)
at the initiative of the General Partner by creating and issuing new Shares (the rights whereof will be strictly similar to
the rights attached to the existing respective class of shares) or by increasing the nominal value of the existing shares.

The General Partner is authorised to issue the new Shares in one or more steps as it may determine from time to

time and the General Partner is specially authorised to issue the new Shares without reserving for the existing share-
holders the preferential right to subscribe for and to purchase the new shares.

4) By resolution dated 18 July 2007, the General Partner approved the increase of the share capital of the Company.

The share capital of the Company was increased with effect as of 7 August 2007 within the framework of the authorised
share capital as set forth in Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company, by an amount of EUR 3,770,508.-
(three million seven hundred seventy thousand five hundred eight Euros) in order to raise it from its current amount of
6,781,824.- (six million seven hundred eighty-one thousand eight hundred twenty-four Euros) to EUR 10,552,332.- (ten
million five hundred fifty-two thousand three hundred thirty-two Euros) by creating and issuing 12,517 (twelve thousand
five hundred seventeen) Class A Shares and 2,501,155 (two million five hundred one thousand one hundred fifty-five)
Class B Shares with a par value of EUR 1.50 (one Euro and fifty cent) each.

All the new 12,517 (twelve thousand five hundred seventeen) Class A Shares and 2,501,155 (two million five hundred

one thousand one hundred fifty-five) Class B Shares with a par value of EUR 1.50 (one Euro and fifty cent) each have been
fully subscribed with a share premium of EUR 13.50 (thirteen Euros and fifty cent) per new share and paid up in cash as
described in the below schedule.

5) Thereupon the General Partner acknowledges that the newly issued share capital of the Company has been sub-

scribed as follows:

Type, Number of shares, Holder, Price per share
Class A Shares, 12,517 Twelve thousand five hundred seventeen, EUROPEAN RETAIL VENTURE, Fifteen Euro
Class B Shares, 131,180 One hundred thirty-one thousand one hundred eighty, MUTAVIE S.A., Fifteen Euro
Class B Shares, 349,812 Three hundred forty-nine thousand eight hundred twelve, CARDIF ASSURANCE VIE, Fifteen

Euro

Class B Shares, 87,453 Eighty-seven thousand four hundred fifty-three, OP LIFE ASSURANCE COMPANY Ltd, Fifteen

Euro

Class B Shares, 174,906 One hundred seventy-four thousand nine hundred six, GERBERA S.A., Fifteen Euro
Class B Shares, 262,359 Two hundred sixty-two thousand three hundred fifty-nine, SCI VENDOME COMMERCES,

Fifteen Euro

Class B Shares, 87,453, Eighty-seven thousand four hundred fifty-three, AXA RE S.A., Fifteen Euro
Class B Shares, 218,632 Two hundred eighteen thousand six hundred thirty-two, STOREBRAND LIVSFORSIKRING

AS, Fifteen Euro

Class  B  Shares,  437,264  Four  hundred  thirty-seven  thousand  two  hundred  sixty-four,  BEDRIJFSTAKPENSIOEN-

FONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID (BPF BOUW), Fifteen Euro

Class  B  Shares,  131,180  One  hundred  thirty-one  thousand  one  hundred  eighty,  STICHTING  PENSIOENFONDS

VOOR DE WONINGCORPORATIES, Fifteen Euro

Class B Shares, 65,590 Sixty-five thousand five hundred ninety, PENSIOENSTICHTING TRANSPORT, Fifteen Euro

116798

Class B Shares, 218,632 Two hundred eighteen thousand six hundred thirty-two, ILMARINEN MUTUAL PENSION

INSURANCE COMPANY, Fifteen Euro

Class B Shares, 174,906 One hundred seventy-four thousand nine hundred six, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIG-

NATIONS, Fifteen Euro

Class B Shares, 109,316 One hundred nine thousand three hundred sixteen, STICHTING PENSIOENFONDS AHOLD,

Fifteen Euro

Class B Shares, 52,472 Fifty-two thousand four hundred seventy-two, MIVTACHIM PENSION FUNDS Ltd, Fifteen

Euro

These subscribers subscribed to the new Class A and Class B Shares and had them fully paid up by payment in cash

as well as the share premium so that the Company had at its free and entire disposal the amount of EUR 37,705,080.-
(thirty-seven million seven hundred five thousand eighty Euros) whereof EUR 3,770,508.- (three million seven hundred
seventy thousand five hundred eight Euros) paid as nominal on the shares and EUR 33,934,572.- (thirty-three million nine
hundred thirty-four thousand five hundred seventy-two Euros) as share premium, as was certified to the undersigned
notary, who expressly acknowledges it.

6) As a consequence of the increase of the share capital, the subscribed share capital of the Company presently amounts

to EUR 10,552,332.- (ten million five hundred fifty-two thousand three hundred thirty-two Euros), divided into 72,412
(seventy-two thousand four hundred twelve) Class A Shares and 6,962,476 (six million nine hundred sixty-two thousand
four hundred seventy-six) Class B Shares, with a par value of EUR 1.50 (one Euro fifty cent) each.

Therefore Article 5.1 of the Articles of Incorporation is amended accordingly and now reads as follows:
«5.1. The subscribed capital is fixed at EUR 10,552,332.- (ten million five hundred fifty-two thousand three hundred

thirty-two Euros), represented by 72,412 (seventy-two thousand four hundred twelve) shares of Unlimited Shareholder
(«actions de commandité», herein defined as «Class A Shares») and 6,962,476 (six million nine hundred sixty-two thousand
four  hundred  seventy-six)  shares  of  Limited  Shareholders  («actions  de  commanditaires»,  herein  defined  as  «Class  B
Shares»; together, with the Class A Shares, herein as the «Shares»), with a par value of€ 1.50 (one Euro and fifty cent)
each. The holders of Shares are hereafter referred to as the «Shareholders».»

Furthermore, consequently to the above mentioned capital increase within the framework of the authorised capital

clause, the amount of the authorised share capital as set out in Article 6.1 of the Articles of Incorporation of the Company
has been decreased to one hundred thirty-nine million four hundred seventy-nine thousand one hundred sixty-eight Euros
(EUR 139,479,168.-) so that Article 6.1 of the Articles of Incorporation is amended accordingly and now reads as follows:

«6.1 The Company has an un-issued but authorised capital of a maximum amount of EUR 139,479,168.- (one hundred

thirty-nine million four hundred seventy-nine thousand one hundred sixty-eight Euros) to be used in order to issue new
Shares or to increase the nominal value of the Shares.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at three hundred eighty-three thousand five hundred Euros
(383,500.-EUR).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

person the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation of the appearing person, the said person signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

En l'an deux mille sept, le quatre septembre,
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg

A comparu:

Madame Bernardine Vos, employée, demeurant professionnellement au Luxembourg,
Agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
EUROPEAN RETAIL VENTURE, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle,

L-1325 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
109.637, agissant en tant que gérant commandité (le «Gérant Commandité») de la société EUROPEAN RETAIL INCOME
VENTURE S.C.A., une société en commandite par actions ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxem-
bourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.566 (la
«Société»);

En vertu de l'autorité qui lui a été conférée par les résolutions adoptées par le conseil de gérance du Gérant Com-

mandité de la Société le 18 juillet 2007.

116799

Laquelle comparante, agissant ès-qualités, a requis le notaire instrumentant de prendre acte de ce qui suit:
1) La Société a été constituée conformément à l'acte du notaire soussigné en date du 14 juillet 2005, et publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C»), en date du 7 décembre 2005, et les statuts de la Société
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 18 avril 2007, publié au Mémorial C
du 4 juillet 2007, page 64.980.

2) Le capital émis de la Société est fixé à EUR 6.781.824,- (six millions sept cent quatre-vingt-un mille huit cent vingt-

quatre Euros) représenté par 59.895 (cinquante-neuf mille huit cent quatre-vingt-quinze) Actions de Classe A et 4.461.321
(quatre millions quatre cent soixante-un mille trois cent vingt et un) Actions de Classe B ayant une valeur nominale de
EUR 1,50 (un Euro et cinquante cent) chacune. Toutes les actions sont entièrement libérées.

3) Conformément à l'article 6 des statuts de la Société, le capital social peut être augmenté d'un montant de EUR

143.249.676,- (cent quarante-trois millions deux cent quarante-neuf mille six cent soixante-seize Euros) à l'initiative du
Gérant Commandité en créant et en émettant de nouvelles Actions (dont les droits seront strictement similaires aux
droits attachés à la classe d'actions existante correspondante) ou en augmentant la valeur nominale des actions existantes.

Le Gérant Commandité est autorisé à émettre les nouvelles Actions en une ou plusieurs étapes tel qu'il pourra le

déterminer en temps utile et le Gérant Commandité est spécialement autorisé à émettre de nouvelles Actions sans
réserver aux actionnaires existants le droit préférentiel de souscrire ou d'acheter les nouvelles actions.

4) Par la résolution prise en date du 18 juillet 2007, le Gérant Commandité a approuvé l'augmentation du capital social

de la Société. Le capital social de la Société a été augmenté, avec effet au 7 août 2007, dans les limites fixées par le capital
autorisé défini à l'Article 6 des statuts de la Société, d'un montant de EUR 3.770.508,- (trois millions sept cent soixante-
dix mille cinq cent huit Euros) afin de l'élever de son montant actuel de EUR 6.781.824,- (six millions sept cent quatre-
vingt-un mille huit cent vingt-quatre Euros) à un montant de EUR 10.552.332,- (dix millions cinq cent cinquante-deux mille
trois cent trente-deux Euros) en créant et émettant 12.517 (douze mille cinq cent dix-sept) Actions de Classe A et
2.501.155 (deux millions cinq cent un mille cent cinquante-cinq) Actions de Classe B ayant une valeur nominale de EUR
1,50 (un Euro et cinquante cent) chacune.

Toutes les 12.517 (douze mille cinq cent dix-sept) nouvelles Actions de Classe A et les 2.501.155 (deux millions cinq

cent un mille cent cinquante-cinq) nouvelles Actions de Classe B ayant une valeur nominale de EUR 1,50 (un Euro et
cinquante cent) chacune ont été totalement souscrites avec une prime d'émission de EUR 13,50 (treize Euros et cinquante
cent) par nouvelle action et libérées par apport en numéraire comme décrit dans le tableau ci-dessous.

5) Ensuite l'Associé Commandité a décidé d'admettre à la souscription des actions nouvelles effectuées comme suit:
Type, Nombre d'actions, Porteur, Prix par action
Actions de Classe A, 12.517 Douze mille cinq cent dix-sept, EUROPEAN RETAIL VENTURE, Quinze Euros
Actions de Classe B, 131.180 Cent trente et un mille cent quatre-vingt, MUTAVIE S.A., Quinze Euros
Actions de Classe B, 349.812 Trois cent quarante-neuf mille huit cent douze, CARDIF ASSURANCE VIE, Quinze Euros
Actions de Classe B, 87.453 Quatre-vingt-sept mille quatre cent cinquante-trois, OP LIFE ASSURANCE COMPANY

Ltd, Quinze Euros

Actions de Classe B, 174.906 Cent soixante-quatorze mille neuf cent six, GERBERA S.A., Quinze Euros
Actions de Classe B, 262.359 Deux cent soixante-deux mille trois cent cinquante-neuf, SCI VENDOME COMMERCES,

Quinze Euros

Actions de Classe B, 87.453 Quatre-vingt-sept mille quatre cent cinquante-trois, AXA RE S.A., Quinze Euros
Actions de Classe B, 218.632 Deux cent dix-huit mille six cent trente-deux STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS,

Quinze Euros

Actions de Classe B, 437.264 Quatre cent trente-sept mille deux cent soixante-quatre, BEDRIJFSTAKPENSIOEN-

FONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID (BPF BOUW), Quinze Euros

Actions de Classe B, 131.180 Cent trente et un mille cent quatre-vingts, STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE

WONINGCORPORATIES, Quinze Euros

Actions de Classe B, 65.590 Soixante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix, PENSIOENSTICHTING TRANSPORT,

Quinze Euros

Actions de Classe B, 218.632 Deux cent dix-huit mille six cent trente-deux, ILMARINEN MUTUAL PENSION INSU-

RANCE COMPANY, Quinze Euros

Actions de Classe B, 174.906 Cent soixante-quatorze mille neuf cent six, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA-

TIONS, Quinze Euros

Actions de Classe B, 109.316 Cent neuf mille trois cent seize, STICHTING PENSIOENFONDS AHOLD, Quinze Euros
Actions de Classe B, 52.472 Cinquante-deux mille quatre cent soixante-douze, MIVTACHIM PENSION FUNDS Ltd,

Quinze Euros

Ces souscripteurs ont souscrit les nouvelles Actions de Classe A et les Actions de Classe B et les ont entièrement

libérées par un apport en numéraire ainsi que la prime d'émission de telle sorte que la Société dispose librement et
entièrement du montant de EUR 37.705.080,- (trente-sept millions sept cent cinq mille quatre-vingts Euros) dont EUR
3.770.508,- (trois millions sept cent soixante-dix mille cinq cent huit Euros) payés en tant que valeur nominale sur les

116800

actions et EUR 33.934.572,- (trente-trois millions neuf cent trente-quatre mille cinq cent soixante-douze Euros) en tant
que prime d'émission, tel qu'il a été prouvé au notaire soussigné, qui le reconnaît expressément.

6) Suite à l'augmentation du capital social, le capital souscrit de la Société s'élève à présent à EUR 10.552.332,- (dix

millions cinq cent cinquante-deux mille trois cent trente-deux Euros) divisé en 72.412 (soixante-douze mille quatre cent
douze) Actions de Classe A et 6.962.476 (six millions neuf cent soixante-deux mille quatre cent soixante-seize) Actions
de Classe B, ayant une valeur nominale de EUR 1,50 (un Euro et cinquante cent) chacune.

Il s'ensuit que l'article 5.1 des statuts de la Société est modifié et doit être lu comme suit:
«5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 10.552.332,- (dix millions cinq cent cinquante-deux mille

trois cent trente-deux Euros), représenté par 72.412 (soixante-douze mille quatre cent douze) actions d'actionnaire
commandité («actions de commandité» ci-après définies en tant qu'«Actions de Classe A») et 6.962.476 (six millions neuf
cent soixante-deux mille quatre cent soixante-seize) actions d'actionnaires commanditaires («action de commanditaires»
ci-après définies en tant qu' «Actions de Classe B»), ensemble avec les Actions de Classe A, repris ci-après comme les
«Actions», d'une valeur nominale d'EUR 1,50 (un Euro et cinquante cent) chacune. Les détenteurs d'Actions sont définis
ci-après comme les «Actionnaires».

De plus, en conséquence de l'augmentation de capital mentionnée ci-dessus dans la limite de la clause de capital autorisé,

le montant du capital autorisé tel qu'il figure à l'Article 6.1 des statuts de la Société a été réduit à EUR 139.479.168,- (cent
trente-neuf millions quatre cent soixante-dix neuf mille cent soixante-huit Euros) de sorte que l'article 6.1 des statuts est
modifié et doit être lu comme suit:

«6.1. La Société a un capital non émis mais autorisé d'un montant maximum de EUR 139.479.168,- (cent trente-neuf

millions quatre cent soixante-dix neuf mille cent soixante-huit Euros) devant être utilisé afin d'émettre de nouvelles actions
ou d'augmenter la valeur nominale des Actions.»

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunération, et autres charges de quelque nature que ce soit, qui doivent être portés au compte de

la Société par suite de cette augmentation de capital, sont estimés à trois cent quatre-vingt-trois mille cinq cents euros
(383.500,-EUR).

Le présent acte a été dressé à Luxembourg à la date mentionnée au début de ce document.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même personne et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte.
Après lecture et interprétation faite à la personne comparante, la dite personne cosigne avec le notaire le présent

acte.

Signé: B. Vos, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2007. LAC/2007/25340. — Reçu 377.050,80 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007116375/220/218.
(070134037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

Abowijs International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 31.922.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007115878/506/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2007, réf. LSO-CI08223. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

116801

Lancaster Invest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 95.339.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2007115884/1463/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2007, réf. LSO-CI09617. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070132605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Extensity, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 113.859.

In the year two thousand and seven, on the second day of August.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

INFOR LUX FINANCE COMPANY, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the

Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 118.070,
having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, being the holder of twenty-six thousand
ninety-four (26,094) shares in the Company,

here represented by Ms Annette Kull, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxem-

bourg, on 31 July 2007.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of EXTENSITY (the «Company»), a société à responsabilité limitée, having

its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 113.859, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 28 October
2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N 

o

 814 dated 24 April 2006. The articles of

incorporation of the Company were amended for the last time on 31 July 2006 pursuant to a deed of the undersigned
notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n 

o

 1798, on 26 September 2006.

The appearing party representing the whole corporate capital has requested the undersigned notary to enact the

following resolution:

<i>Sole resolution

The general meeting decides to amend article 11 of the Company's articles of incorporation, which shall henceforth

read as follows:

« Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of any two managers.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing known to the notary by name, first name,

civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le deux août.

116802

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

INFOR LUX FINANCE COMPANY, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 118.070, ayant son siège
social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, détenteur de vingt-six mille quatre-vingt quatorze (26.094) parts
sociales dans la Société,

ici représentée par Madmeoiselle Annette Kull, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privé donnée à Luxembourg, le 31 juillet 2007.

Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire

soussigné, annexée au présent acte pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant est l'associé unique d'EXTENSITY (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant

son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 113.859, constituée suivant acte reçu du notaire soussigné en date du 28 octobre 2005, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n 

o

 814, daté du 24 avril 2006. Les statuts de la Société ont été modifiés

pour la dernière fois le 31 juillet 2006 suivant acte reçu du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, n 

o

 1798, daté du 26 septembre 2006.

Lequel comparant représentant l'intégralité du capital social a requit le notaire soussigné d'arrêter la résolution sui-

vante:

<i>Résolution unique

L'assemblée générale décide de modifier l'article 11 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toute circonstance, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la

signature conjointe de deux gérants.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Après lecture faite au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le com-

parant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Kull, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2007, Relation: EAC/2007/9594. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 septembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007116490/239/83.
(070133676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

CVI GVF Luxembourg Nineteen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.049.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-third day of August.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

CVT GVF (LUX) MASTER S.à r.l, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies' register under the number B 119.271,

duly represented by Ms Andrea Hoffmann, private employee, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 16 August

2007.

116803

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed in order to be registered therewith. Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity,
has drawn up the following articles of incorporation of a société à responsabilité limitée which it declares organized as
follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incor-
poration.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and loans and the administration, control
and development of its portfolio.

The Company may act as a general partner and manager of partnerships or similar corporate structures with unlimited

liability for all debts and obligations of such entities. An additional purpose of the Company is the acquisition and sale, as
well the holding, leasing, improving, managing and mortgaging of real estate properties either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad as well as the management of all operations relating to real estate properties, including the direct
or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company is incorporated under the name of CVI GVF LUXEMBOURG NINETEEN S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means
of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality
may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos,

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only
be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general
meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares
are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.
In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.

The manager(s) is/are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the

term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as
the case may be, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

116804

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute
grave) or wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.

Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Collective decisions of the shareholders - Decisions of the sole shareholder

Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 20. The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

116805

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's financial year commences on the first of June and ends on the thirty-first of May.

Art. 22. Each year on the thirty-first of May, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole
shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators
shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company have been subscribed by CVI GVF (LUX) MASTER

S.à r.l., as aforementioned, paid up by a contribution in cash for an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500), entirely allocated to the share capital.

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is as

of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 May

2008.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which are to be borne by the Company or

which shall be charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred
Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period of time:
Mr Gregor Klaedtke, born on 10 January 1965 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing professionally

at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

Mr Hille-Paul Schut, lawyer, born on 29 September 1977 in 's-Gravenhage, the Netherlands, residing professionally at

20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, den dreiundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l, eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großherzogtums

Luxemburg, mit Sitz in 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister unter Nummer B 119.271,

116806

hier vertreten durch Andrea Hoffmann, Privatangestellte, wohnhaft in Luxemburg aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 16. August 2007.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société

à responsabilité limitée), die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend  die  «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtli-

chen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.

Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf sowie der Besitz, die Vermietung, die Sanierung,

die Verwaltung von und die Gewährung von Hypotheken auf Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland sowie
die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Erwerbs von Beteiligungen in lu-
xemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Zweck der Erwerb, die Verwertung, die Förderung, der Verkauf,
die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung CVT GVF LUXEMBOURG NINETEEN S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Be-

schluss der Hauptversammlung der Gesellschafter oder gegebenenfalls des alleinigen Gesellschafters an jeden beliebigen
Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch
einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.

Niederlassungen oder andere Filialen können entweder in Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), aufgeteilt in zwölftausendfünf-

hundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1).

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese

Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss, oder gegebenenfalls der Zustimmung des alleinigen Gesellschafters.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die die Miteigentümer gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der

Gesellschaft.

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-

genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

116807

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern oder gegebenenfalls von dem alleinigen Gesellschafter ernannt.

Die Gesellschafter oder der alleinige Gesellschafter bestimmen auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer
können jederzeit, ohne dass ein berechtigter Grund («cause légitimé») hierzu bestehen muss, von den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers verpflichtet.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Der Geschäftsführerrat wird durch jedes seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort

einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Ge-
schäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden
ernennen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der
jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern oder von einer vom Geschäftsführerrat bevollmächtigten Person unterzeichnet.

Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-

sellschaft nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer oder jedes Geschäftsführerratsmitglied sowie deren Erben, Nach-

lassverwalter und Verwalter für Ausgaben, die nach vernünftigem Ermessen in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit,
einer Klage oder einem Verfahren, bei dem der Geschäftsführer oder das Geschäftsführerratsmitglied auf Grund seiner
Funktion als gegenwärtiger oder ehemaliger Geschäftsführer oder Geschäftsführerratsmitglied der Gesellschaft oder, auf
Anfrage der Gesellschaft, jeder anderen Körperschaft, von der die Gesellschaft ein Gesellschafter oder Gläubiger ist und
von der er nicht berechtigt ist, Entschädigung zu erhalten, Partei geworden ist, entstanden sind. Dies gilt für Angelegen-
heiten bei denen letztendlich eine schwere Pflichtverletzung (faute grave) oder eine vorsätzliche Pflichtverletzung (faute
intentionnelle) erkannt wurde. Für den Fall einer Vereinbarung soll eine Entschädigung nur für solche Angelegenheiten
gezahlt werden, die von der Vereinbarung gedeckt sind, sofern die Gesellschaft von einem rechtlichen Beistand darüber

116808

informiert wurde, dass die zu entschädigenden Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht auf
Entschädigung soll nicht die Geltendmachung anderer Rechte, zu der die Person berechtigt ist, ausschließen.

Art. 17 Die Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat können sich dazu entschließen, Zwischendividenden auszu-

schütten, und zwar auf Grundlage eines Rechenschaftsberichts, der von einem Geschäftsführer oder dem Geschäftsfüh-
rerrat vorbereitet wird und aufzeigt, dass genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag
nicht die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Rechnungsjahres überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen
Gewinne und der zur Verteilung zur Verfügung stehenden Rücklagen, jedoch abzüglich der übertragenen Verluste und
der Beträge, die einer gesetzlich oder durch die Satzung vorgeschriebenen Kapitalrücklage zugeführt werden.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 19. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der
Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 20. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

E. Geschäftsjahr - Konten- Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Juni und endet am einunddreißigsten Mai.

Art. 22. Am einunddreißigsten Mai eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer

stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder
Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Zwischendividenden werden in Einklang mit den gesetzlich vorgesehen Bedingungen zugeteilt.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung, oder
gegebenenfalls  der  alleinige  Gesellschafter,  legt  die  Befugnisse  und  Vergütungen  der  Liquidatoren  fest.  Insofern  nicht
anderes vorgesehen ist, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der
Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

oder dem alleinigen Gesellschafter im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweist die Erschienene auf die Bestimmungen des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile wurden von CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., vorgenannt,

gezeichnet und durch eine Bareinlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) eingezahlt, die vollständig
dem Gesellschaftskapital zugewiesen wurde. Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass die
Gesellschaft über ein Gesellschaftskapital von zwölftausendfünftiundert Euro (EUR 12.500) verfügt, wie dem unterzeich-
neten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Mai 2008.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

ein tausend drei hundert euro geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat die oben genannte Person, die das gesamte gezeichnete Gesellschafts-

kapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.
2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern ernannt:
- Herr Gregor Klaedtke geboren am 10. Januar 1965 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in 25B, boulevard Royal, L-2449

Luxemburg; und

116809

- Herr Hille-Paul Schut, Jurist, geboren am 29. September 1977 in 's-Gravenhage, Niederlande, beruflich wohnhaft in

20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten

Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.

Signé: A. Hoffmann, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2007, Relation: LAC/2007/24100. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2007

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007116614/211/355.
(070133994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

Advent Stoco Investment S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 127.694.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 2 août 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007115976/239/12.
(070132856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

CAMPIMOL Société Financière de la Campine, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 3.571.

Constituée par-devant M 

e

 Jules Hamelius, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 juin 1939, acte publié

au Mémorial C no 71 du 1 

er

 juillet 1939. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par-devant M 

e

 Joëlle

Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 septembre 2007, acte pas encore publié au Mémorial C.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CAMPIMOL Société Financière de la Campine
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007115854/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2007, réf. LSO-CI08796. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Mars Propco 26 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.504.075,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.322.

EXTRAIT

En date du 10 août 2007, le conseil d'administration a décidé de transférer son siège social du 14A, rue des Bains,

L-1212 Luxembourg, au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, avec effet au 13 août 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

116810

Luxembourg, le 10 août 2007.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007115759/7801/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06623. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Communauté d'Exploitation agricole DENNEWALD-KLENSCH et Cie, Société Civile.

Siège social: L-5328 Contern, Bruecherhof.

R.C.S. Luxembourg E 1.263.

DISSOLUTION

La société civile, constituée sous seing privé le 23 avril 1991 pour une durée de 16 années commençant à courir à

partir du 1 

er

 mai 1991, suivant l'article 3 des statuts sociaux, est dissoute automatiquement par la révolution de la durée

prévue pour son existence.

Les associés Camille Klensch et son épouse Marie-Louise Kons déclarent avoir procédé à la liquidation de la société

par reprise dans leur patrimoine privé, de l'intégralité de l'actif et du passif de la société.

Les livres et documents sociaux sont gardés au domicile des époux Klensch-Kons.

Fait à Contern, le 15 mai 2007.

C. Klensch / M.-L. Kons.

Référence de publication: 2007115757/262/17.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH05922. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070133194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Technet Investment Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 77.187.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007115873/506/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2007, réf. LSO-CI08248. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

Poseidon S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 13.338.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007115874/506/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2007, réf. LSO-CI08247. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070132669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

116811

PPF Brittany Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PPF Banimmo Holdings S.à r.l.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 128.208.

In the year two thousand and seven, on the first of August.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

PIM WAREHOUSE INC., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, having its registered office

at c/o CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, USA, 19808,
registered under number 3303812 with the Delaware Secretary of States, USA,

here represented by Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Brussels

on the 1st of August 2007.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of PPF BANIMMO HOLDINGS S.à r.l., (hereinafter the «Company») a société

à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9A,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Company Register under number B 128.208, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 16
May 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 11 July 2007 (page 68071, number
1419). The articles of incorporation of the Company have not been amended since the incorporation.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolution:

<i>Sole resolution

The sole partner decides to change the Company's name into PPF BRITTANY HOLDINGS S.à r.l. and to amend article

4 of the articles of incorporation of the Company that shall be read as follows:

« Art. 4. The Company will assume the name of PPF BRITTANY HOLDINGS S.à r.l.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le premier août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

PIM WAREHOUSE INC., une société existant par les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o COR-

PORATION SERVICE COMPANY, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, USA, 19808, immatriculée
auprès du Delaware Secretary of States, USA sous le numéro 3303812,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous

seing privé donnée à Bruxelles, le 1 

er

 août 2007.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de PPF BANIMMO HOLDINGS S.à r.l. (ci-après la «Société»), une

société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9A, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.208, constituée selon un acte notarié par-devant le notaire soussigné
en date du 16 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 11 juillet 2007 (page 68071, numéro
1419). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis la constitution.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter la

résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la société en PPF BRITTANY HOLDINGS S.à r.l. et

de modifier l'article 4 des statuts qui doit être lu comme suit:

116812

« Art. 4. La Société prend la dénomination de PPF BRITTANY HOLDINGS S.à r.l.»

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 août 2007, Relation: EAC/2007/9520. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 septembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007116480/239/69.
(070133390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

GEBPF Finance (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Arlington Europe Finance S.à r.l.).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 94.401.

In the year two thousand and seven, the thirtieth of July.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

GOODMAN EUROPEAN BUSINESS PARK FUND (LUX) S.a r.l., a company with registered address at 6, rue Philippe

II, L-2340, Luxembourg, under registered number B 94.572,

hereby represented by Mr Craig Williamson, employee, with professional address at 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg,

acting as A manager, and Mr Jeff Pulsford, employee, with professional address at 10, Old Burlington Street, London W1S
3AG, United Kingdom, acting as B manager.

Such appearing party is the partner of ARLINGTON EUROPE FINANCE S.à r.l., a Luxembourg private limited liability

company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Philippe II, L-2340, Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 94.401 (the Company). The Company has been
incorporated pursuant to a notarial deed on 20 June 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations, number 805 of 31 July 2003.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from ARLINGTON EUROPE FINANCE S.à r.l.

to GEBPF FINANCE (LUX) S.à r.l.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 2 of the articles of association, which shall read henceforth as follows:
«The Company's name is GEBPF FINANCE (LUX) S.à r.l.»

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Craig Williamson, professionally residing at 8, rue Heine, L-1720, Lux-

embourg, as Type «A» Manager of the Company with immediate effect and for an unlimited duration.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the number of Type «B» Managers from one to three.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Robert Wilkinson, private employee, professionally residing at 10 Old

Burlington Street, London, W1S 3AG, United Kingdom, as Type «B» Manager of the Company with immediate effect and
for an unlimited duration.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Stephen Young, private employee, professionally residing at 10 Old

Burlington Street, London, W1S 3AG, United Kingdom, as Type «B» Manager of the Company with immediate effect and
for an unlimited duration.

116813

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to remove Mr Jean And as Type «A» Manager of the Company with immediate effect.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

GOODMAN EUROPEAN BUSINESS PARK FUND (LUX) S.a r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège

social au 6, rue Philippe II, L-2340, Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
94.572,

représentée par Monsieur Craig Williamson, employé privé, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720

Luxembourg, agissant en tant que gérant de classe A et Monsieur Jeff Pulsford, employé privé, avec adresse professionnelle
au 10, Old Burlington Street, Londres W1S 3AG, Royaume-Uni, agissant en tant que gérant de classe B.

Laquelle partie comparante est l'associée unique de ARLINGTON EUROPE FINANCE S.à r.l., une société à respon-

sabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.401, constituée suivant acte notarié en date
du 20 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 805 du 31 juillet 2003.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination sociale de ARLINGTON EUROPE FINANCE S.à r.l. en GEBPF

FINANCE (LUX) S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 2 des Statuts afin de refléter ce changement de dénomination sociale, de

sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

«La Société aura la dénomination: GEBPF FINANCE (LUX) S.à r.l.»

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Craig Williamson, employé privé, avec adresse professionnelle au 8,

rue Heine, L-1720 Luxembourg, comme gérant de classe A avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le nombre de gérant de classe B de un à trois.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Robert Wilkinson, employé privé, avec adresse professionnelle au 10

Old Burlington Street, Londres, W1S 3AG, Royaume Uni, comme gérant de classe B avec effet immédiat et pour une
durée indéterminée.

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Stephen Young, employé privé, avec adresse professionnelle au 10 Old

Burlington Street, Londres, W1S 3AG, Royaume-Uni, comme gérante de classe B avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.

<i>Septième résolution

L'Associé décide de rayer Monsieur Jean And dans la classe de gérant A avec effet immédiat.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Williamson, J. Pulsford, J.-J. Wagner.

116814

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1 

er

 août 2007, Relation: EAC/2007/9257. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par

Maître Patrick Serres, notaire de résidence à Remich, en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de rési-
dence à Sanem, sur base d'un mandat oral.

Remich, le 28 août 2007.

P. Serres.

Référence de publication: 2007116476/239/100.
(070133382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

TriCage Acquisition, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 113.860.

In the year two thousand and seven, on the second day of August.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

EXTENSITY, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Lux-

embourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Register  under  the  number  B  113.859,  having  its
registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, being the holder of thirteen thousand eight hundred
and sixty-nine (13,869) shares in the Company,

here represented by Annette Kull, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg,

on 31 July 2007.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of TriCage ACQUISITION (the «Company»), a société à responsabilité

limitée, having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 113.860, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 28
October 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N 

o

 812 dated 22 April 2006. The

articles of incorporation of the Company were amended for the last time on 14 March 2006 pursuant to a deed of the
undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n 

o

 1225, on 24 June 2006.

The appearing party representing the whole corporate capital has requested the undersigned notary to enact the

following resolution:

<i>First resolution

The general meeting decides to amend article 11 of the Company's articles of incorporation, which shall henceforth

read as follows:

« Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of any two managers.»

<i>Second resolution

The general meeting decides to modify the Company's accounting year, which shall henceforth begin on the first of

June and end on the thirty-first of May. As a consequence, the current accounting year, which has begun on the first of
May 2007 will end on the thirty-first of May 2007 and the following accounting year, which started on the first of June
2007 shall end on the thirty-first of May 2008.

<i>Third resolution

As a consequence of the above, the general meeting decides to amend articles 20 and 21 of the articles of incorporation,

which shall henceforth read as follows:

« Art. 20. The Company's year commences on the first of June and ends on the thirty-first of May of the following

year.

116815

Art. 21. Each year on the thirty-first of May, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company's registered office.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing known to the notary by name, first name,

civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le deux août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

EXTENSITY, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 113.859, ayant son siège social au 20, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, détenteur de treize mille huit cent soixante neuf (13,869) parts sociales dans la Société,

ici représentée par Mademoiselle Annette Kull, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privé donnée à Luxembourg, le 31 juillet 2007.

Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire

soussigné, annexée au présent acte pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant est l'associé unique de TriCage ACQUISITION (ci-après la «Société»), une société à responsabilité

limité, ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro B 113.860, constituée suivant acte reçu du notaire soussigné, en date du 28 octobre 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n 

o

 812, daté du 22 avril 2006. Les statuts de la Société ont

été modifiés pour la dernière fois le 14 mars 2006 suivant acte reçu du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, n 

o

 1225, daté du 24 juin 2006.

Lequel comparant représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire soussigné d'arrêter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 11 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toute circonstance, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la

signature conjointe de deux gérants.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'année sociale de la société qui commencera désormais le premier juin et se

terminera le trente et un mai. Par conséquent, l'année sociale en cours qui a commencé le premier mai 2007 se terminera
le trente et un mai 2007 et l'année sociale suivante qui commence le premier juin 2007 se terminera le trente et un mai
2008.

<i>Troisième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier les articles 20 et 21 des statuts, qui auront

désormais la teneur suivante:

« Art. 20. L'année sociale commence le premier juin et se termine le trente et un mai de l'année suivante.

Art. 21. Chaque année au trente et un mai, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l'inventaire du bilan.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

116816

Après lecture faite au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le com-

parant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Kull, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2007, Relation: EAC/2007/9593. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 septembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007116484/239/106.
(070133673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

Capital Target Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 80.470.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007116678/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2007, réf. LSO-CJ00422. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070133391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

RES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7565 Mersch, 37, rue Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 51.979.

Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007116696/6584/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2007, réf. LSO-CG00691. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070134022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

CEP II Participations S.à r.l. SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Inves-

tissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 96.017.

L'adresse du gérant Monsieur Christopher Finn et de l'associé CEP II TOP LUXCO S.à r.l. a changé du 30, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg au:

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
avec effet au 1 

er

 septembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2007.

<i>CEP II PARTICIPATIONS S.à r.l. SICAR
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007116092/5480/19.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2007, réf. LSO-CI08153. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070133136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2007.

116817

Noe Participations, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 74.779.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007116682/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2007, réf. LSO-CJ00430. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070133400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

CEFIP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 58.016.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Foetz, le 3 octobre 2007.

<i>C.E.F.I.P. S.à r.l.
Signature
<i>La gérance

Référence de publication: 2007116690/2725/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2007, réf. LSO-CI09128. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070133871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

Holding d'Investissement et de Placement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6231 Bech, 1, Moulin de Bech.

R.C.S. Luxembourg B 75.809.

Le bilan au 31 décembre 2000 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007116695/1175/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2007, réf. LSO-CH08462. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070134019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

Berrak Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.656.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2007.

<i>Pour BERRAK HOLDING SA
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007116985/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2007, réf. LSO-CI09281. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070133807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

116818

Benelugap S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7565 Mersch, 37, rue Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 80.941.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2007.

Référence de publication: 2007116697/6584/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2007, réf. LSO-CG07710. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070134026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

Edelweiss Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 118.080.

Le bilan au 31 décembre 2006 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007116700/4775/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2007, réf. LSO-CJ00702. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070134050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

SCHENGEN asbl, Entente des Syndicats d'Initiative et de Tourisme des Communes de Burmerange,

Mondorf-les-Bains, Remich, Schengen et Wellenstein, Association sans but lucratif.

Siège social: L-5444 Schengen, rue Robert Goebbels.

R.C.S. Luxembourg F 872.

1. Dénomination

Art. 1 

er

 .  L'association porte le nom de ENTENTE DES SYNDICATS D'INITIATIVE ET DE TOURISME des communes

de Burmerange, Mondorf-les-Bains, Remich, Schengen et Wellenstein, dénommée SCHENGEN asbl.

2. Siège

Art. 2. Son siège social se trouve à Schengen.

3. Objets

Art. 3. SCHENGEN asbl a pour mission - conformément à une convention avec les communes de Burmerange, Mon-

dorf-les-Bains, Remich, Schengen et Wellenstein - d'élaborer, de coordonner et d'effectuer la promotion touristique de
la région.

L'association conseille et assiste ses membres dans leurs activités de propagande touristique. Sur demande elle est leur

interprète auprès des autorités.

Dans son activité promotionnelle, elle met en valeur les richesses naturelles, culturelles et historiques de la région.
Elle  collabore  avec  toutes  les  instances  communales,  régionales,  nationales  et  internationales  dans  le  cadre  de  sa

mission.

Elle peut prendre toutes mesures, créer, diriger et surveiller toutes institutions et participer à toutes entreprises qui

lui paraissent utiles et propres à servir les intérêts de ses membres et ceux du tourisme.

4. Durée

Art. 4. Sa durée et illimitée.

5. Membres, Admission, Démission, Exclusion et Cotisation

Art. 5. L'association se compose de membres effectifs et de membres honoraires, personnes physiques ou morales.

Art. 6. Le nombre de membres effectifs est illimité sans pouvoir être inférieur à trois.

Art. 7. Sont membres effectifs de SCHENGEN asbl:
- Le Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Burmerange

116819

- Le Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Mondorf-les-Bains
- Le Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Remich
- Le Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Schengen
- Le Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Wellenstein
Les Syndicats d'Initiative et de Tourisme doivent être en possession de l'agrément du Ministre du Tourisme.
Peuvent être admises comme membres effectifs toutes les personnes physiques ou morales s'intéressant aux objets

poursuivis par l'association.

Les bourgmestres et échevins des communes de Burmerange, Mondorf-les-Bains, Remich, Schengen et Wellenstein,

voire un membre du conseil communal à déléguer par ces derniers, peuvent ès qualités devenir membres de SCHENGEN
asbl; leur qualité d'associé est limitée à la durée de leur mandat communal.

Le Ministre du Tourisme est de droit membre de SCHENGEN asbl.

Art. 8. Une cotisation est fixée annuellement par l'assemblée générale. Elle ne peut dépasser 50.000,- € (cinquante

mille euros) - indice 668,46 valable au 6 avril 2007 - pour les membres effectifs.

La contribution des communes est fixée annuellement par l'assemblée générale. Elle est calculée sur base des habitants

et ne peut dépasser 10,- € (dix euros) - indice 668,46 valable au 6 avril 2007 - par habitant.

Les cotisations et les contributions sont soumises aux adaptations de l'indice valable au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 9. Toute demande d'admission est adressée par écrit au Président qui la transmettra au Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration se prononcera sur la demande dans sa plus prochaine réunion.

Art. 10. Le Conseil d'Administration pourra décerner le titre de membre honoraire à des personnes morales et

physiques ayant rendu des services aux causes de l'association.

Art. 11. Tout membre effectif ou honoraire de l'association est libre de se retirer. La démission est adressée par lettre

recommandée au président du Conseil d'Administration.

Art. 12. L'Assemblée générale, à la majorité des deux tiers des voix, peut prononcer l'exclusion de tout membre ayant

contrevenu aux statuts de l'association.

Art. 13. L'associé démissionnaire exclu ou sortant, et ses héritiers n'ont aucun droit sur le patrimoine social et ne

peuvent réclamer le remboursement des cotisations payées.

6. Assemblée générale

Art. 14. L'Assemblée Générale a pour tâches
• la nomination et la révocation des membres du Conseil d'Administration;
• l'approbation des comptes et budgets;
• la désignation des réviseurs de caisse;
• la fixation des cotisations;
• la modification des statuts;
• la dissolution et la liquidation de l'association.

Art. 15. L'Assemblée générale ordinaire se réunit au cours du premier trimestre de chaque année sur convocation du

président ou de son remplaçant au jour, à l'heure et au lieu indiqués par celui-ci.

Art. 16. Le Conseil d'Administration peut convoquer des assemblées extraordinaires chaque fois qu'il le juge utile ou

nécessaire.

Art. 17. A la demande écrite d'un cinquième des membres effectifs au moins, le Conseil d'Administration doit convo-

quer, dans un délai d'un mois, une Assemblée générale extraordinaire, mentionnant à son ordre de jour le motif de la
demande.

Art. 18. Les convocations aux Assemblées générales ordinaires et extraordinaires se font par simple lettre quinze jours

au moins avant leur date. L'ordre du jour est joint à la convocation.

Art. 19 . L'Assemblée générale est régulièrement constituée si la majorité simple des membres effectifs est présente,

sauf le cas où elle délibère sur des modifications de statuts. Tous les membres effectifs ont le droit de vote égal. Il sera
loisible aux membres effectifs de se faire représenter aux Assemblées générales par un autre membre effectif. Un membre
effectif ne pourra représenter qu'un seul membre effectif. Celui-ci doit être muni d'une procuration dûment signée par
le soumettant.

Avant chaque Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, les membres doivent faire connaître au Président de

l'association les nom, prénoms et demeure de leur délégué effectif et de son remplaçant, au moins trois jours avant la
réunion.

Les membres d'honneur peuvent prendre part aux Assemblées avec voix consultative.

116820

Art. 20. Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à haute voix par les membres effectifs présents ou repré-

sentées. En cas de parité de voix, la proposition mise à l'ordre de jour est rejetée. A la demande d'un tiers des membres
effectifs, le vote aux Assemblées se fait au scrutin secret.

Art. 21. L'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire ne peut valablement délibérer sur les modifications aux

statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué à l'ordre du jour et si l'Assemblée réunit les deux tiers des
membres effectifs de l'association. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix. Si
les deux tiers des membres effectifs ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il est convoqué une
seconde réunion qui délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Cette décision est soumise à l'homologation du Tribunal civil. Toute modification aux statuts est publiée, dans le mois

de sa date, aux annexes du Mémorial.

7. Administration

Art. 22. L'association est administrée par un Conseil d'Administration de dix membres au plus, élus au scrutin secret

parmi les membres effectifs lors de l'Assemblée générale pour une durée de cinq ans. Les membres sortants du Conseil
d'Administration sont rééligibles. La candidature pour un poste de membre au Conseil d'Administration est à adresser
par écrit au Président par le membre effectif au moins cinq jours avant l'Assemblée Générale.

Le Ministère du Tourisme est représenté d'office par un délégué, nommé par le Ministre ayant le Tourisme dans ses

attributions.

Les Administrations communales de Burmerange, Mondorf-les-Bains, Remich, Schengen et Wellenstein sont chacune

représentées d'office par un administrateur à choisir parmi les associés ayant qualité de bourgmestre ou d'échevin, voire
un membre du conseil communal à déléguer par ces derniers, visés à l'article 7 des présents statuts.

La qualité de membre du conseil d'administration se perd avec la perte du mandat de bourgmestre ou d'échevin, voire

de membre du conseil communal.

Art. 23. Le Conseil d'Administration choisit en son sein un Président, deux Vice-présidents, un Secrétaire et un Tré-

sorier. Le Conseil d'Administration peut confier les postes de Secrétaire-adjoint et de Trésorier-adjoint à des personnes
prises en dehors de son sein.

Art. 24 . Le Président, ou en cas d'empêchement, un Vice-président mandaté par lui, convoque les Assemblées générales

et les réunions du Conseil d'Administration, en arrête l'ordre du jour et signe les procès-verbaux des réunions du Conseil
d'Administration et de l'Assemblée générale avec le Secrétaire.

Art. 25. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des votants, la voix du Président

ou de son remplaçant étant prépondérante en cas de partage. Les décisions du Conseil d'Administration ne sont valables
que lorsque la moitié des ses membres est présente.

Art. 26. Le Conseil d'Administration a les pouvoirs d'administration les plus étendus pour la gestion des affaires de

l'association. Il peut procédera l'engagement du personnel qu'il juge opportun pour atteindre les objectifs. Il représente
l'association dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Art. 27. Le Conseil d'Administration peut déléguer des pouvoirs spécifiques à une ou plusieurs personnes choisies en

son sein ou en dehors. L'association est valablement engagée envers des tiers par la signature conjointe du Président ou
de son remplaçant et du Secrétaire.

Art. 28. Le Secrétaire est responsable de la rédaction des procès-verbaux et des actes administratifs.

Art. 29. Le Trésorier perçoit les cotisations et toutes les recettes ordonnées par le Conseil d'Administration. Il effectue

tous les paiements ordonnés par celui-ci. Les ordres de paiement doivent être contresignés par le Président ou son
remplaçant. Le trésorier tient un registre des recettes et des dépenses. Les inscriptions sont faites par ordre de date.

Lors de l'Assemblée générale, 2 contrôleurs de caisse seront désignés par les membres présents afin de vérifier les

comptes de l'association.

Art. 30. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et prend fin le 31 décembre.

8. Dissolution et liquidation

Art. 31. La dissolution et la liquidation de l'association sont décidées par l'Assemblée générale ordinaire ou extraor-

dinaire qui désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs attributions et pouvoirs.

Art. 32 . En cas de dissolution volontaire ou forcée de l'association, le ou les liquidateurs mettent l'actif social à la

disposition d'une oeuvre charitable.

9. Disposition finale

Art. 33. Pour les dispositions non contenues dans les présents statuts, il est référé à la loi modifiée du 21 avril 1928

sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique et de certaines autres dispositions législatives.

pour le Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Burmerange
Chantal Goehler-Wester

116821

pour le Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Mondorf-les-Bains
Roger Weirig
pour le Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Remich
Jean Bohler
pour le Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Schengen
Robert Gelz
pour le Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Wellenstein
Guy Hirtt
pour la Commune de Burmerange
Ben Homan
pour la Commune de Mondorf-les-Bains
Maggy Nagel
pour la Commune de Remich
Jeannot Belling
pour la Commune de Schengen
Roger Weber
pour la Commune de Wellenstein
René Philippy

Schengen, le 6 avril 2007.

Signatures
<i>Les membres du conseil d'administration

Référence de publication: 2007117339/534/160.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2007, réf. LSO-CI01730. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070134390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2007.

B.E.E.P. (Business Economy Engineering Projects) Luxembourg, S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1542 Luxembourg, 23, rue Jean-Baptiste Fresez.

R.C.S. Luxembourg B 121.251.

En l'an deux mille sept, le dix-sept septembre.
Par-devant, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée dénommée B.E.E.P.

(BUSINESS ECONOMY ENGINEERING PROJECTS) LUXEMBOURG, Sàrl, domiciliée à L-9706 Clervaux, 2A, route
d'Eselborn, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 121.251.

La société a été constituée suivant acte reçu le 16 octobre 2006, par le notaire soussigné, publié au Mémorial C de

2006, page 108.098.

L'assemblée est présidée par Monsieur Osman Saglam, chargé de cours, demeurant à L-5884 Howald, 288, Route de

Thionville,

qui nomme comme secrétaire Madame Kulas Chantal, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, 2, rue de la Chapelle.

L'assemblée élit comme scrutateur Osman Saglam, précité.
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I) Que les associés présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II) Qu'il résulte de cette liste de présence que toutes 100 (cent) parts sociales représentative du capital social de

12.500,- € (douze mille Euros) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation
préalable.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de son adresse actuelle, savoir L-9706 Clervaux, 2A, route d'Eselborn, à L-1542 Luxem-

bourg, 23, rue Jean-Baptiste Fresez, et modification subséquente de l'article 4 des statuts, version anglaise et traduction
française, pour lui donner la teneur suivante:

116822

Art. 4. Le siège social est établi à L-1542 Luxembourg, 23, rue Jean-Baptiste Fresez. Il pourra être transféré en toute

autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou
des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

2. Divers.
Après délibérations, l'assemblée générale a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle à L-1542 Luxembourg, 23, rue

Jean-Baptiste Fresez et décide de modifier en conséquence l'article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur
nouvelle suivante:

« Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres
localités du pays et à l'étranger.»

<i>Evaluation des frais

Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à EUR 832,-.
Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture aux personnes comparantes qui sont toutes connues du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: O. Saglam, C. Kulas, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2007. LAC/2007/27.176. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2007.

J. Delvaux.

Référence de publication: 2007117343/208/56.
(070134272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2007.

Advent Stoco Investment S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 127.694.

In the year two thousand and seven, on the eighteenth of June.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ADVENT StoCo HOLDING S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, having its registered office at 32, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 125.980, incorporated pursuant to a deed
of the undersigned notary, dated 22 March 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on
the 6th June 2007 (number 1090, page 52312). The articles of incorporation of the Company have been amended for the
last time on the 25th of May,

here represented by:
Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Luxembourg on the 15th of June 2007.
Said proxy, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of ADVENT StoCo INVESTMENT S.à r.l., (hereinafter the «Company») a

société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 32, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under number B 127.694, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 02 May
2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation of the
Company have been amended for the last time on the 25th May 2007.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to increase the Company's share capital by an amount of fifteen million two hundred thirty-

three thousand five hundred and eighty euro (EUR 15,233,580.-), so as to raise it from its present amount of eighty

116823

thousand six hundred and thirty-eight euro (EUR 80,638.-) up to fifteen million three hundred fourteen thousand two
hundred and eighteen euro (EUR 15,314,218.-) by the issue of fifteen million two hundred thirty-three thousand five
hundred and eighty (15,233,580) shares (hereinafter referred as the «Shares»), having a par value of one euro (EUR 1.-)
each and having the same rights and obligations as the existing shares.

The fifteen million two hundred thirty-three thousand five hundred and eighty (15,233,580) new shares have been

subscribed by ADVENT StoCo HOLDING S.à r.l., prenamed, paid up by a contribution in kind consisting in all the assets
and liabilities of ADVENT StoCo HOLDING S.à r.l..

The total contribution of fifteen million two hundred thirty-three thousand five hundred and eighty-one euro thirty-

five cents (EUR 15,233,581.35) will be allocated as follows (i) fifteen million two hundred thirty-three thousand five
hundred and eighty euro (EUR 15,233,580.-) to the Company's share capital and (ii) one euro thirty-five (EUR 1.35) to
the share premium account.

Evidence of the transfer of all assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a copy of a contribution

agreement and of a valuation report.

Said contribution agreement, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

Insofar as:
(1) the contribution in kind consists of all the assets and liabilities constituting an entire branch of activity of a company;
(2) the contribution is made exclusively against the allotment of new shares and
(3) all the companies enclosed have their registered office in the European Union,
such contribution qualifies under the terms of Article 4-1 of the law date December 29th, 1971, which provides for

capital duty exemption.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to reduce the share capital of the Company by an amount of eighty thousand six hundred

and thirty-eight euro (EUR 80,638.-) by the cancellation of eighty thousand six hundred and thirty-eight euro (80,638)
shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, held by the Company on itself subsequently to the contribution
by ADVENT StoCo HOLDING S.à r.l. of all its assets and liabilities.

<i>Third resolution

The sole partner decides to create ten classes of shares, referred to as the class A shares (the «Class A Shares»), the

class B shares (the «Class B Shares»), the class C shares (the «Class C Shares»), the class D shares (the «Class D Shares»),
the class E shares (the «Class E Shares»), the class F shares (the «Class F Shares»), the class G shares (the «Class G
Shares»), the class H shares (the «Class H Shares»), the class I shares (the «Class I Shares»), the class J shares (the «Class
J Shares»), each with a nominal value of one Euro (EUR 1.-).

<i>Fourth resolution

The sole partner decides to transform all the fifteen million two hundred thirty-three thousand five hundred and eighty

(15,233,580) Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, into one million five hundred twenty-three thousand
three hundred and fifty-eight (1,523,358) Class A Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, one million
five hundred twenty-three thousand three hundred and fifty-eight (1,523,358) Class B Shares with a nominal value of one
Euro (EUR 1.-), one million five hundred twenty-three thousand three hundred and fifty-eight (1,523,358) Class C Shares
with a nominal value of one Euro (EUR 1.-), one million five hundred twenty-three thousand three hundred and fifty-eight
(1,523,358) Class D Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) one million five hundred twenty-three thousand
three hundred and fifty-eight (1,523,358) Class E Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-), one million five
hundred twenty-three thousand three hundred and fifty-eight (1,523,358) Class F Shares with a nominal value of one Euro
(EUR 1.-), one million five hundred twenty-three thousand three hundred and fifty-eight (1,523,358) Class G Shares with
a nominal value of one Euro (EUR 1.-), one million five hundred twenty-three thousand three hundred and fifty-eight
(1,523,358) Class H Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-), one million five hundred twenty-three thousand
three hundred and fifty-eight (1,523,358) Class I Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) and one million five
hundred twenty-three thousand three hundred and fifty-eight (1,523,358) Class J Shares with a nominal value of one Euro
(EUR 1.-) each.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the above-mentioned resolutions, article 6 of the articles of incorporation of the Company is

amended and now reads as follows:

« Art. 6.
6.1. The Company's share capital is set at fifteen million two hundred thirty-three thousand five hundred and eighty

euro (EUR 15,233,580.-) represented by one million five hundred twenty-three thousand three hundred and fifty-eight
(1,523,358) Class A Shares, one million five hundred twenty-three thousand three hundred and fifty-eight (1,523,358)
Class B Shares, one million five hundred twenty-three thousand three hundred and fifty-eight (1,523,358) Class C Shares,
one million five hundred twenty-three thousand three hundred and fifty-eight (1,523,358) Class D Shares, one million five

116824

hundred twenty-three thousand three hundred and fifty-eight (1,523,358) Class E Shares, one million five hundred twenty-
three thousand three hundred and fifty-eight (1,523,358) Class F Shares, one million five hundred twenty-three thousand
three hundred and fifty-eight (1,523,358) Class G Shares, one million five hundred twenty-three thousand three hundred
and fifty-eight (1,523,358) Class H Shares, one million five hundred twenty-three thousand three hundred and fifty-eight
(1,523,358) Class I Shares and one million five hundred twenty-three thousand three hundred and fifty-eight (1,523,358)
Class J Shares (collectively referred hereinafter as to the «Shares»), having a par value of one euro (EUR 1.-) each and
with such rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation.

6.2. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the

manner required for the amendment of the articles of incorporation.

6.3. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation

of one or more entire classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such Class
(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares such cancellations and repurchases of Shares shall
be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).

6.4. In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of Shares (in the

order provided for in article 6.3), such class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such
class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount (as defined below) as
determined by the general meeting of shareholders) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled class of
Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined below) for each
Share of the relevant class held by them and cancelled.

6.4.1. The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number

of Shares in issue in the class of Shares to be repurchased and cancelled.

6.4.2. The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of directors and approved by the

general meeting of shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each
of the Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation
of the relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an
amendment of the articles of incorporation provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher
than such Available Amount.

6.4.3. Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant class, the Cancellation Value Per Share will

become due and payable by the Company.»

<i>Sixth resolution

As a consequence of the above-mentioned resolutions, article 22 of the articles of incorporation of the Company is

amended and now reads as follows:

« Art. 22.
22.1. Out of the net profit five per cent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company.

22.2.The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in ac-

cordance with the provisions set forth hereafter.

22.3. The shareholders may decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared

by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting
year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums
to be allocated to a reserve to be established by law, in accordance with the provisions set forth hereafter.

22.4.  The  share  premium  account  may  be  distributed  to  the  shareholders  upon  decision  of  a  general  meeting  of

shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of shareholders may decide to
allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

22.5. The dividends declared may be paid in any currency selected by the manager or as the case may be the board of

managers and may be paid at such places and times as may be determined by the manager or as the case may be the board
of managers. The manager or as the case may be the board of managers may make a final determination of the rate of
exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on
a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, shall be forfeited by the holder of such
share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by
the Company on behalf of holders of Shares.

22.6. In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:
(i) an amount equal to 0,25% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro

rata to their shares regardless of class, then

(ii) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the

reverse alphabetical order (i.e. first Class J shares, then if no Class J shares are in existence, Class I shares and in such
continuation until only class A shares are in existence).»

116825

<i>Seventh resolution

As a consequence of the above-mentioned resolutions, the sole partner decides to create an article 25 in the articles

of incorporation of the Company, which will include several definitions related to article 22 of the articles of incorporation
of the Company:

« Art. 25. Definition.
25.1. Available Amount means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)

increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves and (ii) as the case may be
by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled
but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to
the requirements of law or of the articles of incorporation, each time as set out in the relevant Interim Accounts (as
defined below) (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR)
Whereby:
AA= Available Amount
NP= net profits (including carried forward profits)
P= any freely distributable share premium and other freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be

cancelled

L= losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the articles of incorporation.
25.2. Interim Accounts means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date (as defined

below).

25.3. Interim Account Date means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and

cancellation of the relevant class of Shares.»

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to six thousand euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxy holder of the appearing party signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu

ADVENT StoCo HOLDING S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social au 32, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.980, constituée selon un acte notarié
par-devant le notaire soussigné en date du 22 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le
6 juin 2007 (numéro 1090, page 52312). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 25 mai 2007,

ici représentée par:
Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 15 juin 2007.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de ADVENT StoCo INVESTMENT S.à r.l. (ci-après la «Société»), une

société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 32, rue Philippe
II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 127.694, constituée selon un acte notarié par-devant le notaire soussigné en date du 02
mai 2007, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société ont été modifiés
pour la dernière fois le 25 mai.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

116826

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quinze millions deux cent trente-

trois mille cinq cent quatre-vingt euros (EUR 15.233.580,-), afin de le porter de son montant actuel de quatre-vingt mille
six cent trente-huit euros (EUR 80.638,-) jusqu'à quinze millions trois cent quatorze mille deux cent dix-huit euros (EUR
15.314.218,-) par l'émission de quinze millions deux cent trente-trois mille cinq cent quatre-vingt euros (15.233.580) parts
sociales d'une valeur d'un euro (EUR 1.-) chacune (désignées ci-après comme les «Parts Sociales»).

Les quinze millions deux cent trente-trois mille cinq cent quatre-vingt euros (15.233.580) parts sociales nouvelles sont

souscrites par ADVENT StoCo HOLDING S.à r.l., prénommée, payées par un apport en nature consistant en l'apport
de l'ensemble du passif et de l'actif de ADVENT StoCo HOLDING S.à r.l.

L'apport de quinze millions deux cent trente-trois mille cinq cent quatre-vingt-un euros et trente-cinq cents (EUR

15.233.581,35) est alloué comme suit (i) quinze millions deux cent trente-trois mille cinq cent quatre-vingt euros (EUR
15.233.580,-) au capital social et (ii) un euro et trente-cinq cents (EUR 1,35) au compte de prime d'émission.

Une copie du contrat d'apport et du rapport d'évaluation mettant en évidence le transfert de de l'intégralité des actifs

et passifs de ADVENT StoCo HOLDING S.à r.l. a été remis au notaire instrumentant.

Le contrat d'apport signés ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné resteront

annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Dans la mesure où:
(1) l'apport en nature consiste dans l'intégralité des actifs et passifs comprenant la branche d'activité d'une société
(2) l'apport est fait exclusivement contre distribution des nouvelles actions, et
(3) toutes les sociétés concernées ont leur siège social dans l'Union Européenne,
un tel apport entre dans le champ d'application de l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exemption

de droit d'apport.

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide de réduire le capital social de la société par un montant de quatre-vingt mille six cent

trente-huit euros (EUR 80.638,-) par l'annulation de quatre-vingt mille six cent trente-huit (80.638) parts sociales d'une
valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, détenues par la Société en propre suite à l'apport par ADVENT StoCo
HOLDING S.à r.l. de l'ensemble de ses actifs et passifs.

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide de créer dix catégories de parts sociales, désignées comme les parts sociales de catégorie A

(les «Parts Sociales de Catégorie A»), les parts sociales de catégorie B («Parts Sociales de Catégorie B»), les parts sociales
de catégorie C («Parts Sociales de Catégorie C»), les parts sociales de catégorie D («Parts Sociales de Catégorie D»),
les parts sociales de catégorie E («Parts Sociales de Catégorie E»), les parts sociales de catégorie F («Parts Soiales de
Catégorie F»), les parts sociales de catégorie G («Parts Sociales de Catégorie G»), les parts sociales de catégorie H («Parts
Sociales de Catégorie H»), les parts sociales de catégorie I («Parts Sociales de Catégorie I»), les parts sociales de catégorie
J («Parts Sociales de Catégorie J»), chacune ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-).

<i>Quatrième résolution

L'associé unique décide de transformer l'ensemble des quinze millions deux cent trente-trois mille cinq cent quatre-

vingt euros (15.233.580) de Parts Sociales, ayant une valeur nominale de un euro chacune (EUR 1.-) en un million cinq
cent vingt-trois mille trois cent cinquante-huit (1.523.358) Parts Sociales de Catégorie A ayant une valeur nominale de
un euro chacune (EUR 1,-), un million cinq cent vingt-trois mille trois cent cinquante-huit (1.523.358) Parts Sociales de
Catégorie B ayant une valeur nominale de un euro chacune (EUR 1,-), un million cinq cent vingt-trois mille trois cent
cinquante-huit (1.523.358) Parts Sociales de Catégorie C ayant une valeur nominale de un euro chacune (EUR 1,-), un
million cinq cent vingt-trois mille trois cent cinquante-huit (1.523.358) Parts Sociales de Catégorie D ayant une valeur
nominale de un euro chacune (EUR 1,-), un million cinq cent vingt-trois mille trois cent cinquante-huit (1.523.358) Parts
Sociales de Catégorie E ayant une valeur nominale de un euro chacune (EUR 1,-), un million cinq cent vingt-trois mille
trois cent cinquante-huit (1.523.358) Parts Sociales de Catégorie F ayant une valeur nominale de un euro chacune (EUR
1,-), un million cinq cent vingt-trois mille trois cent cinquante-huit (1.523.358) Parts Sociales de Catégorie G ayant une
valeur nominale de un euro chacune (EUR 1,-), un million cinq cent vingt-trois mille trois cent cinquante-huit (1.523.358)
Parts Sociales de Catégorie H ayant une valeur nominale de un euro chacune (EUR 1,-), un million cinq cent vingt-trois
mille trois cent cinquante-huit (1.523.358) Parts Sociales de Catégorie I ayant une valeur nominale de un euro chacune
(EUR 1,-) et un million cinq cent vingt-trois mille trois cent cinquante-huit (1.523.358) Parts Sociales de Catégorie J ayant
une valeur nominale de un euro chacune (EUR 1,-).

<i>Cinquième résolution

A la suite des résolutions ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme

suit:

« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de quinze millions deux cent trente-trois mille cinq cent

quatre-vingt  euros  (EUR  15.233.580,-)  représenté  par  un  million  cinq  cent  vingt-trois  mille  trois  cent  cinquante-huit

116827

(1.523.358) Parts Sociales de Catégorie A, un million cinq cent vingt-trois mille trois cent cinquante-huit (1.523.358) Parts
Sociales de Catégorie B, un million cinq cent vingt-trois mille trois cent cinquante-huit (1.523.358) Parts Sociales de
Catégorie C, un million cinq cent vingt-trois mille trois cent cinquante-huit (1.523.358) Parts Sociales de Catégorie D, un
million cinq cent vingt-trois mille trois cent cinquante-huit (1.523.358) Parts Sociales de Catégorie E, un million cinq cent
vingt-trois mille trois cent cinquante-huit (1.523.358) Parts Sociales de Catégorie F, un million cinq cent vingt-trois mille
trois cent cinquante-huit (1.523.358) Parts Sociales de Catégorie G, un million cinq cent vingt-trois mille trois cent cin-
quante-huit (1.523.358) Parts Sociales de Catégorie H, un million cinq cent vingt-trois mille trois cent cinquante-huit
(1.523.358) Parts Sociales de Catégorie I, et un million cinq cent vingt-trois mille trois cent cinquante-huit (1.523.358)
Parts Sociales de Catégorie J (collectivement désignées ci-après les «Parts Sociales»), d'une valeur d'un euro (EUR 1,-)
chacune et dont les droits et obligations sont ceux prévus par les présents Statuts.

6.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière

requise pour la modification des présents Statuts.

6.3. Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation de Parts Sociales y compris par l'annulation de

l'entièreté d'une ou de plusieurs Catégorie(s) de Parts Sociales, par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales
émises de cette/ces classe(s). En cas de rachats et d'annulations de catégorie de Parts Sociales, de tels annulations et
rachats de Parts Sociales seront faits dans l'ordre alphabétique inverse (commençant avec la catégorie J ).

6.4. Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une catégorie de Parts Sociales (dans

l'ordre établi à l'article 6.3), une telle catégorie de Parts Sociales donne droit à son détenteur au pro rata de leurs détention
dans cette catégorie, au Montant Disponible (dans la limite cependant du Montant Total d'Annulation (tel que défini ci-
après) tel que déterminé par l'assemblée générale des associés) et les détenteurs de parts sociales de la catégorie de Parts
Sociales rachetée et annulée recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale (tel que
définie ci-après) pour chaque Part Sociale de la Catégorie concernée détenue par eux et annulée.

6.4.1. La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre

de Parts Sociales émises dans la catégorie de Parts Sociales à être rachetée et annulée.

6.4.2. Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le conseil de gérance et approuvé par l'assemblée

générale des associés sur la base de Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des
Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible de la catégorie concernée au moment de l'annulation de
cette catégorie sauf autrement décidé par l'assemblée générale des associés selon la procédure prévue pour une modi-
fication  des  Statuts  à  condition  toutefois  que  le  Montant  Total  d'Annulation  ne  soit  jamais  supérieur  au  Montant
Disponible.

6.4.3. A compter du rachat et de l'annulation des parts sociales de la catégorie concernée, la Valeur d'Annulation par

Part Sociale sera due et payable par la Société.»

<i>Sixième résolution

A la suite des résolutions ci-dessus, l'article 22 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme

suit:

« Art. 22. Définitions.
22.1. Sur le bénéfice net de la Société, il sera affecté cinq pour cent (5%) sur le compte réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis par la Société.

22.2. Le solde sera distribuée aux associés après décision de l'assemblée générale des associés conformément aux

provisions établies ci-après.

22.3. Les associés peuvent décider de déclarer et de payer des dividendes intérimaires sur la base des comptes sociaux

préparée par le gérant, ou le cas échéant par le conseil de gérance, démontrant que suffisamment de fonds sont disponibles
pour la distribution, étant entendu que le montant devant être distribué ne pourra pas excéder les profits réalisés depuis
la fin de la dernière année comptable augmentés par les profits reportés et réserves distribuables, mais diminué des pertes
reportées  et  des  sommes  devant  être  allouées  à  une  réserve  devant  être  établie  par  la  loi,  conformément  avec  les
dispositions établies ci-après.

22.4. Le compte prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés

conformément aux dispositions établies ci-après. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant
du compte prime d'amission au compte réserve légale.

22.5. Les dividendes déclarés peuvent être payés en toutes devises choisies par le gérant ou le cas échéant par le conseil

de gérance et pourront être payés en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le gérant ou le cas échéant par
le conseil de gérance. Le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, peut prendre une décision finale quant au cours
applicable pour traduire les montants des dividendes en la devise de leur paiement. Un dividende déclaré mais non payé
pour une part sociale pendant cinq ans, ne pourra par la suite plus être réclamé par le propriétaire d'une telle part sociale,
sera perdu pour celui-ci, et reviendra à la société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non réclamés,
qui seront détenus par la Société pour le compte des détenteurs de parts sociales.

22.6. En cas de déclaration de dividende, un tel dividende devra être alloué et payé comme suit:
(i) un montant équivalent à 0.25% de la valeur nominale de chaque part sociale sera distribué de manière égale à tous

les associés au pro rata de leurs parts sociales, sans égard de catégorie, puis

116828

(ii) le solde du montant total distribué sera alloué dans son intégralité aux détenteurs de la dernière catégorie dans

l'ordre alphabétique inversé (i.e en premier les Parts Sociales de Catégorie J, puis si aucune Part Sociale de Catégorie J
existe, les Parts Sociales de Catégorie I, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Parts Sociales de Catégorie A qui
existent.»

<i>Septième résolution

A la suite des résolutions ci-dessus, L'Associé unique décide de créer un article 25 dans les Statuts de la Société, qui

inclura de nombreuses définitions relatives à l'article 22 des Statuts de la Société:

« Art. 25.
25.1. Comptes Intérimaires signifie les Comptes Intérimaires de la Société à la Date Comptable Intérimaire pertinente.
25.2. Date Comptable Intérimaire signifie la date pas plus tôt que huit (8) jours avant la date du rachat et de l'annulation

de la Catégorie pertinente de Parts Sociales Préférentielles, pourvu que cette date ne puisse être postérieure au dernier
jour du troisième mois après la fin de la première année suivant le début de la date de la période pertinente.

25.3. Montant Disponible signifie le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits reportés) augmentés

de (i) la prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables et (ii) selon les cas par le
montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la Catégorie de Parts
Sociales annulée mais réduit de (i) toute perte (incluant les pertes reportées) et (ii) toutes sommes qui devront être
placées en réserve(s) suivant les exigences de la loi ou des statuts déterminés sur base des Comptes Intérimaires afférents
(sans pour éviter tout doute tout calcul en double) tel que:

MD = (PN + P+ RC) - (P + RL)
Pour lequel:
MD= Montant Disponible
PN= Profits Nets (incluant les profits reportés)
P= toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables
RC = montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la Catégorie de

Parts Sociales annulée

P= perte (incluant les pertes reportées)
RL = sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la loi ou des Statuts.»

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à six mille euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2007. Relation: EAC/2007/6837. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 10 août 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007117326/239/359.
(070134448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2007.

Art Limited Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 85.165.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

116829

Luxembourg, le 23 août 2007.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007116961/1453/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI10395. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070133464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

PYTHON Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 75.965.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2007.

<i>Pour PYTHON HOLDING SA
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007116986/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2007, réf. LSO-CI09291. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070133809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

MOOR PARK MB 14 Kassel bei Vellmar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 125.349.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 1 

er

 octobre 2007.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Notaire

Référence de publication: 2007116953/231/14.
(070133847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

Red Nova S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 103.387.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2007.

TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007116995/805/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2007, réf. LSO-CI09892. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070133831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

PYTHON Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 75.965.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

116830

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2007.

<i>Pour PYTHON HOLDING SA
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007116987/1021/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2007, réf. LSO-CI09286. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070133811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2007.

Robin Finance Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 92.749.

L'an deux mille sept, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie:

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme Holding ROBIN FINANCE HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-8705 Useldange, 31, rue de la Gare, R.C.S. Diekirch numéro 6.060, constituée suivant acte
reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 3 avril 2001, publié au Mémorial C
numéro 966 du 6 novembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Kettmann, employé privé, demeurant professionnellement

à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

Le président désigne comme secrétaire Madame Christine Racot, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

L'assemblée  choisit  comme  scrutatrice  Madame  Fanny  Marx,  employée  privée,  demeurant  professionnellement  à

L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

L'actionnaire unique présent ou représenté à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions ont été portés sur

une liste de présence, signée par l'actionnaire présent et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de
présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Restera pareillement annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant de l'actionnaire

unique représenté à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de la première phrase de l'article deux des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante: «Le

siège social de la société est établi à Luxembourg».

2) Modification de l'article quatorze des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:
«L'assemblée générale se réunit le 3 

ème

 vendredi du mois de mai à 10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
L'assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois à cette date en 2007.
3) Le siège est transféré du 31, rue de la Gare à L-8705 Useldange, au 180, rue des Aubépines à L-1145 Luxembourg.
4) Démission des administrateurs actuels et nomination de VALON S.A., LANNAGE S.A. et KOFFOUR S.A., en leur

remplacement jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2012.

5) Nomination de AUDIT TRUST S.A. en remplacement du commissaire aux comptes actuel jusqu'à l'assemblée gé-

nérale ordinaire de l'année 2012.

6) Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, l'action-

naire présent ou représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui lui a été communiqué au préalable.

116831

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide, avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2007, de modifier la première phrase de l'article deux des

statuts de la société pour lui donner la teneur suivante: «Le siège social de la société est établi à Luxembourg».

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2007, de modifier l'article quatorze des statuts de la société,

pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale se réunit le 3 

ème

 vendredi du mois de mai à 10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

L'assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois à cette date en 2007.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2007, de transférer le siège social de la société du 31, rue de

la Gare à L-8705 Useldange, au 180, rue des Aubépines à L-1145 Luxembourg et de modifier la première phrase de l'article
deux des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Luxembourg».

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2007, d'accepter le démission des administrateurs actuels et

leur donne décharge entière et définitive de leur mandat.

L'assemblée décide de nommer les administrateurs suivants en leur remplacement, jusqu'à l'assemblée générale ordi-

naire de l'année 2012.

a) LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-63130.

b) VALON S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-63143.

c) KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-86086

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2007, d'accepter la démission de commissaire aux comptes

actuel et décide de nommer en son remplacement, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2012: AUDIT TRUST
S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.115.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Kettmann, C. Racot, F. Marx, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2007, Relation: LAC/2007/24121. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007117374/211/84.

(070134777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

116832


Document Outline

Abowijs International S.A.

Advanced Network Solutions S.à r.l.

Advent Stoco Investment S.à. r.l.

Advent Stoco Investment S.à. r.l.

Arlington Europe Finance S.à r.l.

Art Limited Company S.A.

B.E.E.P. (Business Economy Engineering Projects) Luxembourg, S.àr.l.

Benelugap S.A.

Berrak Holding S.A.

CAMPIMOL Société Financière de la Campine

Capital Target Europe S.A.

CEFIP S.à r.l.

CEP II Participations S.à r.l. SICAR

Communauté d'Exploitation agricole DENNEWALD-KLENSCH et Cie

CVI GVF Luxembourg Eighteen S.à r.l.

CVI GVF Luxembourg Nineteen S.à r.l.

Edelweiss Immobilière S.A.

Entente des Syndicats d'Initiative et de Tourisme des Communes de Burmerange, Mondorf-les-Bains, Remich, Schengen et Wellenstein

Euromachines S.à.r.l.

European Retail Income Venture S.C.A.

Extensity

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

GEBPF Finance (Lux) S.à r.l.

Holding d'Investissement et de Placement S.A.

Lancaster Invest Holding S.A.

Luxore

Mars Propco 18 S.à r.l.

Mars Propco 19 S.à r.l.

Mars Propco 23 S.à r.l.

Mars Propco 26 S.à r.l.

Mars Propco 28 S.à r.l.

Mars Propco 32 S.à r.l.

Mars Propco 34 S.à r.l.

Mars Propco 40 S.à r.l.

Metrosphère Luxembourg S.à r.l.

MOOR PARK MB 14 Kassel bei Vellmar S.à r.l.

Noe Participations

Poseidon S.A.

PPF Banimmo Holdings S.à r.l.

PPF Brittany Holdings S.à r.l.

PYTHON Holding S.A.

PYTHON Holding S.A.

Red Nova S.A.

RES S.A.

Robin Finance Holding S.A.

Technet Investment Holding

TriCage Acquisition