This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2381
23 octobre 2007
SOMMAIRE
Alvema S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114246
Badengruppe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114242
Basta Così S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114272
Bel-Fa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114258
Beos Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114242
Canotiers de Savoie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
114244
Co-Invest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
114288
Craven Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
114272
CVI GVF Germany GP Two S.à r.l. . . . . . .
114264
CVI GVF Luxembourg Two S.à r.l. . . . . . .
114264
Esther Thirteen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
114258
European Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
114246
Falcon II Real Estate Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114282
Femmes Développement A.s.b.l. (forma-
tion, éducation, maternité, modernité,
entreprise, solidarité, développement)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114279
Financière Chinon Holding S.A. . . . . . . . . .
114251
Fortis Comfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114250
Fortis Quam Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114250
Grainger Luxembourg Germany (No.1) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114255
Grainger Luxembourg Germany (No.8) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114276
Happy and Dolphin, Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
114257
International Logistic Froid SA . . . . . . . . . .
114242
Isline Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114263
Jaga Holding A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114254
Larochettefels S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114288
Levlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114243
Linco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114270
Luxheaven Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . .
114270
Medicover Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
114244
Melia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114271
Melia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114250
Melia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114251
Menara S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114288
Merith International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
114242
Metaldyne Europe Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
114280
M.H.M. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114271
Mom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114255
Nanteuil Logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114279
Overcastle Investments S.A. . . . . . . . . . . . .
114251
Pontoon Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114252
RIA Allocation I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114250
Rozier S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114284
Rutherford S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114271
Sagis Gallica S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114287
UBS Target Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114245
Unit Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114244
Valence S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114271
114241
International Logistic Froid SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 85.046.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu vendredi <i>9 novembre 2007i> à 15.30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007121548/1267/15.
Badengruppe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 82.195.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,
qui aura lieu le <i>8 novembre 2007i> à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 juillet 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
juillet 2007.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007121549/1023/17.
Merith International S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 46.044.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,
qui aura lieu le <i>8 novembre 2007i> à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mai 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
mai 2007.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007121550/1023/16.
Beos Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 27.735.
The shareholders are hereby convened to the
114242
ORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders which will be held on Monday, the <i>12th of November 2007i> at 9.00 a.m. at the registered office, with
the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Management report of the board of directors and reports of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2003, as of December 31, 2004, as of December 31, 2005 and
as of December 31, 2006.
3. Appropriation of results as of December 31, 2003, as of December 31, 2004, as of December 31, 2005 and as of
December 31, 2006.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates during the related
fiscal years.
5. Resignation of Mr Hans De Graaf as director and discharge.
6. Resignation of the public limited company MONTEREY SERVICES S.A. as director and discharge.
7. Resignation of the private limited company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. as director and dis-
charge.
8. Appointment of Mr Cornelius Martin Bechtel, company director, born in Emmerich (Germany), on March 11, 1968,
residing professionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end
of the statutory general shareholders' meeting of 2009.
9. Appointment of Mrs Virginie Dohogne, company director, born in Verviers (Belgium), on June 14, 1975, residing
professionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end of the
statutory general shareholders' meeting of 2009.
10. Appointment of Mrs Christine Schweitzer, company director, born in Thionville (France), on June 20, 1971, residing
professionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end of the
statutory general shareholders' meeting of 2009.
11. Sundry.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2007121551/29/33.
Levlux S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 28.478.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra lundi, le <i>12 novembre 2007i> à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 28 février 2007.
3. Affectation des résultats au 28 février 2007.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Non renouvellement du mandat d'administrateur, venu à échéance, de la société anonyme MONTEREY SERVICES
S.A., et décharge.
6. Non renouvellement du mandat d'administrateur, venu à échéance, de la société anonyme EURO MANAGEMENT
SERVICES S.A., et décharge.
7. Non renouvellement du mandat d'administrateur, venu à échéance, de la société à responsabilité limitée UNIVER-
SAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., et décharge.
8. Nomination de Monsieur Cornelius Martin Bechtel, administrateur de sociétés, né à Emmerich (Allemagne), le 11
mars 1968, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.
9. Nomination de Monsieur Gérard Birchen, administrateur de sociétés, né à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de
Luxembourg), le 13 décembre 1961, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.
10. Nomination de Monsieur Sinan Sar, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
le 5 juin 1980, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.
11. Reconduction de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. dans son mandat de commissaire aux
comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.
12. Divers.
114243
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007121552/29/33.
Unit Investments S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 30.253.
The Shareholders are hereby convened to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on November <i>13, 2007i> at 11.00 a.m. at the registered office with the following
<i>Agenda:i>
- To receive and approve the Management Report of the Directors relating to the consolidated financial statements
for the year ended December 31, 2006,
- To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended December 31, 2006 relating to the conso-
lidated financial statements,
- To receive and approve the consolidated financial statements and appropriation of earnings for the year ended
December 31, 2006.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five
clear days before the date of the meeting at the Registered Office.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2007111698/755/19.
Canotiers de Savoie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 65.831.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra vendredi, <i>2 novembre 2007i> à 15.10 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2006.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Démission de Monsieur Daniel Galhano de son mandat d'administrateur et décharge.
6. Nomination de Monsieur Pietro Longo, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2007117614/29/20.
Medicover Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 59.021.
Time and place
The EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of MEDICOVER HOLDING S.A. will be held at 20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg on <i>31 October 2007i> at 11.00
a.m. to transact the following business:
<i>Agenda:i>
1. Acknowledgment and acceptance of the resignation of the Independent Auditor Mr Marc Hoydonckx, KPMG,
AUDIT, Réviseur d'Entreprises, from his mandate with effect on 31 October 2007;
114244
2. Discharge of the Independent Auditor Mr Marc Hoydonckx, KPMG AUDIT, Réviseur d'Entreprises from liability
for the period January 1, 2007 until 31 October 2007; and
3. Election of ATRIO S.à r.l. as new Independent Auditor of MEDICOVER HOLDING S.A. for a period ending at the
next annual general meeting to be held in 2008 in relation to the accounts of the financial year ended 31 December
2007.
Who may attend the Meeting
Holders of registered shares in the Company registered with the Company Registrar on 19 October 2007 are entitled
to attend the Meeting. Holders of Swedish Depository Receipts may attend the Meeting only upon notification as set
forth below.
How to notify to attend the Meeting
Shareholders have the right to participate in the business of the Meeting and to exercise their voting rights either in
person or by proxy. Shareholders do not have to notify the Company of their intent to participate in person at the
Meeting.
To be entitled attend the Meeting in person, owners of Swedish Depository Receipts must notify SVENSKA HAN-
DELSBANKEN AB, Corporate Finance, by phone +46 8 701 23 82 by 25 October 2007.
Voting
Holders of registered shares registered with the Company Registrar on 19 October 2007 may vote either (i) in person
at the Meeting or (ii) appoint a proxy to represent them. Proxies do not need to be members of the Company. The
procedure for voting by a proxy requires that the shareholder complete a special form (available on the Company's web-
site as «Form of Proxy for Registered Shareholders»). The shareholder shall indicate on the form how (s)he wants to
vote on the issue addressed by the Meeting and deliver it to the Company not less than two full business days before the
day appointed for holding the Meeting.
Holders of Swedish Depository Receipts registered with the Swedish Securities Register Center (VPC) on 19 October
2007 may vote either (i) in person at the Meetings upon notification as described above, or (ii) by delivering to the
Company a duly completed special form (available on the Company's web-site as «Form of Proxy for Swedish Depository
Receipts»). The holder of Swedish Depository Receipts shall indicate on the form how (s)he wants to vote on the issue
addressed by the Meeting and deliver it to MEDICOVER HOLDING S.A. c/o svenska handelsbanken AB, Corporate
Finance, Emissionsavdelningen, 106 70 Stockholm, Sweden by 25 October 2007.
Référence de publication: 2007117620/280/41.
UBS Target Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 87.795.
Shareholders are kindly convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders which will be held at 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, on <i>31 October, 2007i> at 11.00
a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and the Auditor.
2. Approval of the financial statements as of 31 May, 2007.
3. Decision on allocation of net profits.
4. Discharge of the Directors and of the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year
ended 31 May, 2007.
5. Election and Remuneration of the Board Members.
6. Appointment of the Auditor.
7. Miscellaneous.
<i>Voting:i>
Resolutions on the Agenda may be passed without quorum, by a simple majority of the votes cast thereon at the
Meeting.
<i>Notes:i>
Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
* in person by producing at the Meeting a blocking certificate issued by the Custodian Bank, UBS (LUXEMBOURG)
S.A., which will be issued to them against blocking of their shares, at the latest on 26 October, 2007.
114245
* by proxy by completing the proxy form which will be made available to them against blocking of their shares as
aforesaid. The proxies must be sent together with the blocking certificate to and have to be in possession of UBS TARGET
FUND, c/o UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on 26 October, 2007.
Shares so blocked will be retained until the day after the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2007118194/755/31.
Alvema S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 27.142.
By the present we have the pleasure to invite you to the
ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING
of ALVEMA S.A. to be on <i>October 31st, 2007i> at 11.00 a.m. at the offices of M
e
Paul Frieders, notary in Luxembourg,
3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.
The agenda will be the following:
<i>Agenda:i>
1. Directors' report for the business year ending on February 20th, 2007. Independent auditors' report for the bu-
siness year ending on February 20th, 2007. Approval of the balance sheet and the profit and loss account for the
business year ending on February 20th, 2007.
2. Appropriation of net results.
3. Discharge of liability to the Directors.
4. Approval of the decision of the Board not to carry on the activity of the company and to apply for the reinsurance
license withdrawal, as Reinsurance Company.
5. Liquidation of the company.
6. Nomination of a liquidator.
In case you could not be present at this meeting please return the attached proxy to the fax number (+352) 49 69 36,
in Luxembourg before October 30th, 2007.
Oslo, September 3rd, 2007.
Signature / Signature
<i>Directori> / <i>Directori>
Référence de publication: 2007117749/4685/26.
European Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 382.100,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 121.620.
In the year two thousand and seven, on the twenty-eighth day of August.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
EUROPEAN PROPERTY FUND, a société d'investissement à capital variable incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 120.679,
hereby represented by Mr Laurent Clairet, lawyer, residing professionally in Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg),
by virtue of a proxy given in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on 23 August 2007.
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of EUROPEAN PROPERTIES S.à r.l., has requested the
undersigned notary to document the following:
The appearing party is the single shareholder of EUROPEAN PROPERTIES S.à r.l., a limited liability company («société
à responsabilité limitée») incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) (the «Company») incorporated by a
notarial deed, on 20th October 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial
C») N
o
2425 of 28 December 2006, last time amended by a deed of the undersigned notary, on 28th June 2007, not yet
114246
published in the Mémorial C and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, Section B, under the
number B 121.620.
The appearing party, represented as above mentioned, recognises that it has been fully informed of the resolutions to
be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To increase the Company's subscribed capital by an amount of ninety-three thousand nine hundred and twenty-five
euro (EUR 93,925.-) so as to raise it from its current amount of two hundred eighty-eight thousand one hundred and
seventy-five euro (EUR 288,175.-) divided into eleven thousand five hundred and twenty-seven (11,527) shares, each
share with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) to three hundred eighty-two thousand and one hundred euro
(EUR 382,100.-) divided into fifteen thousand two hundred and eighty-four (15,284) shares, each share with a nominal
value of twenty-five euro (EUR 25.-).
2. To issue three thousand seven hundred and fifty-seven (3,757) new shares so as to raise the number of shares from
eleven thousand five hundred and twenty-seven (11,527) shares to fifteen thousand two hundred and eighty-four (15,284)
shares, each share with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those
attached to the existing shares and entitlement to dividends as from the day of the decision of the single shareholder
resolving on the proposed capital increase.
3. To accept the subscription of three thousand seven hundred and fifty-seven (3,757) new shares with a nominal value
of twenty-five euro (EUR 25.-) each by European Property Fund and to accept payment in full of each of these shares by
a contribution in cash.
4. To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the
resolutions to be adopted under items 1 to 3 of the agenda.
5. To authorise any lawyer of LINKLATERS LLP to record the capital increase in the share register of the Company
and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and Companies Register and the Mé-
morial C.
and has requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The single shareholder resolves to increase the Company's subscribed capital by an amount of ninety-three thousand
nine hundred and twenty-five euro (EUR 93,925.-) so as to raise it from its current amount of two hundred eighty-eight
thousand one hundred and seventy-five euro (EUR 288,175.-) divided into eleven thousand five hundred and twenty-seven
(11,527) shares, each share with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) to three hundred eighty-two thousand
and one hundred euro (EUR 382,100.-) divided into fifteen thousand two hundred and eighty-four (15,284) shares, each
share with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-).
<i>Second resolutioni>
The single shareholder resolves to issue three thousand seven hundred and fifty-seven (3,757) new shares so as to
raise the number of shares from eleven thousand five hundred and twenty-seven (11,527) shares to fifteen thousand two
hundred and eighty-four (15,284) shares, each share with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-), having the same
rights and privileges as those attached to the existing shares and entitlement to dividends as from the day of the decision
of the single shareholder resolving on the proposed capital increase.
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon appeared Mr Laurent Clairet, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Euro-
pean Property Fund, a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered
office at 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of the proxy referred to
hereinabove.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of European Property Fund, for three thousand
seven hundred and fifty-seven (3,757) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each of the Com-
pany, and to make payment in full for each of such new shares by a contribution in cash of an amount of ninety-three
thousand nine hundred and twenty-five euro (EUR 93,925.-) (the «Contribution»), which is as of now at the disposal of
the Company, proof of the payment having been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Third resolutioni>
The single shareholder, to the extent that it acts in lieu of the general meeting of shareholders, resolves to accept the
subscription and payment of each of these shares by a contribution in cash consisting of the Contribution and to allot the
three thousand seven hundred and fifty-seven (3,757) shares newly issued, each share with a nominal value of twenty-five
euro (EUR 25.-) each to European Property Fund.
<i>Fourth resolutioni>
The single shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company
to read as follows:
114247
« Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at three hundred eighty-two thousand and one
hundred euro (EUR 382,100.-) divided into fifteen thousand two hundred and eighty-four (15,284) shares, with a nominal
value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.»
<i>Fifth resolutioni>
The single shareholder resolves to authorise any lawyer of LINKLATERS LLP to record the capital increase in the
share register of the Company and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and
Companies Register and the Mémorial C.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document are estimated at approximately two thousand three hundred euro (2,300.- EUR).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt huit août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
EUROPEAN PROPERTY FUND, une société d'investissement à capital variable créée sous droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), étant inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 120.679,
représentée par Monsieur Laurent Clairet, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg),
aux termes d'une procuration donnée à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 23 août 2007.
Ladite procuration sera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Le comparant, agissant en sa qualité d'associé unique de EUROPEAN PROPERTIES S.à r.l., a demandé au notaire
soussigné de prendre acte de ce qui suit:
Le comparant est l'associé unique de EUROPEAN PROPERTIES S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)
(la «Société»), constituée par acte notarié, le 20 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial C») N
o
2425 du 28 décembre 2006, modifié pour la dernière fois par acte du notaire soussigné le 28 juin
2007, en cours de publication au Mémorial C et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
Section B, sous le numéro B-121.620.
Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être parfaitement informé des décisions à intervenir
sur la base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du Jour:i>
1. Augmentation du capital souscrit de la Société d'un montant de quatre-vingt-treize mille neuf cent vingt-cinq euros
(93.925,- EUR) de manière à porter le capital de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-huit mille cent soixante
quinze euros (288.175,- EUR) divisé en onze mille cinq cent vingt-sept (11.527) parts sociales, ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, à trois cent quatre-vingt-deux mille cent euros (382.100,- EUR) divisé en quinze
mille deux cent quatre-vingt-quatre (15.284) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-
EUR).
2. Emission de trois mille sept cent cinquante-sept (3.757) nouvelles parts sociales de manière à porter le nombre de
parts sociales de onze mille cinq cent vingt-sept (11.527) parts sociales à quinze mille deux cent quatre-vingt-quatre
(15.284) parts sociales, chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), ayant les mêmes
droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la
décision de l'associé unique de procéder à l'augmentation de capital proposée.
3. Acceptation de la souscription de trois mille sept cent cinquante-sept (3.757) parts sociales ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune par European Property Fund et acceptation de la libération intégrale de chacune
de ces parts sociales par un apport en numéraire.
4. Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société de manière à refléter les résolutions
devant être adoptées sous les points 1 à 3 de l'ordre du jour.
114248
5. Autorisation à tout avocat de LINKLATERS LLP de procéder à l'enregistrement de l'augmentation de capital dans
le registre des parts de la Société et d'accomplir toutes les formalités nécessaires auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg et du Mémorial C.
et a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital souscrit de la Société d'un montant de quatre-vingt-treize mille neuf
cent vingt-cinq euros (93.925,- EUR) de manière à porter le capital de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-huit
mille cent soixante-quinze euros (288.175,- EUR) divisé en onze mille cinq cent vingt-sept (11.527) parts sociales, ayant
une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, à trois cent quatre-vingt-deux mille cent euros (382.100,-
EUR) divisé en quinze mille deux cent quatre-vingt-quatre (15.284) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de
vingt-cinq euros (25,- EUR).
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide d'émettre trois mille sept cent cinquante sept (3.757) nouvelles parts sociales de manière à
porter le nombre de parts sociales de onze mille cinq cent vingt-sept (11.527) parts sociales à quinze mille deux cent
quatre-vingt-quatre (15.284) parts sociales, chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR),
ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir
du jour de la décision de l'associé unique de procéder à l'augmentation de capital proposée.
<i>Souscription et Libérationi>
Ensuite est intervenu Monsieur Laurent Clairet, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de
EUROPEAN PROPERTY FUND, une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 34, avenue de la Liberté,
L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu de la procuration susvisée.
Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de EUROPEAN PROPERTY FUND, trois mille sept cent
cinquante sept (3.757) nouvelles parts sociales de la Société, chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq
euros (25,- EUR) et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales par un apport en numéraire d'un
montant de quatre-vingt-treize mille neuf cent vingt-cinq euros (93.925,- EUR) (l'«Apport»), qui se trouve dès à présent
à la disposition de la Société, preuve du paiement a été donnée au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide, dans la mesure où il agit pour le compte de l'assemblée générale des associés, d'accepter la
souscription et le paiement de chacune de ces parts sociales par un apport en numéraire correspondant à l'Apport et
d'attribuer les trois mille sept cent cinquante-sept (3.757) parts sociales, nouvellement émises, chaque part sociale ayant
une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) au European Property Fund.
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, qui sera dorénavant
rédigé comme suit:
« Art. 5. Capital social émis. Le capital social émis de la Société est fixé à trois cent quatre-vingt-deux mille cent euros
(382.100,- EUR) divisé en quinze mille deux cent quatre-vingt-quatre (15.284) parts sociales, ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et chaque part sociale étant entièrement libérée.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'associé unique décide d'autoriser tout avocat de LINKLATERS LLP de procéder à l'enregistrement de l'augmentation
de capital dans le registre des parts de la Société et d'accomplir toutes les formalités nécessaires auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg et du Mémorial C.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent
acte sont évalués à approximativement deux mille trois cents euros (2.300,- EUR).
Dont acte, le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant précité,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande du même comparant, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce
dernier a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Clairet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2007, LAC/2007/24461. — Reçu 939,25 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
114249
Luxembourg, le 19 septembre 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007112600/220/190.
(070129451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2007.
Fortis Quam Fund, Fonds Commun de Placement.
Le Règlement de Gestion consolidé enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, le 12 octobre 2007.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2007.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS QUAM FUND
i>FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
B. Quisquater
<i>Managing Directori>
Référence de publication: 2007119768/755/16.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04409. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070139964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2007.
Fortis Comfort, Fonds Commun de Placement.
Le Règlement de Gestion consolidé enregistré à Luxembourg a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg le 12 octobre 2007.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2007.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS COMFORT
i>FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
B. Quisquater
<i>Managing Directori>
Référence de publication: 2007119772/755/16.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04411. - Reçu 40 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070139961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2007.
RIA Allocation I, Fonds Commun de Placement.
Das mit Wirkung vom 19. Oktober 2007 gültige Verwaltungsreglement October 2007 des Fonds RIA ALLOCATION
I wurde registriert in Luxemburg und beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 11. Oktober 2007.
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Anell / Tiburzi
Référence de publication: 2007120489/2393/13.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2007, réf. LSO-CJ05330. - Reçu 52 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070142626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2007.
Melia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 88.086.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
114250
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007114395/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2007, réf. LSO-CI08496. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070131456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Melia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 88.086.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007114396/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2007, réf. LSO-CI08497. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070131459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Overcastle Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 88.602.
Il résulte, d'une part, du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 5 septembre
2007:
- que les mandats des administrateurs sortants:
- M. Lionello Ferrazzini, Président, avec adresse professionnelle au Via Salvioni, CH-6862 Rancate,
- M. Marc Schmit, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, et
ainsi que celui du commissaire aux comptes:
- BOLDWAY SERVICES LTD, n° 3866404 auprès du «Registrar of Companies for England and Wales», avec siège
social au 38, Wigmore Street, GB-W1H 0BX Londres,
ont été reconduits pour une nouvelle période de six ans; leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.
- que M. Fernand Heim, directeur financier, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Lu-
xembourg-Kirchberg, a été nommé au poste d'administrateur en remplacement de M. Gérard Muller, démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance en même temps que celui de ses co-administrateurs, à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2013.
Il résulte, d'autre part, d'une résolution du Conseil d'Administration datée du 5 septembre 2007, que M. Lionello
Ferrazzini a également été reconduit dans son mandat d'administrateur-délégué avec pouvoir d'engager valablement la
société par sa seule signature pour la même durée, qui se terminera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en 2013.
Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Signature
Référence de publication: 2007114458/521/30.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2007, réf. LSO-CI06728. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070131279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Financière Chinon Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 61.141.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
114251
Luxembourg, le 27 septembre 2007.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2007114403/687/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2007, réf. LSO-CI07129. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070131399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Pontoon Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 117.246.
In the year two thousand seven, on the third day of the month of July,
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
was held an extraordinary general meeting of PONTOON LUXCO S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed
by the laws of Luxembourg, with registered office at 6, rue Philippe II, Centre Rosenstiel, L-2340 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of M
e
Jean-Joseph Wagner, notary residing in
Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), on 16 June 2006, published in the Mémorial C number 1587 of 22 August 2006
and entered in the Company Register at Luxembourg, Section B, under the number B 117.246. The articles of incorpo-
ration have been amended for the last time following a deed of M
e
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand
Duchy of Luxembourg), on 14 September 2006 published in the Mémorial C number 2314 of 12 December 2006.
The extraordinary general meeting is declared open with Mr Michael Jonas, lawyer, residing in Luxembourg, in the
chair,
who appointed as secretary Mrs Jennifer Ferrand, lawyer, residing in Luxembourg.
The extraordinary general meeting elected as scrutineer Mr Cédric Bless, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested
the notary to state:
(i) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
<i>Agendai>
1 To amend the last paragraph of article 5 of the articles of incorporation which shall read as follows:
«In addition to the subscribed capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any
share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its partners, to make distributions to the partners (including
at the liquidation of the Company), provided that any such redemption or such distributions out of share premium shall
firstly benefit such shares on which the relevant share premium has originally been paid, to offset any net realised losses
or to allocate funds to the legal reserve.»
2 To amend the last paragraph of article 24 of the articles of association which shall forthwith read as follows:
«After the payment of all debts and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed to the holders of the shares as follows: after repayment of each shareholders' capital contribution
(including any share premium paid), the net liquidation proceeds will be apportioned between the shareholders in pro-
portion to their aggregate contributions to the Company to subscribe for the shares held by them (including any share
premium paid.»
3 Miscellaneous.
(ii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown
on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and
by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.
(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
(iv) The whole corporate capital being represented at the present extraordinary general meeting and all the share-
holders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this
extraordinary general extraordinary general meeting, no convening notices were necessary.
(v) The present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items
of the agenda.
Then the extraordinary general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
114252
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting resolved to amend the last paragraph of article 5 of the articles of incorporation
which shall read as follows:
«In addition to the subscribed capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any
share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to make distributions to the shareholders
(including at the liquidation of the Company), provided that any such redemption or such distributions out of share
premium shall firstly benefit such shares on which the relevant share premium has originally been paid, to offset any net
realised losses or to allocate funds to the legal reserve.»
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting resolved to amend the last paragraph of article 24 of the articles of incorporation
which shall forthwith read as follows:
«After the payment of all debts and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed to the holders of the shares as follows: after repayment of each shareholders' capital contribution
(including any share premium paid), the net liquidation proceeds will be apportioned between the shareholders in pro-
portion to their aggregate contributions to the Company to subscribe for the shares held by them (including any share
premium paid).»
There being no other business, the extraordinary general meeting was thereupon closed.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le troisième jour du mois de juillet.
Par devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société PONTOON LUXCO S.à r.l., une société à
responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec siège social à 6, rue Philippe II, Centre Rosenstiel, L-2340
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire
résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 16 juin 2006, publié au Mémorial C numéro 1587 du 22
août 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 117.246. Les
statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de M
e
Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 14 septembre 2006, publié au Mémorial C numéro 2314 du 12
décembre 2006.
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Monsieur Michael Jonas, juriste, demeurant à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Jennifer Ferrand, avocat, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Monsieur Cédric Bless, juriste, demeurant à Luxem-
bourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
(i) La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1 Modification du dernier paragraphe de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«En plus du capital social souscrit, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes d'émission
payées sur une ou plusieurs actions en sus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut
être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat par la Société des actions des associés, pour effectuer des
distributions aux associés (y compris lors de la liquidation de la Société), sous réserve qu'un tel rachat ou qu'une telle
distribution prélevés sur la prime d'émission bénéficie en priorité aux actions sur lesquelles la prime d'émission en question
a été payée à l'origine, pour compenser des pertes nettes réalisées ou pour allouer des fonds à la réserve légale.»
2 Modification du dernier paragraphe de l'article 24 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net sera réparti
entre tous les associés de la manière suivante: après le remboursement de la contribution de chaque associé au capital
(y compris les primes d'émission payées), le produit net de la liquidation sera réparti entre les associés à proportion des
114253
contributions cumulées à la Société pour souscrire aux actions qu'ils détiennent (comprenant toute prime d'émission
payée).»
3 Divers.
(ii) Les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent,
sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les
mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
(iv) L'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, il a pu être fait
abstraction des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
(v) La présente assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement,
telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale extraordinaire, après avoir délibéré, a alors pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier le dernier paragraphe de l'article 5 des statuts qui aura
dorénavant la teneur suivante:
«En plus du capital social souscrit, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes d'émission
payées sur une ou plusieurs actions en sus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut
être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat par la Société des actions des associés, pour effectuer des
distributions aux associés (y compris lors de la liquidation de la Société), sous réserve qu'un tel rachat ou qu'une telle
distribution prélevés sur la prime d'émission bénéficie en priorité aux actions sur lesquelles la prime d'émission en question
a été payée à l'origine, pour compenser des pertes nettes réalisées ou pour allouer des fonds à la réserve légale.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier le dernier paragraphe de l'article 24 des statuts qui aura
dorénavant la teneur suivante:
«Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net est réparti
entre tous les associés de la manière suivante: après le remboursement de la contribution de chaque associé au capital
(y compris les primes d'émission payées), le produit net de la liquidation sera reparti entre les associés en proportion de
leur participation à la Société de souscrire pour les actions détenues par eux (comprenant toute prime d'émission payée).»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Jonas, J. Ferrand, C. Bless, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 2007. Relation: EAC/2007/7894. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 août 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007114903/239/148.
(070131126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Jaga Holding A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 82.164.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
114254
Luxembourg, 27 septembre 2007.
<i>Pour JAGA HOLDING A.G.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Référence de publication: 2007114443/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07792. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070130984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Mom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 115.885.
Il résulte du procès-verbal de la première Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 5 septembre
2007 que:
- M. Marc Schmit, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-
Kirchberg, a été nommé à la fonction d'administrateur en remplacement de M. Gérard Muller, démissionnaire.
Son mandat arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.
Pour extrait conforme
SG AUDIT Sàrl
Signature
Référence de publication: 2007114465/521/17.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2007, réf. LSO-CI06722. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070131278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Grainger Luxembourg Germany (No.1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.393.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 112.061.
In the year two thousand and seven, on the third of September
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.
There appeared:
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company, incorporated under
the law of the Grand Duchy of Luxembourg, whose registered office is at 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number
112.062,
here represented by Mr. Régis Galiotto, employee, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450, Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy established on August 31st, 2007.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the party appearing and the undersigned notary public, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary public to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under
the name of GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.1) S.à r.l., a company incorporated and existing under the
laws of Luxembourg, whose registered office is at 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxem-
bourg and is registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 112.061 incorpo-
rated by a deed of the undersigned notary public, dated October 11th, 2005, published in the Mémorial C, N° 394, page
18873, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on February 22nd, 2006 and which articles of association have been
amended on December 22nd, 2005, published in the Mémorial C, N° 848, page 40697, Recueil Spécial des Sociétés et
Association on April 28th, 2006.
II. The Company's share capital is set at three million nine hundred seventy-six thousand Euro (EUR 3,976,000.-)
represented by one hundred fifty-nine thousand and forty (159,040) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR
25.-) each.
The sole shareholder has taken the following resolutions:
114255
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by four hundred seventeen thousand five
hundred Euro (EUR 417,500.-) to raise it from its present amount of three million nine hundred seventy-six thousand
Euro (EUR 3,976,000.-) to four million three hundred ninety-three thousand five hundred Euro (EUR 4,393,500.-) by
creation and issuance of sixteen thousand seven hundred (16,700) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR
25.-) each, and an aggregate par value amounting to four hundred seventeen thousand five hundred Euro (EUR 417,500.-),
having the same rights and obligations as the existing shares, such shares to be fully paid up in par value together with a
share premium of four hundred seventeen thousand four hundred sixty Euro (EUR 417,460.-).
<i>Second resolutioni>
Intervention - Subscription - Payment
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS S.à r.l., aforementioned, through its proxy holder, declared to
subscribe to sixteen thousand seven hundred (16,700) newly issued shares of the Company with a par value of twenty-
five Euro (EUR 25.-) and fully pay them up in the amount of four hundred seventeen thousand five hundred Euro (EUR
417,500.-) together with the share premium of four hundred seventeen thousand four hundred sixty Euro (EUR 417,460.-)
by contribution in cash, so that the total amount of eight hundred thirty-four thousand nine hundred sixty Euro (EUR
834,960.-) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges
it.
<i>Third resolutioni>
Pursuant to the above increase of share capital, Article 6 of the articles of association is amended and shall henceforth
read as follows:
« Art. 6. The share capital is set at four million three hundred ninety-three thousand five hundred Euro (EUR
4,393,500.-) represented by one hundred seventy-five thousand seven hundred forty (175,740) shares with a par value
of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, entirely paid in.»
<i>Costs & expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated without prejudice at approximately 11,000.- Euros.
There being no further business, the meeting was adjourned.
The undersigned notary public who understands and speaks English states herewith that on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, who is known to the undersigned
notary public by his last and first name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary public, the
present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le trois septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS S.à r.l., société à responsabilité limitée constituée et régie par
les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Lu-
xembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 112.062 (la
«Société»)
ici représentée par M. Régis Galiotto, employé, avec adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450, Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 31 août 2007.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.1) S.à r.l., société à responsabilité limitée constituée et régie par les
lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxem-
bourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 112.061 constituée
par acte notarié, en date du 11 octobre 2005, publié au Mémorial C, N° 394, page 18873, Recueil Spécial des Sociétés et
114256
Associations le 22 février 2006 et dont les statuts ont été modifiés en date du 22 décembre 2005, publié au Mémorial C,
N° 848, page 40697,Recueil Spécial des Sociétés et Associations le 28 avril 2006.
II. Le capital social de la Société est fixé à trois millions neuf cent soixante-seize mille Euro (EUR 3.976.000,-) représenté
par cent cinquante-neuf mille quarante (159.040) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-)
chacune.
L'associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre cent dix-sept mille cinq
cents Euro (EUR 417.500,-) pour le porter de son montant actuel de trois millions neuf cent soixante-seize mille Euro
(EUR 3.976.000,-) à quatre millions trois cent quatre-vingt-treize mille cinq cents Euro (EUR 4.393.500,-) par la création
et l'émission de seize mille sept cents (16.700) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR
25,-) chacune, et d'une valeur nominale totale de quatre cent dix-sept mille cinq cents Euro (EUR 417.500,-), ayant les
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, lesquelles parts sociales devant être libérées intégralement,
à émettre avec une prime d'émission de quatre cent dix-sept mille quatre cent soixante Euro (EUR 417.460,-).
<i>Deuxième résolutioni>
Intervention - Souscription - Libération
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS S.à r.l., précitée, par son mandataire, déclare souscrire aux seize
mille sept cents (16.700) nouvelles parts sociales de la Société, d'une valeur nominale unitaire de vingt-cinq Euro (EUR
25,-) chacune, et les libérer intégralement au montant de quatre cent dix-sept mille cinq cents Euro (EUR 417.500,-) avec
la prime d'émission de quatre cent dix-sept mille quatre cent soixante Euro (EUR 417.460,-) par apport en espèces de
sorte que le montant total de huit cent trente-quatre mille neuf cent soixante Euro (EUR 834.960,-) est à la disposition
de la société comme l'atteste expressément le notaire instrumentaire.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à quatre millions trois cent quatre-vingt-treize mille cinq cents Euro (EUR 4.393.500,-)
représenté par cent soixante-quinze mille sept cent quarante (175.740) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq
Euro (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.»
<i>Frais & dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 11.000,- Euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état
civil et résidence, il a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2007, Relation: LAC/2007/25088. — Reçu 8.349,60 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007114796/211/130.
(070130909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Happy and Dolphin, Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 87.048.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
114257
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007114392/1123/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2007, réf. LSO-CI08532. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070131060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Bel-Fa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 64.369.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007114393/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05178. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070131448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Esther Thirteen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 131.885.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the eighteenth day of September.
Before Us, Maître Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
the company BLUE S.A., a «société anonyme», incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, established and having its registered office at 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg (R.C.S. Lux-
embourg, section B number 99.145),
here represented by:
Mr Brendan D. Klapp, employee, with professional address in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg,
pursuant to a proxy dated Luxembourg, 5 September 2007.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. There exists established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of
ESTHER THIRTEEN S.à r.l. (the Company).
Art. 2. The Company's main purpose is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition
of participations in any enterprises in any form whatsoever, as well as to the administration, management, control and
development of those participations.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any kind of securities, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, grant any
support, loans, advances or guarantees to the companies in which it has direct or indirect participating interests as well
as to any group company and shareholder.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.
Furthermore, the Company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or
indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all
real estate transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.
The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.
114258
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) repre-
sented by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five euro (25.- EUR) per share.
Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders
meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.
Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the
Companies Act).
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the
shareholders will not bring the Company to an end.
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the
share capital.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore by vote of the majority of the managers
present or represented at the board meeting.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 11 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-
delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The general shareholders meeting or the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration
(if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented,
and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of
managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation by a manager in a meeting by conference call or by other similar means of communication shall be
deemed to be a participation in person at such meeting. The decisions of the board of managers will be recorded in
minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers, present or represented at
the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain
attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it
shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of
114259
such circular resolution shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such
circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.
Art. 12. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 13. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies
Act.
Art. 14. The Company's year starts on the first day of January of each year and ends on the 31st of December the
same year.
Art. 15. Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and the manager, or in
case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.
Art. 17. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended, for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All five hundred (500) shares have been subscribed by the company BLUE S.A., prenamed, and have been fully paid-
up by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is as now at the free
disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2007.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately thousand six hundred euro.
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company
has herewith adopted the following resolutions:
1.- The number of the managers is set at two (2), and the following persons are elected managers for an unlimited
duration, with the powers set forth in article eleven (11) of the articles of incorporation of the Company:
(i) Mr Neil Medlyn, company director, born in Falmouth (United Kingdom), on 19 May 1953, residing professionally
at 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg;
(ii) Mr Tobias Mathews, company director, born in Nottingham (England), on 18 April 1963, residing professionally at
Channel House, St. Helier, Jersey C.I., JE4 5UW, Channel Islands.
2.- The registered office is established at 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed is drawn in Belvaux, in the offices of the undersigned notary, on the date stated
here above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the same proxy holder signed together
with Us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
114260
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
la société BLUE S.A., une société anonyme, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie
et ayant son siège social au 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 99.145),
ici représentée par:
Monsieur Brendan D. Klapp, employé, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration datée Luxembourg, le 5 septembre 2007.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter
ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de ESTHER THIRTEEN S.à r.l. (ci-
après, la Société).
Art. 2. L'objet principal de la société est la réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement
à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, accorder
tous concours, prêts, avances ou garanties tant aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations directes ou
indirectes qu'à toute société du groupe et à ses actionnaires.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
En outre, la société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées direc-
tement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire
toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.
La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,
qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté
par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée
des associés, conformément à l'article 13 des présents statuts.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas
fin à la Société.
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil
de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés
par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque conseil de
gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle
il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents
ou représentés lors du conseil de gérance.
114261
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 11.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la seule signature d'un membre quelconque du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le cadre des
compétences du conseil de gérance.
L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. L'assemblée des associés ou le
gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa
rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes
de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion,
sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de
gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre
gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence télé-
phonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion
de s'entendre mutuellement. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique
ou par tout autre moyen similaire de communication sera considérée comme une participation en personne à la réunion.
Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société
et signé par les gérants, présents ou représentés au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un
président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie
circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion
du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 13. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 14. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la
même année.
Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance
dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est
à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
pourra décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
114262
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de
la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et Libérationi>
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par la société BLUE S.A., prénommée et ont été intégralement
libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès
maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2007.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille six cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique prénommé, représentant la totalité du capital
souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre de gérants est fixé à deux (2), et les personnes physiques suivantes ont été nommées gérants de la
Société pour une durée illimitée, avec les pouvoirs prévus à l'article onze (11) des statuts de la Société:
(i) Monsieur Neil Medlyn, directeur de société, né à Falmouth (Royaume-Uni), le 19 mai 1953, demeurant profession-
nellement au 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg;
(ii) Monsieur Tobias Mathews, directeur de société, né à Nottingham (Royaume-Uni), le 18 avril 1963, demeurant
professionnellement à Channel House, St. Helier, Jersey C.I., JE4 5UW, Channel Islands.
2.- Le siège social de la société est établi au 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé
avec le notaire instrumentant le présent acte.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire de la partie
comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: B. D. Klapp, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2007. Relation: EAC/2007/11323. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 21 septembre 207.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007114496/239/289.
(070131092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Isline Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 25.443.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 juin 2007i>
- la démission de Monsieur François Mesenburg est actée et il n'est pas pourvu à son remplacement;
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2007.
Certifié sincère et conforme
<i>ISLINE HOLDING S.A.
i>FINDI S.à r.l. / LOUV S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>Signature / Signature
Référence de publication: 2007113984/795/17.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2007, réf. LSO-CI06850. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070130452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2007.
114263
CVI GVF Luxembourg Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CVI GVF Germany GP Two S.à r.l.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 129.289.
In the year two thousand and seven, on the twenty-fourth day of July.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies' register under number B 119.271,
duly represented by Mr Pierre-Yves Genot, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in
Luxembourg, on 20 July 2007.
This proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached
to this document in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole shareholder (the «Sole Shareholder») of CVI GVF GERMANY GP TWO S.à r.l., a
société à responsabilité limitée having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with
the Luxembourg trade and companies' register under number B 129.289, incorporated pursuant to a deed of M
e
Henri
Hellinckx on 4 June 2007 (the «Company»).
The Sole Shareholder, representing the entire capital, takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from CVI GVF GERMANY GP TWO S.à r.l. to
CVI GVF LUXEMBOURG TWO S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above mentioned resolution, article 4 of the article of incorporation of the Company is
amended and shall now be read as follows:
« Art. 6. The Company is incorporated under the name of CVI GVF LUXEMBOURG TWO S.à r.l.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the French translation of the articles of incorporation into a German trans-
lation in the following manner:
«A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Personengesellschaften oder ähnlichen gesell-
schaftsrechtlichen Strukturen handeln mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher
Strukturen.
Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung CVI GVF LUXEMBOURG TWO S.à r.l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter oder gegebenenfalls des alleinigen Gesellschafters an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxem-
burg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäfts-
führers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden. Niederlassungen oder andere Fillialen können entweder entweder
in Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.
114264
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in zwölftausendfünf-
hundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese
Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss, oder gegebenenfalls der Zustimmung des alleinigen Gesellschafters.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die die Miteigentümer gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.
Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-
genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern oder gegebenenfalls von dem alleinigen Gesellschafter ernannt.
Die Gesellschafter oder der alleinige Gesellschafter bestimmen auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer
können jederzeit, ohne dass ein berechtigter Grund («cause légitime») hierzu bestehen muss, von den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter entlassen werden.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.
Der Geschäftsführerrat wird durch jedes seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort
einberufen.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
114265
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern oder von einer vom Geschäftsführerrat bevollmächtigten Person unterzeichnet.
Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-
sellschaft nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer oder jedes Geschäftsführerratsmitglied und seine Erben, Nach-
lassverwalter und Verwalter für Ausgaben, die vernünftigerweise in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit, einer Klage
oder Verfahren entstanden sind, zu welchem er aufgrund seiner Stellung als gegenwärtiger oder ehemaliger Geschäfts-
führer der Gesellschaft oder jeder anderen Körperschaft von der er nicht berechtigt ist Entschädigung zu erhalten, Partei
geworden ist. Dies gilt nicht in Verbindung mit Angelegenheiten bei denen letztendlich auf eine schwere Pflichtverletzung
(faute grave) oder eine vorsätzliche Pflichtverletzung (faute intentionnelle) erkannt wurde. Für den Fall einer Vereinbarung
soll eine Entschädigung nur für solche Angelegenheiten gezahlt werden, die von der Vereinbarung gedeckt sind, sofern
die Gesellschaft von einem rechtlichen Beistand darüber informiert wurde, dass die zu entschädigenden Person keine
Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht auf Entschädigung soll nicht die Geltendmachung anderer Rechte
zu der die Person berechtigt ist, ausschliessen.
Art. 17. Die Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat können sich dazu entschliessen Zwischendividenden auf der
Grundlage eines Rechenschaftsberichts, der von einem Geschäftsführer oder dem Geschäftsführerrat vorbereitet wird
und aufzeigt dass genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, auszuschütten, wobei der auszuschüttende Betrag nicht
die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Rechnungsjahres überschreiten darf. Der Betrag erhöht sich durch fort-
getragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, jedoch verringert er sich durch fortgetragene Verluste und Beträge die
einer Kapitalrücklage zugeführt werden, welche gemäss dem Gesetz oder dieser Satzung zu bilden ist.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 19. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 20. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Juni eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Mai desselben Jahres.
Art. 22. Am einunddreißigsten Mai jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer
stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder
Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 23. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des
Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. Zwischendi-
videnden werden in Einklang mit den gesetzlich vorgesehen Bedingungen zugeteilt.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung oder
gegebenfalls der alleinige Gesellschafter legt die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Es sei denn es ist etwas
anderes vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der
Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
114266
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.»
<i>Estimation of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall
be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand two hundred Euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a German version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the German and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendsieben, den vierundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxembourg.
Ist erschienen:
CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet und bestehend nach dem Recht des
Großherzogtums Luxembourg, mit Sitz in 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, eingetragen im Handels-und Ge-
sellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 119.271,
hier vertreten durch Her Pierre-Yves Genot, licencié en droit, wohnhaft zu Luxemburg, durch privatschriftliche Voll-
macht, erteilt am 20. Juli 2007, welche nach Unterzeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den unterzeichneten
Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben registriert zu werden.
Solche erschienene Partei ist alleiniger Gesellschafter von CVI GVF GERMANY GP ONE S.à r.l. (nachfolgend, die
«Gesellschaft»), eine société à responsabilité limitée mit Sitz in 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, gegründet am
4. Juni 2007 gemäß einer Urkunde des Notars Henri Hellinckx, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschafts-
register unter der Nummer B 129.289.
Hiernach fasst der das gesamte Gesellschaftskapital vertretende alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt, den Namen der Gesellschaft von CVI GVF GERMANY GP TWO S.à r.l. in CVI
GVF LUXEMBOURG TWO S.à r.l. umzuwandeln.
<i>Zweiter Beschlussi>
Als Folge des ersten Beschlusses beschließt der alleinige Gesellschafter, Artikel 4 der Gesellschaftssatzung abzuändern,
welcher von nun an wie folgt lautet:
« Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung CVI GVF LUXEMBOURG TWO S.à r.l.».
<i>Dritter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt die französische Übersetzung der Gesellschaftssatzung gegen eine deutsche
Übersetzung der Gesellschaftssatzung auszutauschen, welche nunmehr wie folgt lautet:
«A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Personengesellschaften oder ähnlichen gesell-
schaftsrechtlichen Strukturen handeln mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher
Strukturen.
Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
114267
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung CVI GVF LUXEMBOURG TWO S.à r.l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter oder gegebenenfalls des alleinigen Gesellschafters an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxem-
burg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäfts-
führers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden. Niederlassungen oder andere Fillialen können entweder entweder
in Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in zwölftausendfünf-
hundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese
Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss, oder gegebenenfalls der Zustimmung des alleinigen Gesellschafters.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die die Miteigentümer gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.
Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-
genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern oder gegebenenfalls von dem alleinigen Gesellschafter ernannt.
Die Gesellschafter oder der alleinige Gesellschafter bestimmen auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer
können jederzeit, ohne dass ein berechtigter Grund («cause légitime») hierzu bestehen muss, von den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter entlassen werden.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.
Der Geschäftsführerrat wird durch jedes seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort
einberufen.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
114268
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern oder von einer vom Geschäftsführerrat bevollmächtigten Person unterzeichnet.
Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-
sellschaft nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer oder jedes Geschäftsführerratsmitglied und seine Erben, Nach-
lassverwalter und Verwalter für Ausgaben, die vernünftigerweise in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit, einer Klage
oder Verfahren entstanden sind, zu welchem er aufgrund seiner Stellung als gegenwärtiger oder ehemaliger Geschäfts-
führer der Gesellschaft oder jeder anderen Körperschaft von der er nicht berechtigt ist Entschädigung zu erhalten, Partei
geworden ist. Dies gilt nicht in Verbindung mit Angelegenheiten bei denen letztendlich auf eine schwere Pflichtverletzung
(faute grave) oder eine vorsätzliche Pflichtverletzung (faute intentionnelle) erkannt wurde. Für den Fall einer Vereinbarung
soll eine Entschädigung nur für solche Angelegenheiten gezahlt werden, die von der Vereinbarung gedeckt sind, sofern
die Gesellschaft von einem rechtlichen Beistand darüber informiert wurde, dass die zu entschädigenden Person keine
Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht auf Entschädigung soll nicht die Geltendmachung anderer Rechte
zu der die Person berechtigt ist, ausschliessen.
Art. 17. Die Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat können sich dazu entschliessen Zwischendividenden auf der
Grundlage eines Rechenschaftsberichts, der von einem Geschäftsführer oder dem Geschäftsführerrat vorbereitet wird
und aufzeigt dass genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, auszuschütten, wobei der auszuschüttende Betrag nicht
die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Rechnungsjahres überschreiten darf. Der Betrag erhöht sich durch fort-
getragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, jedoch verringert er sich durch fortgetragene Verluste und Beträge die
einer Kapitalrücklage zugeführt werden, welche gemäss dem Gesetz oder dieser Satzung zu bilden ist.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 19. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 20. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Juni eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Mai desselben Jahres.
Art. 22. Am einunddreißigsten Mai jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer
stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder
Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
114269
Art. 23. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des
Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. Zwischendi-
videnden werden in Einklang mit den gesetzlich vorgesehen Bedingungen zugeteilt.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung oder
gegebenfalls der alleinige Gesellschafter legt die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Es sei denn es ist etwas
anderes vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der
Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt
Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.»
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
ein tausend zwei hundert Euro.
Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien
diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuch-
lichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: P.-Y. Genot, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, Relation: LAC/2007/19703. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (gezeichnet): F. Sandt.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und
Vereinigungen.
Luxemburg, den 9. August 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007114793/211/359.
(070131551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Linco, Société à responsabilité limitée holding.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 19.649.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 25 septembre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007114367/534/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2007, réf. LSO-CI06897. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070131144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Luxheaven Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 108.778.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
114270
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007114402/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05271. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070131444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
M.H.M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 74.894.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2007.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2007114411/687/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05448. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070131367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Valence S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 92.314.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2007.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007114529/550/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2007, réf. LSO-CI08524. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070131204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Rutherford S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 93.099.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2007.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2007114564/550/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2007, réf. LSO-CI08557. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070131203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Melia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 88.086.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
114271
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Signature.
Référence de publication: 2007114394/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2007, réf. LSO-CI08495. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070131452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Basta Così S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 10, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 101.467.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007114389/8148/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2007, réf. LSO-CI10107. - Reçu 117 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070131152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Craven Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 124.797.
In the year two thousand and seven, on the first day of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
- AIREDALE HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of Luxembourg, with registered office at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, registered
with the Trade and Companies Register (RCS) of Luxembourg under the number B 124.961,
represented by Régis Galiotto, jurist, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxem-
bourg, on August 1st, 2007
- YALTON LIMITED, a private limited liability company incorporated under the laws of Gibraltar, with registered office
at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar,
represented by Régis Galiotto, jurist, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxem-
bourg, on August 1st, 2007,
(the Shareholders),
Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-
lowing:
I. That AIREDALE HOLDINGS S.à r.l. is the holder of four hundred seventy-four (474) ordinary shares of the Lux-
embourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the name CRAVEN PROPER-
TIES S.à r.l., having its registered office at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, registered with Trade and
Companies Register (RCS) of Luxembourg under number B 124.797 (the Company), incorporated pursuant to a deed of
the undersigned notary, on January 29, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 771
on May 3, 2007;
II. That YALTON LIMITED is the holder of twenty-six (26) ordinary shares of the Company;
III. That the entirety of the share capital of the Company of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) rep-
resented by five hundred (500) ordinary shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, are represented at
the meeting;
IV. That the agenda for the meeting is as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Creation of preferred shares of the Company with the rights and obligations as set out by the law of August 10,
1915 relating to commercial companies and by the articles of association of the Company (the Articles) to be amended
under item 5 of the agenda;
114272
3. Increase of the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) represented by five hundred (500) ordinary shares, having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each,
by an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), so as to bring the share capital of the Company to
twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-), by way of the creation and issue of (i) three hundred (300) ordinary shares
of the Company, and (ii) two hundred (200) preferred shares of the Company, with a par value of twenty-five Euro (EUR
25.-) each, in consideration for a payment in cash;
4. Subscription to the increase specified under item 3. above, and payment of the consideration for the capital increase;
5. Amendment of article 5.1 of the Articles;
6. Amendment of the books and registers of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority to any manager of the Company and to any lawyer or employee of LOYENS WINANDY, acting individually,
to proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes in the relevant registers of the Company.
V. That the Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to waive the convening notices, the shareholders of the Company considering themselves
as duly convened and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to create preferred shares, with the rights and obligations as set out by the law of August
10, 1915 relating to commercial companies and by the Articles, as amended pursuant the present resolutions.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand
five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) ordinary shares, having a nominal value of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each, by an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), so as to bring the share
capital of the Company to twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-), by way of the creation and issue of (i) three hundred
(300) ordinary shares of the Company, and (ii) two hundred (200) preferred shares of the Company, with a par value of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each, in consideration for a payment in cash.
<i>Subscription and paymenti>
The Shareholders resolve to subscribe for the three hundred (300) ordinary shares and two hundred (200) preferred
shares of the Company as follows:
- AIREDALE HOLDINGS S.à r.l., predefined, represented as stated here above, declares to subscribe for (i) two
hundred eighty-four (284) ordinary shares of the Company with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and for
(ii) one hundred ninety (190) preferred shares of the Company, with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and
to fully pay them up by way of a payment in cash amounting to eleven thousand eight hundred fifty Euro (EUR 11,850.-),
which shall be allocated to the nominal share capital of the Company;
- YALTON LIMITED, predefined, represented as stated here above, declares to subscribe for (i) sixteen (16) ordinary
shares of the Company with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, and for (ii) ten (10) preferred shares of the
Company, with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and to fully pays them up by a payment in cash amounting
to six hundred fifty Euro (EUR 650.-), which shall be allocated to the nominal share capital of the Company.
The newly issued ordinary shares and preferred shares of the Company have all been fully paid up by payment in cash,
so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as of now at the free disposal of the Company,
evidence of which has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Shareholders resolve to amend article 5.1 of the Articles, so that it
shall henceforth read as follows:
«The corporate capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) represented by (i) eight hundred (800)
ordinary shares and (ii) two hundred (200) preferred shares, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all
subscribed and fully paid-up.
Ordinary shares shall have the rights and obligations as set out by the law of August 10, 1915 relating to commercial
companies, and by the articles of association.
The preferred shares shall be entitled to receive with respect to each financial year out of any financial profits and
reserves of the Company legally available for distribution, prior to and in preference of any dividend declaration or
payment in respect of the ordinary shares, a cumulative dividend amounting to 5% of the nominal value of each preferred
share. The preferred shares will not have a right to any further distributions, the remainder of the distributable profits
and reserves and liquidation proceeds being entirely allocated to the ordinary shares except for purposes of reimbursing
the nominal value of the preferred shares»
114273
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the books and registers of the Company, in order to reflect the above changes
with power and authority to any manager of the Company and to any lawyer or employee of LOYENS WINANDY, acting
individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes in the relevant books registers
of the Company.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation
to this deed are estimated at approximately 2,000.-Euros.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing parties, said representative signed together
with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le premier août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
- AIREDALE HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 124.961,
représentée par Régis Galiotto, juriste, avec résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée à Luxembourg, le 1
er
août 2007;
- YALTON LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit de Gibraltar, ayant son siège social à 57/63 Line
Wall Road, Gibraltar,
représentée par Régis Galiotto, juriste, avec résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée à Luxembourg, le 1
er
août 2007;
(les Associés),
Lesquelles procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que AIREDALE HOLDINGS S.à r.l. détient quatre cent soixante-quatorze (474) parts sociales ordinaires de la société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois CRAVEN PROPERTIES S.à r.l., ayant son siège social au L-1511 Luxem-
bourg, 121, avenue de la Faïencerie, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 124.797 (la Société), constituée suivant acte du notaire instrumentant, le 29 janvier 2007, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n° 771 du 3 mai 2007;
II. Que YALTON LIMITED détient vingt-six (26) parts sociales ordinaires de la Société;
III. Que l'entièreté du capital social de la Société de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq
cents (500) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, sont représentés
à l'assemblée;
IV. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocations;
2. Création de parts sociales privilégiées de la Société ayant les même droits et obligations établis par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et par les statuts de la Société (les Statuts) tels qu'ils seront modifiés sous le point 5
de l'ordre du jour;
3. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
représenté par cinq cents (500) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
par l'apport d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), afin de porter le capital social de la Société à
vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), par la création et l'émission de (i) trois cents (300) parts sociales ordinaires de la
Société et de (ii) deux cents (200) parts sociales privilégiées de la Société, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, en contrepartie d'un paiement en numéraire;
4. Souscription à l'augmentation susmentionnée au point 3 et paiement de la contrepartie pour l'augmentation du
capital;
5. Modification de l'article 5.1 des Statuts;
114274
6. Modification des livres et registres de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec le pouvoir et l'autorité
pour tout gérant de la Société et tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY, agissant individuellement, de procéder
pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans les registres concernés de la Société.
V. Les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires se considérant eux-mêmes comme
dûment convoqués et ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de créer des parts sociales privilégiées, avec les droits et les obligations tels que définis dans la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par les Statuts, tels que modifiés par les présentes résolutions.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cent euros
(EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, par l'apport d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), afin de porter le capital
social de la Société à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), par la création et l'émission de (i) trois cents (300) parts
sociales ordinaires de la Société et de (ii) deux cents (200) parts sociales privilégiées de la Société, d'une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, en contrepartie d'un paiement en numéraire.
<i>Souscription et libérationi>
Les Associés décident de souscrire aux trois cents (300) parts sociales ordinaires et deux cents (200) parts sociales
privilégiées de la Société, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune comme suit:
- AIREDALE HOLDINGS S.à r.l., prédéfini, représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire (i) deux cent quatre-
vingt-quatre (284) parts sociales ordinaires de la Société d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
et (ii) cent quatre-vingt-dix (190) parts sociales privilégiées de la Société, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune et de les libérer entièrement par un paiement en numéraire d'un montant de onze mille huit cent cinquante
euros (EUR 11.850,-) qui sera alloué au compte capital social de la Société;
- YALTON LIMITED, prédéfini, représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire (i) seize (16) parts sociales
ordinaires de la Société d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et (ii) dix (10) parts sociales
privilégiées de la Société, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et de les libérer entièrement par
un paiement en numéraire d'un montant de six cent cinquante euros (EUR 650,-) qui sera alloué au compte capital social
de la Société.
Les parts sociales privilégiées et les parts sociales ordinaires de la Société nouvellement émises ont été intégralement
libérées par un paiement en numéraire de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) de telle sorte que cette somme
est désormais à la libre disposition de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentant qui le reconnaît
expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts, qui aura
dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) divisé en (i) huit cents (800) parts sociales ordinaires
et (ii) deux cents (200) parts sociales privilégiées, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
Les parts sociales privilégiées auront le droit de recevoir, chaque exercice, en relation avec les profits financiers et les
réserves de la Société légalement disponibles, avant et par préférence à toute déclaration ou paiement de dividendes en
relation avec les parts sociales ordinaires, un dividende cumulatif correspondant à un montant de 5% de la valeur nominale
de chaque part sociale privilégiée. Les parts sociales privilégiées n'ont pas de droit à d'autres distributions, aux surplus
de profits et de réserves ou boni de liquidation sauf en vue du remboursement de la valeur nominale des parts sociales
privilégiées.».
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de modifier les livres et registres de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec
le pouvoir et l'autorité pour tout gérant de la Société et tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY, agissant
individuellement, de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans les livres et
registres concernés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en
rapport avec le présent acte est estimé à environ 2.000,- euros.
114275
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête des comparants sus-
nommés le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais
et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date stipulée au début des présentes.
Le document ayant été lu au représentant des comparants, ce dernier ainsi que le notaire instrumentant ont signé le
présent acte.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2007, Relation: LAC/2007/21304. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007114798/211/215.
(070131145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Grainger Luxembourg Germany (No.8) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 265.000,00.
Siège social: L-5365 Münsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 113.800.
In the year two thousand and seven, on the third of September
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.
There appeared:
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company, incorporated under
the law of the Grand Duchy of Luxembourg, whose registered office is at 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number
112.062,
here represented by Mr Régis Galiotto, employee, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450, Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy established on August 31st, 2007; and
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.1) S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the
law of the Grand Duchy of Luxembourg, whose registered office is at 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand
Duchy of Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number
112.061,
here represented by Mr Régis Galiotto, employee, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450, Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy established on August 31st, 2007.
The said proxies, signed ne varietur by the proxy holders of the parties appearing and the undersigned notary public,
will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary public to state that:
I. The appearing parties are the shareholders of the private limited liability company established in Luxembourg under
the name of GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.8) S.à r.l., a company incorporated and existing under the
laws of Luxembourg, whose registered office is at 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxem-
bourg and is registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 113.800 incorpo-
rated by a deed of the undersigned notary public, dated December 20th, 2005, published in the Mémorial C, N° 793, page
38056, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on April 20th, 2006, and which articles of association have been
amended on December 22nd, 2005, published in the Mémorial C, N° 841, page 40353, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations on April 27th, 2006.
II. The Company's share capital is set at two hundred forty thousand Euro (EUR 240,000.-) represented by nine
thousand six hundred (9,600) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
The shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolved to increase the share capital of the Company by twenty-five thousand hundred Euro (EUR
25,000.-) to raise it from its present amount of two hundred forty thousand Euro (EUR 240,000.-) to two hundred sixty-
five thousand Euro (EUR 265,000.-) by creation and issuance of one thousand (1,000) new shares with a par value of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and an aggregate par value amounting to twenty-five thousand hundred Euro (EUR
114276
25,000.-), having the same rights and obligations as the existing shares, such shares to be fully paid up in par value together
with a share premium of twenty-five thousand four hundred Euro (EUR 25,400.-).
<i>Second resolutioni>
Intervention - Subscription - Payment
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS S.à r.l., aforementioned, through its proxy holder, declared to
subscribe to one hundred (100) of newly issued shares of the Company with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-)
and fully pay them up in the amount of two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-) together with the share premium
of two thousand five hundred forty Euro (EUR 2,540.-)
and
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.1) S.à r.l., aforementioned, through its proxy holder, declared to sub-
scribe to nine hundred (900) of newly issued shares of the Company with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) and
fully pay them up in the amount of twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 22,500.-) together with the share
premium of twenty-two thousand eight hundred sixty Euro (EUR 22,860.-) by contribution in cash, so that the total
amount of fifty thousand four hundred Euro (EUR 50,400.-) is at the disposal of the Company as has been proved to the
undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Third resolutioni>
Pursuant to the above increase of share capital, Article 6 of the articles of association is amended and shall henceforth
read as follows:
« Art. 6. The share capital is set at two hundred sixty-five thousand Euro (EUR 265,000.-) represented by ten thousand
six hundred (10,600) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, entirely paid in.»
<i>Costs & expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated without prejudice at approximately 2,000.- Euros.
There being no further business, the meeting was adjourned.
The undersigned notary public who understands and speaks English states herewith that on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, who is known to the undersigned
notary public by his last and first name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary public, the
present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le trois septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS S.à r.l., société à responsabilité limitée constituée et régie par
les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Lu-
xembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 112.062 (la
«Société»)
ici représentée par M. Régis Galiotto, employé, avec adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450, Luxembourg,
Grand Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 31 août 2007; et
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.1) S.à r.l., société à responsabilité limitée constituée et régie par les
lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxem-
bourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 112.061 (la
«Société»)
ici représentée par M. Régis Galiotto, employé, avec adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450, Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 31 août 2007.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparantes sont les associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.8) S.à r.l., société à responsabilité limitée constituée et régie par les
114277
lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxem-
bourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 113.800 constituée
par acte notarié, en date du 20 décembre 2005, publié au Mémorial C, N° 793, page 38056, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations le 20 avril 2006 et dont les statuts ont été modifiés en date du 22 décembre 2005, publié au Mémorial
C, N° 841, page 40353, Recueil Spécial des Sociétés et Associations le 27 avril 2006.
II. Le capital social de la Société est fixé à deux cent quarante mille Euro (EUR 240.000,-) représenté par neuf mille six
cents (9.600) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.
Les associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de vingt-cinq mille Euro (EUR 25.000,-)
pour le porter de son montant actuel de deux cent quarante mille Euro (EUR 240.000,-) à deux cent soixante-cinq mille
Euro (EUR 265.000,-) par la création et l'émission de mille (1.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-
cinq Euro (EUR 25,-) chacune, et d'une valeur nominale totale de vingt-cinq mille Euro (EUR 25.000,-), ayant les mêmes
droits et obligations que les parts sociales existantes, lesquelles parts sociales devant être libérées intégralement, à émettre
avec une prime d'émission de vingt-cinq mille quatre cents Euro (EUR 25.400,-).
<i>Deuxième résolutioni>
Intervention - Souscription - Libération
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS S.à r.l., précitée, par son mandataire, déclare souscrire à cent
(100) nouvelles parts sociales de la Société, d'une valeur nominale unitaire de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, et les
libérer intégralement au montant de deux mille cinq cents Euro (EUR 2.500,-) avec la prime d'émission de deux mille cinq
cent quarante Euro (EUR 2.540,-)
et
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.1) S.à r.l., précitée, par son mandataire, déclare souscrire à neuf cent
(900) nouvelles parts sociales de la Société, d'une valeur nominale unitaire de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, et les
libérer intégralement au montant vingt-deux mille cinq cents Euro (EUR 22.500,-) avec la prime d'émission vingt de deux
mille huit cent soixante Euro (EUR 22.860,-) par apport en espèces de sorte que le montant total de cinquante mille
quatre cents Euro (EUR 50.400,-) est à la disposition de la société comme l'atteste expressément le notaire instrumentaire.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à deux cent soixante-cinq mille Euro (EUR 265.000,-) représenté par dix mille six
cent (10.600) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.»
<i>Frais & dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 2.000,- Euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état
civil et résidence, il a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2007, Relation: LAC/2007/25094. — Reçu 504 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007114797/211/146.
(070131162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
114278
Femmes Développement A.s.b.l. (formation, éducation, maternité, modernité, entreprise, solidarité, dé-
veloppement), Association sans but lucratif.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg F 5.311.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Fentange le 20 juillet 2007i>
1) - Remplacer dans l'article 3 des statuts le terme «La fondation» par «L'association»
- Remplacer dans le 2
ème
alinéa de l'article 3 les termes «Elle a» par les termes «L'association a également»
2) Remplacer partout dans les statuts la référence à «associé» par «membre associé» respectivement «membre».
3) - Remplacer l'article 5 par un nouvel article 5 qui a la teneur suivante:
«L'association se compose de membres associés et de membres d'honneur.
Sont admissibles comme membres-associés, désignés comme «membre» dans les présents statuts, toutes personnes
en manifestant la volonté déterminée à observer les présents statuts, agréées par le Conseil d'Administration et qui paient
la cotisation annuelle.
L'admission est constatée par la remise d'une carte de membre.
Les membres associés ont seuls les droits prévus par la loi modifiée du 21 août 1928 sur les associations et fondations
sans but lucratif. Ils prennent part aux assemblées générales et ont seuls le droit de vote.
Sont admissibles comme membres d'honneur toutes personnes qui en manifestent la volonté et qui soutiennent les
activités de l'association. Ils ne jouissent pas du droit de vote et n'exercent aucune prérogative prévue par la loi et les
présents statuts en faveur des membres associés.
La qualité de membre d'honneur s'acquiert par une nomination afférente à prononcer par l'assemblée générale.»
- Reformuler l'intitulé du Chapitre 2 en «Des différents membres et conditions d'entrée.»
4) Modifier le 1
er
tiret du 2
ème
alinéa de l'article 7, la mention à abroger: «et règlements»
5) Modifier l'article 8 et 26 en remplaçant «commissaire-vérificateur» par «commissaire»
6) Modifier l'article 8 point 6: mention à abroger «ou sa fusion avec une autre association»
7) Modifier l'article 9 en remplaçant le terme «clôture annuelle des comptes» par «clôture annuelle de l'exercice»
8) Modifier l'article 26 en y insérant la mention «... par le Conseil d'Administration»
9) Modifier l'article 27 en y ajoutant la phrase suivante:
«L'actif sera affecté à une autre association sans but lucratif reconnue d'utilité publique et poursuivant une activité
analogue.»
Luxembourg, le 24 juillet 2007.
<i>Pour FEMMES DEVELOPPEMENT asbl
i>Signature
Référence de publication: 2007114787/744/38.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007, réf. LSO-CH04822. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070130892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Nanteuil Logistique, Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heine.
R.C.S. Luxembourg B 105.333.
<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 25 mai 2007i>
<i>et de la réunion de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 7 juin 2007i>
<i>3 i>
<i>èmei>
<i> Résolution du Conseil d'Administrationi>
Le Conseil d'Administration désigne Monsieur Daniel Peeters, demeurant au 163, Looiweg, B-2310 Rijkevorsel, Bel-
gique à la fonction de Président du Conseil d'Administration.
<i>5 i>
<i>èmei>
<i> Résolution de l'Assemblée Généralei>
L'Assemblée accepte la démission avec effet immédiat de Monsieur Bart Verhaeghe, demeurant professionnellement
au 8, rue Heine à L-1720 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur de catégorie B.
En remplacement de l'administrateur sortant, l'assemblée décide de nommer Monsieur Michael O'Sullivan, demeurant
à Green Lawns, 21 Broad Highway, Cobham, Surrey (UK) à la fonction d'administrateur de catégorie B.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.
114279
<i>6 i>
<i>èmei>
<i> Résolution de l'Assemblée Généralei>
L'Assemblée décide de renouveler le mandat de HRT REVISION S.A., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 août 2007.
<i>Pour NANTEUIL LOGISTIQUE S.A.
i>D. Peeters / P. Huyghe
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007114773/565/29.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2007, réf. LSO-CI01063. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070131210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Metaldyne Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.961.750,00.
Siège social: L-8181 Kopstal, 96, route de Mersch.
R.C.S. Luxembourg B 67.919.
In the year two thousand and seven, on the seventh of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of METALDYNE EUROPE S.à r.l., a société à re-
sponsabilité limitée, having its registered office at L-8181 Kopstal, 96, route de Mersch, incorporated by deed dated
December 29, 1998,inscribed at Luxembourg trade register section B under number 67.919 published in the Memorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 193 page 9237, of March 22, 1999; and whose Articles of associations
have been amended for the last time by deed enacted on September 30, 2004, published in Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 34, page 1589, dated January 13, 2005.
The meeting is presided by Mrs Rachel Uhl, lawyer, with professional address at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen; lawyer, residing at Lux-
embourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance
list which will be signed and here annexed as well as the proxy and registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 1,278,470 (one million two hundred seventy-eight thousand four hundred
seventy) shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that Meeting can validly decide on
all the items of the agenda of which the shareholder has been beforehand informed. As long as the Company remains
with one sole shareholder, such shareholder exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.
III.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. To acknowledge the resignation of Mr Jeffrey Stafeil as manager of the Company;
2. To appoint Ms Sandra W. Galac as new manager of the Company in replacement of Mr Jeffrey Stafeil;
3. To amend article 13 of the Articles of Association.
4. To fix the next closing date year on March 31, 2008.
After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder decides what follows:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to acknowledge the resignation of Mr Jeffrey Stafeil with an effect as of at April 2, 2007.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to appoint Ms Sandra W. Galac as new manager of the Company in replacement of Mr Jeffrey
Stafeil with effect as of the date of the present extraordinary general meeting.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to amend the financial year of the Company which will run from 1 April to 31 March of the
following calendar year, and to amend accordingly Article 13 of the Articles of the Company, which shall read as follows:
«The Company's financial year begins on the first day of April of each year and closes on the thirty-first day of March
of the following year.»
114280
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the meeting acknowledges, for avoidance of doubt, that the last financial
year closed on 31 December 2006, and that the next financial year will start on January 1, 2007 and will close on March
31, 2008.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L'an deux mille sept le sept août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société METALDYNE EUROPE S.à r.l. (la
«Société»), ayant son siège social à L-8181 Kopstal, 96, route de Mersch, constituée suivant acte reçu le 29 décembre
1998, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés numéro B67.919, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations numéro 193, page 9237 du 22 mars 1999; dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte
reçu le 30 septembre 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 34, page 1589, du 13
janvier 2005.
L'assemblée est présidée par Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,
demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que la procuration, le tout enregistré avec l'acte.
II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les 1.278.470 (un million deux cent soixante dix huit mille quatre cent
soixante-dix) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont
l'associé unique a été préalablement informé. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier
exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des associés.
III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Accepter la démission de M. Jeffrey Stafeil de sa fonction de gérant de la Société.
2) Nommer Mme Sandra W. Galac nouveau gérant de la Société en remplacement de M. Jeffrey Stafeil.
3) Amender l'article 13 des statuts de la Société.
4) Fixer la prochaine date de clôture de l'exercice social au 31 mars 2008.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé unique décide ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter la démission de M. Jeffrey Stafeil avec effet en date du 2 avril 2007.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer Mme Sandra W. Galac en tant que nouveau gérant de la Société en remplacement de
M. Jeffrey Stafeil avec effet à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'exercice social de la Société, lequel courra du 1
er
avril au 31 mars de l'année civile
suivante, et de modifier conformément l'article 13 des statuts lequel sera libellé comme suit:
«L'exercice social commence le 1
er
avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante.»
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de la décision ci-dessus, l'assemblé reconnaît afin de dissiper tout doute, que le dernier exercice social
s'est terminé le 31 décembre 2006, et que le prochain exercice social débutera le 1
er
janvier 2007 pour se terminer le
31 mars 2008.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
114281
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2007, Relation: LAC/2007/22124. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Frising.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007114800/211/105.
(070131271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Falcon II Real Estate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 150.000,00.
Siège social: L-8009 Strassen, 21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 127.451.
In the year two thousand and seven, on the eigtheenth day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
FALCON II REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., a public limited liability company incorporated and organized under
the law of Spain, having its registered office at Avda. Del Doctor Arce 14, 28002 Madrid, Spain, registered with the Madrid
Commercial Registry at Volume 21,771, page 61, section 8, sheet M-387795,
here represented by Annick Braquet, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on September
14, 2007.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. FALCON II REAL ESTATE INVESTMENTS S.A. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the name FALCON II REAL ESTATE
INVESTMENTS S.à r.l., having its registered office at 21, route d'Arlon, L-8009 Strassen, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under the number B 127.451 (the Company), incorporated pursuant to a deed
of the undersigned notary, dated March 30, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of
June 22, 2007, page 59340. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended pursuant to a
deed of the undersigned notary, dated September 6, 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
II. The Company's corporate capital is fixed at one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) represented by four
thousand (4,000) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully
paid-up.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of fifty thousand
euro (EUR 50,000.-), to bring it from its present amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) represented by
four thousand (4,000) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to one hundred
fifty thousand euro (EUR 150,000.-), by the issuance of two thousand (2,000) new shares with a par value of twenty-five
euro (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - paymenti>
Thereupon, FALCON II REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., prequalified and represented as stated above, declares
to subscribe for the two thousand (2,000) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to fully
pay them up, at the price of fifty thousand euro (EUR 50,000.-) by way of a contribution in cash amounting to two million
five hundred fifty thousand euro (EUR 2,550,000.-) of which (i) fifty thousand euro (EUR 50,000.-) shall be allocated to
the share capital account of the Company, (ii) two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-) to the statutory reserve
account of the Company and (iii) the remaining, i.e. two million four hundred ninety-seven thousand five hundred euro
(EUR 2,497,500.-) to the share premium reserve account of the Company, as has been proved to the undersigned notary,
who expressly acknowledges it.
114282
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, which
will henceforth read as follows:
5.1 «The Company's corporate capital is fixed at one hundred fifty thousand euro (EUR 150,000.-) represented by six
thousand (6,000) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully
paid-up.»
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimated costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 29,000.- (twenty-nine thousand).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxy holder, the proxy holder signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le dix-huitième jour de septembre.
Par-devant, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
FALCON II REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., une société anonyme constituée et organisée selon les lois espagnoles,
ayant son siège social à Avda. Del Doctor Arce 14, 28002 Madrid, Espagne, immatriculée auprès du Registre de Commerce
de Madrid, Volume 21, 771, page 61, section 8, feuillet M-387795,
ici représentée par Annick Braquet, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
le 14 septembre 2007.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. FALCON II REAL ESTATE INVESTMENTS S.A. est l'associé unique (l'Associé Unique) de la société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois existant sous la dénomination FALCON II REAL ESTATE INVESTMENTS S.à r.l., ayant
son siège social 21, route d'Arlon, L-8009 Strassen, immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 127.451 (la Société), constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, en date
du 30 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 22 juin 2007, page 59340. Les statuts de
la Société (les Statuts) ont été modifiés suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 septembre 2007,
pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. Le capital social de la Société est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par quatre mille (4.000) parts
sociales sous forme nominative d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinquante mille euros (EUR 50.000)
afin de le porter de son montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par quatre mille (4.000) parts
sociales sous forme nominative d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à cent cinquante mille euros (EUR
150.000,-) par l'émission de deux mille (2.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - libérationi>
Sur ces faits, FALCON II REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., préqualifiée et représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare souscrire aux deux mille (2.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, et de les libérer intégralement pour un montant de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) par un apport en
numéraire s'élevant à deux millions cinq cent cinquante mille euros (EUR 2.550.000,-) desquels (i) cinquante mille euros
(EUR 50.000,-) seront affectés au compte capital social de la Société, (ii) deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) au
compte réserve légale de la Société et (iii) le montant restant, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille
cinq cents euros (EUR 2.497.500,-) au compte prime d'émission de la Société, preuve en ayant été donnée au notaire
instrumentant qui le reconnaît expressément.
114283
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, qui aura
désormais la teneur suivante:
5.1 Le capital social de la Société est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) représenté par six mille (6.000)
parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.»
Plus rien de figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison
du présent acte, s'élève à environ EUR 29.000,- (vingt-neuf mille euros).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et anglais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé le présent acte original avec le notaire.
Signé: A. Braquet, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2007. Relation: LAC/2007/27213. Reçu 25.500 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): F. Sandt.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial.
Luxembourg, le 25 septembre 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007114802/242/122.
(070131301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Rozier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 131.458.
In the year two thousand and seven, on the sixth day of the month of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the associates of ROZIER S.àr.l. (the «Company»), a société à respon-
sabilité limitée having its registered office at 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, incorporated on 6th August
2007 by deed of Maître Joseph Elvinger, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting was presided by Me Kathrin Krämer, maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary Me Camille Wisniewski, maître en droit, residing in Luxembourg, and as scrutineer
Me Thomas Roberdeau, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The associates represented and the number of shares held by each of them is shown on an attendance list signed
by the proxy holder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached
to the present deed to be filed with the registration authorities.
As it appeared from said attendance list, all twelve thousand five hundred (12,500) Shares in issue in the Company
were represented at the general meeting and the associates of the Company declared that they had prior knowledge of
the agenda so that the meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items on the agenda.
2. The agenda of the meeting is as follows:
- To recompose the issued share capital of the Company by changing the currency of the Company's share capital, as
well as the accounting currency of the Company, from EURO to Pound Sterling and convert the issued share capital into
GPB at an exchange rate of one EUR (€ 1.-) to 0.67586 GBP; to amend the nominal value per share to one GBP (£ 1.-)
per share and to reclassify the twelve hundred (12,500) existing shares into shares of a nominal value of one GBP (£ 1.-)
each while increasing the issued share capital by twenty-one thousand five hundred fifty-two GBP (£ 21,552.-) to thirty
thousand GBP (£ 30,000.-) by contribution in cash of thirty-one thousand eight hundred eighty-eight Eur (€ 31,888.-)
(being at the exchange rate of one EUR (€ 1) to 0.67586 GBP, twenty-one thousand five hundred fifty-two GBP (£ 21,552.-)
(rounded), and issue of shares of a nominal value of one GBP (£ 1.-) each, subscription to and payment for such shares
by the subscribers set out in the table schedule here below so that further to the reclassification of the existing shares
and issue the new shares the shares of the Company are held as follows:
Name
Shareholder
Number of
Shares
114284
(including
reclassified
shares)
FOURTH CINVEN FUND (NO.1) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,410
FOURTH CINVEN FUND (NO.2) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,688
FOURTH CINVEN FUND (NO.3 - VCOC) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,631
FOURTH CINVEN FUND (NO.4) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,330
FOURTH CINVEN FUND (UBTI) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,560
FOURTH CINVEN FUND CO-INVESTMENT PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
296
FOURTH CINVEN FUND (MACIF) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30,000
Consequential Amendment of the first sentence of Article 5 of the Articles of Incorporation of the Company, in order
to give it henceforth the following wording:
«Art. 5. Share capital . The issued share capital of the Company is set at thirty thousand Pound Sterling (GBP 30,000.-)
divided into thirty thousand (30,000) shares with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each.»
After deliberation the meeting unanimously took the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The meeting resolved to recompose the issued share capital of the Company by changing the currency of the Com-
pany's share capital, as well as the accounting currency of the Company, from EURO to Pound Sterling and convert the
issued share capital into GPB an exchange rate of GBP 0.67586 for EUR 1.- being an amount of eight thousand four
hundred and forty-eight GPB (£ 8,448.-) (rounded).
The meeting resolved to amend the nominal value per share to one GPB (£ 1.-) per share and to reclassify the twelve
thousand five hundred (12,500) existing shares into eight thousand four hundred forty-eight (8,448) shares of a nominal
value of one GBP (£ 1.-) each.
The meeting then resolved to further increase the issued share capital by twenty-one thousand five hundred fifty-two
GBP (£ 21,552.-) to thirty thousand GBP (£ 30,000.-) by contribution in cash of thirty-one thousand eight hundred eighty-
eight Eur (€ 31,888.-) (being at the exchange rate of one EUR (€ 1.-) to 0.67586 GBP, twenty-one thousand five hundred
fifty-two GBP (21,552.-) (rounded), by the issue twenty-one thousand five hundred and fifty-two (21,552) shares of a
nominal value of one GPB (£ 1.-) each. The subscribers, all here represented by Me Thomas Roberdeau, by virtue of
proxies hereto attached, thereupon subscribed for the new shares so issued so that together with the reclassified shares,
the shares of the Company are held as follows:
Name
Shareholder
Number
of Shares
(including
reclassified
shares)
FOURTH CINVEN FUND (NO.1) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,410
FOURTH CINVEN FUND (NO.2) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,688
FOURTH CINVEN FUND (NO.3 - VCOC) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,631
FOURTH CINVEN FUND (NO.4) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,330
FOURTH CINVEN FUND (UBTI) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,560
FOURTH CINVEN FUND CO-INVESTMENT PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
296
FOURTH CINVEN FUND (MACIF) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30,000
each of the above with place of business at Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M 7AG.
The existing shareholders with respect to the capital increase relating to the reclassified shares and Subscribers with
respect to the subscription price of the new shares issued fully paid the amount of thirty-one thousand eight hundred
eighty-eight EUR (€ 31,888.-) (being at the exchange rate of one EUR (€ 1.-) to 0.67586 GBP, twenty-one thousand five
hundred fifty-two GBP (21,552.-) (rounded), by contribution in cash.
Evidence of the payment thereof was shown to the undersigned notary.
The meeting finally resolved to amend article 5 of the articles of incorporation as set forth in the agenda.
There being no further item on the agenda the meeting was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at EUR 1,800.-.
114285
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française :
L'an deux mille sept, le sixième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de ROZIER S.àr.l. (la «Société»), une société à responsa-
bilité limitée ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg , constituée le 6 août 2007 par acte
de Maître Joseph Elvinger, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'assemblée a été présidée par Me Kathrin Krämer, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Il fut nommé comme secrétaire Me Camille Wisniewski, maître en droit, demeurant à Luxembourg et comme scru-
tateur Me Thomas Roberdeau, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit :
1. Les associés représentés et le nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de
présence signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Il appert de ladite liste de présence que toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises de la Société
étaient représentées à l'assemblée générale et les associés de la Société ont déclaré avoir eu connaissance préalable de
l'ordre du jour de sorte que l'assemblée était valablement constituée et pouvait valablement délibérer sur les points de
l'ordre du jour.
2. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :
- De recomposer le capital social en émission de la Société en changeant la devise dans laquelle le capital social de la
Société est exprimé, ainsi que les comptes et livres comptables de la Société, de l'euro vers la livre sterling et de convertir
le capital social en émission en livre sterling à un taux de change de 0,67586 GBP pour 1,- € ; de modifier la valeur nominale
des parts sociales en l'amenant à une livre sterling (GBP 1,-) par part sociale et de convertir les 12.500 (cinq cents) parts
sociales existantes en parts sociales d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune ; d'augmenter le capital
social en émission de la Société de vingt et un mille cinq cent cinquante-deux livres sterling (21.552,- GBP) à trente mille
livres sterling (30.000,- GBP) par apport en espèce de trente et un mille huit cent quatre-vingt-huit euros (31.888,- €)
(représentant vingt et un mille cinq cent cinquante-deux livres sterling (21.552,- GBP) (arrondi) à un taux de change de
0,67586 GBP pour 1,- €) et par l'émission de parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre sterling (1,- GBP)
chacune, souscription et libération de ces parts sociales par les souscripteurs tel que repris dans la liste ci-dessous de
sorte qu'après recomposition des parts sociales existantes et émission des nouvelles parts sociales les parts sociales de
la Société sont détenues comme suit
Nom de l'associé
Nombre de
parts sociales
(incluses les
parts sociales
recomposées)
FOURTH CINVEN FUND (NO.1) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.410
FOURTH CINVEN FUND (NO.2) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.688
FOURTH CINVEN FUND (NO.3 - VCOC) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.631
FOURTH CINVEN FUND (NO.4) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.330
FOURTH CINVEN FUND (UBTI) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.560
FOURTH CINVEN FUND CO-INVESTMENT PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
296
FOURTH CINVEN FUND (MACIF) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000
Modification subséquente de la première phrase de l'Article 5 des Statuts de la Société qui aura la teneur suivante :
«Art. 5. Capital social . Le capital social émis de la Société est fixé à trente mille livres sterling (30.000,- GBP) divisés
en trente mille (30.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre sterling (1,- GBP) chacune.»
Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée a décidé de recomposer le capital social émis de la Société en changeant la devise dans laquelle le capital
social de la Société est exprimé, ainsi que les comptes et livres comptables de la Société et de convertir le capital social
114286
en émission de l'euro vers la livre sterling à un taux de change de 0.67586 GBP pour 1,- € de sorte que le capital social
de la Société est fixé à huit mille quatre cent quarante-huit livres sterling (GBP 8.448,-) (arrondi).
L'assemblée a décidé de modifier la valeur nominale des parts sociales en l'amenant à une livre sterling (GBP 1,-) par
part sociale et de convertir les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales existantes en huit mille quatre cent quarante-
huit (8.448) parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune.
L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de vingt et un mille cinq cent cinquante-deux
livres sterling (21.552,- GBP) à trente mille livres sterling (30.000,- GBP) par apport en espèce d'un montant total de
trente et un mille huit cent quatre-vingt-huit (31.888,- €) (à un taux de change de 0.67586 GBP pour 1,- € soit un montant
de vingt et un mille cinq cent cinquante-deux livres sterling (21.552,- GBP) (arrondi))et d'émettre vingt et un mille cinq
cent cinquante-deux livres sterling (21.552) parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre sterling (1,- GBP) chacune.
Les souscripteurs, tous ici représentés par Me Thomas Roberdeau, en vertu de procurations ci-annexés, souscrivant aux
nouvelles parts sociales émises et aux parts sociales recomposées, les parts sociales de la Société sont détenues comme
suit :
Nom de l'associé
Nombre de
parts sociales
(incluses les
parts sociales
recomposées)
FOURTH CINVEN FUND (NO.1) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.410
FOURTH CINVEN FUND (NO.2) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.688
FOURTH CINVEN FUND (NO.3 - VCOC) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.631
FOURTH CINVEN FUND (NO.4) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.330
FOURTH CINVEN FUND (UBTI) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.560
FOURTH CINVEN FUND CO-INVESTMENT PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
296
FOURTH CINVEN FUND (MACIF) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000
chacun des associés ayant leur siège social à Warwick Court, Paternoster Square, Londres EC4M 7AG,
Les associés existants en considération de l'augmentation de capital en relation avec la conversion des parts sociales
et les souscripteurs en considération de la souscription des parts sociales nouvellement émises ont payé l'intégralité du
montant de trente et un mille huit cent quatre-vingt-huit euros (31.888,- €) (à un taux de change de 0.67586 GBP pour
1,- € soit un montant de vingt et un mille cinq cent cinquante-deux livres sterling (21.552,- GBP) (arrondi) au moyen d'un
apport en espèces.
Preuves du paiement du prix de souscription a été présentée au notaire instrumentant.
L'assemblée a finalement décidé de modifier l'article 5 des statuts tel que prévu dans l'ordre du jour.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société sont
estimés à EUR 1.800,-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé
en anglais suivi d'une traduction française ; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent acte les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Krämer, C. Wisniewski, T. Roberdeau et H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2007. Relation: LAC/2007/25707. - Reçu 318,88 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): R. Jungers.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 septembre 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007114801/242/197.
(070131347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Sagis Gallica S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 65.856.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
114287
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour la société
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007114614/631/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2007, réf. LSO-CI06838. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070131033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Menara S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 100.748.
<i>Décision prise par la gérance en date du 10 septembre 2007i>
<i>Transfert du siège social de la sociétéi>
La gérance a décidé de transférer le siège de la société avec effet au 1
er
octobre 2007 d'anciennement 44, route
d'Esch, L-1470 Luxembourg à maintenant 10, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2007.
<i>Pour la société
MENARA S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007114637/1276/18.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2007, réf. LSO-CI06165. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070131501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Larochettefels S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 87.965.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2007.
REVILUX S.A.
Signature
Référence de publication: 2007114372/687/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05213. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070131364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Co-Invest Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
R.C.S. Luxembourg B 81.360.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 28 septembre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007114390/1472/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2007, réf. LSO-CI09188. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070131161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
114288
Alvema S.A.
Badengruppe S.A.
Basta Così S.à r.l.
Bel-Fa S.A.
Beos Holding S.A.
Canotiers de Savoie S.A.
Co-Invest Holding S.A.
Craven Properties S.à r.l.
CVI GVF Germany GP Two S.à r.l.
CVI GVF Luxembourg Two S.à r.l.
Esther Thirteen S.à r.l.
European Properties S.à r.l.
Falcon II Real Estate Investments S.à r.l.
Femmes Développement A.s.b.l. (formation, éducation, maternité, modernité, entreprise, solidarité, développement)
Financière Chinon Holding S.A.
Fortis Comfort
Fortis Quam Fund
Grainger Luxembourg Germany (No.1) S.à r.l.
Grainger Luxembourg Germany (No.8) S.à r.l.
Happy and Dolphin, Sàrl
International Logistic Froid SA
Isline Holding S.A.
Jaga Holding A.G.
Larochettefels S.A.
Levlux S.A.
Linco
Luxheaven Real Estate S.A.
Medicover Holding S.A.
Melia S.A.
Melia S.A.
Melia S.A.
Menara S. à r.l.
Merith International S.A.
Metaldyne Europe Sàrl
M.H.M. S.A.
Mom S.A.
Nanteuil Logistique
Overcastle Investments S.A.
Pontoon Luxco S.à r.l.
RIA Allocation I
Rozier S.à r.l.
Rutherford S.A.
Sagis Gallica S.A.
UBS Target Fund
Unit Investments S.A.
Valence S.A.