logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2255

10 octobre 2007

SOMMAIRE

2000 Volts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108207

Arbre Mondial Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . .

108194

Assumption Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

108233

BATI CV S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108232

B.F. Promotions S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

108235

Cedef S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108231

Cedef S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108233

Cedef S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108232

Central Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

108230

Christa Intershipping S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .

108207

Color-Center Lucien Steinhäuser . . . . . . . .

108231

Comptoir Technique et Industriel S.A. . . .

108224

Corneille S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108240

Costa Del Sol S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108238

C.V.S. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108236

Davlani S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108231

Distrisport S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108232

Easy Solutions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108237

Eischen-Immobilière S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

108231

Etablissement Rolux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

108219

Europäische Beteiligungsgesellschaft A.G.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108219

Européenne de Participations et de Signa-

lisation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108240

Finimpex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108240

Fondation Kannerschlass . . . . . . . . . . . . . . . .

108194

Frebela S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108239

Frebela S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108238

Frebela S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108239

F.T.F. Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108219

Genpact Global Holdings SICAR S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108208

Genpact Global Holdings SICAR S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108219

George Forrest Holding  . . . . . . . . . . . . . . . .

108240

Good Energies Investments (Luxembourg)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108196

Ideal Standard International Holding  . . . .

108213

Isoletanche S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108224

Joco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108232

Leger S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108237

Little Smets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108208

Luxarbanne S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108239

Mic Cargo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108208

Mobilop S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108231

Nic. Zeien Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108237

Sevres I S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108233

Smets Gallery S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108207

Sofindex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108236

Sofipar PME  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108238

Teekay Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

108238

Transport Ksibi&PF S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

108236

United in Sports Management S.à r.l.  . . . .

108194

Valbella S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108196

Valma S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108239

Vintners S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108194

Web Technologies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

108237

Zulu II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108225

108193

United in Sports Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 113.597.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Baden
<i>Notaire

Référence de publication: 2007104437/7241/11.
(070117693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Arbre Mondial Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 12.271.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Baden
<i>Notaire

Référence de publication: 2007104441/7241/11.
(070117706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Vintners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 128.278.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Baden
<i>Notaire

Référence de publication: 2007104434/7241/11.
(070117699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Fondation Kannerschlass.

Siège social: L-4434 Sanem, 12, rue Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg G 47.

BUDGET PREVISIONNEL 2008

2008

2007

Dépenses MIFA
1. Frais d'entretien
1.1. CERES / ECOLE DES PARENTS
Honoraires intervenants, indemnités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.000,-

28.000,-

Réservation salles et matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.200,-

1.200,-

Achat livres et documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.400,-

1.800,-

Brochures, dépliants, relations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000,-

10.000,-

Entretien voiture et frais de route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.800,-

1.500,-

Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.500,-

3.600,-

Total CERES / ECOLE DES PARENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.900,-

46.100,-

1.2. CAEMO (PAMO)
Total CAEMO (PAMO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

1.3. CAC-CAS-SLEMO
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.000,-

42.000,-

108194

Argent de poche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.800,-

5.300,-

Assurances et taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.000,-

18.000,-

Auto-transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.000,-

26.000,-

Entretien, buanderie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.500,-

10.500,-

Eau, électricité, combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.000,-

43.000,-

Habillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.000,-

11.000,-

Lingerie, literie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.400,-

3.400,-

Petit matériel, réparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.000,-

22.000,-

Alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86.000,-

86.000,-

Loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000,-

30.000,-

Frais d'école . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.500,-

5.500,-

Médecins, pharmacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.000,-

11.000,-

Total CAC - CAS - SLEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

313.200,-

313.700,-

Total frais d'entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

381.100,-

379.800,-

2. Traitements et salaires
2.1. CERES / ECOLE DES PARENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,-

119.000,-

2.2. CAEMO (PAMO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000,-

340.000,-

2.3. CAC - CAS - SLEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.677.000,-

2.615.000,-

Total traitements et salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.177.000,-

3.074.000,-

3. Frais de spécialisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000,-

4.000,-

4. EMPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.000,-

18.000,-

5. Frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.200,-

6.200,-

6. Projet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

7.500,-

7. Petites acquisitions
7.1. CERES / ECOLE DES PARENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300,-

916,-

7.2. CAEMO (PAMO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

860,-

2.396,-

7.3. CAC - CAS - SLEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000,-

16.688,-

Total dépenses MIFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.591.460,-

3.509.500,-

Recettes MIFA
1. Domiciles de secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,-

170.000,-

2. Participations parents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45.000,-

35.000,-

3. Allocations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,-

95.000,-

4. Rentes pens, (orph., AVI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.000,-

8.000,-

5. Participations pensionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000,-

6.000,-

6. CERES / ECOLE DES PARENTS
Inscriptions ECOLE DES PARENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.000,-

16.500,-

7. Participation MIFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.265.460,-

3.179.000,-

Total recettes MIFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.591.460,-

3.509.500,-

Dépenses logements pour familles
1. Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120,-

120,-

2. Taxes communales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800,-

800,-

3. Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.200,-

1.200,-

4. Eau, électricité, combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.000,-

9.000,-

5. Réparations, entretien, travaux divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.000,-

20.000,-

6. Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400,-

400,-

Total dépenses log. pour familles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.520,-

31.520,-

Recettes logements pour familles
1. Loyers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.500,-

13.000,-

2. Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.500,-

5.400,-

3. Intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800,-

1.000,-

Total recettes log. pour familles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.800,-

19.400,-

Solde logements pour familles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.720,-

- 12.120,-

108195

Dépenses Fondation
1. Frais de fonctionnement
1.1. Remplacement d'une voiture (25%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000,-

4.000,-

1.2. Relations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,-

5.000,-

1.3. Repas annuel, cadeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.000,-

7.800,-

1.4. Intérêts débiteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000,-

2.500,-

1.5. Prix Korczack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

3.000,-

1.6. Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.000,-

5.000,-

Total frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.000,-

27.300,-

2. Frais de personnel
2.1. Responsable administrative (30h.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59.500,-

58.500,-

2.2. Diff. poste éduc. dipl./grad. 235 CI-M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.500,-

9.300,-

2.3. Primes de responsable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.700,-

6.750,-

2.4. Formation continue du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.500,-

6.500,-

Total frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85.200,-

81.050,-

3. CERES / ECOLE DES PARENTS
3.1. Educatrice graduée (20h./sem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.500,-

37.000,-

3.2. Educateur gradué Ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64.800,-

-

3.3. Frais de fonctionnem. Ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000,-

-

3.4. CERES formations pour professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45.000,-

24.000,-

3.5. Livres, documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000,-

5.000,-

3.6. Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500,-

1.500,-

Total frais CERES / ECOLE DES PARENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175.800,-

67.500,-

Total dépenses Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287.000,-

175.850,-

Recettes Fondation
1.1. Intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.000,-

33.000,-

1.2. Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.000,-

25.000,-

1.3. Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,-

500,-

Total Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73.500,-

58.500,-

2. CERES / ECOLE DES PARENTS
2.1. CERES Ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84.800,-

-

2.2. Formations, séminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.000,-

60.000,-

Total CERES / ECOLE DES PARENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209.800,-

60.000,-

Total recettes Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

283.300,-

118.500,-

Solde Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.700,-

- 57.350,-

Référence de publication: 2007104426/2690/113.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2007, réf. LSO-CH07200. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070116611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2007.

Good Energies Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Valbella S.A.).

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 35.872.

In the year two thousand and seven, on the seventeenth of July.
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg.

Was held:

an extraordinary general meeting of shareholders of VALBELLA S.A., a société anonyme incorporated and existing

under the laws of Luxembourg, with registered office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 35.872 (hereafter «the Company»), incorporated
pursuant to a notarial deed on 27 December 1990, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on
3 June 1991, number 261. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a notarial deed
on 7 December 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 11 April 2002, number 565.

108196

The general meeting was opened at 11.00 a.m with Mr Raf Bogaerts, Administrateur de sociétés, residing professionally

in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Ms Blazenka Bartolovic, private employee, residing in Nospelt.

The general meeting appointed as scrutineer Ms Peggy Partigianone, private employee, residing professionally in Lu-

xembourg.

The board of the general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to

state:

I.- That the agenda of the general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. To bring the nominal value of the shares to twenty-five euros (EUR 25.00) it is proposed to exchange five hundred

(500,000) shares with a nominal value of twenty-four euros and eighty cents (EUR 24.80) against four hundred ninety-six
thousand (496,000) shares with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.00) each;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of fifty euros (EUR 50.00) to bring it from its current

amount of twelve million four hundred thousand euros (EUR 12,400,000.00) to an amount of twelve million four hundred
thousand and fifty euros (EUR 12,400,050.00);

3. Payment and subscription of the new issued shares;
4. Conversion of the Company into a «société à responsabilité limitée», change of the name of the Company into

GOOD ENERGIES INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.à r.l. and restatement of the articles;

5. Resignation of the directors and of the auditor and discharge;
6. Appointment of managers and confirmation of the auditor's mandate;
7. Miscellaneous.
II. - That the shareholders present and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance

list, signed by the shareholders and by the board of the general meeting, will remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.

III. - That the whole share capital being present or represented at the present general meeting and all the shareholders

present declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this general meeting so that
no convening notices were necessary.

IV. - That the present general meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly

deliberate on the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting proposes to exchange five hundred thousand (500,000) shares with a nominal value of twenty-

four euros and eighty cents (EUR 24.80) against four hundred ninety-six thousand (496,000) shares with a nominal value
of twenty-five euros (EUR 25.00) each.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of twelve million

four hundred thousand euros (EUR 12,400,000.00) up to twelve million four hundred thousand and fifty euros (EUR
12,400,050.00) through the issue of two (2) new shares of the Company with a nominal value of twenty-five euros (EUR
25.00) each.

<i>Subscription and payment

The newly issued two (2) shares are subscribed by COFRA HOLDING AG, having its registered office in CH-6300

Zug, Grafenauweg, 10, here represented by Mr Raf Bogaerts, prenamed, by virtue of a proxy hereto attached, at a total
price  of  one  hundred  thirty-seven  million  four  hundred  sixty-five  thousand  nine  hundred  sixty-two  euros  (EUR
137,465,962.00) out of which fifty euros (EUR 50.00) are allocated to the share capital and one hundred thirty-seven
million four hundred sixty-five thousand nine hundred and twelve euros (EUR 137,465,912.00) to the share premium.

Those subscribed shares are fully paid up through a contribution in kind of three hundred thousand two hundred

(300,200) shares (i.e. 100%) of ENTREPRENEURS FUND BV, a company incorporated under Dutch law having its regis-
tered office at Jachthavenweg 111, 1081 KM Amsterdam (Pays-Bas).

The value of this contribution has been subject to a report dated 17 July 2007, established by ERNST &amp; YOUNG,

réviseur d'entreprises, having its registered office in L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, in accordance with Article
26-1 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, and the conclusion of the report reads
as follows:

«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe

that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 2 shares with
a nominal value of EUR 25 each to be issued with total related share premium of EUR 137,465,912, hence total consi-
deration of EUR 137,465,962.»

108197

The said report will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
COFRA HOLDING AG acting through its proxy hereby certifies with respect to the contribution in kind of the shares,

that on the day and at the moment of such contribution:

1. it is the legal and beneficial owner of all the shares being contributed;
2. all the transfer formalities have been complied with and there are no pre-emption rights nor any other rights attached

to the shares by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the shares be transferred to
him;

3. it has all corporate powers to accomplish and execute all documents necessary to the present transfer of shares ;
4. the shares are, to the best of the knowledge of COFRA HOLDING AG, unencumbered and freely transferable to

the Company;

5. the transfer of the shares of ENTREPRENEURS FUND BV shall be recorded in the register of shareholders of the

relevant companies.

Furthermore, a certificate issued by ENTREPRENEURS FUND BV confirming that COFRA HOLDING AG is registered

as sole shareholder and that the shares are freely transferable to the Company, has been produced to the undersigned
notary, and remain attached to the present deed.

The transfer of the shares of ENTREPRENEURS FUND BV is documented simultaneously with the present deed by a

notarial deed in The Netherlands, a copy of which is attached hereto.

The notary shall be provided by the Company with the relevant proof that all these formalities have been accomplished.
If supplementary formalities should be required in relation with the transfer of the shares, COFRA HOLDING AG,

as the contributor, will undertake the necessary steps as soon as possible.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to convert the Company from a société anonyme into a société à responsabilité limitée

and to change the name of the Company into GOOD ENERGIES INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.à r.l.

The general meeting further resolves that the share capital of the société à responsabilité limitée shall amount to twelve

million four hundred thousand and fifty euros (EUR 12,400,050.00) represented by 496,002 shares of a société à respo-
nabilité limitée.

<i>Fourth resolution

The general meeting acknowledges the termination of the mandates with effect as of today of Mr Raf Bogaerts, Mr

Armand Haas, Mr Michel De Groote, Mr John Drury and Mr Robert Smeele, as directors of the Company as well as of
the auditor in charge and grants full discharge to them until the date of the present extraordinary general meeting of
shareholders.

<i>Fifth resolution

The general meeting resolves to change the name of the Company into GOOD ENERGIES INVESTMENTS (LUXEM-

BOURG) S.à r.l. and to proceed to a complete restatement of the articles of incorporation of the Company in order to
adapt them to the new form of the Company.

The articles of incorporation of the Company shall now read as follows:

Art. 1. Form and Name. There exists a société à responsabilité limitée under the name of GOOD ENERGIES IN-

VESTMENTS (LUXEMBOURG) S.à r.l. (hereinafter the «Company»).

Art. 2. Purpose. The purpose of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form in other,

either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The Company may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights deriving

from these patents or complementary thereto.

The Company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a parti-

cipation or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out any commercial, industrial

or financial activities which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly
or indirectly to its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the

general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg. Branches or other offices

may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

108198

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the

manager or board of managers. If the manager or board of managers determines that extraordinary political, economic,
social or military events have occurred or are imminent which would render impossible the normal activities of the
Company at its registered office or the communication between such registered office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provi-
sional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer,
shall remain a Luxembourg company.

Art. 5. Capital. The share capital of the Company is set at twelve million four hundred thousand and fifty euros (EUR

12,400,050.00) represented by four hundred ninety-six thousand and two (496,002) shares with a nominal value of twenty-
five euros (EUR 25.00) each.

Art. 6. Amendment of the capital. The share capital may be amended at any time by decision of the sole shareholder

or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be, with approval of a majority of
shareholders representing three quarters of the share capital at least. The existing shareholder(s) shall have a preferential
subscription right in proportion to the number of shares held by him (them).

Art. 7. Shares. Each share is entitled to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at ordinary

and extraordinary general meetings of shareholders.

The Company recognizes only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who

shall represent them towards the Company.

The issued shares shall be entered in the register of shareholders, which shall be kept by the Company or by one or

more persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each shareholder, his
address or registered office.

Any transfer of shares in accordance with article 8 hereafter, shall be recorded in the register of shareholders.

Art. 8. Transfer of shares. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter may freely transfer its shares.
The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred to non-shareholders

subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code.

Neither creditors, nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

Art. 9. Bankruptcy or insolvency of a shareholder. The bankruptcy, insolvency or any similar event affecting the sole

shareholder or any of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 10. Management. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be,

which will determine their number and their term, and they will hold office until their successors are appointed. They
are re-eligible, but they may be dismissed freely at any time and without specific cause by a resolution of the sole share-
holder or by the general meeting of shareholders, as the case may be.

The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Meetings of the board of managers. In case of several managers, they will form a board of managers. The board

of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman.
It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of
the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of the board of managers and at general meetings of shareholders, but in

his absence, the shareholders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote
of the majority present or represented at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, e-mail, or any other similar means of communication. Any such notice shall specify the time and place
of the meeting as well as the agenda. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a
time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers, or if all the managers are present
or represented and declare having due knowledge of the agenda of the meeting.

108199

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile, e-mail or any

other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his
colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call, videoconference, or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if the majority but at least two of the managers are present

or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval by facsimile,

e-mail or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving
evidence of the passing of the resolution.

Art. 12. Minutes of meetings of the board of managers. The minutes of any meeting of the board of managers shall be

signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman of the board of managers,
or by any two managers or by any other person duly appointed to that effect by the board of managers.

Art. 13. Powers of the board of managers. The board of managers is vested with the broadest powers (except for

those powers which are expressly reserved by law to the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as
the case may be) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the purpose of the Company. All powers not
expressly reserved by law to the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, are in the
competence of the board of managers.

Art. 14. Delegation of powers. The board of managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined

permanent or temporary functions, including the daily management of the Company to persons or agents chosen by it.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the signature of any

two managers or by the joint signature or single signature of any persons to whom such signatory power has been
delegated by the board of managers, but only within the limits of such power.

Art. 16. General meeting of shareholders or resolutions of the sole shareholder. Each shareholder may participate in

the collective decisions, irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many
votes as he holds or represents shares.

Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the

share capital.

If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of shareholders.

If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting

of shareholders or, in case there are less than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions
to be adopted which will be sent by the board of managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the
shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed
resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 17. Decisions. The decisions of the sole shareholder or of the general meeting of shareholders are documented

in writing and recorded in a register. The votes of the shareholders and the power-of-attorneys are attached to the
minutes.

Art. 18. Financial year. The Company's financial year begins on the 1st January of each year and shall terminate on the

31st December of the same year.

Art. 19. Balance sheet. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the board of managers

prepares an inventory including an indication of the value of the assets and liabilities of the Company. Each shareholder
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

The books and accounts of the Company may be audited by an audit firm appointed by the sole shareholder or by a

general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 20. Allocation of profits. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of the legal reserve,

until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting

of shareholders, as the case may be, notwithstanding the power of the board of managers to distribute interim dividends
within the limits permissible under law.

108200

Art. 21. Dissolution, liquidation. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one

or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the sole shareholder or by the
general meeting of shareholders, as the case may be, who will determine their powers and fees. The liquidator(s) shall
have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 22. Amendments to the Articles of Incorporation. The present articles of incorporation may be amended from

time to time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 23. General provisions. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in ac-

cordance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 24. Language. The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case

of divergence between the English and the French text, the French version shall prevail.

<i>Sixth resolution

The general meeting resolves to set the number of managers at five (5) and to appoint:
1) Mr Michel de Groote, Administrateur de sociétés, born on 7 June 1954 in Kamina (Congo), residing professionally

in L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

2) Mr Raf Bogaerts, Administrateur de sociétés, born on 31 October 1970 in Lier (Belgium), residing professionally in

L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

3) Mr John Drury, Administrateur de sociétés, born on 25 May 1955 in Croydon (United Kingdom), residing in London

SW1Y 6EE, United Kingdom, Eagle House, 4th Floor, 108-110 Jermyn Street.

4) Mr Robert Smeele, Administrateur de sociétés, born on 9 January 1960 in Gravenhage (Netherlands), residing in

CH-6300 Zug, Grafenauweg, 10.

5) Mr Armand Haas, Administrateur de sociétés, born on 27 October 1937 in Esch-sur-Alzette, residing in L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

as managers of the Company for a period ending with the general meeting of shareholders to be held in 2008.
The general meeting confirms the mandate of ERNST &amp; YOUNG, réviseur d'entreprises, having its registered office

in L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activités Syrdall, a auditor, for a period ending with the general meeting of shareholders
to be held in 2008.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this

deed are estimated at approximately six thousand two hundred euros (EUR 6,200.00).

<i>Capital duty request

Considering that the present deed documents an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg company

by a contribution in kind consisting of 100% of the shares of a company having its registered office in an European Union
Member State, the Company requests in accordance with article 4-2 of the law of 29 Decembre 1971, as modified,
exemption from the capital duty.

There being no further business, the general meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary on the day stated at

the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by an French version; upon request of the appearing persons
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons known to the notary by their names, first names, civil status

and residences, said persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-sept juillet.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VALBELLA S.A., une société anonyme constituée

et existante sous les lois du Luxembourg, avec siège social à 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, enregistrée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 35.872, constituée suivant acte notarié du 27
décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 3 juin 1991, numéro 261. Les statuts ont
été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 7 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations le 11 avril 2002, numéro 565, (ci-après la «Société»).

108201

L'assemblée  générale  est  ouverte  à  onze  heures  sous  la  présidence  de  Monsieur  Raf  Bogaerts,  administrateur  de

sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Blazenka Bartolovic,
employée privée, demeurant à Nospelt.

L'assemblée générale choisit comme scrutatrice Mademoiselle Peggy Partigianone, employée privée, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I- Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Afin de porter la valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (EUR 25,00) il est proposé d'échanger cinq cent

mille (500.000) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingt cents (EUR 24,80) contre quatre cent
quatre-vingt-seize mille (496.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinquante euros (EUR 50,00) pour le porter de son

montant actuel de douze millions quatre cent mille euros (EUR 12.400.000,00) à un montant de douze millions quatre
cent mille cinquante euros (12.400.050,00);

3. Souscription et libération des nouvelles actions;
4. Transformation de la Société en société à responsabilité limitée, changement de la dénomination de la Société en

GOOD ENERGIES INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.à r.l. et modification des statuts;

5. Démission des administrateurs, du commissaire et décharge;
6. Nomination de gérants et confirmation du mandat du commissaire;
7. Divers.
II. Que les actionnaires présents, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence;

cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale, les actionnaires

présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur
a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. Que la présente assemblée générale, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale propose d'échanger cinq cent mille (500.000) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros

et quatre-vingt cents (EUR 24,80) contre quatre cent quatre-vingt-seize mille (496.000) actions d'une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de son montant actuel de douze millions quatre cent mille

euros (EUR 12.400.000,00), à douze millions quatre cent mille cinquante euros (EUR 12.400.050,00) par l'émission de
deux (2) actions nouvelles de la Société ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

<i>Souscription et libération

Les deux (2) nouvelles actions émises sont souscrites par COFRA HOLDING AG, ayant son siège social à CH-6300

Zug,  Grafenauweg,  10,  ici  représentée  par  Monsieur  Raf  Bogaerts,  prénommé,  en  vertu  d'une  procuration  ci-jointe,
souscrit à un prix total de cent trente-sept millions quatre cent soixante-cinq mille neuf cent soixante-deux euros (EUR
137.465.962,00) dont cinquante euros (EUR 50,00) sont affectés au capital social de la Société et cent trente-sept millions
quatre cent soixante-cinq mille neuf cent douze euros (EUR 137.465.912,00) à la prime d'émission.

Ces actions souscrites sont entièrement libérées par un apport en nature de trois cent mille deux cents (300.200)

actions (i.e. 100%) de ENTREPRENEURS FUND BV, une société régie par les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à
Jachthavenweg 111, 1081 KM Amsterdam (Pays-Bas).

La valeur de cet apport a fait l'objet d'un rapport en date du 17 juillet 2007, établi par ERNST &amp; YOUNG, réviseur

d'entreprises, ayant son siège social à 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, conformément à l'article 26-1 de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, dont la conclusion est la suivante:

«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe

that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 2 shares with
a nominal value of EUR 25 each to be issued with total related share premium of EUR 137,465,912, hence total consi-
deration of EUR 137,465,962.»

Ledit rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
COFRA HOLDING AG, agissant par son mandataire, certifie par la présente qu'au jour et au moment de la contri-

bution:

108202

1. elle est propriétaire de toutes les actions apportées;
2. toutes les formalités de transfert ont été respectées et il n'y a pas de droit de préemption ni autres droits attachés

aux actions par lesquels une quelconque personne serait en droit de demander qu'une ou plusieurs actions lui soient
transférées;

3. elle a tous pouvoirs sociaux pour accomplir et exécuter les documents nécessaires au présent transfert;
4. les actions, sont, à la meilleure connaissance de COFRA HOLDING AG, libres de toute charge et librement trans-

férables à la Société;

5. le transfert des actions de ENTREPRENEURS FUND BV sera inscrit par une inscription dans le registre d'actionnaires

des sociétés concernées.

Un certificat signé par ENTREPRENEURS FUND BV confirmant que COFRA HOLDING AG est bien inscrite comme

actionnaire unique de ladite Société et que les actions sont librement transférables à la Société, a été fourni au notaire
soussigné et restera annexé au présent acte.

Le transfert des actions de ENTREPRENEURS FUND BV est documenté simultanément avec le présent acte par acte

notarié établi aux Pays-Bas dont une copie est jointe au présent acte.

La preuve de l'exécution de ces formalités sera fournie au notaire soussigné par la Société.
Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert de l'intégralité du patrimoine, COFRA

HOLDING AG, en tant qu'apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de transformer la forme juridique de la Société d'une société anonyme en société à

responsablilité limitée et de changer la dénomination sociale de la Société en GOOD ENERGIES INVESTMENTS (LU-
XEMBOURG) S.à r.l.

L'assemblée générale décide en outre que le montant du capital social de la société à responsabilité limitée sera de

douze millions quatre cent mille cinquante euros (EUR 12.400.050,00), représentée par quatre cent quatre-vingt-seize
mille deux (496.002) parts sociales.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale constate la fin des mandats avec effet au jour d'aujourd'hui de Monsieur Raf Bogaerts, Monsieur

Armand Haas, Monsieur Michel De Groote, Monsieur John Drury et Monsieur Robert Smeele, comme administrateurs
de la Société ainsi que celui du commissaire en fonction et leur donne pleine décharge jusqu'à la date de la présente
assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide changer la dénomination de la Société en GOOD ENERGIES INVESTMENTS (LUXEM-

BOURG) S.à r.l. et de procéder à une refonte intégrale des statuts de la Société pour les adapter à la nouvelle forme
juridique.

Les statuts de la Société auront désormais la teneur suivante:

Art. 1 

er

 . Forme et dénomination.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GOOD

ENERGIES INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.à r.l. (la «Société»).

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La Société peut réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales,

industrielles ou financières qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient
directement ou indirectement à cet objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés,

selon le cas.

Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg. La Société peut ouvrir des agences ou succursales soit au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision du

gérant ou du conseil de gérance. Au cas où le conseil de gérance ou le gérant estimerait que des événements extraordi-
naires d'ordre politique, économique, social ou militaire, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou

108203

la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette me-
sure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire,
restera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze millions quatre cent mille cinquante

euros (EUR 12.400.050,00) représenté par quatre cent quatre-vingt-seize mille deux (496.002) parts sociales, d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié par une décision de l'associé

unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas, avec l'accord de la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social au moins. L'(les) associé(s) existant(s) a (ont) un droit de souscription préférentiel,
proportionnellement à la partie du capital qui représente ses (leurs) parts sociales.

Art. 7. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices et dans tout l'actif

social de la Société et a une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de

se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Toutes les parts émises seront inscrites au registre des associés qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs

personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque associé, son adresse ou siège
social.

Tout transfert de parts conformément à l'article 8 ci-après, sera inscrit au registre des associés.

Art. 8. Transfert de parts. Lorsque la Société est composée d'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés

qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou

acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Les créanciers ou ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 9. Faillite ou déconfiture d'un associé. La faillite ou déconfiture ou tout autre événement similaire affectant l'associé

unique ou l'un quelconque des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 10. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Les gérants sont nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, lesquels fixeront leur

nombre et la durée de leur mandat, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués librement à tout moment et sans motif par l'associé unique ou l'assemblée générale
des associés, selon le cas.

Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 11. Réunions du conseil de gérance. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance. Le

conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président.
Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de

convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance et les assemblées générales des associés; en son

absence les associés ou le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes ou représentées un
autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. La convocation indiquera l'heure et le lieu de la
réunion et contiendra l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de
gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de
gérance, ni si tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion et qu'ils déclarent avoir eu connaissance
préalable de l'ordre du jour.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, télécopie ou e-

mail ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter
plus d'un de ses collègues.

108204

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou

autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les
unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité mais au moins deux des gérants sont

présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le tout ensemble constituant
le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 12. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de

gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou
extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président du conseil de gérance
ou par deux gérants ou par toute autre personne dûment nommée à cet effet par le conseil de gérance.

Art. 13. Pouvoirs du conseil de gérance. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus larges (à l'exception des pouvoirs

qui sont expressément réservés par la loi à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés, selon le cas) pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
par la loi expressément à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés, selon le cas, sont de la compétence du
conseil de gérance.

Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonc-

tions déterminées de façon permanente ou temporaire, y compris la gestion journalière de la Société, à des personnes
ou agents de son choix.

Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature de deux quelconques

gérants ou par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué
par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 16. Décisions de l'associé unique ou des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel

que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il
possède ou représente.

Les décisions  collectives  ne  sont valablement  prises  que  pour  autant  qu'elles  aient  été  adoptées  par  des  associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée

générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou,

dans le cas où la Société comporte moins de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter,
lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, les associés ont
l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du
texte de la résolution proposée.

Art. 17. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit

et consignées dans un registre. Les votes des associés ainsi que les procurations seront annexés aux procès-verbaux.

Art. 18. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de la même

année.

Art. 19. Bilan. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance

dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre
communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Les comptes annuels et le compte de profit et perte sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, selon le cas, de

l'assemblée générale des associés.

Les livres et les comptes de la Société peuvent être audités par une société d'audit, nommée par l'associé unique ou

l'assemblée générale des associés selon le cas.

Art. 20. Répartition des bénéfices. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la

réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés, sans

préjudice du pouvoir du conseil de gérance de payer des acomptes sur dividendes dans les limites permises par la loi.

Art. 21. Dissolution, liquidation. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liqui-

dateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon
le cas, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs aura (auront) les pouvoirs les plus étendus
pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

108205

Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement du passif sera distribué aux associés proportionnellement

aux nombres de parts qu'ils détiennent dans la Société.

Art. 22. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée

générale des associés décidant selon les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 23. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 24. Langue. Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence

entre les deux textes, la version française prévaudra.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide de fixer le nombre de gérants à cinq (5) et de nommer:
1) Monsieur Michel de Groote, Administrateur de sociétés, né le 7 juin 1954 à Kamina (Congo), avec adresse profes-

sionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

2) Monsieur Raf Bogaerts, Administrateur de sociétés, né le 31 octobre 1970 à Lier (Belgique), avec adresse profes-

sionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

3) Monsieur John Drury, Administrateur de sociétés, né le 25 mai 1955 à Croydon (Grande-Bretagne), avec adresse

privée à SW1Y 6EE Londres (Grande-Bretagne), Eagle House, 4th Floor, 108-110 Jermyn Street.

4) Monsieur Robert Smeele, Administrateur de sociétés, né le 9 janvier 1960 à Gravenhage (Pays-Bas), avec adresse

privée à CH-6300 Zug, Grafenauweg, 10.

5) Monsieur Armand Haas, Administrateur de sociétés, né le 27 octobre 1937 à Esch-sur-Alzette, avec adresse privée

à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

comme gérants de la Société pour une durée s'achevant avec l'assemblée générale des actionnaires qui sera tenue en

2008.

L'assemblée générale confirme le mandat de ERNST &amp; YOUNG, réviseur d'entreprises, avec siège social à L-5365

Munsbach, 7, Parc d'Activités Syrdall, en tant que commissaire, pour une période s'achevant avec l'assemblée générale
des actionnaires qui sera tenue en 2008.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué approximativement à
la somme de six mille deux cents euros (EUR 6.200,00).

<i>Demande en exonération du droit d'apport

Compte tenu du fait que le présent acte documente une augmentation du capital d'une société luxembourgeoise par

apport de 100% des actions d'une société ayant son siège social dans un pays de la Communauté Européenne, la Société
requiert, conformément à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, l'exonération du droit d'apport.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la
version française fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Bogaerts, B. Bartolovic, P. Partigianone, J. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2007, LAC/2007/18964. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2007.

J. Baden.

Référence de publication: 2007102718/7241/556.
(070116447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2007.

108206

2000 Volts, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 262, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 80.736.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 14 septembre 2007.

<i>Pour 2000 VOLTS Sàrl
J. Reuter

Référence de publication: 2007108645/517/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04329. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070124008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Smets Gallery S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 262, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 54.967.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 14 septembre 2007.

<i>Pour SMETS GALLERY s.à r.l.
J. Reuter

Référence de publication: 2007108646/517/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04327. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Christa Intershipping S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 62.982.

<i>Extrait du contrat de cession de parts sociales date du 9 janvier 2007

Il résulte du contrat de cession de parts sociales conclu en date du 9 janvier 2007 que la société ALPHA DIREC-

TORSHIP LIMITED, ayant son siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, a cédé une (1 ) part sociale
qu'elle détenait dans la Société à la société BKDV HOLDING S.A., ayant son siège social au 9, rue du Chemin de Fer,
L-8057 Bertrange, dont le numéro d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés est le B 112.126.

Par suite du contrat de cession susmentionné, les associés actuels de la Société sont les suivants:

Nom des associés

Nombre

des parts

WESTGATE FINANCIAL HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

499

BKDV HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2007.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007108108/1035/26.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2007, réf. LSO-CI03580. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070123373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2007.

108207

Little Smets, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 262, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 24.325.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 14 septembre 2007.

<i>Pour LITTLE SMETS S.à r.l.
J. Reuter

Référence de publication: 2007108648/517/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04315. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070124002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Mic Cargo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9673 Oberwampach, Maison 105.

R.C.S. Luxembourg B 40.181.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 14 septembre 2007.

<i>Pour MIC CARGO s.à r.l.
J. Reuter

Référence de publication: 2007108650/517/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04312. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Genpact Global Holdings SICAR S.à r.l., Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'In-

vestissement en Capital à Risque.

Capital social: USD 200.864.221,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 104.548.

In the year two thousand and seven, the second day of July,
before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of GENPACT GLOBAL HOLDINGS

SICAR S.à r.l., a Luxembourg investment company in risk capital in the form of a private limited liability company (société
d'investissement en capital à risque sous forme de société à responsabilité limitée), with its registered office at 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
104.548 (the Company). The Company has been incorporated on 6 December 2004 pursuant to a deed of Maître Henri
Hellinckx, notary residing in Luxembourg (but at that time residing in Mersch), Grand Duchy of Luxembourg, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N 

o

 164 of 23 February 2005. The articles of association of the

Company have been amended several time as and for the last time on 26 June 2007 pursuant to a deed of Maître Martine
Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

There appeared:

1) GENPACT GLOBAL (LUX) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

with its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under the number B 104.547,

hereby represented by Mr Dirk Hamann, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

2) GE CAPITAL (MAURITIUS) HOLDINGS Ltd., a corporation organised under the laws of Mauritius and having its

registered office at Les Cascades, Edith Cavell Street, Port Louis, Mauritius,

108208

hereby represented by Mr Dirk Hamann, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

3) WIH HOLDINGS, a private company limited by shares organised under the laws of Mauritius and having its regis-

tered office at c/o ANAND S. PATHAK P&amp;A LAW OFFICES, 1st Floor, Dr. Gopal Das Bhavan, 28 Barakhamba Road,
New Delhi, 110 001 India,

hereby represented by Mr Dirk Hamann, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

4) BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A., a credit institution organised as a public limited company,

with its registered office at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, being registered with the Luxembourg trade and
companies register under number B 44.365,

hereby represented by Mr Dirk Hamann, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

Such proxies after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I.  that  3,077,346  (three  million  seventy-seven  thousand  three  hundred  and  forty-six)  series  A  preferred  shares,

3,017,346 (three million seventeen thousand three hundred forty-six) series B preferred shares and 384,790 (three hun-
dred eighty-four thousand seven hundred and ninety) common shares, having a par value of USD 31.- (thirty-one United
States Dollars) each, representing the entirety of the share capital of the Company are duly represented at the Meeting,;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by a nominal amount of USD 279.- (two hundred and seventy-nine

United States Dollars), to be paid together with a share premium of USD 5,328.- (five thousand three hundred and twenty-
eight United States Dollars), by way of creation of 9 (nine) common shares having a par value of USD 31.- (thirty-one US
Dollars) each;

3. Subscription to the share capital increase specified under item 2. above by BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE.

(LUXEMBOURG) S.A. and payment in cash of the share capital increase and share premium;

4. Subsequent amendment to article 4 first paragraph of the articles of association of the Company (the Articles) in

order to reflect the share capital increase specified under item 2. above;

5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG, to proceed, under
his/her sole signature, on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of
the Company; and

6. Miscellaneous.
III. that the Meeting has taken the following resolutions unanimously:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the shareholders represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 279.- (two hundred seventy-

nine United States Dollars) in order to bring the share capital from its current amount of USD 200,863,942.- (two hundred
million  eight  hundred  and  sixty-three  thousand  nine  hundred  and  forty-two  United  States  Dollars)  represented  by
3,077,346 (three million seventy-seven thousand three hundred and forty-six) series A preferred shares, 3,017,346 (three
million seventeen thousand three hundred forty-six) series B preferred shares and 384,790 (three hundred eighty-four
thousand seven hundred and ninety) common shares, having a par value of USD 31.- (thirty one United States Dollars)
each to an amount of USD 200,864,221.- (two hundred million eight hundred and sixty-four thousand two hundred and
twenty-one United States Dollars) represented by 3,077,346 (three million seventy-seven thousand three hundred and
forty-six) series A preferred shares, 3,017,346 (three million seventeen thousand three hundred forty-six) series B pre-
ferred shares and 384,799 (three hundred eighty-four thousand seven hundred and ninety-nine) common shares, having
a par value of USD 31.- (thirty one United States Dollars) each.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to accept and record the following intervention, subscription to and full payment of the 9 (nine)

newly issued common shares of the Company as follows:

<i>Subscription - Payment

BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A., a credit institution organised as a public limited company,

with registered office 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, being registered with the Luxembourg Trade and Com-

108209

panies Register under number B 44.365, being hereby represented by Mr Dirk Hamann, lawyer, professionally residing
in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, declares (i) to subscribe for the 9 (nine) newly issued
common shares of the Company having a par value of USD 31.- (thirty one US Dollars) each and (ii) to fully pay them up
by way of a contribution in cash consisting of a payment in an aggregate amount of USD 5,607.- (five thousand six hundred
and seven United States Dollars).

The contribution in cash, in the aggregate amount of 5,607 (five thousand six hundred and seven United States Dollars)

is to be allocated as follows:

(i) an amount of USD 279.- (two hundred and seventy-nine United States Dollars) to the nominal share capital account

of the Company; and

(ii) the balance of USD 5,328.- (five thousand three hundred and twenty-eight United States Dollars) to the share

premium account of the Company.

The aggregate amount of 5,607.- (five thousand six hundred and seven United States Dollars) is forthwith at the free

disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate
issued by BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A. on 2 July 2007 confirming the availability of the
subscription amount on the Company's bank account and the notary expressly acknowledges the availability of the funds
so paid.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 4 first paragraph of the Articles in order to reflect the above resolutions, so

that it reads henceforth as follows:

«The Company's subscribed capital is set at USD 200,864,221.- (two hundred million eight hundred and sixty-four

thousand two hundred and twenty-one United States Dollars) represented by 3,077,346 (three million seventy-seven
thousand three hundred and forty-six) series A preferred shares, designated as Series A Preferred Stock, 3,017,346 (three
million seventeen thousand three hundred forty-six) series B preferred shares, designated as Series B Preferred Stock
(together with the Series A Preferred Stock, the Preferred Stock) and 384,799 (three hundred eighty-four thousand seven
hundred and ninety-nine) common shares (the Common Stock) (together the Shares or the Stock), each with a par value
of USD 31.- (thirty-one United States Dollars) (the Share Capital).»

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby

empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG
to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company
and to see to any formalities in connection therewith.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2,100.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, the proxyholders of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le deuxième jour du mois de juillet,
par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de GENPACT GLOBAL HOLDINGS SICAR

S.à r.l., une société d'investissement en capital à risque de droit luxembourgeois sous forme de société à responsabilité
limitée, ayant son siège social sis 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Com-
merce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 104.548 (la Société). La Société a été constituée suivant un acte
de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg (habitant alors à Mersch),
en date du 6 décembre 2004 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N 

o

 164 du 23 février 2005.

Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois, et pour la dernière fois en vertu d'un acte daté du 26 juin 2007
de Maître Martine Schaeffer, notaire demeurant à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Ont comparu:

1) GENPACT GLOBAL (LUX) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 104.547,

108210

représenté par M. Dirk Hamann, juriste résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
2) GE CAPITAL INTERNATIONAL (MAURITIUS), une société régie par le droit de Maurice, ayant son siège social à

Edith Cavell Street, à Port Louis, à Maurice,

représenté par M. Dirk Hamann, juriste résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
3) WIH HOLDINGS, une société régie par le droit de Maurice, ayant son siège social au c/o ANAND S. PATHAK

P&amp;A LAW OFFICES, 1st Floor, Dr. Gopal Das Bhavan, 28 Barakhamba Road, à New Delhi 110 001 en Inde,

représenté par M. Dirk Hamann, juriste résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
4) BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE (LUXEMBOURG) S.A., une institution de crédit sous forme de société anonyme,

ayant son siège social au 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44.365,

représenté par M. Dirk Hamann, juriste résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Les procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et

par le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les parties, représentées selon les modalités susmentionnées, ont requis le notaire instrumentaire d'acte ce qui suit:
I. que 3.077.346 (trois million soixante-dix sept mille trois cent quarante-six) parts sociales préférentielles de catégorie

A, 3.017.346 (trois million dix-sept mille trois cent quarante-six) parts sociales préférentielles de catégorie B, et 384.790
(trois cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de
USD 31,- (trente et un Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune sont dûment représentées à la présente Assemblée
de la Société. L'Assemblée peut par conséquent être considérée comme dûment constituée et apte à délibérer des points
de l'ordre du jour mentionnés ci-dessous;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 279,- (deux cent soixante-dix neuf Dollars des

Etats-Unis d'Amérique) a être payés conjointement avec une prime d'émission de USD 5.328,- (cinq mille trois cent vingt-
huit Dollars des Etats-Unis d'Amérique), par la création de 9 (neuf) nouvelles parts ordinaires d'une valeur nominale de
USD 31,- (trente et un Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune;

3. Souscription et paiement en numéraire de l'augmentation de capital social indiquée au point 2. ci-dessus par la BANK

SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE (LUXEMBOURG) S.A. ainsi que l'attribution d'une prime d'émission;

4. Modification consécutive du premier paragraphe de l'article 4. des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y refléter

l'augmentation de capital social spécifiée au point 2. ci-dessus;

5. Modification du registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, avec pouvoir et

autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG de procéder,
sous sa seule signature et pour le compte de la Société, à l'enregistrement des nouvelles parts sociales émises dans le
registre de parts sociales de la Société; et

6. Divers.
III. que l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer

aux formalités de convocation, les associés de la Société représentés se considérant comme dûment convoqués et dé-
clarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de USD 279,- (deux cent soixante-dix

neuf Dollars des Etats-Unis d'Amérique) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de USD
200.863.942,- (deux cent millions huit cent soixante-trois mille neuf cent quarante-deux Dollars des Etats-Unis d'Amé-
rique) représenté par 3.077.346 (trois million soixante-dix sept mille trois cent quarante-six) parts sociales préférentielles
de catégorie A, 3.017.346 (trois million dix-sept mille trois cent quarante-six)parts sociales préférentielles de catégorie
B, et 384.790 (trois cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix) parts sociales ordinaires, ayant une valeur
nominale de USD 31,- (trente et un Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, à un montant de USD 200.864.221,-
(deux cent millions huit cent soixante-quatre mille deux cent vingt et un Dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté
par 3.077.346 (trois million soixante-dix sept mille trois cent quarante-six) parts sociales préférentielles de catégorie A,
3.017.346 (trois million dix-sept mille trois cent quarante-six)) parts sociales préférentielles de catégorie B, et 384.799
(trois cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix neuf) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale
de USD 31,- (trente et un Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer l'intervention, la souscription et la libération suivantes des 9 (neuf)

parts sociales ordinaires nouvellement émises de la Société de la manière suivante:

108211

<i>Souscription et libération

BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE (LUXEMBOURG) S.A., une institution de crédit sous forme de société anonyme,

ayant son siège social au 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44.365, ci-après représentée par M. Dirk Hamann, juriste résidant profes-
sionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare (i) souscrire à 9 (neuf) parts
sociales ordinaires nouvellement émises de la Société, ayant une valeur nominale de USD 31,- (trente et un Dollars des
Etats-Unis d'Amérique) chacune et (ii) les libérer entièrement par voie d'apport en numéraire consistant en le paiement
d'un montant total de USD 5.607,- (cinq mille six cent sept Dollars des Etats- Unis d'Amérique).

L'apport en numéraire, d'un montant total de USD 5.607,- cinq mille six cent sept Dollars des Etats-Unis d'Amérique)

devra être alloué comme suit:

1. un montant de USD 279,- (deux cent soixante-dix neuf Dollars des Etats-Unis d'Amérique) sera attribué au compte

capital social nominal de la Société; et

2. le solde de USD 5.328,- (cinq mille trois cent vingt-huit Dollars des Etats-Unis d'Amérique) sera attribué au compte

de prime d'émission de la Société;

Le montant total de USD 5.607,- (cinq mille six cent sept Dollars des Etats- Unis d'Amérique) est par conséquent à

l'entière disponibilité de la Société, comme en atteste le certificat de blocage émis par BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp;
CIE. (LUXEMBOURG) S.A. le 2 juillet 2007, certificat qui confirme la disponibilité du montant de souscription sur le
compte bancaire de la Société. Le notaire instrumentaire reconnaît expressément la disponibilité des fonds ainsi versés.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des Statuts de la Société, afin d'y refléter les

modifications ci-dessus. Il aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est établi à USD 200.864.221,- (deux cent millions huit cent soixante-quatre mille deux

cent vingt et un Dollars des Etats-Unis d'Amérique), représenté par 3.077.346 (trois millions soixante-dix sept mille trois
cent quarante-six) parts sociales préférentielles de catégorie A désignées Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A,
3.017.346 (trois millions dix-sept mille trois cent quarante-six) parts sociales préférentielles de catégorie B désignées
Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B (ensemble avec les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A, les Parts
Sociales Préférentielles), et 384.799 (trois cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix neuf) parts sociales
ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires) (désignées ensemble les Parts Sociales), ayant une valeur nominale de USD 31,-
(trente et un Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune (le Capital Social).»

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus,

et confère pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY LU-
XEMBOURG de procéder pour le compte de la Société, à l'enregistrement des nouvelles parts sociales émises dans le
registre de parts sociales de la Société et d'effectuer toutes les formalités y afférentes.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 2.100,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle Anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

a  été  établi  en  Anglais,  suivi  d'une  version  française.  A  la  requête  de  ces  mêmes  parties  comparantes,  et  en  cas  de
divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.

Et après lecture faite aux mandataires des parties comparantes, lesdits mandataires ont signé ensemble avec le notaire

l'original du présent acte.

Signé: D. Hamann, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2007, LAC/2007/16209. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007107044/5770/247.

(070121479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2007.

108212

Ideal Standard International Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 131.260.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the twentieth day of July, at noon.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BAIN CAPITAL FUND VIII-E, L.P., a limited partnership organized and existing under the laws of the Cayman Islands,

having its registered office at WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908 GT, Walker House, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands,

duly represented by Ms Caroline Streiff, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in London on 20 July 2007.

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present
articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds and notes.
The Company may further guarantee, grant loans, manage or otherwise assist the companies in which it holds a direct

or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will assume the name of IDEAL STANDARD INTERNATIONAL HOLDING.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Munsbach, urban district of Schuttrange, Grand Duchy

of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of
a general meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at fifteen thousand euro (EUR 15,000.-) represented by fifteen thousand

(15,000) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint co-

owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

108213

C. Management

Art. 10. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders. In case of several

managers, the managers shall form a board of managers.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The

managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of two managers or the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated
by the sole manager / board of managers.

The sole manager / board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private

instrument.

Art. 11. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with
the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager acting individually at the place indicated

in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board
of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate
or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by one manager. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by one manager.

Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 14. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 15. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 16. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 17. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts -distribution of profits

Art. 18. The Company's financial year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December.

108214

Art. 19. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 20. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10 ) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. The manager or,
in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any
time, under the following conditions:

1. the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. these interim statement of accounts show that sufficient funds are available for distribution, it being understood that

the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried
forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve
in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended or the articles of incorporation of
the Company.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 21. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All the fifteen thousand (15,000) shares have been subscribed by BAIN CAPITAL FUND VIII-E, L.P., pre-named, for a

total price of fifteen thousand euro (EUR 15,000.-).

All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000.-) entirely

allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately 1,900.- euro.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 9A, Pare d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of

Luxembourg.

2. The following persons are appointed as managers:
a) Mr Sean Doherty, general counsel, born in Groton, Connecticut, USA, on 30 September 1968, residing at 111,

Huntington Avenue, Boston MA 02199, USA;

b) Mr Steven Barnes, managing, born in Syracuse, New-York on 6 April 1960, residing at 111, Huntington Avenue,

Boston MA 02199, USA;

c) Mrs Ailbhe Jennings, director, born in Dublin on 27 March 1963, residing at 17, rue du Verger, L-5372 Schuttrange,

Luxembourg.

3. The term of office of the members of the board of managers is set for an unlimited period of time.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

108215

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt juillet, à midi.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

BAIN CAPITAL FUND VIII-E, L.P., un limited partnership constitué et existant sous les lois des îles Cayman ayant son

siège social à WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908 GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, îles Cayman,

représenté par Mademoiselle Caroline Streiff, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration sous seing privé donnée à Londres le 20 juillet 2007.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  II est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra procéder à des emprunts sous quelque forme que ce soit et de quelque nature que ce soit, de même

qu'elle pourra émettre des titres et des obligations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de IDEAL STANDARD INTERNATIONAL HOLDING.

Art. 5. Le siège social est établi à Munsbach, commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être

transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des
associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par quinze mille (15.000)

parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-
associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts
appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts
sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

C. Gérance

Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. S'il y a plus d'un gérant

à être nommé, les gérants devront constituer un conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Les

gérants sont librement et à tout moment révocables, sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.

108216

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'il y a plusieurs gérants, par

la signature conjointe d'au moins deux gérants ou la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de
signature auront été délégués par le gérant unique / conseil de gérance.

Le gérant unique / conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou

sous seing privé.

Art. 11. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-

président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d'un des gérants agissant individuellement au lieu

indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le
conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer
la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence ou

par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 12. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par un gérant. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par un gérant.

Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

D. Décisions de l'associe unique - Décisions collectives des associes

Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 16. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 17. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 19. Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l'inventaire et du bilan.

Art. 20. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le

108217

gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ou les présents statuts.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 21. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif
et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Toutes les quinze mille (15.000) parts sociales ont été souscrites par Bain CAPITAL FUND VIII-E, L.P. ci-avant nommée,

pour un montant total de quinze mille euros (EUR 15.000,-).

Toutes les parts sociales souscrites ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de quinze mille euros (EUR

15.000,-) entièrement allouée au capital social, est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ 1.900,- euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant l'intégralité du capital social et

exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 9A, Parc d'Activité Syrdall, L-5365, Munsbach, Grand Duché de Luxembourg.
2. Sont nommés comme membres du conseil de gérance de la Société:
a) Monsieur Sean Doherty, chef du département juridique, né à Groton, Connecticut, USA le 30 septembre 1968,

demeurant au 111, Huntington Avenue, Boston, MA 02199, USA;

b) Monsieur Steven Barnes, administrateur délégué, né à Syracuse, New-York, USA, le 6 avril 1960, demeurant au 111,

Huntington Avenue, Boston, MA 02199, USA;

c) Madame Ailbhe Jennings, née à Dublin le 27 mars 1963, demeurant au 17, rue du Verger, L-5372 Schuttrange,

Luxembourg.

3. Le mandat des membres du conseil de gérance est établi pour une durée indéterminée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Streiff, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007. Relation: LAC/2007/20034. — Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 10 septembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007106443/242/319.
(070121403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2007.

108218

F.T.F. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 66.381.

<i>Résolutions prises lors de l'assemblée générale du 26 mars 2007

1. les actionnaires révoquent Madame Ingrid Hoolants de son poste d'administrateur avec effet au 15 mars 2007;
2. les actionnaires décident de nommer Monsieur Michal Wittmann, résidant professionellement 1, rue Goethe, L-1637

Luxembourg, comme administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108663/777/15.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2007, réf. LSO-CH08495. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070123779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2007.

Europäische Beteiligungsgesellschaft A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 86.427.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108676/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2007, réf. LSO-CI02402. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Etablissement Rolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4807 Rodange, 101, rue Nic Biever.

R.C.S. Luxembourg B 29.780.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108683/510/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2007, réf. LSO-CI03277. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Genpact Global Holdings SICAR S.à r.l., Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'In-

vestissement en Capital à Risque.

Capital social: USD 200.854.363,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 104.548.

In the year two thousand and seven, on the fifth of June.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of GENPACT GLOBAL HOLDINGS

SICAR S. à r.l., a Luxembourg investment company in risk capital in the form of a private limited liability company (société
d'investissement en capital à risque sous forme de société à responsabilité limitée), with its registered office at 23, avenue
Monterey L-2086, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
104.548 (the Company). The Company has been incorporated on 6 December 2004 pursuant to a deed of Maître Henri
Hellinckx, notary then residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg) published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations - N 

o

 164 of 23 February 2005. The articles of association of the Company (the Articles) have been

108219

amended several times as and for the last time by a deed of the undersigned notary dated 11 May 2007, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared:

1) GENPACT GLOBAL (LUX), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with

its registered office at 23, avenue Monterey L-2086 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B 104.547, hereby represented by Mrs Rosy-Mathilde Mounthault, lawyer, residing in Lux-
embourg, by virtue of a proxy given under private seal;

2) GE CAPITAL INTERNATIONAL (MAURITIUS), a corporation organised under the laws of Mauritius and having

its registered office at Edith Cavell Street, Port Louis, Mauritius, hereby represented by Mrs Rosy-Mathilde Mounthault,
lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

3) WIH HOLDINGS, a private company limited by shares organised under the laws of Mauritius and having its regis-

tered office at C/O ANAND S. PATHAK P&amp;A LAW OFFICES, 1st Floor, Dr. Gopal Das Bhavan, 28 Barakhamba Road,
New Delhi, 110 001 India, hereby represented by Mrs Rosy-Mathilde Mounthault, lawyer, residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal;

4) BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A., a credit institution organised as a public limited company,

with registered office 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, being registered with the Luxembourg trade and com-
panies  register  under  number  B  44.365,  hereby  represented  by  Mrs  Rosy-Mathilde  Mounthault,  lawyer,  residing  in
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxies after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that 3,077,346 (three million seventy-seven thousand three hundred forty-six) series A preferred shares, 3,017,346

(three million seventeen thousand three hundred forty-six) series B preferred shares, and 384,715 (three hundred eighty-
four thousand seven hundred and fifteen) common shares, having a par value of USD 31.- (thirty-one United States Dollars)
each, representing the entirety of the share capital of the Company are duly represented at this Meeting. The Meeting is
consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver of the convening notices;
2. approval of the redemption of 234 (two hundred and thirty-four) common shares held by BANK SAL. OPPENHEIM

JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A. (the Redeemed Shares) for an amount of approximately USD 682,812.- (six hundred
eighty-two thousand eight hundred and twelve United States Dollars);

3. reduction of the share capital of the Company by an amount of USD 7,254.- (seven thousand two hundred and fifty-

four United States Dollars) by way of cancellation of the Redeemed Shares;

4. subsequent amendment to article 4 first paragraph of the articles of association of the Company (the Articles) in

order to reflect the share capital decrease specified under item 3. above;

5. amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any officer of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG, to proceed, under his/
her sole signature, on behalf of the Company to the registration of the redemption of the Redeemed Shares and the share
capital decrease specified under item 3. above in the share register of the Company; and

6. miscellaneous.
III. that the Meeting has taken unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the shareholders represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting acknowledges that the compensation committee of the Company approved on 29 May 2007 the exercise

of (i) a call option under the terms and conditions of a stock purchase agreement entered into by, amongst others, the
Company and BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A. with respect to 210 (two hundred and ten)
Common Stocks held by BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A. for an aggregate amount of USD
612,780.- (six hundred and twelve thousand seven hundred and eighty United States Dollars) (the A Redemption), and
(ii) a call option under the terms and conditions of a stock purchase agreement entered into by, amongst others, the
Company and BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A. with respect to 24 (twenty-four) Common
Stocks held by BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A. for an aggregate amount of USD 70,032.-
(seventy thousand thirty-two United States Dollars) (the B Redemption), the exercise of these two call options being
subject to the approval of the Meeting.

108220

The Meeting acknowledges that the call option notice regarding the A Redemption and the call option notice regarding

the B Redemption have been duly signed by the Company and BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG)
S.A.

The Meeting further acknowledges that (A), according to a stock transfer agreement entered into by the Company

and BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A., legal title to the 210 (two hundred and ten) Common
Stocks to be redeemed by the Company under the A Redemption shall be transferred from BANK SAL. OPPENHEIM
JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A. to the Company with effect as of the moment on which the Meeting approves the
transfer of such 210 (two hundred and ten) Common Stocks (the A Transfer) and (B) according to a stock transfer
agreement entered into by the Company and BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A., legal title to
the 24 (twenty-four) Common Stocks to be redeemed by the Company under the B Redemption shall be transferred
from BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A. to the Company with effect as of the moment on which
the Meeting approves the transfer of such 24 (twenty-four) Common Stocks (the B Transfer).

The Meeting resolves to approve the exercise of (i) the call option regarding the A Redemption for an aggregate

amount of USD 612,780.- (six hundred and twelve thousand seven hundred and eighty United States Dollars) and on the
other terms and condition set out in the relevant call option notice and (ii) the call option regarding the B Redemption
for an aggregate amount of 70,032.- (seventy-thousand and thirty-two United States Dollars) and on the other terms and
condition set out in the relevant call option notice. The Meeting further resolves to approve the A Transfer and the B
Transfer.

The Meeting acknowledges that, as a consequence, (i) the aggregate of 234 (two hundred and thirty-four) Common

Stocks held by BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A. shall be transferred to the Company with
immediate effect, and (ii) the aggregate amount of USD 682,812.- (six hundred eighty-two thousand eight hundred and
twelve United States Dollars) shall be paid by the Company.

In the light of the letter, duly signed on the 1 June 2007 by an officer of the Company, the Meeting acknowledges that

the share redemptions referred to in this second resolution does not have the effect of reducing the net assets below
the subscribed share capital of the Company.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to hereby cancel the 234 (two hundred and thirty-four) common shares held by BANK SAL.

OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A. for an aggregate amount of USD 682,812.- (six hundred eighty-two thou-
sand eight hundred and twelve United States Dollars) of the Company that were redeemed under the second resolution.
Subsequently, the subscribed capital is reduced by an amount of USD 7,254.- (seven thousand two hundred and fifty-four
United States Dollars) and is brought from its present amount of USD 200,861,617.- (two hundred million eight hundred
sixty-one thousand six hundred and seventeen United States Dollars) to USD 200,854,363.- (two hundred million eight
hundred fifty-four thousand three hundred and sixty-three United States Dollars) represented by 3,077,346 (three million
seventy-seven thousand three hundred forty-six) Series A Preferred Stock, by 3,017,346 (three million seventeen thou-
sand  three  hundred  and  forty-six)  Series  B  Preferred  Stock,  and  384,481  (three  hundred  eighty-four  thousand  four
hundred eighty-one) common shares, having a par value of USD 31.- (thirty-one United States Dollars) each.

<i>Fourth resolution

As a result of the capital decreases resolved upon by the Meeting in the third resolution, the first paragraph of article

4 of the Articles shall henceforth read as follows:

« Art. 4. First paragraph. The Company's subscribed capital is set at USD 200,854,363.- (two hundred million eight

hundred fifty-four thousand three hundred and sixty-three United States Dollars) divided into 3,077,346 (three million
seventy-seven thousand three hundred and forty-six) series A preferred shares designated as Series A Preferred Stock,
by 3,017,346 (three million seventeen thousand three hundred and forty-six) series B preferred shares designated as
Series B Preferred Stock (together with the Series A Preferred Stock, the Preferred Stock), and by 384,481 (three hundred
eighty-four thousand four hundred eighty-one) common shares (the Common Stock) (together the Shares or the Stock),
each with a nominal par value of USD 31.- (thirty-one United States Dollars) (the Share Capital).»

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby

empowers and authorizes any officer of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG
to proceed on behalf of the Company, under his/her sole signature, to the registration of the share redemption and the
share cancellation referred to in the above resolutions in the share register of the Company and to see to any formalities
in connection therewith.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,000.- (one thousand Euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

108221

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, the proxyholders of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le cinq juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de GENPACT GLOBAL HOLDINGS SICAR

S. à r.l., une société d'investissement en capital à risque de droit luxembourgeois sous forme de société à responsabilité
limitée, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Com-
merce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 104.548 (la Société). La Société a été constituée suivant un acte
de Maître Henri Hellinckx, notaire alors résident à Mersch, en date du 6 décembre 2004 publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations - N 

o

 164 du 23 février 2005. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois, et

pour la dernière fois en vertu d'un acte daté du 11 mai 2007 du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.

Ont comparu:

1) GENPACT GLOBAL (LUX) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 104.547, représenté par Mme Rosy-Mathilde Mounthault, juriste résidant au Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

2) GE CAPITAL INTERNATIONAL (MAURITIUS), une société régie par le droit de Maurice, ayant son siège social à

Edith Cavell Street, à Port Louis, à Maurice, représenté par Mme Rosy-Mathilde Mounthault, juriste résidant au Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

3) WIH HOLDINGS, une société régie par le droit de Maurice, ayant son siège social au c/o ANAND S. PATHAK

P&amp;A LAW OFFICES, 1st Floor, Dr. Gopal Das Bhavan, 28 Barakhamba Road, à New Delhi 110 001 en Inde, représenté
par Mme Rosy-Mathilde Mounthault, juriste résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

4) BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE (LUXEMBOURG) S.A., une institution de crédit sous forme de société anonyme,

ayant son siège social au 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44.365, représenté par Mme Rosy-Mathilde Mounthault, juriste résidant au
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Les procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et

par le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les parties, représentées selon les modalités susmentionnées, ont requis le notaire instrumentaire d'acte ce qui suit:
I. que 3.077.346 (trois millions soixante-dix sept mille trois cent quarante-six) parts sociales préférentielles de catégorie

A, 3.017.346 (trois millions dix-sept mille trois cent quarante-six) parts sociales préférentielles de catégorie B, et 384.715
(trois cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quinze) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de USD 31,-
(trente et un Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune sont dûment représentées à la présente Assemblée de la Société.
L'Assemblée peut par conséquent être considérée comme dûment constituée et apte à délibérer des points de l'ordre
du jour mentionnés ci-dessous;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Approbation du rachat de 234 parts ordinaires détenues par BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG)

S.A. (les Parts Sociales Rachetées) pour une valeur approximative de USD 682.812,- (six cent quatre-vingt-deux mille huit
cent douze Dollars des Etats-Unis d'Amérique);

3. Réduction du capital social de la Société d'un montant de USD 7.254,- (sept mille deux cent cinquante-quatre Dollars

des Etats-Unis d'Amérique) par voie d'annulation des Parts Sociales Rachetées;

4. Modification consécutive du premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y refléter

la réduction du capital social spécifiée au point 3 ci-dessus;

5. Modification du registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, avec pouvoir et

autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG de procéder,
sous sa seule signature et pour le compte de la Société, à l'enregistrement de la réduction de capital spécifiée au point 3
ci-dessus dans le registre de parts sociales de la Société; et

6. Divers.
III. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

108222

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer

aux formalités de convocation, les associés de la Société représentés se considérant comme dûment convoqués et dé-
clarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée reconnaît que le compensation committee de la Société a approuvé le 29 mai 2007 l'exercice (i) d'une

option d'achat suivant les stipulations d'un stock purchase agreement conclu par, entre autres, la Société et BANK SAL.
OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A., concernant 210 (deux cent dix) Parts Sociales Ordinaires détenus par
BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A., pour un montant total de USD 612.780,- (six cent douze
mille sept cent quatre-vingts Dollars des Etats-Unis d'Amérique) (le Rachat A), et (ii) d'une option d'achat suivant les
stipulations d'un stock purchase agreement conclu par, entre autres, la SOCIÉTÉ ET BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE.
(LUXEMBOURG) S.A., concernant 24 (vingt-quatre) Parts Sociales Ordinaires détenus par BANK SAL. OPPENHEIM JR.
&amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A. pour un montant total de USD 70.032,- (soixante-dix mille trente-deux Dollars des Etats-
Unis d'Amérique) (le Rachat B), l'exercice de ces deux options d'achat étant conditionné à l'approbation de l'Assemblée.

L'Assemblée reconnaît que la notice d'exercice de l'option d'achat concernant le Rachat A et la notice d'exercice de

l'option d'achat concernant le Rachat B ont été dûment signé par la Société et BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE.
(LUXEMBOURG) S.A.

L'Assemblée reconnaît par ailleurs que (A), en vertu d'un stock transfer agreement conclu par la SOCIÉTÉ ET BANK

SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A., la propriété des 210 (deux cent dix) Parts Sociales Ordinaires qui
doivent être rachetées par la Société dans le cadre du Rachat A doivent être transférées de BANK SAL. OPPENHEIM
JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A. à la Société au moment auquel l'Assemblée approuve le transfert de ces 210 (deux cent
dix) Parts Sociales Ordinaires (le Transfert A) et (B) en vertu d'un stock transfer agreement conclu par la Société et
BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A., la propriété des 24 (vingt-quatre) Parts Sociales Ordinaires
qui doivent être rachetées par la Société dans le cadre du Rachat B doivent être transférées de BANK SAL. OPPENHEIM
JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A. à la Société au moment auquel l'Assemblée approuve le transfert de ces 24 (vingt-quatre)
Parts Sociales Ordinaires (le Transfert B).

L'Assemblée décide d'approuver l'exercice (i) de l'option d'achat concernant le Rachat A pour un montant de USD

612.780,- (six cent douze mille sept cent quatre-vingts Dollars des Etats-Unis d'Amérique) et selon les autres stipulations
de cette notice d'exercice de l'option d'achat et (ii) de l'option d'achat concernant le Rachat B pour un montant de
70.032,- (soixante-dix mille et trente-deux Dollars des Etats-Unis d'Amérique) et selon les autres stipulations de cette
notice d'exercice de l'option d'achat. L'Assemblée décide également d'approuver le Transfert A et le Transfert B.

L'Assemblée reconnaît que, par conséquent, le montant total de 234 (deux cent trente-quatre) Parts Sociales Ordi-

naires détenus par BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. (LUXEMBOURG) S.A. sont transférées à la Société avec effet
immédiat, et (ii) le montant total de USD 682.812,- (six cent quatre-vingt-deux mille huit cent douze Dollars des Etats-
Unis d'Amérique) doit être payé par la Société.

A la lumière de la lettre signée par un officier de la Société en date du 1 

er

 juin 2007, l'Assemblée reconnaît que les

rachat de parts sociales auxquels il est fait référence dans la présente résolution n'ont pas pour effet de réduire l'actif net
en dessous du montant total du capital souscrit de la Société.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide, d'annuler les parts ordinaires 234 parts ordinaires détenues par BANK SAL. OPPENHEIM JR. &amp;

CIE. (LUXEMBOURG) S.A. (les Parts Sociales Rachetées) pour une valeur de USD 682.812,- (six cent quatre-vingt-deux
mille huit cent douze Dollars des Etats-Unis d'Amérique) qui ont été rachetées en vertu de la seconde résolution. Ensuite,
le capital souscrit est réduit d'un montant de USD 7.254,- (sept mille deux cent cinquante-quatre Dollars des Etats-Unis
d'Amérique) et le capital actuel s'élevant à un montant de USD 200.861.617,- (deux cent millions huit cent soixante et
une mille six cent dix-sept Dollars des Etats-Unis d'Amérique) à 200.854.363,- (deux cent million huit cent cinquante-
quatre mille trois cent soixante-trois Dollars d'Etats-Unis d'Amérique) divisés en 3.077.346 (trois millions soixante-dix
sept mille trois cent quarante-six) Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A, 3.017.346 (trois millions dix-sept mille
trois cent quarante-six) Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B et 384.481 (trois cent autre vingt-quatre mille quatre
cent quatre-vingt et une) parts sociales ordinaires, dont chacune a une valeur nominale de USD 31,- (trente et un Dollars
des États-Unis d'Amérique).

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des Statuts de la Société, afin d'y refléter les

modifications ci-dessus. Il aura désormais la teneur suivante:

« Art. 4. Premier paragraphe. Le capital social souscrit de la Société est fixé à 200.854.363,- (deux cent millions huit

cent cinquante-quatre mille trois cent soixante-trois Dollars d'Etats-Unis d'Amérique) divisés en 3.077.346 (trois millions
soixante-dix sept mille trois cent quarante-six) parts sociales préférentielles de catégorie A, désignées comme Parts
Sociales Préférentielles de Catégorie A, 3.017.346 (trois millions dix-sept mille trois cent quarante-six) parts sociales
préférentielles de Catégorie B, désignées comme Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B (ensemble avec les Parts

108223

Sociales Préférentielles de Catégorie A, les Parts Sociales Préférentielles), et 384.481 (trois cent quatre-vingt-quatre mille
quatre cent quatre-vingt et une) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires) (ensemble les Parts Sociales),
ayant une valeur nominale de USD 31,- (trente et un Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune (le Capital Social).»

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus,

et confère pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY LU-
XEMBOURG de procéder pour le compte de la Société, à l'enregistrement du rachat des parts sociales et à leur annulation
dans le registre de parts sociales de la Société et d'effectuer toutes les formalités y afférentes.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.000,- (mille Euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite aux mandataires des parties comparantes, lesdits mandataires ont signé ensemble avec le notaire

l'original du présent acte.

Signé: R. M. Mounthault, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2007, LAC/2007/12401. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007107034/5770/266.
(070121476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2007.

Comptoir Technique et Industriel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 321, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 6.229.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108688/510/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2007, réf. LSO-CI03284. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Isoletanche S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3980 Wickrange, 11, rue des Bois.

R.C.S. Luxembourg B 94.155.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108689/510/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2007, réf. LSO-CI03286. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

108224

Zulu II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 131.300.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsieben, den vierundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joëlle Baden, mit Amtssitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

Die Gesellschaft luxemburgischen Rechts FREO GERMANY II PARTNERS (SCA) SICAR rechtsgültig gegründet gemäss

der  luxemburgischen  Gesetzgebung,  eingeschrieben  beim  Handels-  und  Gesellschaftsregister  unter  der  Nummer  B
123.906, mit Sitz in 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg,

rechtsmäßig hier vertreten durch Herrn Christopher Dortschy mit Geschäftsadresse in 121, avenue de la Faïencerie,

L-1511 Luxembourg,

gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Luxembourg, am 10. Juli 2007.
Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den unter-

zeichnenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung der Gesellschaft mit

beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (nachstehend die «Ge-

sellschaft») für den gegenwärtigen und zukünftigen Gesellschafter nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom
zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung und mit der vor-
liegenden Satzung gegründet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche

der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, dieser Gesellschaften Kredite gewähren
oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann für sich selbst oder für Dritte, alle Tätigkeiten vornehmen, die ihr zur Erreichung ihrer Zwecke

förderlich erscheinen oder direkt oder indirekt mit diesen in Verbindung stehen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbeschränkte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft wird unter dem Namen ZULU II S.àr.l. gegründet.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Der Sitz kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter in jedwedige Gemeinde des Groß-

herzogtums  Luxemburg  verlegt  werden.  Der  Gesellschaftssitz  kann  innerhalb  der  gleichen  Gemeinde  durch  einen
Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern durch Beschluss des Rates der Ge-
schäftsführer, verlegt werden. Zweigstellen oder Agenturen können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch
Beschluss des Geschäftsführers oder durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer errichtet werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in einhundertfünfund-

zwanzig (125) Anteile zu je einhundert Euro (EUR 100,-).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei

Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden. Im Fall einer Bareinlage haben die Gesellschafter ein Vor-
zugsrecht, im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen in der Gesellschaft.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu,

so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesellschafts-

anteilen unter Lebenden an Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung der anderen Gesellschafter mit einer Mehrheit von
wenigstens drei Vierteln des Gesellschaftskapitals.

Im Fall des Todes eines Gesellschafters bedarf die Übertragung von Anteilen des verstorbenen Gesellschafters an einen

Dritten der Zustimmung der anderen Gesellschafter in einer Hauptversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit des Ge-

108225

sellschaftskapitals der anderen Gesellschafter. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung
an Eltern oder Abkömmlinge oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines

ihrer Gesellschafter aufgelöst.

C. Geschäftsführung

Art. 11. Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht unbedingt Gesellschafter

sein müssen. Sie können als Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B bestellt werden.

Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafter bestellt, welche die Dauer ihres Mandates bestimmen. Ein Ge-

schäftsführer kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen von den Gesellschaftern widerrufen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder bei mehreren Geschäfts-

führern  durch  die  gemeinsame  Unterschrift  eines  A-Geschäftsführers  sowie  eines  B-Geschäftsführers  oder  durch
Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Rat der Geschäftsführer bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

Art. 12. Im Fall von mehreren Geschäftführern kann der Rat der Geschäftsführer aus dem Kreis seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden auswählen. Er kann außerdem einen Sekretär bestimmen, welcher
kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokollierung der Sitzungen der Geschäftsführung und der Haupt-
versammlung verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem im Einladungs-

schreiben genannten Ort einberufen.

Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung und der Hauptversammlung wahr, jedoch

kann in seiner Abwesenheit der Rat der Geschäftsführer oder die Gesellschafter per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden
einen anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt

ein schriftliches Einladungsschreiben per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), außer in dringenden Fällen, in denen
Art und Grund der Dringlichkeit im Einladungsschreiben angegeben werden sollen. Auf das Einladungsschreiben kann
durch schriftliche Zustimmung, durch Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein
gesondertes Einladungsschreiben ist für Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung
in einem vorangegangenen Beschluss des Rates der Geschäftsführer festgesetzt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen des Rates der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer

mittels einer schriftlich, per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), per Fax oder durch ein vergleichbares Kommuni-
kationsmittel erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares

Kommunikationsmittel teilnehmen, das den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung untereinander
erlaubt. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Rat der Geschäftsführer ist nur beschlussfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer bei einer Sitzung

anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder

vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die

Zustimmung schriftlich, per E-Mail oder Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Diese
werden schriftlich bestätigt, so dass die Gesamtheit der Unterlagen das Protokoll bilden, das dem Nachweis der Be-
schlussfassung dient.

Art. 13. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei
Geschäftsführern oder von einer durch den Rat der Geschäftsführer zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.

Art. 14. Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die

Auflösung der Gesellschaft.

Art. 15. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen

der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als
solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen

teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

Art. 17. Wirksam gefasste Entscheidungen bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche

zumindest die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

108226

Jede andere Änderung der Satzung bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei

Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 18. Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß

Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung aus.

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 20. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Geschäftsführer oder der

Rat der Geschäftsführer erstellt ein Inventar, das Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der
Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 21. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn

Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht der Hauptversammlung der Gesellschafter
zur freien Verfügung. Der Rat der Geschäftsführer kann entscheiden, Abschlagsdividenden auszuzahlen.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 22. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung der Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Hauptver-
sammlung bestimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Die Abwickler haben die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung
der Vermögenswerte und zur Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Überschuss, der aus der Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesell-

schaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesellschaftskapital aufgeteilt.

Art. 23. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Fragen gilt ergänzend das Gesetz vom 10. August 1915 über Han-

delsgesellschaften in seiner geänderten Fassung.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Alle einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile werden durch FREO GERMANY II PARTNERS (SCA) SICAR, vorgenannt,

gezeichnet.

Alle Anteile werden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen

Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dies dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007;

<i>Gründungskosten

Der Gründer schätzt die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger

Gründung erwachsen, auf ungefähr zweitausendzweihundert (2.200,- EUR) Euro.

<i>Beschlüsse

Sodann fasst die FREO GERMANY II PARTNERS (SCA) SICAR, die das gesamte Kapital vertritt, folgende Beschlüsse:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
2. Zu Geschäftsführern für eine unbeschränkte Dauer der Gesellschaft werden ernannt:
Als Geschäftsführer der Kategorie A:
- Matthias Luecker, Geschäftsführer, wohnhaft in Kiefernweg 21, 64390 Erzhausen, Germany
- Oliver Brazier, Geschäftsführer, mit Berufsadresse in 67, rue Ermersinde, L - 1469 Luxemburg
- Brigitte Petermann-Rack, Rechtsanwältin, mit Berufsadresse in Taunusanlage 21, 60325 Frankfurt am Main, Germany.
Als Geschäftsführer der Kategorie B:
- Robert Faber, geprüfter Buchhalter, mit Berufsadresse in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg,
- Charles Meyer, geprüfter Buchhalter, mit Berufsadresse in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg,
- Alain Heinz, geprüfter Buchhalter, mit Berufsadresse in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der deutschen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Vertreters der vor-

genannten Partei diese Urkunde in deutschen Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in englischer Sprache.
Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die deutsche Fassung maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter der Erschienenen, hat dieser mit dem Notar

gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Folgend die englische Übersetzung des vorhergenden Textes:

In the year two thousand and seven, on the twenty-fourth of July.
Before the undersigned Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,

108227

There appeared:

FREO GERMANY II PARTNERS (SCA) SICAR a company duly incorporated ad existing under the laws of Luxembourg,

registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 123.906, and having its registered office
at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg,

here represented by Christopher Dortschy, residing professionally in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on the 10th of July.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of incorporation
of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. The Company will be incorporated under the name of ZULU II S.àr.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general

meeting of its shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through resolution of the
manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg
or abroad through resolution of the manager or the board of managers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by one

hundred twenty-five (125) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion
to the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders. They may be

elected as catagory A and category B managers.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

108228

In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any Category A

manager and any Category B manager or by the sole signature of any person to whom such signatory power shall be
delegated by the board of managers.

Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and

may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-

holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting by electronic mail (without electronic signature), except in case of emer-
gency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be
omitted  in  case  of  assent  of  each  manager  in  writing,  by  electronic  mail  or  facsimile,  or  any  other  similar  means  of
communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by electronic mail (without

electronic signature) or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 18. If the Company has only one shareholder, such sole shareholder exercises the powers granted to the general

meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 19. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 20. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. The board of
managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

108229

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

All of the one hundred twenty-five (125) shares are subscribed by FREO GERMANY II PARTNERS (SCA) SICAR,

aforementioned.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of December

2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately two thousand two hundred (2,200.-) euros.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, FREO GERMANY II PARTNERS (SCA) SICAR, passed the fol-

lowing resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
2. The sole shareholder resolves to elect as managers of the company for an indefinite period:
- Mr Matthias Luecker, company manager, residing in D-64390 Erzhausen, Germany, Category A manager
- Mr Oliver Brazier, company manager, residing professionally at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, Category A

manager

- Mrs Brigitte Petermann-Rack, attorney at law, residing professionally at Taunusanlage 21, D-60325 Frankfurt am Main,

Germany, Category A manager

- Mr Robert Faber, chartered accountant, residing professionally in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

Category B manager

- Mr Charles Meyer, chartered accountant, residing professionally 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

Category B manager;

- Mr Alain Heinz, chartered accountant, residing professionally in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

Category B manager

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

party, this deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, said proxyholder appearing signed

together with the notary the present deed.

Gezeichnet: C. Dortschy, J. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, LAC/2007/20135. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Sandt.

Für gleichlautende ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 27. August 2007.

J. Baden.

Référence de publication: 2007107084/7241/319.
(070122072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2007.

Central Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 78.416.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

108230

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108693/802/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04444. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Davlani S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 56.531.

<i>Résolutions prises lors de l'assemblée générale du 26 mars 2007

1. les actionnaires révoquent Madame Ingrid Hoolants de son poste d'administrateur avec effet au 15 mars 2007;
2. les actionnaires décident de nommer Monsieur Michal Wittmann, résidant professionnellement 1, rue Goethe,

L-1637 Luxembourg, comme administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de
l'an 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108696/777/16.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2007, réf. LSO-CH08307. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070123730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2007.

Cedef S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 35, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 78.712.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108697/802/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04447. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Color-Center Lucien Steinhäuser, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 262-266, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 33.948.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 14 septembre 2007.

<i>Pour COLOR-CENTER LUCIEN STEINHÄUSER s.à r.l.
J. Reuter

Référence de publication: 2007108647/517/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04325C. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Mobilop S.A., Société Anonyme,

(anc. Eischen-Immobilière S.à r.l.).

Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 2, avenue Dr Klein.

R.C.S. Luxembourg B 88.461.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

108231

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108684/510/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2007, réf. LSO-CI03271. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Joco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 2, avenue Dr. Klein.

R.C.S. Luxembourg B 27.664.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108686/510/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2007, réf. LSO-CI03272. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070124078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

BATI CV S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 11, rue des Bois.

R.C.S. Luxembourg B 110.493.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108690/510/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2007, réf. LSO-CI03290. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Distrisport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, Zone Industrielle rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 60.579.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108692/510/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2007, réf. LSO-CI03293. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Cedef S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 35, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 78.712.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108698/802/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04451. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

108232

Cedef S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 35, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 78.712.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108700/802/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04459. - Reçu 36 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070124089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Assumption Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 124.439.

<i>Résolutions prises lors de l'assemblée générale du 26 mars 2007

1. les actionnaires révoquent Madame Ingrid Hoolants de son poste d'administrateur avec effet au 15 mars 2007;
2. les actionnaires décident de nommer Monsieur Michal Wittmann, résidant professionnellement 1, rue Goethe,

L-1637 Luxembourg, comme administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de
l'an 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108699/777/16.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2007, réf. LSO-CH08501. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070123728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2007.

Sevres I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 119.774.

In the year two thousand and seven, on the eighth day of January,
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared KKR EUROPEAN FUND II, Limited Partnership, represented by M 

e

 Toinon Hoss pursuant to a proxy

dated of January 2 007, being the sole holder of shares of SEVRES I S.àr.l. (the «Company»), a société à responsabilité
limitée having its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, incorporated on 22nd of September
2 006 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C-2096 of 9 November 2 006 and whose articles
have been amended last by virtue of a deed of the undersigned notary of 9 October 2006 published in the Mémorial
C-2265 of 5 December 2006.

The appearing party declared and requested the notary to record that:
I. The sole member holds all one hundred and seven thousand and seventy (107,070) shares in issue in the Company,

so that decisions can validly be taken on all the items of the agenda.

II. The agenda of the meeting was as follows:
1. Increase of the issued share capital of the Company to two millions seven hundred sixty one thousand five hundred

and seventy-five euro (€ 2,761,575.-) by the issue of three thousand three hundred and ninety-three (3,393) new shares
each with a nominal value of twenty-five euro (€ 25.-); subscription to such new shares by the sole shareholder of the
Company and payment by way of a contribution in kind of a receivable due by the Company to its sole shareholder for
an amount of eighty-four thousand eight hundred and twenty-five euro (€ 84,825.-); acknowledgement of the report of
the board of managers on the valuation of the contribution in kind; approval of the valuation and issue of new shares;
allocation of eighty-four thousand eight hundred and twenty-five euro (€ 84,825.-) to the share capital of the Company.

2. Consequential amendment of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the decision

taken under item 1 of the agenda.

Thereafter the following decisions were taken:

108233

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued share capital of the Company to two millions seven hundred sixty-one thousand

five hundred and seventy-five euro (€ 2,761,575.-) by the issue of three thousand three hundred and ninety-three (3,393)
new shares each with a nominal value of twenty-five euro (€ 25.-).

Thereupon the sole shareholder of the Company subscribed to all such new shares and paid such new shares through

a contribution in kind of part of a receivable due by the Company to its sole shareholder for an amount of eighty-four
thousand eight hundred and twenty-five euro (€ 84,825.-) and waiver of any payment rights thereunder.

The report of the board of managers of the Company on the valuation of the contribution in kind is acknowledged.
The conclusion of said report reads as follows:
«The Board of Managers believes that the value of the contribution in kind being the Receivable due by the Company

to the contributor amounts to eighty-four thousand eight hundred and twenty-five euro (€ 84,825.-).»

It is decided to valuate the contribution in kind at eighty-four thousand eight hundred and twenty-five euro (€ 84,825.-).
It is decided to issue three thousand three hundred and ninety-three (3,393) new shares each with a nominal value of

twenty five euro (€ 25.-) and to allocate eighty-four thousand eight hundred and twenty-five euro (€ 84,825.-) to the
share capital of the Company.

Proof of the contribution in kind has been shown to the undersigned notary.

<i>Second resolution

In consequence to the prior resolution it is resolved to amend article 5 of the articles of incorporation to be read as

follows:

«The issued share capital of the Company is set at two millions seven hundred sixty-one thousand five hundred and

seventy-five euro (€ 2,761,575.-) divided into one hundred ten thousand four hundred and sixty-three (110,463) with a
nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner

required for amendment of these articles of association.

Any available share premium shall be distributable.»
There being no further business on the agenda the meeting was closed.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at two thousand Euro.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le huitième jour du mois de janvier,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,

A comparu KKR EUROPEAN FUND II, Limited Partnership, représentée par M 

e

 Toinon Hoss, en vertu d'une pro-

curation datée du janvier 2 007, le détenteur unique de toutes les parts sociales de SEVRES I S.àr.l. (la «Société»), une
société à responsabilité limitée ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, constituée le 22
septembre 2006 par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C-2096 du 9 novembre 2006 et dont les statuts ont
été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné du 9 octobre 2006 publié au Mémorial C-2265 du 5
décembre 2006.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. L'associé unique détient toutes les cent sept mille soixante-dix (107.070) parts sociales émises dans la Société, de

sorte que les décisions peuvent être valablement adoptées sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II. L'ordre du jour était le suivant:
1. Augmentation du capital social émis de la Société à deux millions sept cent soixante et un mille cinq cent soixante-

quinze Euros (€ 2.761.575,-) par l'émission de trois mille trois cent quatre-vingt-treize (3.396) nouvelles parts sociales
ayant une valeur nominale chacune de vingt-cinq Euros (€25,-); souscription de ces nouvelles parts sociales par l'associé
unique de la Société et paiement par apport en nature d'une créance payable par la Société à son associé unique pour un
montant de quatre vingt quatre mille huit cent vingt-cinq Euros (€ 84.825,-); lecture du rapport du conseil de gérance
sur l'évaluation de l'apport en nature; approbation de l'évaluation et de l'émission des nouvelles parts sociales; allocation
de quatre vingt quatre mille huit cent vingt-cinq Euros (€ 84.825,-) au capital social de la Société.

2. Modification conséquente de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter la décision prise sous le point 1 de

l'ordre du jour.

A la suite de quoi, les résolutions suivantes ont été prises:

108234

<i>Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social émis de la Société à deux millions sept cent soixante et un mille cinq cent

soixante-quinze Euros (€ 2.761.575,-) par l'émission de trois mille trois cent quatre-vingt-treize (3.393) nouvelles parts
sociales ayant une valeur nominale chacune de vingt-cinq Euros (€ 25,-).

A la suite de quoi l'associé unique de la Société a souscrit à toutes ces nouvelles parts sociales et a payé ces nouvelles

parts sociales par un apport en nature d'une partie d'une créance payable par la Société à son associé unique pour un
montant de quatre-vingt-quatre mille huit cent vingt-cinq Euros (€ 84.825,-) et une renonciation à tous droits à paiement
y relatifs.

Le rapport du conseil de gérance de la Société sur l'évaluation de l'apport en nature a été lu.
La conclusion de ce rapport est la suivante:
«Le Conseil de Gérance estime que la valeur de l'apport en nature, représentant la Créance payable par la Société à

l'apporteur s'élève à quatre-vingt-quatre mille huit cent vingt-cinq Euros (€ 84.825,-).»

Il est décidé d'évaluer l'apport en nature à quatre-vingt-quatre mille huit cent vingt-cinq Euros (€ 84.825,-).
Il est décidé d'émettre trois mille trois cent quatre-vingt-treize (3.393) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale

de vingt-cinq Euros (€ 25,-) chacune et d'allouer quatre-vingt-quatre mille huit cent vingt-cinq Euros (€ 84.825,-) au capital
social de la Société.

Preuve de l'apport en nature a été montrée au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 5 des statuts afin qu'il ait la teneur

suivante:

«Le capital social émis de la Société est fixé à deux millions sept cent soixante et un mille cinq cent soixante-quinze

Euros (€ 2.761.575,-) divisé en cent dix mille quatre cent soixante-trois (110.463) parts sociales d'une valeur nominale
de vingt-cinq Euros (€ 25,-) chacune.

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise

pour la modification des présents Statuts.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour l'assemblée a été déclarée terminée.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent

acte sont évaluées à environ deux mille Euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais a constaté qu'à la demande des parties, le présent acte est rédigé

en anglais suivi par une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes parties, en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Signé: T. Hoss, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, vol. 31cs, fol. 58, case 11. — Reçu 848,25 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 16 février 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007107023/242/122.
(070122452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2007.

B.F. Promotions S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 80.309.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2007.

BF PROMOTIONS sàrl
Signature

Référence de publication: 2007108710/1044/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2007, réf. LSO-CI02164. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

108235

Sofindex, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 43.380.

<i>Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 31 août 2007

Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

L'adresse professionnelle des administrateurs est modifiée comme suit:
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue Char-

les de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007108712/534/22.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2007, réf. LSO-CI01297. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070123507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2007.

Transport Ksibi&amp;PF S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5401 Ahn, 5, rue des Vignes.

R.C.S. Luxembourg B 117.471.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ahn, le 17 septembre 2007.

TRANSPORT KSIBI &amp; PF s.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007108711/1044/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2007, réf. LSO-CH04432. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

C.V.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 79.827.

<i>Résolutions prises lors de l'assemblée générale du 26 mars 2007

1. les actionnaires révoquent Madame Ingrid Hoolants de son poste d'administrateur avec effet au 15 mars 2007;
2. les actionnaires décident de nommer Monsieur Michal Wittmann, résidant professionnellement 1, rue Goethe,

L-1637 Luxembourg, comme administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de
l'an 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108708/777/16.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2007, réf. LSO-CH08347. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070123724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2007.

108236

Nic. Zeien Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4410 Soleuvre, Z.A. Um Woeller.

R.C.S. Luxembourg B 20.502.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Soleuvre, le 17 septembre 2007.

NIC. ZEIEN sàrl
Signature

Référence de publication: 2007108709/1044/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2007, réf. LSO-CI02167. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070124329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Easy Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3918 Mondercange, 1, rue d'Ehlerange.

R.C.S. Luxembourg B 103.571.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondercange, le 17 septembre 2007.

EASY SOLUTIONS s.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007108713/1044/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2007, réf. LSO-CH04433. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Web Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 459, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 77.431.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108706/3130/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2007, réf. LSO-CI03712. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Leger S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4880 Lamadelaine, 53, rue des Près.

R.C.S. Luxembourg B 39.277.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Lamadelaine, le 17 septembre 2007.

LEGER sàrl
Signature

Référence de publication: 2007108707/1044/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2007, réf. LSO-CI02168. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

108237

Sofipar PME, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 117.536.

<i>Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 31 août 2007

Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

L'adresse professionnelle des administrateurs est modifiée comme suit:
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue Char-

les de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007108714/534/22.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2007, réf. LSO-CI01299. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070123506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2007.

Costa Del Sol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 59.085.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108793/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2007, réf. LSO-CI02480. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070123217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2007.

Teekay Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 150.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 100.277.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108786/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2007, réf. LSO-CI02463. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070123224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2007.

Frebela S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 56.959.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

108238

Luxembourg, le 13 septembre 2007.

<i>Pour FREBELA S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
L. Heck / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2007108785/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2007, réf. LSO-CI02364. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Frebela S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 56.959.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2007.

<i>Pour FREBELA S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
L. Heck / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2007108787/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2007, réf. LSO-CI02362. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Valma S.A., Société Anonyme,

(anc. Luxarbanne S.A.).

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 112.496.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2007.

<i>Pour VALMA S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
L. Heck / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2007108788/1017/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2007, réf. LSO-CI02359. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Frebela S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 56.959.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2007.

<i>Pour FREBELA S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
L. Heck / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2007108784/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2007, réf. LSO-CI02368. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

108239

Finimpex S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 19.076.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2007.

<i>Pour FINIMPEX S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
L. Heck / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2007108783/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2007, réf. LSO-CI02384. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070124033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Corneille S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 121.242.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2007.

<i>Pour CORNEILLE S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
L. Heck / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2007108782/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2007, réf. LSO-CI02388. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

George Forrest Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 47.479.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108799/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2007, réf. LSO-CI02207. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Européenne de Participations et de Signalisation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 75.916.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007108797/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2007, réf. LSO-CI01589. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070124060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

108240


Document Outline

2000 Volts

Arbre Mondial Holdings S.A.

Assumption Finances S.A.

BATI CV S.àr.l.

B.F. Promotions S.à.r.l.

Cedef S.A.

Cedef S.A.

Cedef S.A.

Central Properties S.A.

Christa Intershipping S.à.r.l.

Color-Center Lucien Steinhäuser

Comptoir Technique et Industriel S.A.

Corneille S.A.

Costa Del Sol S.A.

C.V.S. S.A.

Davlani S.A.

Distrisport S.à r.l.

Easy Solutions S.à r.l.

Eischen-Immobilière S.à r.l.

Etablissement Rolux S.à r.l.

Europäische Beteiligungsgesellschaft A.G.

Européenne de Participations et de Signalisation S.A.

Finimpex S.A.

Fondation Kannerschlass

Frebela S.A.

Frebela S.A.

Frebela S.A.

F.T.F. Holding S.A.

Genpact Global Holdings SICAR S.à r.l.

Genpact Global Holdings SICAR S.à r.l.

George Forrest Holding

Good Energies Investments (Luxembourg) S.à r.l.

Ideal Standard International Holding

Isoletanche S.A.

Joco S.à r.l.

Leger S.àr.l.

Little Smets

Luxarbanne S.A.

Mic Cargo S.à r.l.

Mobilop S.A.

Nic. Zeien Sàrl

Sevres I S. à r.l.

Smets Gallery S.à r.l.

Sofindex

Sofipar PME

Teekay Luxembourg S.à r.l.

Transport Ksibi&amp;PF S.àr.l.

United in Sports Management S.à r.l.

Valbella S.A.

Valma S.A.

Vintners S.à r.l.

Web Technologies S.A.

Zulu II S.à r.l.