logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2115

27 septembre 2007

SOMMAIRE

Abundancia de Vida S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

101482

Adjutoris Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101502

Amberlux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101512

Banque Privée Edmond de Rothschild Eu-

rope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101474

Banque Privée Edmond de Rothschild Eu-

rope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101490

Banque Privée Edmond de Rothschild Eu-

rope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101502

Bantleon Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101499

Belux Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101516

Cafco International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

101514

CEP II Co-Investment S.à r.l. SICAR  . . . . .

101491

CEP II Participations S.à r.l. SICAR  . . . . . .

101490

CeraTech S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101503

CeraTech S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101512

Compagnie d'Uzaru  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101481

CVI GVF Luxembourg Six S.à r.l.  . . . . . . . .

101475

Dexamenos Développement  . . . . . . . . . . . .

101512

Dusseldorf Arcaden Luxco  . . . . . . . . . . . . . .

101516

Düsseldorf/Wilmersdorfer Arcaden . . . . . .

101517

Electricité du Grand Duché de Luxem-

bourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101500

Everyday Media S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101515

Générale Alimentaire Franco-Luxembour-

geoise S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101513

Générale Alimentaire Franco-Luxembour-

geoise S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101502

Geosite C Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101474

Geosite LM Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101474

GTA 2 S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101516

GTC S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101516

GVI GVF Luxembourg Eight S.à r.l. . . . . . .

101483

Humboldt Multi Invest Management Com-

pany S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101499

IKO 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101482

ILAWA Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

101483

ILP III Participations S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

101483

Independance et Expansion SICAV  . . . . . .

101519

Ivanhoe Europe Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . .

101519

Ivanhoe Europe Equities  . . . . . . . . . . . . . . . .

101518

J. Hirsch & Co International  . . . . . . . . . . . . .

101520

Lombard Odier Darier Hentsch Selective

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101520

LSF4 Mega Investments II S.àr.l. . . . . . . . . .

101491

Media Tele S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101514

Medrom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101515

M. Organisation S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

101516

MSREF VI Spirit S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

101516

Nomura Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101512

Opus Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

101501

Parfood Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101475

Paunsdorf Centre Luxco  . . . . . . . . . . . . . . . .

101518

Paunsdorf/Zwickau Arcaden  . . . . . . . . . . . .

101517

Power Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

101500

Prinus Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101515

Ryburton Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101482

Traction S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101519

Venus Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101501

Weinberg Real Estate S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

101503

Wilmersdorfer Arcaden Luxco  . . . . . . . . . .

101518

Zwickau Arcaden Luxco  . . . . . . . . . . . . . . . .

101517

101473

Geosite C Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 127.719.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 29 mai 2007

L'assemblée générale extraordinaire a pris acte de la démission de:
- Madame Samia Rabia, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, et de
- Monsieur Pii Ketvel, demeurant à L-1479 Luxembourg, 1, Kansallis House - place de l'Etoile,
de leurs fonctions de gérants avec effet au 29 mai 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007100933/280/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06540. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070113680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Geosite LM Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 127.722.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 29 mai 2007

L'assemblée générale extraordinaire a pris acte de la démission de:
- Madame Samia Rabia, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, et de
- Monsieur Pii Ketvel, demeurant à L-1479 Luxembourg, 1, Kansallis House - place de l'Etoile,
de leurs fonctions de gérants avec effet au 29 mai 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007100934/280/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06538. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 19.194.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg le 10 avril 2007

<i>Quatrième résolution

A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de réélire en tant qu'administrateurs pour un terme d'un an expirant à

l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008:

- Baron Benjamin de Rothschild,
- Messieurs John Alexander, Luc Baatard, Laurent Dassault, José Luis de Vasconcelos e Sousa, Guy Grymberg, Claude

Messulam, Frédéric Otto, E. Trévor Salathé et Daniel Yves Trèves.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 15 mai 2007.

L. Gregoire / F. Otto
<i>Secrétaire Général / Administrateur - Directeur Général

Référence de publication: 2007100951/10/20.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2007, réf. LSO-CF00895. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070114054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

101474

Parfood Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 62.532.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 4 juillet

<i>2007

Monsieur Alexis De Bernardi, Monsieur Rossi Jacopo et Monsieur Donati Régis sont renommés administrateurs pour

une nouvelle période d'un an. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>PARFOOD INVEST S.A.
J. Rossi / R. Donati
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007100935/545/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05531. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070113711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

CVI GVF Luxembourg Six S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 130.765.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-fourth of July.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies' register under the number B 119.271,

duly represented by Mr Pierre-Yves Genot, licencié en droit, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 16 July

2007.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here above stated capacity, has drawn up the following articles of incorporation of

a société à responsabilité limitée which it declares organized as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incor-
poration.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and loans and the administration, control
and development of its portfolio.

The Company may act as a general partner and manager of partnerships or similar corporate structures with unlimited

liability for all debts and obligations of such entities.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company is incorporated under the name of CVI GVF LUXEMBOURG SIX S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means

101475

of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality
may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos,

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.
In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.

The manager(s) is/are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the

term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as
the case may be, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings

101476

or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute
grave) or wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.

Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Collective decisions of the shareholders - Decisions of the sole shareholder

Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 20. The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's financial year commences on the first of June and ends on the thirty-first of May.

Art. 22. Each year on the thirty-first of May, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5 %) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10 %) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole
shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators
shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company have been subscribed by CVI GVF (LUX) MASTER

S.à r.l., as aforementioned, paid up by a contribution in cash for an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), entirely allocated to the share capital.

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is

as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

101477

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 May

2008.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which are to be borne by the Company or

which shall be charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred
Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period of time:
- Mr Gregor Klaedtke, born on 10 January 1965 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing professionally

at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Mr Hille-Paul Schut, lawyer, born on 29 September 1977 in's-Gravenhage, the Netherlands, residing professionally

at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, den vierundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großherzogtums

Luxemburg, mit Sitz 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels -und Gesellschafts-
register unter Nummer B 119271,

hier vertreten durch Herrn Pierre-Yves Genot, licencié en droit, wohnhaft in Luxemburg aufgrund einer privatschrift-

lichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 16 Juli 2007.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine  Gesellschaft mit beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend  die  «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtli-

chen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung CVI GVF LUXEMBOURG SIX S.à r.l.

101478

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter oder gegebenenfalls des alleinigen Gesellschafters an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxem-
burg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäfts-
führers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden. Niederlassungen oder andere Fillialen können entweder entweder
in Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in zwölftausendfünf-

hundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese

Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss, oder gegebenenfalls der Zustimmung des alleinigen Gesellschafters.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die die Miteigentümer gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der

Gesellschaft.

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-

genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern oder gegebenenfalls von dem alleinigen Gesellschafter ernannt.

Die Gesellschafter oder der alleinige Gesellschafter bestimmen auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer
können jederzeit, ohne dass ein berechtigter Grund («cause légitime») hierzu bestehen muss, von den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Der Geschäftsführerrat wird durch jedes seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort

einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle

101479

anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern oder von einer vom Geschäftsführerrat bevollmächtigten Person unterzeichnet.

Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-

sellschaft nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer oder jedes Geschäftsführerratsmitglied und seine Erben, Nach-

lassverwalter und Verwalter für Ausgaben, die vernünftigerweise in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit, einer Klage
oder Verfahren entstanden sind, zu welchem er aufgrund seiner Stellung als gegenwärtiger oder ehemaliger Geschäfts-
führer der Gesellschaft oder jeder anderen Körperschaft von der er nicht berechtigt ist Entschädigung zu erhalten, Partei
geworden ist. Dies gilt nicht in Verbindung mit Angelegenheiten bei denen letztendlich auf eine schwere Pflichtverletzung
(faute grave) oder eine vorsätzliche Pflichtverletzung (faute intentionnelle) erkannt wurde. Für den Fall einer Vereinbarung
soll eine Entschädigung nur für solche Angelegenheiten gezahlt werden, die von der Vereinbarung gedeckt sind, sofern
die Gesellschaft von einem rechtlichen Beistand darüber informiert wurde, dass die zu entschädigenden Person keine
Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht auf Entschädigung soll nicht die Geltendmachung anderer Rechte
zu der die Person berechtigt ist, ausschliessen.

Art. 17. Die Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat können sich dazu entschliessen Zwischendividenden auf der

Grundlage eines Rechenschaftsberichts, der von einem Geschäftsführer oder dem Geschäftsführerrat vorbereitet wird
und aufzeigt dass genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, auszuschütten, wobei der auszuschüttende Betrag nicht
die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Rechnungsjahres überschreiten darf. Der Betrag erhöht sich durch fort-
getragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, jedoch verringert er sich durch fortgetragene Verluste und Beträge die
einer Kapitalrücklage zugeführt werden, welche gemäss dem Gesetz oder dieser Satzung zu bilden ist.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 19. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel

des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 20. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

E. Geschäftsjahr - Konten- Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Juni eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Mai desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Mai jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer

stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder
Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. Zwischendi-
videnden werden in Einklang mit den gesetzlich vorgesehen Bedingungen zugeteilt.

101480

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  oder
gegebenfalls der alleinige Gesellschafter legt die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Es sei denn es ist etwas
anderes vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der
Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

oder dem alleinigen Gesellschafter im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile wurden von CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., vorgenannt,

gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über ein Gesell-

schaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Mai 2008.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

ein tausend drei hundert Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 25B, rue boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt:
- Mr Gregor Klaedtke, geboren am 10. Januar 1965 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in 25B, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg; und

- Mr Hille-Paul Schutt, Rechtsanwalt, geboren am 29. September 1977 in s-Gravenhage, die Niederlanden, beruflich

wohnhaft in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: P.-Y. Genot, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, Relation: LAC/2007/19708. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007100140/211/349.
(070113051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Compagnie d'Uzaru, Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 94.612.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 45084 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007101001/211/11.
(070114210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

101481

IKO 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 123.068.

<i>Ex

<i>11 juillet 2007

La date de clôture du premier exercice social de la société a été modifiée du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2007.

Pour extrait sincère et conforme
<i>IKO 2 S.A.
J.-M. Heitz / R. Donati
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007100936/545/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007, réf. LSO-CH04803. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070113713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Abundancia de Vida S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 127.603.

<i>Extrait du contrat de cession de parts signé le 27 mars 2007

En vertu de l'acte de cession de parts du 27 mars 2007
M. William Ayyad, demeurant à 16156 Valle de Oro, CA - 92067 Rancho Santa Fe, USA a transféré 250 parts sociales

détenues dans la Société à

IFI EQUITIES LLC, une société établie et ayant son siège social à 10940 S. Parker RD PMB # 323, 80134 Parker Co,

USA

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA
Signatures

Référence de publication: 2007100938/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007, réf. LSO-CH05065. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Ryburton Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 40.147.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 22 juin 2007 à Luxembourg

L'Assemblée décide d'accepter la démission de M. Emile Schneider, Maison 41, L-9762 Lullange de son poste d'Admi-

nistrateur.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d'Administrateur M. Etienne Gillet, 3B, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2009.
L'Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Guy Glesener au 36, rue Frantz Seimetz, L-2531 Luxem-

bourg.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007100961/3842/20.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2007, réf. LSO-CH01864. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

101482

ILAWA Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 116.903.

<i>Extrait du contrat de cession de parts signé le 4 juin 2007

En vertu de l'acte de cession de parts du 4 juin 2007,
M. Jan Smólski, demeurant à Pl. Wilsona 4/71, PL 01-626 Warsaw, Pologne, a transféré 53 parts ordinaires détenues

dans la Société à

KARMALINAR LIMITED, une société établie et ayant son siège social à 48 Themistokli Dervi, Centennial Building, 7th

Floor, Flat/Office 701, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus.

Luxembourg, le 31 juillet 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA
Signatures

Référence de publication: 2007100939/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05678. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070113724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

ILP III Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.559.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 25 juillet 2007

Il résulte des décisions de l'assemblée générale de la Société du 25 juillet 2007:
- que l'assemblée a accepté les démissions de:
- M. John F. Harris, né le 29 avril 1960 à Washington D.C., Etats-Unis, et de
- M. William Conway, né le 27 août 1949 à Massachusetts, Etats-Unis,
de leurs fonctions de membre du conseil de gérance de la Société avec effet au 25 juillet 2007.
- que l'assemblée a nommé:
- CEP III LIMITED, avec adresse à Walker House, 87 St Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-Q001, Iles

Caïmans, et

- David Pearson, de nationalité américaine, né le 13 décembre 1968 à Washington D.C., Etats-Unis, avec adresse

professionnelle 1001 Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington, DC 20004-2505, Etats-Unis,

comme nouveaux membres du conseil de gérance de la Société avec effet au 25 juillet 2007 et pour une période

indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2007.

<i>ILP III PARTICIPATIONS S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007100941/5480/27.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05757. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

GVI GVF Luxembourg Eight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 130.766.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-fourth of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

there appeared:

101483

CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies' register under the number B 119.271,

duly represented by Mr Pierre-Yves Genot, licencié en droit, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 16 July

2007.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here above stated capacity, has drawn up the following articles of incorporation of

a société à responsabilité limitée which it declares organized as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incor-
poration.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and loans and the administration, control
and development of its portfolio.

The Company may act as a general partner and manager of partnerships or similar corporate structures with unlimited

liability for all debts and obligations of such entities

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company is incorporated under the name of CVI GVF LUXEMBOURG EIGHT S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means
of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality
may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each. Each share is entitled to one vote at
ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos,

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.
In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.

101484

The manager(s) is/are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the

term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as
the case may be, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting. Written notice of any
meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in advance of the date foreseen
for  the  meeting,  except  in  case  of  emergency,  in  which  case  the  nature  and  the  motives  of  the  emergency  shall  be
mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex
or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting
to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate
or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. The board of
managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram,
telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company.

They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute
grave) or wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.

Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Collective decisions of the shareholders - Decisions of the sole shareholder

Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 20. The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

101485

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's financial year commences on the first of June and ends on the thirty-first of May.

Art. 22. Each year on the thirty-first of May, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole
shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators
shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company have been subscribed by CVI GVF (LUX) MASTER

S.à r.l., as aforementioned, paid up by a contribution in cash for an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), entirely allocated to the share capital.

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is

as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 May

2008.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which are to be borne by the Company or

which shall be charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred
Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period of time:
- Mr Gregor Klaedtke, born on 10 January 1965 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing professionally

at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Mr Hille-Paul Schut, lawyer, born on 29 September 1977 in 's-Gravenhage, the Netherlands, residing professionally

at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Es folgt die Deutsche Übersetzung des Englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, den vierundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großherzogtums

Luxemburg, mit Sitz 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels -und Gesellschafts-
register unter Nummer B 119271,

101486

hier vertreten durch Herrn Pierre-Yves Genot, licencié en droit, wohnhaft in Luxemburg aufgrund einer privatschrift-

lichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 16 Juli 2007.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend  die  «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtli-

chen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung CVI GVF LUXEMBOURG EIGHT S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter oder gegebenenfalls des alleinigen Gesellschafters an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxem-
burg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäfts-
führers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden. Niederlassungen oder andere Fillialen können entweder entweder
in Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in zwölftausendfünf-

hundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese

Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss, oder gegebenenfalls der Zustimmung des alleinigen Gesellschafters.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an.
Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen eine Person ernennen, die die Miteigentümer gegenüber der Gesellschaft

vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der

Gesellschaft.

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-

genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

101487

Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern oder gegebenenfalls von dem alleinigen Gesellschafter ernannt.

Die Gesellschafter oder der alleinige Gesellschafter bestimmen auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer
können jederzeit, ohne dass ein berechtigter Grund («cause légitime») hierzu bestehen muss, von den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Der Geschäftsführerrat wird durch jedes seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort

einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst. Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch
Rundschreiben mittels einer oder mehrere schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommu-
nikationsmittel  belegter  Unterlagen  gefasst  werden,  unter  der  Bedingung,  dass  solche  Beschlüsse  schriftlich  bestätigt
werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern oder von einer vom Geschäftsführerrat bevollmächtigten Person unterzeichnet.

Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-

sellschaft nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer oder jedes Geschäftsführerratsmitglied und seine Erben, Nach-

lassverwalter und Verwalter für Ausgaben, die vernünftigerweise in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit, einer Klage
oder Verfahren entstanden sind, zu welchem er aufgrund seiner Stellung als gegenwärtiger oder ehemaliger Geschäfts-
führer der Gesellschaft oder jeder anderen Körperschaft von der er nicht berechtigt ist Entschädigung zu erhalten, Partei
geworden ist. Dies gilt nicht in Verbindung mit Angelegenheiten bei denen letztendlich auf eine schwere Pflichtverletzung
(faute grave) oder eine vorsätzliche Pflichtverletzung (faute intentionnelle)erkannt wurde. Für den Fall einer Vereinbarung
soll eine Entschädigung nur für solche Angelegenheiten gezahlt werden, die von der Vereinbarung gedeckt sind, sofern
die Gesellschaft von einem rechtlichen Beistand darüber informiert wurde, dass die zu entschädigenden Person keine
Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht auf Entschädigung soll nicht die Geltendmachung anderer Rechte
zu der die Person berechtigt ist, ausschliessen.

Art. 17. Die Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat können sich dazu entschliessen Zwischendividenden auf der

Grundlage eines Rechenschaftsberichts, der von einem Geschäftsführer oder dem Geschäftsführerrat vorbereitet wird
und aufzeigt dass genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, auszuschütten, wobei der auszuschüttende Betrag nicht
die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Rechnungsjahres überschreiten darf. Der Betrag erhöht sich durch fort-

101488

getragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, jedoch verringert er sich durch fortgetragene Verluste und Beträge die
einer Kapitalrücklage zugeführt werden, welche gemäss dem Gesetz oder dieser Satzung zu bilden ist.

D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 19. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel

des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 20. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Juni eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Mai desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Mai jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer

stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder
Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. Zwischendi-
videnden werden in Einklang mit den gesetzlich vorgesehen Bedingungen zugeteilt.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  oder
gegebenfalls der alleinige Gesellschafter legt die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Es sei denn es ist etwas
anderes vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der
Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

oder dem alleinigen Gesellschafter im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile wurden von CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., vorgenannt,

gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über ein Gesell-

schaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Mai 2008.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

ein tausend drei hundert Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 25B, rue Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt:
- Mr Gregor Klaedtke, geboren am 10. Januar 1965 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in 25B, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg; und

- Mr Hille-Paul Schutt, Rechtsanwalt, geboren am 29. September 1977 in s-Gravenhage, die Niederlanden, beruflich

wohnhaft in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

101489

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend. Nach Vorlesung
und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P.-Y. Genot, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, Lac/2007/19710. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 9 août 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007100139/211/347.
(070113052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

CEP II Participations S.à r.l. SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Inves-

tissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 96.017.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 31 juillet 2007

Il résulte des décisions de l'assemblée générale annuelle de la Société du 31 juillet 2007:
- que l'assemblée a accepté la démission de:
- M. John F. Harris, né le 29 avril 1960 à Washington D.C., Etats-Unis, et de
- M. William Conway, né le 27 août 1949 à Massachusetts, Etats-Unis,
de leurs fonctions de membre du conseil de gérance de la Société avec effet au 30 juillet 2007.
- que l'assemblée a nommé CEP II LIMITED avec adresse à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand

Cayman, KY1-Q001, Iles Caïmans, comme nouveau membre du conseil de gérance de la Société avec effet au 31 juillet
2007 et pour une période illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2007.

<i>CEP II PARTICIPATIONS S.à r.l. SICAR
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007100942/5480/24.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05745. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 19.194.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 7 mars 2007 à Luxembourg

2.3 Réviseur d'Entreprises: PricewaterhouseCoopers S.à.r.l.
Il décide... de renouveler son mandat de réviseur de la Banque pour un nouveau terme d'une année.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2007.

L. Gregoire / F. Otto
<i>Secrétaire Général / Administrateur - Directeur Général

Référence de publication: 2007100952/10/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2007, réf. LSO-CH07121. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070114054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

101490

CEP II Co-Investment S.à r.l. SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'In-

vestissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.414.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 31 juillet 2007

Il résulte des décisions de l'assemblée générale ordinaire de la Société du 31 juillet 2007:
- que l'assemblée a accepté la démission de:
- M. John F. Harris, né le 29 avril 1960 à Washington D.C., Etats-Unis, et de
- M. William Conway, né le 27 août 1949 à Massachusetts, Etats-Unis,
de leurs fonctions de membre du conseil de gérance de la Société avec effet au 30 juillet 2007.
- que l'assemblée a nommé CEP II LIMITED avec adresse à Walker House, 87 St Mary Street, George Town, Grand

Cayman, KY1-9001, Iles Caïmans, comme nouveau membre du conseil de gérance de la Société avec effet au 31 juillet
2007 et pour une période illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2007.

<i>CEP II CO-INVESTMENT S.à r.l. SICAR
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007100943/5480/24.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05747. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

LSF4 Mega Investments II S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 186.625,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 125.868.

In the year two thousand and seven, on the twenty-third of May.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.

There appeared:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS S.àr.l., a private limited liability company established at 10B, rue Henri Schnadt,

L-2530 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, here
represented by Ms Julie Chartrain, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney
given in McLean, Virginia (US), on 21st May, 2007,

(the Shareholder),
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the

entire share capital of LSF4 MEGA INVESTMENTS II S.àr.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg,
in the course of being registered with the Luxembourg trade and companies register, incorporated pursuant to a deed
of Maître André Schwachtgen, dated 22 March 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, and amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 21 May 2007, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may

validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Conversion of one share of the Company into a preferred share and redenomination of the remaining shares of the

Company into ordinary shares;

2. Decision to amend and restate the articles of association;
3. Decision to appoint Mr Alain Heinz as independent manager of the Company; and
4. Decision to confer signatory powers to Mr Philippe Detournay, with professional address at 10B, rue Henri Schnadt,

L-2530 Luxembourg, on the Company's bank account for any transactions not exceeding EUR 5,000 (five thousand euros).

101491

This having been declared, the Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Company's share capital is currently represented by 1,493 (one thousand four hundred and ninety-three) shares

having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each.

The Sole Shareholder resolves to convert one share of the Company into a preferred share giving its holder the right

to a preferred dividend of EUR 10 (ten euros) per year. The preferred dividend will be paid out if distributable profits
exist and will be cumulated if no distributable profits are available in a given year. This preferred share will however not
participate in the ordinary profits of the Company, meaning that it will not have a right to the ordinary dividends, if any,
which will be shared only among the ordinary shares. It will not participate in the distribution of any liquidation surplus.
The preferred share has ordinary voting rights.

The remaining 1,492 (one thousand four hundred and ninety-two) shares of the Company are redenominated into

ordinary shares.

<i>Second resolution

The Shareholder decides to amend and restate the articles of association of the Company in order to reflect the above

resolution and to state that the Company is a sole purpose company. The articles of association shall thus read henceforth
in their English version as follows:

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of LSF4 MEGA

INVESTMENTS II S.àr.l. (the Company).

Art. 2. The Company is incorporated as a single purpose company.
A. The sole, specific and limited objects for which the Company is formed and incorporated are to act as a holding

company and to acquire, own and dispose of the preferred shares and the common shares (tokutei shusshi) of Kokusai
Akasaka Capital The Second TMK, a Japan tokutei mokuieki kaisha (as renamed from time to time) (TMK JAPAN), and
to take such actions in relation thereto as are necessary in furtherance of such investment (the Investment). The Company
is restricted to the foregoing objects, and no other objects may be engaged in by the Company, but for the avoidance of
doubt, the Company is permitted, in furtherance of the investment, to do the following:

(1) to exercise and enforce all rights and powers conferred by or incidental to the ownership of the shares of TMK

JAPAN including, without prejudice to the generality of the foregoing, all such powers of veto or control as may be
conferred by virtue of the holding by the Company of such shares;

(2) to enter into, execute or deliver, and to cause TMK JAPAN to enter into, execute or deliver all documents,

instruments, agreements, certificates or mortgages evidencing, securing or relating to any loans made to TMK JAPAN or
bonds issued by TMK JAPAN on or about 25 May 2007 (collectively, the Credit Documents).

(3) to carry on any other activities and do or perform any such acts, matters or things and enter into such other

instruments or agreements in furtherance of, or related or incidental to, the foregoing objects, or which in the opinion
of any manager of the Company or any attorney-in-fact of the Company be considered necessary or desirable for the
purpose of compliance with any condition precedent or the coming into effect or otherwise giving effect to, consummating
or completing or procuring the performance and completion of all or any of the transactions contemplated by or referred
to in all of the Credit Documents, and to engage in any other activity permitted to companies under the laws of Luxem-
bourg but only to the extent that such activity is necessary, expedient, incidental or conducive to the accomplishment of
the foregoing object.

B. Powers of the Company
(1) Subject to Clause 2 of this Section B, the Company shall have all powers necessary, convenient or incidental to

accomplish its purposes as set forth in Section A.

(2) In order to comply with certain provisions required in order to qualify the Company as a «single purpose company»,

the Company shall, at all times until repayment in full of any loans received and redemption in full of any bonds issued
pursuant to the Credit Documents:

a. Not engage in any activities other than as specified in Section A above;
b. Not engage in any business unrelated to its interests in TMK JAPAN or own any assets other than those related to

such interests;

c. Not commingle its assets with those of any other entity that is controlling, controlled by or under common control

with it;

d. Not guarantee or become obligated for the debts of any other entity or hold out its credit as being available to

satisfy the obligations of others except as expressly permitted by the Credit Documents;

e. Not acquire obligations, securities or interests in LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS S.àr.l., LONE STAR FUND

IV (U.S.), L.P., LONE STAR FUND IV (BERMUDA), LP., or any other sponsor under the Credit Documents;

f. Not pledge its assets for the benefit of any other entity other than any lenders and/or bondholders, as the case may

be, under the Credit Documents or make any loans or advances to any entity, other than as expressly permitted by the
Credit Documents;

101492

g. Maintain adequate initial capital in light of its contemplated business operations;
h. Have books, records, accounts, financial statements, stationery, invoices and checks which are separate and apart

from those of any other entity;

i. Hold itself out as being an entity separate and apart from any other entity, conduct its business in its own name and

exercise reasonable efforts to correct any known misunderstanding actually known to it regarding its separate identity;

j. Pay its own liabilities out of its own funds and make reasonable payments in respect of shared office space;
k. Have no employees but maintain a sufficient number of agents in light of its contemplated business operations;
1. Observe all applicable corporate or company formalities in all material respects;
m. only have a single manager who is an Independent Manager (as defined in Article 11);
n. not take, cause or allow any Significant Action (defined below) without the consent of its Independent Manager; and
o. At all times from its date of formation comply in all cases with the requirements set forth in subclauses (a) through

(n) above.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are

directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development, within the limited object
set out above.

As used in this clause 2 of this section B, the term Significant Action shall mean:
1. filing or consenting to the filing (to the extent permitted under applicable legal provisions) of any voluntary bank-

ruptcy or insolvency petition or otherwise instituting or consenting to any bankruptcy or insolvency proceeding with
respect to TMK JAPAN or the Company, under any law relating to bankruptcy, insolvency, corporate reorganization,
company arrangement, civil rehabilitation or special liquidation, or similar dissolution or liquidation law or statute of any
jurisdiction, whether now or hereafter in effect;

2. making a settlement agreement with respect to or an assignment of all or substantially all of the assets of TMK

JAPAN or the Company for the benefit of creditors;

3. applying for, consenting to, approving of, or acquiescing (to the extent permitted under applicable legal provisions)

in any petition, application, proceeding or order for relief or the appointment of a conservator, trustee, supervisor,
inspector, custodian, or receiver for TMK JAPAN or the Company or for all or any substantial part of its assets;

4. stipulating or consenting (to the extent permitted under applicable legal provisions) to an attachment, execution or

other judicial seizure of (or a proceeding to attach, execute or seize) all or substantially all of the assets of TMK JAPAN
or the Company;

5. the Company admitting to a creditor its inability to pay its debts;
6. selling all or substantially all of the Company's assets except as permitted in the Credit Documents;
7. appointing, dismissing or replacing any of the directors of TMK JAPAN except as permitted in the Credit Documents;

or

8. amending, altering, changing or repealing any provisions of the articles of incorporation of TMK JAPAN except as

permitted in the Credit Documents.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred within the municipality of Luxembourg by means of a decision of the managers.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR186,625 (one hundred eighty-six thousand six hundred

and twenty-five euro) represented by 1,492 (one thousand four hundred and ninety-two) ordinary shares and 1 (one)
preferred share with a nominal value of EUR125 (one hundred twenty-five euro) each.

Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders

meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.

Art. 7. Each ordinary share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

The preferred share or the preferred shares, as the case may be, are each entitled to a preferred and cumulative

dividend of EUR 10 (ten euros) a year and will not participate in the profit distribution mentioned in the preceding
paragraph. Preferred shares do not participate in the distribution of any liquidation surplus.

Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

101493

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the
Companies Act).

Art. 10.  The  death,  suspension  of  civil  rights,  insolvency  or  bankruptcy  of  the  sole  shareholder  or  of  one  of  the

shareholders will not bring the Company to an end.

Art. 11. For so long as (i) any loans made pursuant to the Credit Documents have not been repaid in full and (ii) any

bonds issued pursuant to the Credit Documents are outstanding, the Company shall at all times be managed by a sole
individual who is an «Independent Manager» in accordance with the standards set forth below in this Article 11 (the
Independent Manager). The Independent Manager is appointed, revoked and replaced by the general shareholder meeting,
by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share capital (subject to the third paragraph of Article
13 of these articles of association).

The Independent Manager shall not have been at the time of such individual's appointment, and may not have been at

any time during the preceding three (3) years:

(a) a shareholder, unitholder, director, officer, employee, partner, attorney or counsel of the Company or any of its

respective affiliates (other than his or her service as an independent director and/or independent manager of an affiliate);
or

(b) a customer, supplier or other person who derives more than two percent (2%) of its purchases or revenues from

its activities with the Company or any of its respective affiliates (other than his or her service as an independent director
and/or independent manager).

For purposes of these articles of association, the term «manager» means the Independent Manager.
In dealing with third parties, the Independent Manager will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 11 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the Independent Manager.

The Company shall be bound by the sole signature of its Independent Manager.
The general shareholders' meeting or the Independent Manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents. The general shareholders' meeting or the Independent Manager will determine this agent's
responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of his agency.

Art. 12. The Independent Manager assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commit-

ment validly made by him in the name of the Company.

Art. 13. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which it owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital. However,
resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies Act and to the
third paragraph of this Article 13.

Prior to repayment in full of any loans received and redemption in full of any bonds issued pursuant to the Credit

Documents, decisions on (i) consolidating or merging the Company with or into any other person or entity, (ii) dissolving,
reorganizing or completing the final liquidation of the Company or (iii) resolutions to alter these articles of association
(other than in connection with an increase or decrease of the Company's subscribed share capital) or (iv) appointing,
revoking or replacing the Independent Manager, in each case can only be adopted unanimously by all the shareholders.

Art. 14. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 15. Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and the manager, or in

case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholders commensurate to his/their share holding in
the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

Art. 17. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

101494

Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is

made in these articles of association.

<i>Third resolution

The Shareholder resolves to appoint Mr Alain Heinz, with professional address at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511

Luxembourg, who is currently manager of the Company, as Independent Manager of the Company with effect from today's
date and for an unlimited duration.

<i>Fourth resolution

The Shareholder decides to confer signatory powers to Mr Philippe Detournay, with professional address at 10B, rue

Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, on the Company's bank account for any transactions not exceeding EUR 5,000 (five
thousand euros).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-trois.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Remich,

A comparu:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS S.àr.l., une société à responsabilité limitée établie au 10B, rue Henri Schnadt,

L-2530 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796,
représentée par Philippe Detournay, ici représentée par M 

e

 Julie Chartrain, avocat, ayant son adresse professionnelle à

Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à McLean, Virginie (EU) le 21 mai 2007,

(l'Associé)
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

L' Associé a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de la

société à responsabilité limitée dénommée LSF4 MEGA INVESTMENTS II S.àr.l. (la Société), une société de droit luxem-
bourgeois, en cours d'immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée selon
acte du notaire Maître Schwachtgen, daté du 22 Mars 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, modifié pour la dernière fois par un acte du notaire Martine Schaeffer, daté du 21 mai 2007, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion d'une part sociale de la Société en part sociale préférentielle et re-nomination du reste des parts sociales

de la Société en parts sociales ordinaires;

2. Décision de modifier et refondre les statuts;
3. Décision de nommer Monsieur Alain Heinz comme gérant indépendant de la Société; et
4. Décision de conférer pouvoir de signature sur le compte bancaire de la Société à Monsieur Philippe Detournay,

ayant son adresse professionnelle au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, pour toutes transactions n'excédant
pas EUR 5.000 (cinq mille euros).

Ceci ayant été déclaré, l'Associé représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la Société est actuellement représenté par 1.493 (mille quatre cent quatre-vingt-treize) parts sociales

d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

L'Associé décide de convertir une part sociale de la société en une part sociale préférentielle, donnant ainsi à son

détenteur le droit à un dividende préférentiel de EUR 10 (dix euros) par an. Le dividende préférentiel sera versé si des
bénéfices distribuables existent et sera cumulé si des bénéfices distribuable ne sont pas disponibles une année donnée.
Cette part sociale préférentielle ne participe toutefois pas aux bénéfices ordinaires de la Société et ne se verra pas octroyé
des dividendes ordinaires. Ceux-ci seront seulement partagés entre les parts sociales ordinaires. La part sociale préfé-
rentielle ne participera pas à la distribution de tout boni de liquidation. Elle dispose de droits de vote ordinaires.

Les 1.492 (mille quatre cent quatre-vingt-douze) parts sociales restantes de la Société sont re-nommées en tant que

parts sociales ordinaires.

101495

<i>Seconde résolution

L'Associé décide de modifier et de reformuler les statuts de la Société en vue de transposer les résolutions ci-dessus

et en vue d'indiquer que la Société est une société à objet unique. Les statuts auront désormais la teneur suivante dans
leur version française:

Art. 1 

er

 .  II existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de LSF4 MEGA INVESTMENTS II

S.àr.l. (ci-après, la Société).

Art. 2. La Société est constituée en tant que société à objet social unique.
A. La Société est constituée seulement, exclusivement et limitativement pour servir de société de participations fi-

nancières et pour acquérir, détenir et vendre les actions préférentielles et les actions ordinaires (tokutei shusshi) de
Kokusai Akasaka Capital The Second TMK, une tokutei mokuteki kaisha japonaise (ou autre tout nom qu'elle pourra
prendre à l'avenir) (TMK JAPAN), et pour effectuer tous actes en relation avec cette participation qui sont nécessaires
pour développer cet investissement (l'Investissement). La Société est limitée à l'objet social énuméré ci-dessus et elle ne
pourra s'engager dans aucun autre objet, sauf, pour éviter tout doute, en vue du développement de l'Investissement, la
Société peut effectuer les opérations suivantes:

(1) exercer et mettre en oeuvre tous les droits et pouvoirs conférés par la propriété des actions de TMK JAPAN ou

qui y sont accessoires, y inclus, sans préjudice de la généralité de ce qui précède, tous les pouvoirs de veto ou de contrôle
qui peuvent être conférés à la Société du fait de la détention de ces actions;

(2) entrer dans, exécuter ou remplir ses engagements, ou faire en sorte que TMK JAPAN entre dans, exécute ou

remplisse ses engagements sous tous documents, actes, contrats, certificats ou hypothèques prouvant, garantissant ou
étant en relation avec tout prêt fait à TMK JAPAN ou toute obligation émise par TMK JAPAN à la date approximative
du 25 mai 2007 (ensemble les Documents de Crédit).

(3) effectuer toute autre activité et faire ou effectuer tous actes, affaires ou choses et entrer dans tous instruments

ou conventions pour développer les objets précités ou liés ou accessoires aux objets précités, ou qui sont, dans l'opinion
d'un quelconque gérant de la Société ou d'un mandataire de la Société considérés comme nécessaires ou souhaitables
pour la conformité avec toute condition suspensive ou pour l'entrée en vigueur ou pour autrement donner effet à, parfaire
ou compléter ou causer l'exécution et l'achèvement de toutes les transactions ou une des transactions envisagées par
les Documents de Crédit ou auxquelles ils font référence et elle peut s'engager dans toute autre activité permise aux
sociétés sous la loi luxembourgeoise, mais seulement dans la mesure ou cette activité est nécessaire opportune, attachée
à ou favorable à l'accomplissement de l'objet précité.

B. Pouvoirs de la Société
(1) Dans les limites de la Clause 2 de cette section B, la Société a tous les pouvoirs nécessaires, opportuns ou acces-

soires à l'accomplissement des objectifs énoncés dans la section A.

(2) En vue de se conformer à certaines dispositions requises en vue de qualifier la Société comme une «société à objet

social unique», la Société doit, en permanence jusqu'au remboursement en totalité de tous prêts reçus et du rachat en
totalité de toutes obligations émises en vertu des Documents de Crédit:

a. Ne pas s'engager dans des activités autres que celles déterminées dans la section A ci-dessus;
b. Ne pas s'engager dans des affaires non liées à la participation dans TMK JAPAN et ne pas détenir des avoirs autres

que ceux liés à cette participation;

c. Ne pas mélanger ses avoirs à ceux d'une autre entité qui la contrôle, qu'elle contrôle ou qui est contrôlée par la

même entité qu'elle-même;

d. Ne pas garantir ou d'être tenue des dettes d'une autre entité ou mettre à la disposition son crédit pour satisfaire

les obligations de tiers, sauf les cas expressément autorisés sous les Documents de Crédit;

e. Ne pas acquérir des obligations, titres ou participations dans LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS S.àr.l., LONE

STAR FUND IV (U.S.), LP., LONE STAR FUND IV (BERMUDA) LP., ou toute autre apparaissant comme garant (sponsor)
sous les Documents de Crédit;

f. Ne pas gager ses avoirs au profit d'une autre entité sauf, le cas échéant, au profit des prêteurs et/ou obligataires sous

les Documents de Crédit et ne pas faire des prêts ou avances à une autre entité, autrement que dans les cas expressément
autorisés par les Documents de Crédit;

g. Maintenir un capital social adapte aux affaires envisagées;
h. Tenir des livres, registres, comptes, états financiers, papiers, factures et chèques qui sont séparés et distincts de

ceux de toute autre entité;

i. Apparaître comme une entité séparée et distincte de toute autre entité, mener ses affaires dans son propre nom et

faire des efforts raisonnables pour clarifier tout malentendu dont elle aurait connaissance quant à son identité séparée;

j. Payer ses propres dettes avec ses propres fonds et faire des paiements raisonnables pour des surfaces de bureau

partagées;

k. Ne pas avoir d'employés mais maintenir un nombre suffisant de représentants en vue des affaires envisagées;
l. Observer toutes les formalités applicables aux sociétés à tous égards;

101496

m. N'avoir qu'un gérant unique qui est un Gérant Indépendant (tel que défini à l'article 11);
n. Ne pas prendre ni causer, ni autoriser aucune «Action Importante» (telle que définie ci-dessous) sans le consente-

ment du Gérant Indépendant; et

l. Toujours, depuis sa constitution, se conformer à toutes les exigences énumérées dans les points (a) à (n) ci-dessus.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, personnelles et immobiliè-

res, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, dans
les limites de l'objet social déterminé ci-dessus.

Le terme Action Importante tel qu'utilisé au point (2) de cette section B. signifie:
1. (i) déposer ou consentir au dépôt (dans la mesure où c'est autorisé par les dispositions législatives en vigueur) de

toute demande de liquidation volontaire ou de faillite; (ii) ou instituer ou consentir d'une à toute procédure de liquidation
ou de faillite concernant TMK JAPAN ou la Société, en vertu de toutes lois concernant les faillites, liquidations, réorga-
nisations de sociétés, décisions de société, ou liquidations spéciales, ou toute autre disposition concernant la dissolution
et la liquidation dans toute juridiction, actuellement en vigueur ou susceptible d'entrer en vigueur ultérieurement;

2. Clôturer une transaction en relation avec une assignation de tout ou partie des actifs de TMK JAPAN ou la Société

au bénéfice de ses créanciers;

3. Postuler, consentir, ou approuver (dans la mesure où c'est autorisé par les dispositions législatives en vigueur) toute

demande, requête, candidature, procédure ou ordre de décharge ou de nomination d'un conservateur, trustee, super-
viseur, inspecteur, dépositaire ou receveur pour TMK JAPAN ou la Société ou tout ou partie de ses actifs;

4. Stipuler ou consentir (dans la mesure où c'est autorisé par les dispositions législatives en vigueur) à la jonction,

l'exécution, ou à la confiscation judiciaire (ou toute procédure joignant, exécutant ou confisquant) de tout ou partie des
actifs de TMK JAPAN ou la Société;

5. Concéder à un créancier son incapacité à honorer ses dettes;
6. Vendre tout ou partie des actifs de la Société, à moins que ceci soit autorisé par les Documents de Crédit;
7. Nommer, révoquer ou remplacer tout administrateur de TMK JAPAN, à moins que ceci ne soit autorisé par les

Documents de Crédit; ou

8. Modifier, altérer, changer ou abroger toute disposition des statuts de TMK JAPAN, à moins que ceci ne soit autorisé

par les Documents de Crédit.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être transféré dans la commune de Luxembourg par une décision des gérants.
II peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR186.625 (cent quatre-vingt-six mille six cents vingt-

cinq euros) représenté par 1.492 (mille quatre cent quatre-vingt-douze) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale
préférentielle d'une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée

des associés, conformément à l'article 13 des présents statuts.

Art. 7. Chaque part sociale ordinaire donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de

l'actif social ainsi que des bénéfices.

La ou les parts sociales préférentielles donnent droit chaque année à un dividende préférentiel et cumulatif de EUR10

(dix euros) et ne participeront pas à la distribution de bénéfices mentionnée au paragraphe précédent. Les parts sociales
préférentielles ne participeront pas à la distribution d'un quelconque boni de liquidation.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par I'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas

fin à la Société.

Art. 11. Aussi longtemps que les (i) Obligations et (ii) le Prêt ne sont pas complètement remboursés, la Société est

gérée par un gérant unique qui est considéré comme un «Gérant Indépendant» conformément aux indications ci-dessous
dans cet Article 11 (le Gérant Indépendant). Le Gérant Indépendant est désigné, révoqué et remplacé par l'assemblée

101497

des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social (sous réserve
du troisième paragraphe de l'article 13 des présents statuts).

Le Gérant Indépendant ne sera, au moment de sa nomination ou n'aura été, à aucun moment au cours des 3 (trois)

années précédentes:

(a) un actionnaire, un investisseur, administrateur, agent représentant, employé, associé, mandataire ou conseiller de

la Société ou d'une de ses sociétés affiliées (autre que sa fonction d'administrateur indépendant et/ou gérant indépendant
d'une société affiliée),

(b) un client, fournisseur ou toute autre personne dont plus de 2% de ses achats ou revenus proviennent de ses activités

avec la Société ou d'une société affiliée (autre que sa fonction d'administrateur indépendant et/ou gérant indépendant),

Pour les besoins de ces statuts, le terme «gérant» signifie «le Gérant Indépendant».
Vis-à-vis des tiers, le Gérant Indépendant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent Article 11.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du Gérant Indépendant.

La Société sera engagée par la seule signature du Gérant Indépendant.
L'assemblée des associés ou le Gérant Indépendant pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques

à un ou plusieurs mandataires ad hoc. L'assemblée des associés ou le Gérant Indépendant déterminera la responsabilité
du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres
conditions pertinentes de ce mandat.

Art. 12. Le Gérant Indépendant ne contracte, à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société.

Art. 13. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été
adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Cependant, les résolutions modifiant les statuts
de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915 et du troisième paragraphe du présent article 13.

Jusqu'au remboursement en totalité de tout prêt reçu et jusqu'au rachat en totalité de toutes obligations émises en

vertu des Documents de Crédit, les décisions portant sur (i) la consolidation ou la fusion de la Société avec une autre
entité, (ii) la dissolution, la réorganisation, ou la finalisation d'opérations de liquidation de la Société, (iii) la modification
des présents statuts (à l'exception des modifications statutaires résultant d'augmentations ou de réductions de capital)
ou (iv) nommant, révoquant ou remplaçant le Gérant Indépendant ne pourront être adoptées qu'à l'unanimité des asso-
ciés.

Art. 14. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance

dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre
communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est
à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de

la Loi de 1915.

<i>Troisième résolution

L'Associé décide de nommer Gérant Indépendant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

M. Alain Heinz, ayant son adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, qui est actuelle-
ment gérant de la Société.

101498

<i>Quatrième résolution

L'Associé décide de conférer pouvoir de signature sur le compte bancaire de la Société à M. Philippe Detournay, ayant

son adresse professionnelle au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, pour toutes transactions n'excédant pas
EUR 5.000 (cinq mille euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: J. Chartrain, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 25 mai 2007, REM/2007/1189. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations

Remich, le 31 mai 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007100129/5770/433.
(070113304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Bantleon Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 72.580.

<i>Election de membre du conseil d'administration

Madame Michaela Imwinkelried, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été élu aux fonctions de membre

du Conseil d'Administration de BANTELON INVEST S.A. avec effet le 31 juillet 2007 pour une période se terminant à
l'Assemblée Générale qui aura lieu en 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2007.

<i>Pour BANTLEON INVEST S.A.
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
A. Trappendreher / A. Giel
<i>Associate Director / Associate Director

Référence de publication: 2007100944/1360/19.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06407. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070114198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Humboldt Multi Invest Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 125.585.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique tenue à Luxembourg le mardi 19 juin 2007 à 18.15

<i>heures

<i>Première résolution

L'assemblée prend connaissance des lettres datées du 19 juin 2007, adressées à l'associé unique, la société mère de la

Société, par lesquelles M. Roland Franz et M. Ludger Feldmann démissionnent de leur poste de gérants de la Société. Elle
décide de confirmer la démission de M. Roland Franz et de M. Ludger Feldmann de leur poste de gérants de la Société,
avec effet le même jour, et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat de la date de leur nomination jusqu'à
la date de leur démission.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide dé nommer
- M. Stefan Leusder, Werseesch 57, D-48157 Münster;
- M. Torsten Scheinpflug, Humboldtstraße 25, D-04105 Leipzig;
- M. Holger Pastel, 52a Cromwell Road, UK-London SW7 5BE;

101499

- M. Rainer Schmitz, Truchseßstraße 19, D-40625 Düsseldorf,
avec effet rétroactif au 19 juin 2007, sous réserve de l'approbation de ces nominations par l'autorité régulatrice lu-

xembourgeoise, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), pour une période illimitée.

Suite auxdites démissions et nominations, les membres du conseil de gérance seront les suivants:
Registre de Commerce et des Sociétés
- M. Stefan Leusder;
- M. Torsten Scheinpflug;
- M. Holger Pastel;
- M. Rainer Schmitz;
- M. Andreas Stehr.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2007100996/3085/34.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06800. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070113874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Electricité du Grand Duché de Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R.C.S. Luxembourg B 102.381.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2007

Les associés décident:
- d'accepter la démission de Monsieur Olivier Farah, demeurant à F-68740 Genas, 7, rue Marcel Merieu, de son poste

d'administrateur;

- d'accepter la démission de Monsieur Franck Salvador, demeurant à F-54750 Trieux, 7, rue des Jardins, de son poste

d'administrateur;

- de nommer Monsieur Cyrille Ercolani, chargé d'affaires, né le 16 novembre 1978 à Algrange (F), demeurant à F-57710

Aumetz, 3b, route d'Audun-le-Tiche, à la fonction d'administrateur. Le mandat d'administrateur de Monsieur Cyrille
Ercolani prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour ELECTRICITE DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG SA
O. Watrin / F. Bologna
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2007100956/1058/22.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05886. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Power Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 47.477.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 15 juin 2007 au siège social à Luxembourg

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs ainsi que du commissaire sont venus à leurs échéances.
L'assemblée décide de nommer au poste
- d'administrateur:
a) Monsieur Michel Garnier, gérant administratif, né le 24 octobre 1955 à F-Besançon, demeurant à L-8399 Windhof,

6, rue d'Arlon;

b) Monsieur Yves Garnier, chargé mission, né le 5 décembre 1958 à F-Besançon, demeurant à F-06700 Saint Laurent

du Var - Le Rhodes A 436, Corniche d'Agrimont;

c) Monsieur Jean Garnier, Sophrologue-Energéticien, né le 18 février 1954 à F-Besançon, demeurant à F-24100 Ber-

gerac, 41, rue Ferdinand de Labattut;

- d'administrateur-délégué:

101500

Monsieur Michel Garnier, prénommé;
- de commissaire:
Monsieur Claude Garnier, gérant technique, né le 19 décembre 1956 à F-Besançon, demeurant à B-6860 Leglise, 1,

rue du Fet,

jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2013.
Pour extrait sincère et conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2007.

<i>POWER INVESTMENT S.A.
M. Garnier
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2007100955/664/31.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2007, réf. LSO-CH04234. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070113779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Opus Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.012.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 116.778.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions des associés en date du 25 juillet 2007 que la personne suivante a démissionné avec effet

immédiat de sa fonction de gérant de catégorie A de la société:

- Monsieur John Harris, né le 29 avril 1960 à Washington (Etats-Unis d'Amérique), ayant pour adresse professionnelle

1001 Pennsylvania Avenue 20004-2505 Washington DC (Etats-Unis d'Amérique).

Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée avec effet immédiat, pour une durée

indéterminée, en qualité de gérant de catégorie A de la société:

- Monsieur David B. Pearson, né le 13 décembre 1968 à Washington (Etats-Unis d'Amérique), ayant pour adresse

professionnelle 1001 Pennsylvania Avenue 20004-2505 Washington DC (Etats-Unis d'Amérique).

Le Conseil de Gérance est composé comme suit:

<i>Gérants A:

M. David B. Pearson
M. Christopher Finn

<i>Gérants B:

M. Desmond Mitchell
M. Godfrey Abel
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2007.

Pour extrait conforme
ATOZ
Signature

Référence de publication: 2007100950/4170/31.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05546. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070114008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Venus Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 87.380.

<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique datées du 6 août 2007

En remplacement de la société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., gérant démissionnaire, Monsieur Cornelius

Martin Bechtel, né à Emmerich/Rh (Allemagne), le 11 mars 1968, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg,

101501

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir
d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Luxembourg, le 7 août 2007.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour VENUS FINANCE S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007100947/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05769. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Adjutoris Conseil, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 18, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 105.897.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg le 7 décembre 2006

2. Démission de M. Benoît de Hults de ses fonctions d'administrateur et proposition de cooptation de M. Marc Am-

broisien

Le Président informe le Conseil que M. Benoît de Hults a présenté sa démission de ses fonctions d'administrateur de

la société avec effet immédiat.

Le Conseil décide à l'unanimité de coopter M. Marc Ambroisien, demeurant professionnellement au 18, boulevard

Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur pour la durée restante du mandat de M. de Hults,
soit jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice social 2006. M. Marc
Ambroisien accepte cette cooptation.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 15 mai 2007.

R. Paulet / G. Linard
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007100948/10/22.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2007, réf. LSO-CF01357. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

G.A.F.L. S.A., Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 90.483.

Le bilan au 31 décembre 2006, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007100967/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH06081. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 19.194.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social à Luxembourg le 31 mai 2007

<i>Délibération

L'Assemblée aborde l'ordre du jour et, à l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Didier Bottge,

demeurant professionnellement au 1, rue Bellot CH-1206 Genève, en qualité d'administrateur pour un terme expirant à
l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes sociaux de la Société relatif à l'exercice social 2007.

101502

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2007.

L. Grégoire / F. Otto
<i>Secrétaire Général / Administrateur - Directeur Général

Référence de publication: 2007100954/10/18.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2007, réf. LSO-CH07118. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070114054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

CeraTech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 88.677.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007100962/740/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2007, réf. LSO-CH07211. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070114083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Weinberg Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 130.907.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the sixth day of July.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

There appeared:

1. Mr Serge Weinberg, partner, having its professional address at 40, rue La Boétie, 75008 Paris;
represented by Mrs Annette Brewer, lawyer, with professional address in Luxembourg, under a proxy given in Paris,

on 5th July, 2007; and

2. Mr Laurent Halimi, partner, having its professional address at 40, rue La Boétie, 75008 Paris;
represented by Mrs Annette Brewer, lawyer, with professional address in Luxembourg, under a proxy given in Paris,

on 5th July, 2007; and

3. Mr Guillaume d'Angerville, partner, having its professional address at 40, rue La Boétie, 75008 Paris;
represented by Mrs Annette Brewer, lawyer, with professional address in Luxembourg, under a proxy given in Paris,

on 5th July, 2007; and

4. Mr Philippe Klocanas, partner, having its professional address at 40, rue La Boétie, 75008 Paris;
represented by Mrs Annette Brewer, lawyer, with professional address in Luxembourg, under a proxy given in Paris,

on 5th July, 2007; and

5. Mr Henri Gagnaire, partner, having its professional address at 40, rue La Boétie, 75008 Paris;
represented by Mrs Annette Brewer, lawyer, with professional address in Luxembourg, under a proxy given in Paris,

on 5th July, 2007; and

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

«I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

WEINBERG REAL ESTATE S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in

101503

particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by
the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company. The
registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a reso-
lution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines
that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these develop-
ments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg incorporated company.

Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is to act as the general partner (associé commandité) of a société en commandite par

actions, acting under the name WEINBERG REAL ESTATE PARTNERS # 1 S.C.A.

3.2 Furthermore the purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,

in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other
securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and
financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a
portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.3. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge,
transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

3.4. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and other risks.

3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by

twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed
and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

101504

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers composed of one A manager and two B managers. The managers

are appointed and designated as A manager or B manager by a resolution of the shareholders which sets the term of their
office. The managers need not to be shareholders.

7.2. The A manager shall be designated as Chairman of the board of managers.
7.3. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, by a unanimous

decision of the board of managers of the Company, in accordance with article 9.6 of the present articles of association.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. For matters valued up to an amount of ten thousand euro (EUR 10,000.-) (or its foreign currency equivalent), the

board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented, including at
least the A manager and one B manager. In such cases, resolutions of the board of managers are validly taken by the
majority of the votes cast provided that at least the A manager and a B manager agreed on those resolutions.

9.6. For matters valued above the amount of ten thousand euro (EUR 10,000.-) (or its foreign currency equivalent),

the board of managers can validly deliberate and act only if all of its members are present or represented. Resolutions of
the board of managers are validly taken by the unanimous vote of the A manager and the two B managers. For all matters,
the resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented
at the meeting.

9.7. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.8. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties (i) for the day-to-day management up to

an amount of ten thousand euro (EUR 10,000.-) (or its foreign currency equivalent) by the single signature of the A
manager, and (ii) in all other matters by the joint signatures of the A manager together with the two B managers, or the
single or joint signature(s) of any agent to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with
article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

101505

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single shareholder, if any, assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December of the same year.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the board of managers must prepare the balance

sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the man-
agers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular

allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the general meeting of shareholders;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who

do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the general meeting of shareholders which will determine
their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the
liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of
the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.

VI. General provision

Art. 17. General Provision. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.»

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2007.

101506

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the appearing parties, represented as stated here-above, declare to subscribe to the shares of the Company

as follows:

1) Mr Serge Weinberg subscribes to six thousand three hundred and seventy-five (6,375) shares of the Company,

having a par value of one euro (EUR 1.-) each;

2) Mr Laurent Halimi subscribes to three thousand one hundred and twenty-five (3,125) shares of the Company, having

a par value of one euro (EUR 1.-) each;

3) Mr Guillaume d'Angerville subscribes to one thousand (1,000) shares of the Company, having a par value of one

euro (EUR 1.-) each;

4) Mr Philippe Klocanas subscribes to one thousand (1,000) shares of the Company, having a par value of one euro

(EUR 1.-) each; and

5) Mr Henri Gagnaire subscribes to one thousand (1,000) shares of the Company, having a par value of one euro (EUR

1.-) each.

The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro

(EUR 12,500.-) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately two thousand one hundred euro (EUR 2.100,-).

<i>Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entirety of

the subscribed share capital have passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as A manager of the Company for an indefinite period:
(i) Mr Franciscus Welman, born on September 21, 1963 at Heerlen (Netherlands), with professional address at 46A,

avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. The following persons are appointed as B managers of the Company for an indefinite period:
(i) Mr Benjamin Teszner, born on May 26, 1975 at Clamart (France), with professional address at 40, rue La Boétie,

75008 Paris.

(ii) Mr Vincent Vaïtty, born on June 20, 1966, at Karikal (India), with professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg.

3. The registered office of the Company is set at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le sixième jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Serge Weinberg, partenaire, résidant professionnellement au 40, rue La Boétie, 75008 Paris;
ici représenté par Maître Annette Brewer, avocat, résidant à Luxembourg, selon la procuration donnée à Paris, le 5

juillet 2007;

2. M. Laurent Halimi, partenaire, résidant professionnellement au 40, rue La Boétie, 75008 Paris;
ici représenté par Maître Annette Brewer, avocat, résidant à Luxembourg, selon la procuration donnée à Paris, le 5

juillet 2007;

3. M. Guillaume d'Angerville, partenaire, résidant professionnellement au 40, rue La Boétie, 75008 Paris;
ici représenté par Maître Annette Brewer, avocat, résidant à Luxembourg, selon la procuration donnée à Paris, le 5

juillet 2007;

4. M. Philippe Klocanas, partenaire, résidant professionnellement au 40, rue La Boétie, 75008 Paris;
ici représenté par Maître Annette Brewer, avocat, résidant à Luxembourg, selon la procuration donnée à Paris, le 5

juillet 2007;

101507

5. M. Henri Gagnaire, partenaire, résidant professionnellement au 40, rue La Boétie, 75008 Paris;
ici représenté par Maître Annette Brewer, avocat, résidant à Luxembourg, selon la procuration donnée à Paris, le 5

juillet 2007;

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par les parties comparantes et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquelles parties comparantes, ès-qualité qu'elles agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

«I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination WEINBERG REAL

ESTATE S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de
modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par décision du conseil de gérance de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou des événements
extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre les activités normales de la Société au siège
social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette
mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet d'agir comme associé commandité d'une société en commandite par actions sous la dé-

nomination de WEINBERG REAL ESTATE PARTNERS # 1 S.C.A.

3.2 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, incluant l'acquisition et l'octroi de brevets concernant
de tels droits de propriété intellectuelle, de quelque nature ou origine que ce soit.

3.3 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder,

par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations,
à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au
profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.4 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque crédit, le risque
de change, de fluctuations de taux d'intérêt et tout autres risques.

3.5 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de
son objet social.

4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cent (12.500)

parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entière-
ment libérées.

101508

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé qui le requiert.

6.5. La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'un gérant A et de deux gérants B. Les gérants sont

nommés et désignés comme gérant A ou gérant B par résolution des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Les
gérants n'ont pas besoin d'être associés.

7.2 Le gérant A sera désigné Président du conseil de gérance.
7.3 Les gérants sont révocables à tout moment ad nutum (sans aucun motif).

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opé-
rations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, par

décision unanime du conseil de gérance de la Société, conformément à l'article 9.6 des présents statuts.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des

gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants une notification écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de telles circonstances
sera mentionnée dans la notification de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Pour les matières dont la valeur n'excède pas dix mille euros (EUR 10.000,-) (ou l'équivalent en devise étrangère),

le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée,
incluant au moins le gérant A et un gérant B. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité
des voix des gérants présents ou représentés, à condition que au moins le gérant A et un gérant B aient donnés leur
accord sur ces résolutions.

9.6. Pour les matières dont la valeur excède dix mille euros (EUR 10.000,-) (ou l'équivalent en devise étrangère), le

conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si tous les gérants sont présents ou représentés. Les
décisions du conseil de gérance sont prises valablement à l'unanimité des voix du gérant A et des deux gérants B. Pour
toutes matières, les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

9.7. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

101509

9.8. Dans les cas d'urgence, des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant

valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures
des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées
par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers, (i) pour la gestion journalière

n'excédant pas un montant de dix mille euros (EUR 10.000,-) (ou son équivalent en devise étrangère) par la signature
individuelle du gérant A et (ii) pour toutes les autres matières, par la signature conjointe du gérant A et des deux gérants
B ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été
valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne ou entité comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la

même année.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance doit préparer le bilan et les comptes de profits

et pertes de la Sociétés ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société, avec
une annexe présentant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, de l'auditeur statutaire (s'il y en a)
et des associés à l'égard de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.

101510

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition
contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les
plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Disposition Générale. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts,

il est fait référence à la Loi.»

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2007.

<i>Souscription - Libération

Les parties comparantes, représentées comme dit ci-dessus, déclarent avoir souscrit aux parts sociales de la Société

comme suit:

1) Monsieur Serge Weinberg déclare avoir souscrit à six mille trois cent soixante-quinze (6.375) parts sociales de la

Société, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune;

2) Monsieur Laurent Halimi déclare avoir souscrit à trois mille cent vingt-cinq (3.125) parts sociales de la Société, ayant

une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune;

3) Monsieur Guillaume d'Angerville déclare avoir souscrit à mille (1.000) parts sociales de la Société, ayant une valeur

nominale de un euro (EUR 1,-) chacune;

4) Monsieur Philippe Klocanas déclare avoir souscrit à mille (1.000) parts sociales de la Société, ayant une valeur

nominale de un euro (EUR 1,-) chacune; et

5) Monsieur Henri Gagnaire déclare avoir souscrit à mille (1.000) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale

de un euro (EUR 1,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de douze

mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire,
qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Les parties comparantes ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille cent euros
(EUR 2.100,-).

<i>Décision des associés

Et aussitôt après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social, ont

pris les résolutions suivantes:

1. La personne suivante est nommée comme gérant A de la Société pour une durée indéterminée:
(i) Monsieur Franciscus Welman, né le 21 septembre 1963, à Heerlen (Pays-Bas), domicilié professionnellement au

46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants B de la Société pour une durée indéterminée:
(i) Monsieur Benjamin Teszner, né le 26 mai 1975, à Clamart (France), domicilié professionnellement au 40, rue La

Boétie, 75008 Paris.

(ii) Monsieur Vincent Vaïtty, né le 20 juin 1966, à Karikal (Inde), domicilié professionnellement au 46A, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg.

3. Le siège social de la Société est établi à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent

acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au détenteur des procurations des parties comparantes, il a signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: A. Brewer, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2007, LAC/2007/ 17802. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

101511

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007101095/5770/473.
(070115111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2007.

CeraTech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 88.677.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007100963/740/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2007, réf. LSO-CH07210. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070114080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Amberlux, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 40.492.

Le bilan au 31 décembre 2006, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007100968/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH06084. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Dexamenos Développement, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 51.914.

Le bilan au 31 décembre 2006, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007100969/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH06087. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Nomura Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 107.078.

EXTRAIT

I. Monsieur Hiroshi Terasaki avait démissionné de sa fonction d'administrateur du conseil d'administration de NO-

MURA FUNDS (la «Société») en date du 5 septembre 2005.

Il résulte d'une résolution du conseil d'administration en date du 5 septembre 2005 que Monsieur Toshihiko Matsunaga

avait été coopté en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 5 septembre 2005.

La nomination de Monsieur Matsunaga avait été confirmée par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la

Société en date du 26 juin 2006.

101512

Le conseil d'administration de la Société se composait comme suit, pour une période expirant à l'assemblée générale

qui s'était tenue en 2007:

- M. Yoshikazu Chono, President and Managing Director, NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., 33, rue de Gas-

perich, L-5826 Hesperange;

- M. Toshihiko Matsunaga, Managing Director, NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED, Nomura House, 1

St. Martin's-le-Grand, London EC1A 4NT, United Kingdom;

- M. Koichi Sudo, Director and General Manager, NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., 33, me de Gasperich,

L-5826 Hesperange.

Et que la société suivante avait été réélue comme réviseur d'entreprises de la Société pour une période expirant à la

prochaine assemblée générale qui s'est tenue en 2007:

- DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
II. Il résulte d'une résolution de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société en date du 25 juin 2007

que M. Takashi Kawazoe a été nommé comme administrateur de la Société et que M. Yoshikazu Chono, M. Toshihiko
Matsunaga et M. Koichi Sudo ont été renommés comme administrateurs de la Société avec effet au 25 juin 2007.

Le conseil d'administration de la Société se compose comme suit, pour une période expirant à la prochaine assemblée

générale qui se tiendra en 2008:

- M. Yoshikazu Chono, President and Managing Director, NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., 33, rue de Gas-

perich, L-5826 Hesperange;

- M. Toshihiko Matsunaga, Managing Director, NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED, Nomura House, 1

St. Martin's-le-Grand, London EC1A 4NT, United Kingdom;

- M. Koichi Sudo, Director and General Manager, NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., 33, rue de Gasperich,

L-5826 Hesperange;

- M. Takashi Kawazoe, Managing Director, NOMURA ASSET MANAGEMENT Co., LIMITED, 1-12-1, Nihonbashi,

Chuo-ku, Tokyo 103-0022 Japan.

Et que la société suivante a été réélue comme réviseur d'entreprises de la Société pour une période expirant à la

prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2008:

- DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2007.

<i>Pour NOMURA FUNDS
Signature

Référence de publication: 2007101074/260/47.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2007, réf. LSO-CH07162. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070114094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

G.A.F.L. S.A., Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 90.483.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 6 août 2007 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston

Churchill L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.
L'assemblée générale du 6 août 2007 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster, RCS Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

101513

Luxembourg, le 6 août 2007.

<i>Pour G.A.F.L. S.A. GENERALE ALIMENTAIRE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE S.A., Société anonyme holding
Signature

Référence de publication: 2007101068/833/23.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH06080. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Media Tele S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 106.239.

Il résulte des décisions prises à l'unanimité par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de MEDIA TELE S.A.

(la «Société»), tenue le 18 juin 2007 à 10.30 heures au siège social que:

1. Le renouvellement des mandats des administrateurs suivants a été confirmé jusqu'à l'assemblée générale des ac-

tionnaires devant se prononcer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2007, soit en 2008:

- M. Francesco D'Angelo, demeurant à L-2440 Luxembourg, 40, rue du Rollingergrund,
- M. Lars-Johan Jarnheimer, demeurant à S-18147 Lidingö, Elfviksvägen 40
et
- M. Anders Olsson, demeurant à S-11328 Stockholm, Heimdalsgatan 3, 5 

e

 étage.

2. l'assemblée décide de:
ne pas renouveler le mandat de M. Christophe Lambot et de M. Simon Falk comme commissaires aux comptes de la

société

et
de nommer
Mme Delphine Lorho, demeurant à 25, rue de Cessange, L-3347 Leudelange et Mme Nadia Dziwinsky, demeurant à

18, rue Waltzing, L-8478 Eischen comme nouveaux commissaires aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée générale
des actionnaires devant se prononcer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2007, soit en 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2007101043/1053/28.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2007, réf. LSO-CH06884. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Cafco International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 20.903.

EXTRAIT

En date du 31 juillet 2007, l'associé unique de la Société a accepté la démission de M. Francis Pandolfi et de M. Carl

Turner de leur poste d'administrateur de la Société avec effet au 31 juillet 2007 et a nommé en tant qu'administrateurs
supplémentaires avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle délibérant sur les comptes sociaux pour
l'année sociale se clôturant en mars 2008 les personnes suivantes:

- M. Erik Frans Angele Johan M. Spillemaeckers, directeur général, né le 16 juillet 1959 à Anvers (Belgique) et demeurant

au 20, Fruithoflaan, B-2500 Lier, Belgique; et

- M. Reinhold Ernst Axel Vom Scheidt, gérant, né le 4 mai 1951 à Wuppertal (Allemagne) et demeurant à Via Lorenzo

Costa 2/14, I-16136, Genova, Italie.

Suite à ce qui précède, le conseil d'administration de la Société se compose comme suit:
- M. David Hey
- M. Erik Frans Angele Johan M. Spillemaeckers
- M. Reinhold Ernst Axel Vom Scheidt
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

101514

Luxembourg, le 8 août 2007.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2007101061/260/26.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH05950. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070114275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Medrom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 63.567.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 48328 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007101005/211/11.

(070114223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Prinus Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.590.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 48323 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007101006/211/11.

(070113965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Everyday Media S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 78.227.

Il résulte des décisions prises à l'unanimité par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de EVERYDAY MEDIA

S.A. (la «Société»), tenue le 18 juin 2007 à 9.30 heures au siège social que:

1. Le renouvellement des mandats des administrateurs suivants a été confirmé jusqu'à l'assemblée générale des ac-

tionnaires devant se prononcer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2007, soit en 2008:

- M. Francesco D'Angelo, demeurant à L-2440 Luxembourg, 40, rue du Rollingergrund,

- M. Lars-Johan Jarnheimer, demeurant à S-18147 Lidingö, Elfviksvägen 40 et

- M. Anders Olsson, demeurant à S-11328 Stockholm, Heimdalsgatan 3, 5 

e

 étage.

2. l'assemblée décide de:

ne pas renouveler le mandat de M. Christophe Lambot et de M. Simon Falk comme commissaires aux comptes de la

société

et

de nommer

Mme Delphine Lorho, demeurant à 25, rue de Cessange, L-3347 Leudelange, et Mme Nadia Dziwinsky, demeurant à

18, rue Waltzing, L-8478 Eischen comme nouveaux commissaires aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée générale
des actionnaires devant se prononcer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2007, soit en 2008.

101515

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2007101044/1053/27.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2007, réf. LSO-CH06886. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

MSREF VI Spirit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 128.450.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2007.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2007101041/5770/13.
(070113791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

GTC S. à r. l., Société à responsabilité limitée,

(anc. GTA 2 S. à r. l.).

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 117.942.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2007.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2007101039/5770/13.
(070114246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Belux Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. M. Organisation S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 108.234.

<i>Déclaration de changement dans les personnes des associés au 30 juillet 2007

Le gérant déclare que la part détenue dans le capital de la Société par Monsieur Patrick Mbaya Kapita né le 21 mars

1974 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) à été transférée à la société CARRIBEAN DREAMS S.A., Francis
Rachel Street 13-1, Victoria (Seychelles). Toutes les 250 parts de la société sont ainsi aujourd'hui détenues par CARRI-
BEAN DREAMS S.A.

Référence de publication: 2007102231/8053/16.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2007, réf. LSO-CH09110. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070115864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2007.

Dusseldorf Arcaden Luxco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.069.

<i>Extraits des résolutions et décisions prises lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 15 juin 2007

Il a été décidé:

101516

- de rayer Messieurs Paul Chehab et John Comery, en tant que Gérants de la Société, et de nommer Monsieur Pierre

Lalonde, né le 13 août 1954, résidant à 813, Chemin Marie-le-Ber, Verdun (Québec) H3E 1Y5, Canada, en tant que
nouveau Gérant de la société, avec effet immédiat, pour un mandat à durée indéterminée.

En plus de Madame Jacqueline Kost et de Monsieur Kuy Ly Ang.

Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007102226/7446/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2007, réf. LSO-CH07773. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070115915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2007.

Düsseldorf/Wilmersdorfer Arcaden, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.142.

<i>Extraits des résolutions et décisions prises lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 15 juin 2007

Il a été décidé:
- de rayer Messieurs Paul Chehab et John Comery, en tant que Gérants de la Société, et de nommer Monsieur Pierre

Lalonde, né le 13 août 1954, résidant à 813, Chemin Marie-le-Ber, Verdun (Québec) H3E 1Y5, Canada, en tant que
nouveau Gérant de la société, avec effet immédiat, pour un mandat à durée indéterminée.

En plus de Madame Jacqueline Kost et de Monsieur Kuy Ly Ang.

Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007102225/7446/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2007, réf. LSO-CH07772. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070115911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2007.

Zwickau Arcaden Luxco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.926.

<i>Extraits des résolutions et décisions prises lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 15 juin 2007

Il a été décidé:
- de rayer Messieurs Paul Chehab et John Comery, en tant que Gérants de la Société, et de nommer Monsieur Pierre

Lalonde, né le 13 août 1954, résidant à 813, Chemin Marie-le-Ber, Verdun (Québec) H3E 1Y5, Canada, en tant que
nouveau Gérant de la société, avec effet immédiat, pour un mandat à durée indéterminée.

En plus de Madame Jacqueline Kost et de Monsieur Kuy Ly Ang.

Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007102224/7446/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2007, réf. LSO-CH07774. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070115908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2007.

Paunsdorf/Zwickau Arcaden, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.143.

<i>Extraits des résolutions et décisions prises lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 15 juin 2007

Il a été décidé:

101517

- de rayer Messieurs Paul Chehab et John Comery, en tant que Gérants de la Société, et de nommer Monsieur Pierre

Lalonde, né le 13 août 1954, résidant à 813, Chemin Marie-le-Ber, Verdun (Québec) H3E 1Y5, Canada, en tant que
nouveau Gérant de la société, avec effet immédiat, pour un mandat à durée indéterminée.

En plus de Madame Jacqueline Kost et de Monsieur Kuy Ly Ang.

Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007102223/7446/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2007, réf. LSO-CH07776. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070115905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2007.

Paunsdorf Centre Luxco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.927.

<i>Extraits des résolutions et décisions prises lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 15 juin 2007

Il a été décidé:
- de rayer Messieurs Paul Chehab et John Comery, en tant que Gérants de la Société, et de nommer Monsieur Pierre

Lalonde, né le 13 août 1954, résidant à 813, Chemin Marie-le-Ber, Verdun (Québec) H3E 1Y5, Canada, en tant que
nouveau Gérant de la société, avec effet immédiat, pour un mandat à durée indéterminée.

En plus de Madame Jacqueline Kost et de Monsieur Kuy Ly Ang.

Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007102222/7446/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2007, réf. LSO-CH07777. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070115900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2007.

Ivanhoe Europe Equities, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.039.

<i>Extraits des résolutions et décisions prises lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 15 juin 2007

Il a été décidé:
- de rayer Messieurs Paul Chehab et John Comery, en tant que Gérants de la Société, et de nommer Monsieur Pierre

Lalonde, né le 13 août 1954, résidant à 813, Chemin Marie-le-Ber, Verdun (Québec) H3E 1Y5, Canada, en tant que
nouveau Gérant de la société, avec effet immédiat, pour un mandat à durée indéterminée.

En plus de Madame Jacqueline Kost et de Monsieur Kuy Ly Ang.

Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007102221/7446/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2007, réf. LSO-CH07778. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070115875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2007.

Wilmersdorfer Arcaden Luxco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.160.

<i>Extraits des résolutions et décisions prises lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 15 juin 2007

Il a été décidé:

101518

- de rayer Messieurs Paul Chehab et John Comery, en tant que Gérants de la Société, et de nommer Monsieur Pierre

Lalonde, né le 13 août 1954, résidant à 813, Chemin Marie-le-Ber, Verdun (Québec) H3E 1Y5, Canada, en tant que
nouveau Gérant de la société, avec effet immédiat, pour un mandat à durée indéterminée.

En plus de Madame Jacqueline Kost et de Monsieur Kuy Ly Ang.

Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007102219/7446/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2007, réf. LSO-CH07775. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070115871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2007.

Ivanhoe Europe Capital, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.008.

<i>Extraits des résolutions et décisions prises lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 15 juin 2007

Il a été décidé:
- de rayer Messieurs Paul Chehab et John Comery, en tant que Gérants de la Société, et de nommer Monsieur Pierre

Lalonde, né le 13 août 1954, résidant à 813, Chemin Marie-le-Ber, Verdun (Québec) H3E 1Y5, Canada, en tant que
nouveau Gérant de la société, avec effet immédiat, pour un mandat à durée indéterminée.

En plus de Madame Jacqueline Kost et de Monsieur Kuy Ly Ang.

Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007102220/7446/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2007, réf. LSO-CH07779. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070115874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2007.

Traction S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 82.284.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 16 juillet 2007

Monsieur Kara Mohammed, Monsieur Reggiori Robert et Monsieur Heitz Jean-Marc sont renommés administrateurs

pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur De Bernardi Alexis est renommé commissaire aux comptes pour la
même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Pour extrait sincère et conforme
TRACTION S.A.
R. Reggiori / M. Kara
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007102217/545/18.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2007, réf. LSO-CH08531. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070115758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2007.

Independance et Expansion SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 34.355.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2007

En date du 22 juin 2007, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

101519

- de renouveler les mandats de Monsieur Jean-Marie Rinie, de Monsieur Antoine Gilson De Rouvreux, de Monsieur

Vincent Marc, de Monsieur William de Durand de Premorel-Higgons et de Monsieur Dominique Nouvellet en qualité
d'Administrateurs, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2008.

Luxembourg, le 25 juin 2007.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2007102216/1024/18.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2007, réf. LSO-CG05647. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070115725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2007.

Lombard Odier Darier Hentsch Selective, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 45.036.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2007

En date du 31 mai 2007, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de M. Patrick Odier, M. Yvar C. Mentha, M. Jacques Elvinger, M. Peter E.F. Newbald, M.

Jean-Claude Ramel, M. Stefan Bichsel et M. Patrick Zurstrassen en qualité d'administrateurs pour une durée d'un an,
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires en 2008.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2007.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2007102210/1024/18.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2007, réf. LSO-CH03715. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070115673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2007.

J. Hirsch &amp; Co International, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 102.323.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale du 18 juin 2007

- Les mandats de Gérant de Messieurs Adrien Coulombel et de Christophe Blondeau sont reconduits pour une nouvelle

période statutaire de un an. Ils viendront a à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2007.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2007.

Certifié sincère et conforme
J. HIRSCH &amp; CO INTERNATIONAL Sàrl
A. Coulombel / C. Blondeau
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2007101932/565/18.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2007, réf. LSO-CH08305. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070115239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

101520


Document Outline

Abundancia de Vida S.à r.l.

Adjutoris Conseil

Amberlux

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

Bantleon Invest S.A.

Belux Services S.à r.l.

Cafco International S.A.

CEP II Co-Investment S.à r.l. SICAR

CEP II Participations S.à r.l. SICAR

CeraTech S.à r.l.

CeraTech S.à r.l.

Compagnie d'Uzaru

CVI GVF Luxembourg Six S.à r.l.

Dexamenos Développement

Dusseldorf Arcaden Luxco

Düsseldorf/Wilmersdorfer Arcaden

Electricité du Grand Duché de Luxembourg S.A.

Everyday Media S.A.

Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise S.A.

Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise S.A.

Geosite C Sàrl

Geosite LM Sàrl

GTA 2 S. à r. l.

GTC S. à r. l.

GVI GVF Luxembourg Eight S.à r.l.

Humboldt Multi Invest Management Company S.à r.l.

IKO 2 S.A.

ILAWA Investment S.à r.l.

ILP III Participations S.à r.l.

Independance et Expansion SICAV

Ivanhoe Europe Capital

Ivanhoe Europe Equities

J. Hirsch &amp; Co International

Lombard Odier Darier Hentsch Selective

LSF4 Mega Investments II S.àr.l.

Media Tele S.A.

Medrom S.A.

M. Organisation S.à r.l.

MSREF VI Spirit S.à r.l.

Nomura Funds

Opus Investment S.à r.l.

Parfood Invest S.A.

Paunsdorf Centre Luxco

Paunsdorf/Zwickau Arcaden

Power Investment S.A.

Prinus Invest S.A.

Ryburton Holding S.A.

Traction S.A.

Venus Finance S.à r.l.

Weinberg Real Estate S.à r.l.

Wilmersdorfer Arcaden Luxco

Zwickau Arcaden Luxco