logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2104

26 septembre 2007

SOMMAIRE

Access Storage Holdings (France), S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100980

American Clothing Retail S.A.  . . . . . . . . . .

100978

Andar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100961

Beenyn Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

100986

Blue River Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

100989

BNP Paribas Securities Services - Succur-

sale de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100991

Bureau Economique de Gestion et Holding

International - S.A.B.E.G.H.I.N.  . . . . . . . .

100946

Coal & Oil Trade Company S.A. . . . . . . . . .

100968

Coffee Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

100990

Cordura Property S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

100979

CVI GVF Luxembourg Five S.à r.l.  . . . . . . .

100962

CVI GVF Luxembourg Four S.à r.l.  . . . . . .

100969

DAB Investments Luxembourg SNC . . . . .

100977

Del Monte Finance Luxembourg S.A.  . . . .

100977

Elgae S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100953

Emeth Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100946

Euro-Packaging S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100962

Expanco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100975

Fashion and Cosmetics Isabelle T . . . . . . . .

100952

Fashion and Cosmetics Isabelle T . . . . . . . .

100953

Financière le Rachinel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

100969

Financière Light III S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

100976

Flag Distribution S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100979

Flag Distribution S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100980

Gramont S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100991

Groupe CNS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100976

Hailey Investments Sp. z o.o. Luxembourg

Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100981

Ifonas Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100961

Immo-Euro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100979

International Paper Investments (Luxem-

bourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100983

International Sporting Travel S.A.  . . . . . . .

100990

Java S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100987

Joy Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100987

Lasting Placement Holding SA  . . . . . . . . . .

100989

Lehman Brothers (Luxembourg) Equity Fi-

nance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100980

Magdalena S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100992

Mantilla S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100988

Nature and Health Investments SAH  . . . .

100977

N.D. Associés Financière Immo Europe

(F.I.E.) S.C.P.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100992

Nouveaux Ets. Liebaert S.à r.l.  . . . . . . . . . .

100982

Pao de Açucar International S.A.  . . . . . . . .

100976

Parkridge Italy Offices S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

100946

Parkridge Retail Ukraine S.à r.l.  . . . . . . . . .

100946

Par Trois S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100991

Par Trois S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100952

Par Trois S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100952

PICO Invest HSA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100953

Rether Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100978

Russian Investment Company  . . . . . . . . . . .

100981

S.E.B. ImmoInvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

100987

Socavia II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100979

Studio Cophia, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100981

Tensor Property Investments S.à r.l. . . . . .

100989

Tribune S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100978

Tribune S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100990

Universal Business S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

100981

Universal Luxembourg Holding  . . . . . . . . .

100992

Venus Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100977

Wefra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100946

Wolseley Finance (Rockhopper) S.à r.l.  . .

100976

Worldwide International Trade  . . . . . . . . .

100982

Xantra S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100978

Zentralux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100980

100945

Bureau Economique de Gestion et Holding International - S.A.B.E.G.H.I.N., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 15.543.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007100265/5863/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007, réf. LSO-CH04909. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070113258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Emeth Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 101.186.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007100266/5863/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007, réf. LSO-CH04923. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Wefra, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 12.637.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007100268/5863/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007, réf. LSO-CH04911. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Parkridge Retail Ukraine S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Parkridge Italy Offices S.à r.l.).

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 127.301.

In the year two thousand seven, on the eighth day of August.
Before Mr Jean Seckler, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The company PARKRIDGE WESTERN EUROPEAN HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company «société à

responsabilité limitée», incorporated under Luxembourg law, with registered office in L-1130 Luxembourg, 37, rue d'An-
vers, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 127.305,

duly represented by Maître Catherine Delsemme, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg, by virtue

of a proxy given on private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be registered at the same time with the registration authorities.

The presaid PARKRIDGE WESTERN EUROPEAN HOLDINGS S.à r.l. is the sole member of the company PARKRIDGE

ITALY OFFICE S.à r.l., with registered office in L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 127.301, incorporated by a deed received by the
undersigned notary on April 19, 2007, (hereinafter referred to as the «Company»).

100946

Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity of sole member of the Company, has requested

the undersigned notary to state its following resolutions:

<i>First resolution

The sole member resolves to change the name of the Company into PARKRIDGE RETAIL UKRAINE S.à r.l.

<i>Second resolution

The sole member resolves to amend Article 1 of the articles of association of the Company so as to reflect the change

of name of the Company.

Consequently, Article 1 of the articles of association of the Company shall henceforth be read as follows:
«There is hereby established between the subscribers and all those who may become members in the future, a cor-

poration  with  limited  liability  («société  à  responsabilité  limitée»)  governed  by  Luxembourg  law,  under  the  name  of
PARKRIDGE RETAIL UKRAINE S.à r.l. (hereinafter referred to as the «Corporation»).»

<i>Third resolution

The sole member resolves to adopt a nominal value often cents (EUR 0.10) per unit and to exchange the one hundred

and twenty-five (125) units with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each for one hundred and twenty-five
thousand (125,000) units with a par value of ten cents ( EUR 0.10) each.

<i>Fourth resolution

The sole member resolves to create two categories of corporate units namely the preference units (the «Preference

Units») and the ordinary units (the «Ordinary Units») having the same rights and obligations, save that:

(i) with respect to the distribution policy, the profits of the Company available for distribution shall be used to pay

dividends in the following order of priority:

a. first, in paying to the holders of the Preference Units a fixed cumulative dividend of 3% above the Interbank Offer

Rate (per annum) for deposits of the relevant amount in Euros for a 3 month period (EURIBOR) per annum accruing
from the date of subscription and payable quarterly in arrears each 31 December, 31 March, 30 June, and 30 September
in each year with the first payment due on 30 September 2007 (the «Preference Dividend»); and

b. second, to the holders of the Ordinary Units any amount that the Members may decide.
(ii) with respect to any return of assets on a winding up or capital reduction or otherwise, the assets of the Company

shall be applied in the following order of priority:

a. first, in paying to the holder of the Preference Units EUR 0.10 per Unit together with a sum equal to any arrears or

accruals of the Preference Dividend calculated down to the date of return of capital; and

b. second, in paying to the holder of the Ordinary Units EUR 0.10 per Unit and the balance of the assets shall be

distributed amongst the holders of the Ordinary Units in proportion to the number of Ordinary Units held by them
respectfully.

<i>Fifth resolution

The sole member resolves to convert one hundred and twenty five thousand (125,000.-) units having a par value often

cents (EUR 0.10) each into one hundred and twenty five thousand (125,000) Ordinary Units having a par value often cents
(EUR 0.10) each.

<i>Sixth resolution

The sole member resolves that the corporate capital of the Company will then be set at twelve thousand five hundred

euros (EUR 12,500.-) represented by one hundred and twenty-five thousand (125,000) units having a par value of ten
cents (EUR 0.10) each, divided into none (0) Preference Units and one hundred and twenty-five thousand (125,000)
Ordinary Units (together with the Preference Units, the «Units»). The sole member resolves that the legal majority
requirements or the majority requirements stated in the Articles of Association of the Company will not need to be met
in each category of Units, except when the rights of one of the category of Units are particularly concerned.

<i>Seventh resolution

The sole member resolves (i) to create an authorized capital in an aggregate maximum amount of one hundred millions

euros (EUR 100,000,000.-), which can be subscribed exclusively by the holder of the Preference Units, and (ii) to grant
a relating power of attorney to the board of managers of the Company for a period of five years starting from the date
of publication of the present resolutions, to increase the share capital of the Company within the amount of the authorised
capital and to issue Preference Units by way of board meetings.

<i>Eighth resolution

The sole member resolves to amend Article 5 of the Articles of Association of the Company, which shall henceforth

be read as follows:

«The subscribed share capital of the Corporation is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), rep-

resented by one hundred and twenty-five thousand units (125,000) having a par value often cents (EUR 0.10) each, divided

100947

into none (0) preference units (the «Preferences Units») and one hundred and twenty-five thousand (125,000) ordinary
units (the «Ordinary Units» and, together with the Preference Units, the «Units»).

The legal majority requirements or the majority requirements stated in the Articles of Association of the Corporation

will not need to be met in each class of Units, except when the rights of one of the class of Units are particularly concerned.

The share capital may be increased or decreased by a decision of the sole member or pursuant to a resolution of the

partners as the case may be.

The share capital may further be increased by a resolution of the manager or of the board of managers as set forth

hereafter.

The  authorised  capital  is  fixed  at  one  hundred  million  euros  (EUR  100,000,000.-)  represented  by  one  billion

(1,000,000,000) units having a par value of ten cents (EUR 0.10) each, divided into one billion (1,000,000,000) Preference
Units with a par value of ten cents (EUR 0.10 ) each, and none (0) Ordinary Units.

The manager or the board of managers is (are) authorized and empowered during a period ending five years after the

publication date of the present resolutions to amend the articles of association of the Company in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, to realise any increase of the share capital of the Company within the limits of the authorised
capital in one or several times.

Such increased amount of capital may be issued exclusively for and subscribed by the holders of the Preference Units

and under the terms and conditions as the manager or the board of managers may determine, more specifically only in
respect to the subscription and payment of the Preference Units to be issued and subscribed, such as to determine the
time and the number of the Preference Units to be issued and subscribed, to determine if the Preference Units are to be
subscribed with or without an issue premium, to determine to what extent the payment of the newly subscribed Pref-
erence Units is acceptable either on cash or assets other than cash.

The manager or the board of managers may delegate to any duly authorised manager or officer of the Company or

to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for Preference Units
representing part or all of such increased amount of share capital.

Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by the commercial companies

Act dated 10 August 1915 as amended, the first paragraph of this article will be amended so as to reflect the actual
increase; such amendment will be recorded in authentic form by the manager or the board of managers or by any person
duly authorized and empowered by it for this purpose within one month from the end of the subscription period or
within three months from the day on which that period began.

The Preference Units and the Ordinary Units shall have the same rights and obligations, save that:
(i) with respect to the distribution policy, the profits of the Company available for distribution shall be used to pay

dividends in the following order of priority:

(a) first, in paying to the holders of the Preference Units a fixed cumulative dividend of 3% above the Interbank Offer

Rate (per annum) for deposits of the relevant amount in Euros for a 3 month period (EURIBOR) per annum accruing
from the date of subscription and payable quarterly in arrears each 31 December, 31 March, 30 June, and 30 September
in each year with the first payment due on 30 September 2007(the «Preference Dividend»); and

(b) second, to the holders of the Ordinary Units any amount that the Members may decide.
(ii ) with respect to any return of assets on a winding up or capital reduction or otherwise, the assets of the Company

shall be applied in the following order of priority:

(a) first, in paying to the holder of the Preference Units EUR 0.10 per Unit together with a sum equal to any arrears

or accruals of the Preference Dividend calculated down to the date of return of capital; and

(b) second, in paying to the holder of the Ordinary Units EUR 0.10 per unit and the balance of the assets shall be

distributed amongst the holders of the Ordinary Units in proportion to the number of Ordinary Units held by them
respectfully.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single member or, as the case may be, by

decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these Articles of
Association.»

<i>Ninth resolution

The sole member resolves to amend Article 20 of the Articles of Association of the Company, which shall henceforth

be read as follows:

«In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members resolving such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation.

In the event of any return of assets on a winding up or capital reduction or otherwise, the assets of the Company shall

be applied in the following order of priority:

(a) first, in paying to the holder of the Preference Units EUR 0.10 per Unit together with a sum equal to any arrears

or accruals of the Preference Dividend calculated down to the date of return of capital; and

100948

(b) second, in paying to the holder of the Ordinary Units EUR 0.10 per Unit and the balance of the assets shall be

distributed amongst the holders of the Ordinary Units in proportion to the number of Ordinary Units held by them
respectfully.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring

the Corporation to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Corporation shall be allocated to the members proportionally

to the Units they hold in the Corporation.»

<i>Tenth resolution

The sole member resolves to amend Article 11 paragraph 2 of the Articles of Association of the Company, which shall

henceforth be read as follows:

«The managers are appointed by the sole member or by the general meeting of members as the case may be and may

be removed at any time at the sole discretion of the sole member or of the general meeting of members as the case may
be which determines their powers, compensation and duration of their mandates.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Corporation, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately one thousand two hundred and fifty euros.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the Office, on the day stated at the beginning of

this document.

The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, he/she signed together with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le huit août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire, de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société PARKRIDGE WESTERN EUROPEAN HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée «société à

responsabilité limitée», constituée selon la loi luxembourgeoise, avec siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.305,

dûment représentée par Maître Catherine Delsemme, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexé au

présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La société préqualifiée PARKRIDGE WESTERN EUROPEAN HOLDINGS S.à r.l. est l'associée unique de la société

PARKRIDGE ITALY OFFICE S.à r.l., ayant son siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.301, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 19 avril 2007, (ci-après la «Société»).

Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d'associée unique de la Société a demandé

au notaire instrumentant d'acter ses résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide de changer le nom de la Société en PARKRIDGE RETAIL UKRAINE S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L'associée unique décide de modifier l'article 1 

er

 des statuts de la Société afin de refléter le changement de dénomi-

nation sociale.

En conséquence, l'article 1 

er

 des statuts de la Société devra désormais être lu comme suit:

Il est créé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront associés dans le futur, une société à responsabilité

limitée régie par le droit luxembourgeois sous le nom de PARKRIDGE RETAIL UKRAINE S.à r.l. (ci-après dénommée la
«Société»).

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide d'adopter une valeur nominale de dix cents (EUR 0,10) par part sociale et d'échanger les cent

vingt-cinq (125) parts sociales avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune pour cent vingt-cinq mille
(125.000) parts sociales d'une valeur nominale de dix cents (EUR 0,10) chacune.

100949

<i>Quatrième résolution

L'associé unique décide de créer deux catégories de parts sociales nommées les parts sociales préférentielles (les

«Parts sociales Préférentielles») et les parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») ayant les mêmes droits
et obligations excepté que:

(i) en relation avec la politique de distribution, les profits de la Société disponibles pour la distribution seront utilisés

pour payer des dividendes dans l'ordre de priorité suivant:

(a) en premier, en payant les détenteurs de parts sociales préférentielles un dividende fixe cumulatif de 3 % au-dessus

du Interbank Offer Rate (par an) pour les dépôts des montants concernés pour une période de 3 mois (EURIBOR), par
an, augmenté à partir de la date de souscription et payable par trimestre arriérés chaque 31 décembre, 31 mars, 30 juin,
et 30 septembre de chaque année avec le premier paiement due au 30 septembre 2007 (les «Dividendes Préférentiels»);
et

(b) en second, aux détenteurs des parts sociales ordinaires, tout montant que les Associés peuvent décider.
(ii) concernant tout retour d'actif sur une dissolution ou une réduction de capital ou autre, les actifs de la Société

seront traités dans l'ordre de priorité suivant:

(a) d'abord, en payant le détenteur de parts sociales préférentielles EUR 0,10 par part ensemble avec une somme égale

à tout arriéré ou accumulation des Dividendes Préférentiels calculé à partir de la date de retour de capital; et

(b) en second, en payant le détenteur des parts ordinaires EUR 0,10 par part et le solde des actifs sera distribué parmi

les détenteurs de parts sociales ordinaires en proportion du nombre des parts sociales ordinaires qu'ils détiennent res-
pectivement.

<i>Cinquième résolution

L'associé unique décide de convertir cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales ayant une valeur nominale de dix

cents (EUR 0,10) chacune en cent vingt-cinq mille (125.000) Parts Sociales Ordinaires ayant une valeur nominale de dix
cents (EUR 0,10) chacune.

<i>Sixième résolution

L'associé unique décide que le capital social de la Société sera ensuite fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-)

représenté par cent vingt-cinq mille parts sociales (125.000) ayant une valeur nominale de dix cents (EUR 0,10) chacune,
divisée en aucune (0) Part Sociale Préférentielle et cent vingt-cinq mille (125.000) Parts Sociales Ordinaires (ensemble
avec les Parts Sociales Préférentielles, les «Parts Sociales»). L'associé unique décide que les exigences de majorité légale
ou de majorité requise par les Statuts de la Société n'auront pas besoin d'être réunies dans chaque catégorie de Parts
Sociales, excepté lorsque les droits de l'une des catégories de Parts Sociales sont particulièrement concernés.

<i>Septième résolution

L'associé  unique  décide  de  créer  un  capital  autorisé  d'un  montant  total  maximum  de  cent  million  d'euros  (EUR

100.000.000,-) qui peuvent être souscrits exclusivement par les détenteurs des Parts Sociales Préférentielles et de donner
pouvoir au conseil de gérance de la Société pour une période de cinq ans commençant à la date de publication des
présentes  résolutions,  d'augmenter  le  capital  social  de  la  Société  dans  les  limites  du  montant  du  capital  autorisé  et
d'émettre des Parts Sociales Préférentielles par le biais d'une réunion du conseil de gérance.

<i>Huitième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 5 des Statuts de la Société qui devra désormais être lu comme suit:
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-

cinq mille parts sociales (125.000) ayant une valeur nominale de dix cents (EUR 0,10) chacune, divisé en aucune (0) part
sociale préférentielle (les «Parts Sociales Préférentielles») et cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales ordinaires (les
«Parts Sociales Ordinaires» ensemble avec les Parts Sociales Préférentielles, ci après les «Parts Sociales»).

Les exigences de majorité légale ou de majorité requise par les Statuts de la Société n'auront pas besoin d'être réunies

dans chaque catégorie de Parts Sociales, excepté lorsque les droits de l'une des catégories de Parts Sociales sont parti-
culièrement concernés.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par une décision de l'associé unique ou selon une décision de l'assemblée

des associés selon le cas.

Le capital social peut aussi être augmenté par une décision du gérant unique ou du conseil de gérance comme établi

ci-après.

Le capital autorisé est fixé à cent millions d'euros (EUR 100.000.000,-) représenté par un milliard (1.000.000.000) de

parts sociales ayant une valeur nominale de dix cents (EUR 0,10) chacune, divisé en un milliard (1.000.000.000) de Parts
Sociales Préférentielles avec une valeur nominale de dix cents (EUR 0,10) chacune et aucune (0) Part Sociale Ordinaire
avec une valeur nominale de dix cents (EUR 0,10) chacune.

Le gérant unique ou le conseil de gérance est autorisé durant une période de cinq ans après la date de la publication

des présentes résolutions modifiant les statuts au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association, de réaliser toute aug-
mentation de capital dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs fois.

100950

Cette augmentation du capital social peut être exclusivement émise au bénéfice et souscrite par des détenteurs des

Parts Sociales Préférentielles et sous les termes et conditions que le gérant unique ou le conseil de gérance peut déter-
miner,  plus  spécifiquement  concernant  la  souscription  et  paiement  des  Parts  Sociales  Préférentielles  à  émettre  et  à
souscrire, en déterminant si les Parts Sociales Préférentielles sont à souscrire avec ou sans prime d'émission, en déter-
minant si le paiement des nouvelles Parts Sociales Préférentielles souscrites peut être effectué soit en numéraire soit en
actif autres qu'en numéraire.

Le gérant ou le conseil de gérance peut déléguer a tout gérant ou organe dûment autorisé de la Société ou à toute

autre personne dûment autorisée, la tâche d'accepter des souscriptions et de recevoir le paiement pour les Parts Sociales
Préférentielles représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Suivant chaque augmentation de capital réalisée et dûment établie dans la forme prévue par la loi, le premier paragraphe

de cette article sera modifié afin de refléter l'augmentation en cause, cette modification sera constatée par acte authen-
tique par le(s) gérants ou par toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet dans le mois à partir de la fin de
la période de souscription ou dans les trois mois à partir du jour où la période a commencé.

Les Parts Sociales Préférentielles et les Parts Sociales Ordinaires auront les mêmes droits et obligations excepté:
(i) en relation avec la politique de distribution, les profits de la Société disponibles pour la distribution seront utilisés

pour payer des dividendes dans l'ordre de priorité suivant:

(a) en premier, en payant les détenteurs de Parts Sociales Préférentielles un dividende fixe cumulatif de 3 % au-dessus

du Interbank Offer Rate (par an) pour les dépôts des montants concernés pour une période de 3 mois (EURIBOR), par
an, augmenté à partir de la date de souscription et payable par trimestre arriérés chaque 31 décembre, 31 mars, 30 juin,
et 30 septembre de chaque année avec le premier paiement du au 30 septembre 2007 (les «Dividendes Préférentiels»);
et

(b) en second, aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, tout montant que les Associés peuvent décider.
(ii) concernant tout retour d'actif sur une dissolution ou une réduction de capital ou autre, les actifs de la Société

seront traités dans l'ordre de priorité suivant:

(a) d'abord, en payant le détenteur de Parts Sociales Préférentielles EUR 0,10 par part ensemble avec une somme égale

à tout arriéré ou accumulation des Dividendes Préférentiels calculé à partir de la date de retour de capital; et

(b) en second, en payant le détenteur des Parts Sociales Ordinaires EUR 0,10 par part et le solde des actifs sera distribué

parmi les détenteurs de parts sociales ordinaires en proportion du nombre des parts sociales ordinaires qu'ils détiennent
respectivement.

Le capital social souscrit peut être changé à tout moment par une décision du seul associé ou, le cas échéant, par

décision de l'assemblée des associés délibérant comme en matière de modification de ces Statuts.»

<i>Neuvième résolution

L'associé unique décide de modifier l'Article 20 des statuts de la Société qui devra désormais être lu comme suit:
«En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des

personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déterminera
leurs pouvoirs et leur rémunération.

En cas de tout retour d'actif sur une dissolution ou une réduction de capital ou autre, les actifs de la Société seront

traités dans l'ordre de priorité suivant:

(a) d'abord, en payant le détenteur de Parts Sociales Préférentielles EUR 0,10 par part ensemble avec une somme égale

à tout arriéré ou accumulation des Dividendes Préférentiels calculé à partir de la date de retour de capital; et

(b) en second, en payant le détenteur des Parts Sociales Ordinaires EUR 0,10 par part et le solde des actifs sera distribué

parmi les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires en proportion du nombre des Parts Sociales Ordinaires qu'ils détiennent
respectivement.

Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés ne

mettra pas fin à l'existence de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux Parts Sociales

qu'ils détiennent dans la Société.»

<i>Dixième résolution

L'Associé unique décide de modifier l'Article 11 paragraphe 2 des Statuts de la Société qui devra désormais être lu

comme suit:

«Les gérants sont nommés par le seul associé ou par l'assemblée générale des associés le cas échéant et peut être

révoqué à tout moment à la seule discrétion de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés le cas échéant
qui détermine leur pouvoirs, la rémunération et la durée de leur mandats.»

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à mille deux cent cinquante euros.

100951

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante ci-dessus,

dûment représentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A à la demande de la même
personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, le présent acte est dressé à Luxembourg, en l'Etude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire, ès-qualité qu'elle agit, elle a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Delsemme, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 août 2007. Relation GRE/2007/3631. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 16 août 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007100152/231/308.
(070113248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Par Trois S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 125.535.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2007.

PAR TROIS S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007100290/4/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06501. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Par Trois S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 125.535.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2007.

PAR TROIS S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007100291/4/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06500. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Fashion and Cosmetics Isabelle T, Société Anonyme.

Siège social: L-2410 Luxembourg, 164, rue de Reckenthal.

R.C.S. Luxembourg B 45.786.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2007.

FIDUCIAIRE B+C s.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2007100292/7759/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2007, réf. LSO-CG10805. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

100952

Fashion and Cosmetics Isabelle T, Société Anonyme.

Siège social: L-2410 Luxembourg, 164, rue de Reckenthal.

R.C.S. Luxembourg B 45.786.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2007.

FIDUCIAIRE B + C s.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2007100293/7759/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2007, réf. LSO-CG10806. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070113540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

PICO Invest HSA, Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 41.331.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2007.

FIDUCIAIRE B + C s.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2007100294/7759/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2007, réf. LSO-CG10809. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Elgae S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 130.770.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-seventh of July.
Before US Maître Patrick Serres, notary residing in Remich, acting in replacement of Maître Martine Schaeffer, notary

residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present minutes.

There appeared:

1) P4 SUB L.P.1 a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995

(as amended), acting by its manager, PERMIRA IV MANAGERS L.P., a limited partnership registered in Guernsey under
the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995 (as amended), acting by its general partner PERMIRA IV MANAGERS
LIMITED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, here
represented by Cédric Pedoni, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in
Guernsey, on July 26, 2007;

2) PERMIRA IV L.P.2 a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law,

1995 (as amended), acting by its manager, PERMIRA IV MANAGERS L.P., a limited partnership registered in Guernsey
under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995 (as amended), acting by its general partner PERMIRA IV MAN-
AGERS LIMITED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,
here represented by Cédric Pedoni, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in
Guernsey, on July 26, 2007;

3) P4 Co-INVESTMENT L.P., acting by its general partner PERMIRA IV G.P. L.P., acting by its general partner PERMIRA

IV GP LIMITED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, here
represented by Cédric Pedoni, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in
Guernsey, on July 26, 2007;

4) PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, acting by its nominee PERMIRA NOMINEES LIMITED whose registered office

is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, here represented by Cédric Pedoni, with
professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on July 26, 2007.

100953

The said powers of attorneys, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing persons and the notary, will

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in his here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he deems to incorporate and the
articles of association of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of ELGAE S.àr.l. (hereinafter the

«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as
well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participating interests, in any

form whatsoever, in Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, to acquire patents and licences, to
manage and develop them.

The Company may borrow and raise funds, including, but not limited to, borrowing money in any form or obtaining

any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, debentures,
promissory notes, and other debt or equity instruments, convertible or not, on a private basis for the purpose listed
above.

The Company can also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into

any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the
financial sector:

- lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to

its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies;

- give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its

assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and,
generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person;

- enter into agreements, including, but not limited to any kind of credit derivative agreements, partnership agreements,

underwriting  agreements,  marketing  agreements,  distribution  agreements,  management  agreements,  advisory  agree-
ments, administration agreements and other services contracts, selling agreements, or other in relation to its purpose;

The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to

enhance the above-mentioned objectives as well as operations directly or indirectly linked to the activities described in
this article.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the City of Luxembourg by means of a resolution of the Board of Managers. Branches or other offices may be established
either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of

shares in existence.

Art. 6. The shares held by the sole partner are freely transferable among living persons and by way of inheritance or

in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more partners, the shares are freely transferable among partners. In the same case they are transferable to

non-partners only with the prior approval of the partners representing at least three quarters of the capital. In the same
case the shares shall be transferable because of death to non-partners only with the prior approval of the owners of
shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the decision of the sole partner or, should this happen, by

approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the disso-

lution of the Company.

100954

C. Management

Art. 10. The Company shall be managed by a board of managers composed of two members at least, who need not

be partners of the Company.

The managers shall be elected by a resolution of the partners for an unlimited duration. A manager may be removed

with or without cause and replaced at any time by a resolution adopted by the partners.

In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, the remaining managers

may elect, by majority vote, a manager to fill such vacancy until the next resolution of the partners ratifying such election.

Art. 11. The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the board of managers and of the partners.

The board of managers shall meet upon call by the chairman or two managers at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of partners and the board of managers, but in his absence the managers or

the board of managers may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in

advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or
e-mail of each manager.

Separate notice shall not be required for meetings at which all the managers are present or represented and have

declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax or, provided the

genuineness thereof is established, electronic transmission, another manager as his proxy.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decision shall be taken by a majority of the votes of the managers present or
represented at such meeting.

In the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company

(other than that arising by virtue of serving as a manager, officer or employee in the other contracting party), such manager
shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions,
and such manager's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of partners.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communications. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the chairman pro tempore who presided at such meeting, or by two managers.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 13. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the resolution of the
partners fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board who may
constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons who need not be managers, appoint and dismiss all officers and employees and fix their
remuneration.

Art. 14. The Company will be bound by the sole signature of any manager of the Company, as well as by the joint or

single signature of any person or persons to whom specific signatory powers shall have been delegated by the board of
managers.

Art. 15. To the extent permissible under Luxembourg Law and provided that, to the extent applicable, discharge has

been granted by the general meeting of shareholders for any liability resulting from the performance of their duties, the
Managers, auditor, secretary and other officers, servants or agents for the time being of the Company shall be indemnified
out of the assets of the Company from and against all actions, costs, charges, losses, damages and expenses, which they
or any of them shall or may incur or sustain by reason of any contract entered into or any act done, concurred in, or

100955

omitted, on or about the execution of their duty or supposed duty or in relation thereto except such (if any) as they shall
incur or sustain by or through their own willful act, neglect or default respectively and except as provided for in article
59 paragraph 2 of the Luxembourg company law, and none of them shall be answerable for the act, receipts, neglects or
defaults of the other or others of them, or for joining in any receipt for the sake of conformity, or for any bankers or
other persons with whom any moneys or effects belonging to the Company shall or may be lodged or deposited for safe
custody, or for any bankers, brokers, or other persons into whose hands any money or assets of the Company may come,
or for any defect of title of the Company to any property purchased, or for the insufficiency or deficiency or defect of
title of the Company, to any security upon which any moneys of the Company shall be invested, or for any loss or damage
occasioned by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever
which shall happen in the execution of their respective offices or in relation thereto, except the same shall happen by or
through their own willful neglect or default respectively.

D. Decisions of the Sole Partner - Collective decisions of the partners

Art. 16. The sole partner exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of section XII

of the law of August 10, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions, which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
In case of more partners the decisions, which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.
Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares, which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Any issuance of shares as a result of the conversion of convertible bonds or other similar financial instruments shall

mean the convening of a prior general meeting of partners in accordance with the provisions of Article 7 above. Each
convertible bond or other similar financial instrument shall be considered for the purpose of the conversion as a sub-
scription for shares to be issued upon conversion.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 17. The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the

same year.

Art. 18. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amount to one tenth of the issued capital but must

be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.

The excess is attributed to the sole partner or distributed among the partners. However, the sole partner or, as the

case may be, the meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit,
after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 19. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners, which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization
of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:

- P4 SUB L.P.1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,430
- PERMIRA IV L.P.2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,816
- P4 Co-INVESTMENT L.P.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

- PERMIRA INVESTMENTS LIMITED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

198

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR)

is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

100956

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,

2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately two thousand one hundred euro (EUR 2,100.-).

<i>General meeting of partners

Immediately after the incorporation of the Company, the members, representing the entirety of the subscribed capital

has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 282, route de Longwy L-1940 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite duration:
- Séverine Michel, born on July 19, 1977 in Epinal, France, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940

Luxembourg.

- Paul Guilbert, born on February 20, 1961 in Salisbury, Great Britain, with professional address at Trafalgar Court,

Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernsey.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,

the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the mandatory of the persons appearing, said mandatory signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-sept juillet
Par-devant Nous Maître Patrick Serres, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de Maître Martine

Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente, laquelle dernière nommée restera dépositaire
du présent acte.

Ont comparu:

1) P4 SUB L.P.1 un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995,

agissant par son general partner, PERMIRA IV MANAGERS L.P., un limited partnership inscrite à Guernesey sous la loi
du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995, agissant par son general partner PERMIRA IV MANAGERS LIMITED avec
siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, dûment représenté par Cédric
Pedoni, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Guernesey le 26 juillet 2007;

2) PERMIRA IV L.P.2 un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de

1995, agissant par son general partner, PERMIRA IV MANAGERS L.P., un limited partnership inscrite à Guernesey sous
la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995, agissant par son general partner PERMIRA IV MANAGERS LIMITED
avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, dûment représenté par Cédric
Pedoni, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Guernesey le 26 juillet 2007;

3) P4 Co-INVESTMENT L.P., agissant par son general partner PERMIRA IV G.P. L.P., agissant par son general partner

PERMIRA IV GP LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,
dûment représenté par Cédric Pedoni, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
à Guernesey le 26 juillet 2007;

4) PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, agissant par son nominée PERMIRA NOMINEES LIMITED avec siège social à

Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, dûment représenté par Cédric Pedoni, avec
adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Guernesey le 26 juillet 2007.

Les procurations signées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts

d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ELGAE S.àr.l. (ci-après la «Société»)

laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations, sous quelque

forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères; l'acquisition de tous titres, droits et actifs par

100957

voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière, l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur.

La Société peut emprunter et lever des fonds, y compris, mais sans être limité à, emprunter de l'argent sous toutes

formes et obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers, y compris, mais sans être limité à, l'émission
d'obligations, de titres de prêt, de billets à ordre et d'autres titres de dette ou de capital convertibles ou non, dans le
cadre de l'objet décrit ci-dessus.

La Société peut également entrer dans les transactions suivantes, étant entendu que la Société n'entrera pas dans une

quelconque transaction qui l'engagerait dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité régle-
mentée du secteur financier:

- Accorder des prêts sans limitation à ses filiales, sociétés liées ou toute autre société, y compris, les fonds provenant

d'emprunts, d'émission de titres de prêt ou de titres de capital;

- Accorder des garanties, mises en gage, transférer, nantir, créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses

actifs, garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de tout autre société et, plus
généralement, dans son propre intérêt ou dans celui de toute autre société ou personne.

- entrer dans des accords, y compris, mais non limité à n'importe quelle sorte d'accords de dérivée de crédit, d'accords

d'association, d'accords de garantie, d'accords de marketing, d'accords de distribution, d'accords de gestion, d'accords
de conseil, d'accords d'administration et d'autres contrats de services, d'accords de vente, ou d'autre en rapport avec
son objet social.

La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont utiles

à la réalisation de son objet tel que décrit dans le présent article ainsi que des opérations directement ou indirectement
liées aux activités décrites dans cet article.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il pourra être transféré à n'importe

qu'elle autre place dans la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par
simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché du Luxembourg qu'à
l'étranger.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents

(12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Chaque part donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des

parts existantes.

Art. 6. Les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de succession

ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés
survivants.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l'associé unique ou si le cas se

réalise, moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés n'entraînent pas la dissolution de la

Société.

C. Gérance

Art. 10. La société est gérée par un conseil de gérance composé de deux membres au moins, lesquels ne seront pas

nécessairement associés de la Société.

Les gérants sont élus par une résolution des associés pour une durée illimitée. Un gérant peut être révoqué avec ou

sans motif et remplacé à tout moment par une décision des associés.

En cas de vacance d'un poste d'un gérant pour cause de décès, démission ou toute autre cause, les gérants restants

pourront élire, à la majorité des votes, un gérant pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la
confirmation de cette élection par les associés.

100958

Art. 11. Le conseil de gérance peut nommer un président parmi ses membres ainsi qu'un vice-président. Il pourra alors

être désigné un secrétaire, gérant ou non, qui sera en charge de la tenue des procès verbaux des conseils de gérance et
des associés.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le Président ou par deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis

de convocation.

Le Président est tenu de présider toutes les réunions d'associés et tous les conseils de gérance, cependant en son

absence les associés ou les membres du conseil de gérance pourront nommer un président pro-tempore par vote à la
majorité des voix présentes à cette réunion ou à ce conseil.

Un avis écrit portant sur toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt quatre

heures avant la date prévue pour ladite réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera men-
tionnée dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation écrite sur accord de chaque gérant donné
par écrit en original, téléfax ou e-mail.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil de gérance au cours desquelles l'ensemble

des gérants sont présents ou représentés et ont déclaré avoir préalablement pris connaissance de l'ordre du jour de la
réunion ainsi que pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution adoptée préala-
blement par le conseil de gérance.

Tout gérant peut se faire représenter aux conseils de gérance en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax,

soit par un moyen de communication électronique dont l'authenticité aura pu être établie, un autre gérant comme son
mandataire.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des membres est présente

ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à une telle réunion.

Au cas où un gérant de la Société aurait un intérêt personnel opposé dans une quelconque affaire de la Société (autre

qu'un intérêt opposé survenu en sa qualité de gérant, préposé ou employé d'une autre partie en cause) ce gérant devra
informer le conseil de gérance d'un tel intérêt personnel et opposé et il ne pourra délibérer ni prendre part au vote sur
cette affaire. Un rapport devra, par ailleurs, être fait au sujet de l'intérêt personnel et opposé de ce gérant à la prochaine
assemblée des associés.

Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, et
communiquer entre elles. Une réunion peut ainsi ne se tenir qu'au moyen d'une conférence téléphonique. La participation
par ce moyen à une réunion est considérée avoir été assurée en personne.

Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions portant sur un ou plusieurs documents par voie

circulaire pourvu qu'elles soient prises après approbation de ses membres donnée au moyen d'un écrit original, d'un
facsimile, d'un e-mail ou de tous autres moyens de communication. L'intégralité formera le procès-verbal attestant de la
résolution prise.

Art. 12. Les procès-verbaux des conseils de gérance seront signés par le Président et, en son absence, par le président

pro-tempore qui aurait assumé la présidence d'une telle réunion, ou par deux gérants.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le

secrétaire ou par deux gérants.

Art. 13. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et

d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents
statuts aux associés sont de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société pour

la gestion journalière, à tout gérant ou gérants, qui à leur tour peuvent constituer des comités délibérant dans les con-
ditions déterminées par le conseil de gérance. Il peut également conférer des pouvoirs et mandats spéciaux à toute
personne, gérant ou non, nommer et révoquer tous préposés, employés et fixer leurs émoluments.

Art. 14. La Société sera engagée par la seule signature de chacun des gérants de la Société ou encore par les signatures

conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auraient été délégués par le conseil
de gérance.

Art. 15. Pour autant que la Loi luxembourgeoise l'autorise et à condition que décharge ait été accordée par l'assemblée

générale des associés concernant toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions, les gérants, commissaires
aux comptes, secrétaires, employés ou agents de la Société seront indemnisés sur l'actif de la Société contre toute action,
coûts, charges, pertes, dommages et dépenses qu'ils auront encouru pour cause de signature de contrats ou de tout
action effectuée ou omise directement ou indirectement liée à l'exercice de leurs fonctions, excepté s'ils les ont encouru
suite à leur propre acte de malveillance, négligence, ou défaut et excepté selon les provisions de l'article 59 paragraphe
2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés, et aucun d'entre eux ne devra être responsable collectivement pour un
acte,  négligence  ou  défaut  commis  par  l'un  ou  l'autre  d'entre  eux,  ou  pour  avoir  agi  conjointement  dans  un  but  de
conformité, ou encore pour un banquier ou toute autre personne auprès duquel des actifs de la Société pourraient être

100959

déposés, ou pour un banquier, broker ou toute autre personne dans les mains desquelles des actifs de la Société ont été
remis, ou pour un défaut de titre de la Société pour l'achat de tout bien, pour l'absence ou l'invalidité de titres détenus
la Société alors que des fonds de la Société ont été investis, pour toute perte ou dommage occasionné par une erreur
de jugement ou d'inadvertance de leur part, pour toute perte, dommage ou inconvénients de toute sorte qui se produi-
raient dans l'exercice de leurs fonctions respectives ou en relation avec leurs fonctions, excepté s'ils sont causés par leur
propre malveillance, négligence ou défaut.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il s'en suit que toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Toute émission de parts sociales suite à la conversion d'obligations convertibles ou d'autres instruments financiers

similaires entraîne la convocation préalable d'une assemblée générale d'associés conformément aux dispositions de l'Ar-
ticle 7 ci-dessus. Pour les besoins de la conversion, chaque obligation convertible ou autre instrument financier similaire
sera considéré comme une souscription de parts sociales à émettre lors de la conversion.

E. Exercice social - Bilan - Répartitions

Art. 17. L'exercice social commencera le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même

année.

Art. 18. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Le solde créditeur du compte de pertes et profits après déduction tous dépenses, amortissements, charges et provi-

sions représentent le bénéfice net de la société.

Chaque année il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net qui sera alloué à la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pourcent du capital social, étant entendu

que ce prélèvement doit reprendre jusqu'à ce que le fond de réserve soit entièrement reconstitué si, à tout moment et
pour quelque raison que ce soit, il a été entamé.

Le surplus est attribué à l'associé unique ou est distribué entre les associés. Cependant l'associé unique ou l'assemblée

générale des associés peut décider selon vote majoritaire en vertu des dispositions légales applicables que le bénéfice,
après déduction de la réserve sera reporté ou alloué à une réserve spéciale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront
les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suivant:

- P4 SUB L.P.1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.430
- PERMIRA IV L.P.2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.816
- P4 Co-INVESTMENT L.P.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

- PERMIRA INVESTMENTS LIMITED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

198

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ deux mille cent (2.100,-) euros.

100960

<i>Assemblée générale des associés

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentant l'intégralité du capital social ont pris les

résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 282, route de Longwy L-1940 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Séverine Michel, née le 19 juillet 1977 à Epinal (France), avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940

Luxembourg.

- Paul Guilbert, né le 20 février 1961 à Salisbury (Grande-Bretagne), avec adresse professionnelle à Trafalgar Court,

Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernsey.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: C. Pedoni, P. Serres.

Enregistré à Luxembourg, le 1 

er

 août 2007, LAC/2007/ 21051. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007100149/5770/436.
(070113184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Ifonas Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 40.023.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2007.

FIDUCIAIRE B + C s.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2007100295/7759/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2007, réf. LSO-CG10811. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Andar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8116 Bridel, 2, Beim Antonskraeiz.

R.C.S. Luxembourg B 36.611.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2007.

FIDUCIAIRE B+C s.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2007100296/7759/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2007, réf. LSO-CG10813. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

100961

Euro-Packaging S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9543 Wiltz, route de Noertrange.

R.C.S. Luxembourg B 73.209.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2007.

FIDUCIAIRE B+C s.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2007100297/7759/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2007, réf. LSO-CG05666. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070113547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

CVI GVF Luxembourg Five S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 130.764.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-fourth of July.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies' register under the number B 119.271,

duly represented by Mr Pierre-Yves Genot, licencié en droit, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 16 July

2007.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here above stated capacity, has drawn up the following articles of incorporation of

a société à responsabilité limitée which it declares organized as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incor-
poration.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and loans and the administration, control
and development of its portfolio.

The Company may act as a general partner and manager of partnerships or similar corporate structures with unlimited

liability for all debts and obligations of such entities.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company is incorporated under the name of CVI GVF LUXEMBOURG FIVE S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means
of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality
may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

100962

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos,

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.
In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.

The manager(s) is/are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the

term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as
the case may be, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

100963

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute
grave) or wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.

Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Collective decisions of the shareholders - Decisions of the sole shareholder

Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 20. The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's financial year commences on the first of June and ends on the thirty-first of May.

Art. 22. Each year on the thirty-first of May, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole
shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators
shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company have been subscribed by CVI GVF (LUX) MASTER

S.à r.l., as aforementioned, paid up by a contribution in cash for an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), entirely allocated to the share capital.

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is

as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 May

2008.

100964

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which are to be borne by the Company or

which shall be charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred
Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period of time:
- Mr Gregor Klaedtke, born on 10 January 1965 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing professionally

at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Mr Hille-Paul Schut, lawyer, born on 29 September 1977 in 's-Gravenhage, the Netherlands, residing professionally

at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, den vierundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großherzogtums

Luxemburg, mit Sitz 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels -und Gesellschafts-
register unter Nummer B 119.271,

hier vertreten durch Herrn Pierre-Yves Genot, licencié en droit, wohnhaft in Luxemburg aufgrund einer privatschrift-

lichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 16. Juli 2007.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger Recht  (nachstehend  die  «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtli-

chen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung CVI GVF LUXEMBOURG FIVE S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter oder gegebenenfalls des alleinigen Gesellschafters an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxem-
burg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäfts-

100965

führers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden. Niederlassungen oder andere Fillialen können entweder entweder
in Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in zwölftausendfünf-

hundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese

Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss, oder gegebenenfalls der Zustimmung des alleinigen Gesellschafters.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die die Miteigentümer gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der

Gesellschaft.

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-

genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern oder gegebenenfalls von dem alleinigen Gesellschafter ernannt.

Die Gesellschafter oder der alleinige Gesellschafter bestimmen auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer
können jederzeit, ohne dass ein berechtigter Grund («cause légitime») hierzu bestehen muss, von den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Der Geschäftsführerrat wird durch jedes seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort

einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

100966

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern oder von einer vom Geschäftsführerrat bevollmächtigten Person unterzeichnet.

Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-

sellschaft nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer oder jedes Geschäftsführerratsmitglied und seine Erben, Nach-

lassverwalter und Verwalter für Ausgaben, die vernünftigerweise in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit, einer Klage
oder Verfahren entstanden sind, zu welchem er aufgrund seiner Stellung als gegenwärtiger oder ehemaliger Geschäfts-
führer der Gesellschaft oder jeder anderen Körperschaft von der er nicht berechtigt ist Entschädigung zu erhalten, Partei
geworden ist. Dies gilt nicht in Verbindung mit Angelegenheiten bei denen letztendlich auf eine schwere Pflichtverletzung
(faute grave) oder eine vorsätzliche Pflichtverletzung (faute intentionnelle) erkannt wurde. Für den Fall einer Vereinbarung
soll eine Entschädigung nur für solche Angelegenheiten gezahlt werden, die von der Vereinbarung gedeckt sind, sofern
die Gesellschaft von einem rechtlichen Beistand darüber informiert wurde, dass die zu entschädigenden Person keine
Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht auf Entschädigung soll nicht die Geltendmachung anderer Rechte
zu der die Person berechtigt ist, ausschliessen.

Art. 17. Die Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat können sich dazu entschliessen Zwischendividenden auf der

Grundlage eines Rechenschaftsberichts, der von einem Geschäftsführer oder dem Geschäftsführerrat vorbereitet wird
und aufzeigt dass genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, auszuschütten, wobei der auszuschüttende Betrag nicht
die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Rechnungsjahres überschreiten darf. Der Betrag erhöht sich durch fort-
getragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, jedoch verringert er sich durch fortgetragene Verluste und Beträge die
einer Kapitalrücklage zugeführt werden, welche gemäss dem Gesetz oder dieser Satzung zu bilden ist.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 19. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel

des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 20. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Juni eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Mai desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Mai jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer

stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder
Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. Zwischendi-
videnden werden in Einklang mit den gesetzlich vorgesehen Bedingungen zugeteilt.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  oder
gegebenfalls der alleinige Gesellschafter legt die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Es sei denn es ist etwas

100967

anderes vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der
Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

oder dem alleinigen Gesellschafter im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile wurden von CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., vorgenannt,

gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über ein Gesell-

schaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Mai 2008.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

eintausenddreihundert Euro.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 25B, rue boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt:
- Mr Gregor Klaedtke, geboren am 10. Januar 1965 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in 25B, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg; und

- Mr Hille-Paul Schutt, Rechtsanwalt, geboren am 29. September 1977 in s-Gravenhage, die Niederlanden, beruflich

wohnhaft in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: P-Y. Genot, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, LAC/2007/19707. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 9 août 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007100141/211/350.
(070113050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Coal &amp; Oil Trade Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 25.278.

Le bilan au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2007.

FIDUCIAIRE B+C s.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2007100300/7759/14.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2007, réf. LSO-CG10803. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

100968

Financière le Rachinel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 121.097.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2007.

FIDUCIAIRE B+C s.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2007100301/7759/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2007, réf. LSO-CG06867. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070113554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

CVI GVF Luxembourg Four S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 130.763.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-fourth of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies' register under the number B 119271,

duly represented by Mr Pierre-Yves Genot, licencié en droit, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 16 July

2007.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its herea bove stated capacity, has drawn up the following articles of incorporation of

a société à responsabilité limitée which it declares organized as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incor-
poration.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and loans and the administration, control
and development of its portfolio.

The Company may act as a general partner and manager of partnerships or similar corporate structures with unlimited

liability for all debts and obligations of such entities.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company is incorporated under the name of CVI GVF LUXEMBOURG FOUR S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means
of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality
may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

100969

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos,

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.
In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.

The manager(s) is/are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the

term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as
the case may be, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

100970

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute
grave) or wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.

Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Collective decisions of the shareholders - Decisions of the Sole Shareholder

Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 20. The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's financial year commences on the first of June and ends on the thirty-first of May.

Art. 22. Each year on the thirty-first of May, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole
shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators
shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company have been subscribed by CVI GVF (LUX) MASTER

S.à r.l., as aforementioned, paid up by a contribution in cash for an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), entirely allocated to the share capital.

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is

as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 May

2008.

100971

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which are to be borne by the Company or

which shall be charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred
Euro.

<i>Resolutions of the Sole Shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period of time:
- Mr Gregor Klaedtke, born on 10 January 1965 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing professionally

at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Mr Hille-Paul Schut, lawyer, born on 29 September 1977 in 's-Gravenhage, the Netherlands, residing professionally

at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, den vierundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großherzogtums

Luxemburg, mit Sitz 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels -und Gesellschafts-
register unter Nummer B 119271,

hier vertreten durch Herrn Pierre-Yves Genot, licencié en droit, wohnhaft in Luxemburg aufgrund einer privatschrift-

lichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 16 Juli 2007.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend  die  «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtli-

chen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung CVI GVF LUXEMBOURG FOUR S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter oder gegebenenfalls des alleinigen Gesellschafters an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxem-
burg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäfts-

100972

führers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden. Niederlassungen oder andere Fillialen können entweder entweder
in Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in zwölftausendfünf-

hundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese

Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss, oder gegebenenfalls der Zustimmung des alleinigen Gesellschafters.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die die Miteigentümer gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der

Gesellschaft.

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-

genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern oder gegebenenfalls von dem alleinigen Gesellschafter ernannt.

Die Gesellschafter oder der alleinige Gesellschafter bestimmen auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer
können jederzeit, ohne dass ein berechtigter Grund («cause légitime») hierzu bestehen muss, von den Gesellschaftern
oder dem alleinigen Gesellschafter entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Der Geschäftsführerrat wird durch jedes seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort

einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

100973

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern oder von einer vom Geschäftsführerrat bevollmächtigten Person unterzeichnet.

Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-

sellschaft nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer oder jedes Geschäftsführerratsmitglied und seine Erben, Nach-

lassverwalter und Verwalter für Ausgaben, die vernünftigerweise in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit, einer Klage
oder Verfahren entstanden sind, zu welchem er aufgrund seiner Stellung als gegenwärtiger oder ehemaliger Geschäfts-
führer der Gesellschaft oder jeder anderen Körperschaft von der er nicht berechtigt ist Entschädigung zu erhalten, Partei
geworden ist. Dies gilt nicht in Verbindung mit Angelegenheiten bei denen letztendlich auf eine schwere Pflichtverletzung
(faute grave) oder eine vorsätzliche Pflichtverletzung (faute intentionnelle) erkannt wurde. Für den Fall einer Vereinbarung
soll eine Entschädigung nur für solche Angelegenheiten gezahlt werden, die von der Vereinbarung gedeckt sind, sofern
die Gesellschaft von einem rechtlichen Beistand darüber informiert wurde, dass die zu entschädigenden Person keine
Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht auf Entschädigung soll nicht die Geltendmachung anderer Rechte
zu der die Person berechtigt ist, ausschliessen.

Art. 17. Die Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat können sich dazu entschliessen Zwischendividenden auf der

Grundlage eines Rechenschaftsberichts, der von einem Geschäftsführer oder dem Geschäftsführerrat vorbereitet wird
und aufzeigt dass genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, auszuschütten, wobei der auszuschüttende Betrag nicht
die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Rechnungsjahres überschreiten darf. Der Betrag erhöht sich durch fort-
getragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, jedoch verringert er sich durch fortgetragene Verluste und Beträge die
einer Kapitalrücklage zugeführt werden, welche gemäss dem Gesetz oder dieser Satzung zu bilden ist.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 19. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel

des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 20. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Juni eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Mai desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Mai jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer

stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder
Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. Zwischendi-
videnden werden in Einklang mit den gesetzlich vorgesehen Bedingungen zugeteilt.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  oder
gegebenfalls der alleinige Gesellschafter legt die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Es sei denn es ist etwas

100974

anderes vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der
Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

oder dem alleinigen Gesellschafter im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile wurden von CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., vorgenannt,

gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über ein Gesell-

schaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Mai 2008.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

ein tausend dreihundert Euro.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 25B, rue boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.
2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt:
- Mr Gregor Klaedtke, geboren am 10. Januar 1965 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in 25B, boulevard Royal, L-2449

Luxemburg; und

- Mr Hille-Paul Schutt, Rechtsanwalt, geboren am 29. September 1977 in s-Gravenhage, die Niederlanden, beruflich

wohnhaft in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Unterzeichnet: P.-Y.Genot, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, LAC/2007/19705. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 9 août 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007100142/211/350.
(070113049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Expanco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 245, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 39.800.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2007.

FIDUCIAIRE B+C s.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2007100298/7759/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2007, réf. LSO-CG05664. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

100975

Groupe CNS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 92.589.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2007.

FIDUCIAIRE B+C s.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2007100299/7759/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2007, réf. LSO-CG05663. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070113551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Pao de Açucar International S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 11.444.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007100302/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06412. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Wolseley Finance (Rockhopper) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 2.006.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 115.146.

Les comptes annuels pour la période du 27 février 2006 (date de constitution) au 31 juillet 2006 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007100304/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH06181. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Financière Light III S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.083.450,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 87.770.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007100303/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH06187. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

100976

DAB Investments Luxembourg SNC, Société en nom collectif.

Capital social: USD 10.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 100.188.

Les comptes annuels au 31 juillet 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007100305/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH06176C. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070113057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Del Monte Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 81.761.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007100306/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH06172. - Reçu 36 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Venus Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 87.380.

Constituée par-devant M 

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 6 mai 2002, acte publié au

Mémorial C n 

o

 1132 du 26 juillet 2002.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour VENUS FINANCE S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007100336/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH05902. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Nature and Health Investments SAH, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 89.893.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007100315/1268/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH06105. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

100977

Xantra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 58.128.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007100316/657/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007, réf. LSO-CH05332. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070113348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Rether Finance S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 9.841.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007100317/657/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007, réf. LSO-CH05333. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Tribune S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 85.853.

Constituée par-devant M 

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 21 décembre 2001, acte publié

au Mémorial C n 

o

 755 du 17 mai 2002

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TRIBUNE S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007100338/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH05906. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

American Clothing Retail S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 75, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 92.214.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

100978

Luxembourg, le 23 août 2007.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007100309/231/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06401. - Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Socavia II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 106.097.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007100319/657/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007, réf. LSO-CH05335. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Immo-Euro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 74.211.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007100320/657/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007, réf. LSO-CH05336. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Flag Distribution S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 67.771.

Le bilan de la société au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007100366/5387/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2007, réf. LSO-CH03441. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Cordura Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 89.224.

Le bilan au 31 octobre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

100979

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007100364/4642/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2007, réf. LSO-CG05121. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Access Storage Holdings (France), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 9.020,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 65.722.

Les comptes annuels 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MERCURIA SERVICES S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007100362/1005/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06514. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070113147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Lehman Brothers (Luxembourg) Equity Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 101.448.

Le bilan au 30 novembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2007.

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007100365/805/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06506. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Zentralux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 17, Op d'Schleid.

R.C.S. Luxembourg B 93.297.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 24 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007100361/800071/12.
Enregistré à Diekirch, le 24 août 2007, réf. DSO-CH00191. - Reçu 99 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070113476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Flag Distribution S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 67.771.

Le bilan de la société au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

100980

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007100367/5387/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2007, réf. LSO-CH03446. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Studio Cophia, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 53.840.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2007.

<i>STUDIO COPHIA s.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007100368/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05362. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Russian Investment Company, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 55.168.

Le bilan au 31 mars 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Luxembourg, le 8 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007100376/801/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06622. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Universal Business S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.017.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 106.751.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

B. Zech.

Référence de publication: 2007100375/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06697. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Hailey Investments Sp. z o.o. Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 118.356.

<i>Extrait des résolutions écrites du seul actionnaire datées du 23 mai 2007

L'actionnaire a décidé:

100981

- D'accepter la démission de Madame Marta Joanna Krawczyk demeurant au 20 M. 60, Remiszewska, PL-03-550 Var-

sovie, Pologne, à la fonction d'administrateur avec effet au 23 mai 2007.

- De nommer Monsieur Alwyn Jacobus de Lange, né le 20 décembre 1973 en Afrique du Sud, demeurant au 5, ul.

Koszycka, Varsovie, Pologne, à la fonction d'administrateur avec effet au 23 mai 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007100387/5564/17.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2007, réf. LSO-CH03921. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Nouveaux Ets. Liebaert S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, rue de Neuhausgen.

R.C.S. Luxembourg B 26.319.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2007.

<i>NOUVEAU ETS. LIEBAERT S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007100372/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05374. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Worldwide International Trade, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 99.434.

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 juillet 2007 à 07:00 au siège

social de notre société que les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Résolution - Démission d'un administrateur

L'Administrateur GENERAL MANAGEMENT HOLDING CIE LLC, sise aux Etats-Unis d'Amérique, 3100, Mill Street

Reno,  suite  102,  USA-NV89502  NEVADA  et  enregistrée  au  Registre  de  Commerce  du  Nevada  sous  le  numéro
15139-2003 a démissionné du poste d'administrateur.

L'Assemblée délibère est décidé d'accepter la démission de l'Administrateur GENERAL MANAGEMENT HOLDING

CIE LLC, qui ne se tient donc plus à disposition pour un nouveau mandat d'administrateur.

La résolution est adoptée par tous les membres de l'Assemblée.

<i>Résolution - Démission d'un administrateur

L'Administrateur  TRANSCONTINENTAL  CONSULTING  LLC,  sise  aux  Etats-Unis  d'Amérique,  3100,  Mill  Street

Reno, suite 102, USA-NV89502 Nevada et enregistrée au Registre de Commerce du Nevada sous le numéro 15149-2003
a démissionné du poste d'administrateur.

L'Assemblée délibère est décide d'accepter la démission de l'Administrateur TRANSCONTINENTAL CONSULTING

LLC, qui ne se tient donc plus à disposition pour un nouveau mandat d'administrateur.

La résolution est adoptée par tous les membres de l'Assemblée.

<i>Résolution - Nomination d'un nouvel administrateur

L'Assemblée nomme la société AA&amp;C ASSOCIATES SA, exploitant sous l'enseigne de Financière le Lion, établie au

23, rue Dideschpont à L-3622 Kayl, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro 124948, section
B au poste d'administrateur.

Le mandat d'administrateur commence ce jour et se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2012,

lors de laquelle l'Assemblée statuera sur les comptes 2011.

La résolution est adoptée par tous les membres de l'Assemblée.

100982

<i>Résolution - Nomination d'un nouvel administrateur

L'Assemblée nomme la société HOLFIN WORLDWIDE SA, établie au 23, rue Dideschpont à L-3622 Kayl, enregistrée

au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro 127204, section B au poste d'administrateur.

Le mandat d'administrateur commence ce jour et se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2012,

lors de laquelle l'Assemblée statuera sur les comptes 2011.

La résolution est adoptée par tous les membres de l'Assemblée.

<i>Résolution - Nomination d'un président du conseil d'administration

Le Président de l'Assemblée soumets une acceptation pour le poste de Président du Conseil d'Administration par

Monsieur Claude Karp, né le 11 octobre 1972 à Esch-sur-Alzette et domicilié professionnellement à 261, route de Longwy
L-1941 Luxembourg.

Après délibération l'Assemblée nomme Monsieur Claude Karp au poste de Président du Conseil d'Administration.
Le mandat du Président du Conseil d'Administration commence ce jour et se terminera lors de l'assemblée générale

ordinaire de l'année 2012, lors de laquelle l'Assemblée statuera sur les comptes 2011.

La résolution est adoptée par tous les membres de l'Assemblée.

Signatures du bureau
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur
Signatures des actionnaires
Signature / Signature
<i>Actionnaire 1 / Actionnaire 2

Référence de publication: 2007100389/2741/53.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2007, réf. LSO-CH07198. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 90.703.

In the year two thousand seven, on the tenth day of July.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

INTERNATIONAL PAPER COMPANY a company incorporated and organized under the laws of the State of New

York, having its principal place of business at 6400 Poplar Avenue, Tower III, Memphis, Tennessee 38197 (USA),

here represented by:
Mr Jean-Marc Delcour, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal to him.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- INTERNATIONAL PAPER COMPANY is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of INTERNATIONAL PAPER

INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorpo-
rated pursuant to a notaria deed enacted on December 12, 2002, published on February 18, 2003 in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 170, page 8147 (the Company); and

- the Company's share capital is presently set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) divided into

two hundred (200) shares with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each, all fully paid-up and
subscribed.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxy holder, has requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder of the Company decides to increase the subscribed capital of the Company by an amount of

eight  hundred  seventy-four  million  five  hundred  forty-five  thousand  four  hundred  United  States  Dollars  (USD
874,545,400.-) in order to bring the Company's share capital from its present amount of twenty thousand United States
Dollars (USD 20,000.-) divided into two hundred (200) shares with a par value of one hundred United States Dollars
(USD 100.-) each, to eight hundred seventy-four million five hundred sixty-five thousand four hundred United States

100983

Dollars (USD 874,565,400.-) by the issuance of eight million seven hundred forty-five thousand four hundred and fifty-
four (8,745,454) new shares with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each, having the same
rights as the already existing shares.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder of the Company agrees to admit the subscription of the above eight million seven hundred forty-

five thousand four hundred and fifty-four (8,745,454) new shares by IP (GIBRALTAR) HOLDING LIMITED, a limited
liability company incorporated and organised under the laws of Gibraltar, having its registered office at 57/63 Line Wall
Road, Gibraltar, and registered with the Registry of Companies of Gibraltar under the number 98177.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, IP (GIBRALTAR) HOLDING LIMITED (IP GIBRALTAR), prenamed,
here duly represented by Mr Jean-Marc Delcour, prenamed,
by virtue of a proxy given on 6 July 2007 which remains attached to the present deed for registration purposes, then

intervenes and declares (a) to subscribe for the eight million seven hundred forty-five thousand four hundred and fifty-
four (8,745,454) new shares and to have them fully paid up at the price of nine hundred sixty-two million nine hundred
sixty-one thousand four hundred sixty-six United States Dollars (USD 962,961,466.-), of which (i) eight hundred seventy-
four million five hundred forty-five thousand four hundred United States Dollars (USD 874,545,400.-) shall be allocated
to the share capital account of the Company (ii) eighty-seven million four hundred fifty-four thousand five hundred forty
United States Dollars (USD 87,454,540.-) shall be allocated to the legal reserve account of the Company (iii) nine hundred
sixty-one thousand five hundred twenty-six United States Dollars (USD 961,526.-) shall be allocated to a share premium
account of the Company and (b) to receive from the Company a cash payment of one hundred and one United States
Dollars (USD 101.-), by way of a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities, known or unknown as per
the date hereof.

Proof of the ownership and the value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a balance

sheet of IP GIBRALTAR as per July 10, 2007.

The  balance  sheet  of IP  GIBRALTAR shows net  assets  of  nine  hundred  sixty-two  million  nine  hundred  sixty-one

thousand five hundred sixty-seven United States Dollars (USD 962,961,567.-).

It results from a certificate issued on July 10, 2007 by the management of IP GIBRALTAR that:
- all assets and liabilities of IP GIBRALTAR are shown on the attached certified balance sheet as of July 10, 2007;
- based on generally accepted accountancy principles the net worth of IP GIBRALTAR per attached balance sheet as

of July 10, 2007 is estimated to be nine hundred sixty-two million nine hundred sixty-one thousand five hundred sixty-
seven United States Dollars (USD 962,961,567.-);

- no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of such assets and liabilities to the Company

exist;

- all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to the Company will be accomplished by IP

Gibraltar.

Such certificate and such balance sheet, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and

the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, the shareholders decide to amend article 6. of the articles of association

of the Company, which will henceforth have the following wording:

« Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at eight hundred seventy-four million five hundred sixty-five thousand

four hundred United States Dollars (USD 874,565,400.-) represented by eight million seven hundred forty-five thousand
six hundred and fifty-four (8,745,654) shares with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each, all
subscribed and fully paid-up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Statement

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring all the assets and liabilities from IP GIBRALTAR,

a company incorporated under the laws of Gibraltar, part of the European Union, such contribution being remunerated
with shares with a total value of nine hundred sixty-two million nine hundred sixty-one thousand four hundred sixty-six
United States Dollars (USD 962,961,466.-) and a cash payment of one hundred and one United States Dollars (USD 101.-)
in accordance with article 4-1 of the law dated December 29, 1971, as amended, the Company applies for the capital duty
exemption.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately six thousand five
hundred euro.

100984

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, such person signed together with the notary the present

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dixième jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, une société constituée et organisée selon le droit de l'Etat de New York,

ayant son principal établissement au 6400 Poplar Avenue, Tower III, Memphis, Tennessee 38197 (USA),

représentée par Monsieur Jean-Marc Delcour, avocat, résidant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration lui donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- INTERNATIONAL PAPER COMPANY, est l'associé unique (l'Associé Unique) de INTERNATIONAL PAPER IN-

VESTMENTS (LUXEMBOURG) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte notarié du 12 décembre
2002, publié le 18 février 2003 dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 170, page 8147 (la
Société); et

- le capital social de la Société est actuellement fixé à vingt-mille dollars américains (USD 20.000,-) représenté par deux

cents (200) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-) chacune.

La partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique de la Société, décide d'augmenter le capital social souscrit par un montant de huit cent soixante-

quatorze millions cinq cent quarante-cinq mille quatre cents dollars américains (USD 874.545.400,-) pour le porter de
son montant actuel de vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) composé de deux cents (200) parts sociales d'une
valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-), à huit cent soixante-quatorze millions cinq cent soixante-cinq
mille quatre cents dollars américains (USD 874.565.400,-) par l'émission de huit millions sept cent quarante-cinq mille
quatre cent cinquante-quatre (8.745.454) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD
100,-) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique de la Société, accepte d'admettre la souscription desdites huit millions sept cent quarante-cinq mille

quatre cent cinquante-quatre (8.745.454) nouvelles parts sociales par IP (GIBRALTAR) HOLDING LIMITED, une société
à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois de Gibraltar, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road,
Gibraltar, et enregistrée auprès du Registre de commerce et des Sociétés sous le numéro 98177.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ces faits exposés, IP (GIBRALTAR) HOLDING LIMITED (IP GIBRALTAR), préqualifiée et représentée par:
Monsieur Jean-Marc Delcour, prénommé,
en vertu d'une procuration donné le 6 juillet 2007, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux

formalités de l'enregistrement, intervient ensuite et déclare (a) souscrire aux huit millions sept cent quarante-cinq mille
quatre  cent  cinquante-quatre  (8.745.454)  nouvelles  parts  sociales  et  les  libérer  entièrement  à  un  prix  de  neuf  cent
soixante-deux millions neuf cent soixante et un mille quatre cent soixante-six dollars américains (USD 962.961.466,-),
sur lesquels (i) huit cent soixante-quatorze millions cinq cent quarante-cinq mille quatre cents dollars américains (USD
874.545.400,-) seront alloués au compte de capital de la Société, (ii) quatre-vingt-sept millions quatre cent cinquante-
quatre mille cinq cents quarante dollars américains (USD 87.454.540,-) seront alloués à un compte de réserve légale de
la Société, et (iii) neuf cent soixante et un mille cinq cent vingt-six dollars américains (USD 961.526,-) seront alloués à un
compte prime d'émission de la Société et (b) recevoir de la Société un montant de cent-un dollars américains (USD 101,-)
en liquide, au moyen d'un apport en nature consistant en tous les actifs et passifs, connus ou inconnus à la date du présent
acte.

Preuve de la propriété et de la valeur de tels actifs et passifs ont été apportées au notaire instrumentant par un bilan

de IP GIBRALTAR en date du 10 juillet 2007.

Le bilan de IP GIBRALTAR fait état d'un actif net de neuf cent soixante deux millions neuf cent soixante et un mille

cinq cent soixante-sept dollars américains (USD 962.961.567,-).

100985

Il résulte d'un certificat délivré le 10 juillet 2007 par la gérance de IP Gibraltar que:

- tous les actifs et passifs de IP GIBRALTAR sont repris au bilan certifié en date du 10 juillet 2007 ci-annexé;

- sur base des principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de IP GIBRALTAR selon le bilan ci-annexé

en date du 10 juillet 2007, est évalué à neuf cent soixante deux millions neuf cent soixante et un mille cinq cent soixante
sept dollars américains (USD 962.961.567,-);

- il n'existe aucune empêchement, ni légal ni contractuel, pour effectuer le transfert de ses actifs et passifs à la Société;

- toutes les formalités pour le transfert juridique de tous ses actifs et passifs à la Société ont été accomplies par IP

GIBRALTAR.

Ledit certificat et le bilan intérimaire, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 6, des statuts de la Société

qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à huit cent soixante-quatorze millions cinq cent soixante-cinq mille quatre cents

dollars américains (USD 874.565.400,-), représenté par huit millions sept cent quarante-cinq mille six cent cinquante-
quatre (8.745.654) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Dans la mesure où l'apport en nature fait à la Société consiste en tous les actifs et passifs de IP GIBRALTAR, une

société constituée selon les lois de Gibraltar, faisant partie de l'Union Européenne, et que cette contribution est rému-
nérée avec des parts sociales d'une valeur totale de neuf cent soixante deux millions neuf cent soixante et un mille quatre
cent soixante six dollars américains (USD 962.961.466,-) et un paiement en liquide de cent et un dollars américains (USD
101,-), la Société sollicite une exemption de droit d'apport conformément à l'article 4-1 de la loi en date du 29 décembre
1971.

<i>Estimation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital à environ six mille cinq cents
euros.

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties

comparantes l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: J.-M. Delcour, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 juillet 2007. Relation: EAC/2007/8415. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 13 août 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007100459/239/185.

(070113996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Beenyn Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 32.958.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

100986

Luxembourg, le 22 août 2007.

<i>BEENYN INVESTMENTS S.A.
R. Scheifer-Gillen / M.F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007100328/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH05954. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Joy Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 116.623.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2007.

<i>JOY REAL ESTATE S.A.
R. Donati / M. Kara
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007100329/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH05953. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Java S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 122.057.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2007.

<i>JAVA S.A.
A. De Bernardi / J. Rossi
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007100330/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH05952. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

S.E.B. ImmoInvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 118.568.

L'an deux mille sept, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.E.B. ImmoInvest S.A., ayant

son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 118.568, con-
stituée suivant acte reçu le 3 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1902
du 10 octobre 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Fons Mangen, Réviseur d'entreprises, demeurant à Ettelbruck.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

100987

II.- Il ressort de la liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée générale

extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les
actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg en Belgique à l'adresse suivante: B-1050

Bruxelles, 480B, avenue Louise, cette résolution étant à prendre sous la condition résolutoire de la non inscription de la
société au Registre des Sociétés en Belgique.

2.- Pouvoir à accorder à: Monsieur Robert Cohen-Skalli, administrateur de sociétés, demeurant à B-1050 Bruxelles,

2/6, rue de Belle-Vue, à l'effet d'accomplir toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société en
Belgique.

3.- Attribution de tous pouvoirs à: Monsieur Robert Cohen-Skalli, prénommé, à l'effet de radier l'inscription de la

société au Luxembourg et d'accorder décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes,
sur base de la preuve de l'inscription de la société en Belgique.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En conformité avec les prescription de l'article 67 (1) 1 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, tous

les  actionnaires  réunis  en  assemblée  décident  unanimement  de  transférer  le  siège  social,  administratif  et  le  siège  de
direction effective avec effet à la date de ce jour, le 29 juin 2007, du Grand-Duché de Luxembourg vers la Belgique, et
de faire adopter par la Société la nationalité belge, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de
siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle, et le tout sous la
condition résolutoire de la non-inscription de la Société en Belgique.

L'assemblée décide que l'adresse du siège social en Belgique, sera fixée à B-1050 Bruxelles, 480B, avenue Louise.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à: Monsieur Robert Cohen-Skalli, prénommé,

à l'effet d'accomplir toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société en Belgique, de signer
tous actes et documents y afférents et de faire toutes les démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Monsieur Robert Cohen-Skalli, prénommé,

à l'effet de radier l'inscription de la société au Grand-Duché de Luxembourg et d'accorder décharge aux membres du
conseil d'administration et au commissaire aux comptes, sur base de la preuve de l'inscription de la société en Belgique.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide que tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg seront conservés pendant

une période de cinq ans à l'ancien siège social.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F. Mangen, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2007, LAC/2007/16103. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007100488/211/63.
(070113992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2007.

Mantilla S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 69.304.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

100988

Luxembourg, le 22 août 2007.

<i>MANTILLA S.A.
A. De Bernardi / R. Donati
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007100332/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05527. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Lasting Placement Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 72.246.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2007.

<i>LASTING PLACEMENT HOLDING S.A.
J. Rossi / M.F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007100333/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, réf. LSO-CH05519. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Blue River Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 31.056.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 20 juin 2007 a appelé aux fonctions d'admi-

nistrateur Madame Nancy Bleumer et Madame Monique Juncker, toutes deux ayant leur adresse professionnelle au 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg en remplacement de MONTEREY SERVICES S.A. et UNI-
VERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., administrateurs démissionnaires. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée
Générale de 2011.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Gerard Jacobus Marsman, Administrateur
- Monsieur Hans de Graaf, Administrateur
- Madame Nancy Bleumer, Administrateur
- Madame Monique Juncker, Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2007.

<i>Pour BLUE RIVER HOLDING S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007100492/29/24.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH06340. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Tensor Property Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 106.351.

Constituée par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23

février 2005, acte publié au Mémorial C n 

o

 627 du 29 juin 2005.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

100989

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TENSOR PROPERTY INVESTMENTS S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007100346/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH05896. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Coffee Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 86.459.

Constituée par-devant M 

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du

19 février 2002, acte publié au Mémorial C n 

o

 913 du 14 juin 2002.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour COFFEE INVESTMENTS S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007100347/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH05898. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

International Sporting Travel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 46.907.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée générale ordinaire du 31 juillet 2007

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateur Madame Catherine Poiret, demeurant au 97, rue de la Brasserie,

F- 59530, Villereau (France), Madame Catherine Weisemburger née Poiret, demeurant au 72, rue de l'Orée du bois
F-80000 Amiens (France) et Monsieur Jean-Luc Poiret demeurant au 97, rue de la Brasserie, F-59530, Villereau (France)
en remplacement de Madame Béatrix Rubillon du Latay, demeurant à Comines, Monsieur Daniel Lemarteleur, demeurant
au 34, rue Jean-Abraham Poupart, F-08300, Neuflize (France) et Madame Marie-Martine Lemarteleur, demeurant au 34,
rue Jean-Abraham Poupart, F-08300, Neuflize (France).

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.
L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007100505/657/22.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007, réf. LSO-CH05343. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Tribune S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 85.853.

Constituée par-devant M 

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 21 décembre 2001, acte publié

au Mémorial C n 

o

 755 du 17 mai 2002

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

100990

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TRIBUNE S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007100339/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH05908. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Gramont S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 96.740.

Constituée par-devant M 

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 octobre 2003, acte publié au

Mémorial C n 

o

 1316 du 10 décembre 2003. Les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire en date du 6

juillet 2005, acte publié au Mémorial C n 

o

 19 du 4 janvier 2006, et en date du 8 août 2005, acte en cours de

publication.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GRAMONT S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007100337/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2007, réf. LSO-CH05904. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Par Trois S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 125.535.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2007

L'assemblée générale conformément à l'article 6 des statuts procède à la nomination d'administrateurs suivants:
- Monsieur Claude Prim avec adresse professionnelle à 50, avenue J-F Kennedy L-2951 Luxembourg pour un mandat

qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

- Monsieur Romain Wehles avec adresse professionnelle à 1-2, Place de Metz L-1930 Luxembourg pour un mandat

qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

- Monsieur Marco Goeler avec adresse professionnelle à 7, rue St Esprit L-1475 Luxembourg pour un mandat qui

viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Luxembourg, le 9 août 2007.

Pour extrait conforme
<i>PAR TROIS S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007100515/4/21.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06499. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 86.862.

Le bilan au 31 décembre 2006 de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES société mére de BNP PARIBAS SECURITIES

SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

100991

Luxembourg, le 22 août 2007.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - LUXEMBOURG BRANCH
Signatures

Référence de publication: 2007100352/3085/15.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2007, réf. LSO-CH04779. - Reçu 84 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Universal Luxembourg Holding, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 108.635.

Le bilan à la liquidation au 18 mai 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2007.

<i>Pour UNIVERSAL LUXEMBOURG HOLDING Sàrl
MERCURIA SERVICES S.A.
<i>Mandataire
Signature

Référence de publication: 2007100356/1005/17.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2007, réf. LSO-CG01056. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Magdalena S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 86.797.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 26 juillet 2007 que

Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-
Neuve, a été cooptée en fonction d'administrateur en remplacement de Madame Danièle Martin, démissionnaire.

Luxembourg, le 26 juillet 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d'administration
Signature

Référence de publication: 2007100527/535/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007, réf. LSO-CH05055. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070113452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

N.D. Associés Financière Immo Europe (F.I.E.) S.C.P.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 124.978.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Weber
<i>Notaire

Référence de publication: 2007100255/236/11.
(070113236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

100992


Document Outline

Access Storage Holdings (France), S.à r.l.

American Clothing Retail S.A.

Andar S.à r.l.

Beenyn Investments S.A.

Blue River Holding S.A.

BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg

Bureau Economique de Gestion et Holding International - S.A.B.E.G.H.I.N.

Coal &amp; Oil Trade Company S.A.

Coffee Investments S.A.

Cordura Property S.A.

CVI GVF Luxembourg Five S.à r.l.

CVI GVF Luxembourg Four S.à r.l.

DAB Investments Luxembourg SNC

Del Monte Finance Luxembourg S.A.

Elgae S.àr.l.

Emeth Holdings S.A.

Euro-Packaging S.A.

Expanco S.A.

Fashion and Cosmetics Isabelle T

Fashion and Cosmetics Isabelle T

Financière le Rachinel S.à r.l.

Financière Light III S.à.r.l.

Flag Distribution S.A.

Flag Distribution S.A.

Gramont S.àr.l.

Groupe CNS S.A.

Hailey Investments Sp. z o.o. Luxembourg Branch

Ifonas Holding S.A.

Immo-Euro S.A.

International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l.

International Sporting Travel S.A.

Java S.A.

Joy Real Estate S.A.

Lasting Placement Holding SA

Lehman Brothers (Luxembourg) Equity Finance S.A.

Magdalena S.A.

Mantilla S.A.

Nature and Health Investments SAH

N.D. Associés Financière Immo Europe (F.I.E.) S.C.P.A.

Nouveaux Ets. Liebaert S.à r.l.

Pao de Açucar International S.A.

Parkridge Italy Offices S.à r.l.

Parkridge Retail Ukraine S.à r.l.

Par Trois S.A.

Par Trois S.A.

Par Trois S.A.

PICO Invest HSA

Rether Finance S.A.

Russian Investment Company

S.E.B. ImmoInvest S.A.

Socavia II S.à r.l.

Studio Cophia, s.à r.l.

Tensor Property Investments S.à r.l.

Tribune S.A.

Tribune S.A.

Universal Business S.à r.l.

Universal Luxembourg Holding

Venus Finance S.à r.l.

Wefra

Wolseley Finance (Rockhopper) S.à r.l.

Worldwide International Trade

Xantra S.A.

Zentralux S.A.