logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2006

17 septembre 2007

SOMMAIRE

Admy Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96248

AFET (Poland) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96252

AGD Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96254

AIM Fund SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96242

Alpine Resort Properties S.A.  . . . . . . . . . . .

96257

Armauric-Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96288

Cameron (Luxembourg) Sàrl  . . . . . . . . . . .

96288

Carlson Wagonlit Luxembourg S.à r.l.  . . .

96247

CEB Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96250

Courtain Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96285

DB Akela Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96252

Design Lardo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96245

Dinya S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96249

EDL Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96244

Euro Haus + Lufttechnik S.à r.l.  . . . . . . . . .

96245

Fidessa Business Services S.à r.l. . . . . . . . . .

96288

Francesca International S.A.  . . . . . . . . . . . .

96253

GE Healthcare European Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96284

Gesilux-Gestion d'Investissement Luxem-

bourgeois S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96249

Green Side Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

96287

H51 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96243

Iberian Opportunities Fund  . . . . . . . . . . . . .

96287

Immobilière de l'Europe S.A.  . . . . . . . . . . .

96245

Indowood S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96254

Interlatsco Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

96256

Iplink S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96244

I.S.C. - International Sponsoring Corpora-

tion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96246

K Alpha S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96247

LeaseFin No 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96255

L'Orchidea S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96244

LSF IV Euro LT Properties  . . . . . . . . . . . . . .

96251

LSF IV Euro Properties  . . . . . . . . . . . . . . . . .

96251

MHP S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96243

Michelman International Sàrl  . . . . . . . . . . .

96255

Michelman Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96256

Nicoba S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96254

Nori S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96285

O-Mega Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96244

Orion Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96248

Pardus Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

96250

Parfinance S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96256

Prague 4 Residential (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96270

Preferred Retail S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96274

Principe SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96250

Raiffeisen EU Enlargement Fund Participa-

tions (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

96255

Restevent Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96246

Sanpaolo Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . .

96246

Signum Holdings 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

96252

S.P.I. Aero S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96242

S.P.I. Aerospace S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

96243

Super Jeci S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96253

T2 Capital Finance Company S.A.  . . . . . . .

96253

Tele2 Services Luxembourg S.A.  . . . . . . . .

96286

The Carlyle Group (Luxembourg) JV  . . . .

96242

Thomson Travel Holdings S.A.  . . . . . . . . . .

96247

UniCredit International Bank (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96248

UnionCSO S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96249

Unité Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96246

Velox Bidco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96243

Velox Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96242

WAGON Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

96251

WCSCF Finance Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96262

Winpro International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

96245

96241

S.P.I. Aero S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 124.714.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 48141 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007095469/211/11.
(070106834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

The Carlyle Group (Luxembourg) JV, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 95.676.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 48187 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007095465/211/11.
(070106857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

Velox Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 129.921.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 48249 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007095461/211/11.
(070106678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

AIM Fund SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 110.258.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui s'est tenue extraordinairement le 6 juillet 2007, décide:
- de renouveler le mandat d'administrateur de:
Monsieur Martin Wachter (Président du Conseil), 20, Rathausstrasse, A-1011 Vienne, Autriche
Monsieur Ernst Abensperg Und Traun, 20, Rathausstrasse, A-1011 Vienne, Autriche
Monsieur Christian Freilinger, C, Riviera del Sol, Triq il Qaliet, M-ZBR 12 Marsascala, Malte
Monsieur Friedrich Kiradi, 17/1, Schottenring, A-1011 Vienne, Autriche
- de renouveler le mandat de la société ERNST &amp; YOUNG S.A., Luxembourg à la fonction de Réviseur d'Entreprises.
Ces mandats seront valables pour une période d'un an jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra

en 2008 ou jusqu'à ce que leurs successeurs aient été désignés.

<i>Pour AIM FUND SICAV
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007095513/1126/21.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09853. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2007.

96242

S.P.I. Aerospace S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 97.036.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 48142 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007095467/211/11.
(070106837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

H51 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 125.659.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 48034 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007095463/211/11.
(070106823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

Velox Bidco S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 128.894.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 48250 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007095471/211/11.
(070106254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

MHP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 116.838.

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société du 25 juin 2007:
- qu'il est mis fin au mandat de DELOITTE S.A., une société anonyme, ayant son siège social à 560, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 67.895, en tant que com-
missaire aux comptes de la Société;

- que DELOITTE S.A., précitée, est nommée en tant que réviseur d'entreprises, suite à l'émission et à la cotation de

senior notes à la bourse de Londres (London Stock Exchange), pour une durée expirant lors de l'assemblée générale
appelée à se prononcer sur les comptes annuels de la Société du 31 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2007.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007095517/250/21.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10592. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070107015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2007.

96243

Iplink S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5852 Hesperange, 9, rue d'Itzig.

R.C.S. Luxembourg B 111.337.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Biel
<i>Notaire

Référence de publication: 2007095477/203/11.
(070106605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

L'Orchidea S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4818 Rodange, 9, rue Dr. Gaasch.

R.C.S. Luxembourg B 103.936.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Biel
<i>Notaire

Référence de publication: 2007095479/203/11.
(070106637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

EDL Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 117.005.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Biel
<i>Notaire

Référence de publication: 2007095481/203/11.
(070106608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

O-Mega Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 79.712.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2007

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5,

rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de la société LUX KONZERN Sàrl, ayant son siège social au 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT Sàrl ayant son siège social au 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., avec
siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée qui statuera sur
les comptes 2007.

Luxembourg, le 29 juin 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007095533/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2007, réf. LSO-CG08753. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070107167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2007.

96244

Immobilière de l'Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 66.207.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 48212 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007095474/211/11.
(070106252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

Euro Haus + Lufttechnik S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 55.919.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007095470/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2007, réf. LSO-CH02257. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070107304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2007.

Design Lardo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 19, rue Saint Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 68.147.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007095464/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2007, réf. LSO-CH02249. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070107310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2007.

Winpro International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 93.053.

Par décision de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 16 juillet 2007 ont été nommés,

jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2009:

<i>Administrateurs:

- Paul Lutgen, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Président
- Luc Braun, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur-délégué
- ARMOR S.A., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur.

<i>Commissaire:

EURAUDIT Sàrl, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007095536/504/19.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2007, réf. LSO-CH00618. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070107181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2007.

96245

I.S.C. - International Sponsoring Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 19, rue Saint Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 55.018.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007095466/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2007, réf. LSO-CH02250. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070107309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2007.

Restevent Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 321, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 70.777.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007095462/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2007, réf. LSO-CH02246. - Reçu 36 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070107313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2007.

Sanpaolo Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 55.753.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire en date du 27 mars 2007, acte n 

o

 179 devant

Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2007095494/208/12.
(070106634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

Unité Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 107.688.

EXTRAIT

En date du 20 avril 2007, Messieurs Alain Lam et Bruno Beernaerts ont démissionné de leur fonction de gérant, avec

effet immédiat.

En date du 23 mai 2007, l'assemblée a décidé de révoquer de ses fonctions de gérant Monsieur Eddy Dome.
En date du 23 mai 2007, Monsieur Jacques Detroux, né à Namur, Belgique, le 23 septembre 1953, résidant au 83,

Stijdomstreet, Hatbesspoortdam, Afrique du Sud, a été nommé gérant unique, avec effet rétroactif au 20 avril 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007095508/799/18.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2007, réf. LSO-CH02171. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2007.

96246

Carlson Wagonlit Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2226 Luxembourg, 4, rue Fort Niedergrünewald.

R.C.S. Luxembourg B 9.916.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale des associés, tenue en date du 13 juin 2007 que:
La société DELOITTE SA (anciennement DELOITTE &amp; TOUCHE), avec siège social au 560, rue de Neudorf, Luxem-

bourg L-2220, avec numéro RCS B 67.895, a été renommée aux fonctions de commissaire jusqu'à l'Assemblée appelée à
se tenir en l'année 2008.

Pour mention déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007095512/799/18.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2007, réf. LSO-CH02169. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070106980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2007.

Thomson Travel Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 62.806.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale annuelle tenue le 19 juillet 2007

L'assemblée générale décide de réélire Messieurs Martin Lange, Jacques Loesch, Henrik Turesson Norlin et David

Taylor comme administrateurs dont le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes
de l'exercice 2007.

L'assemblée générale décide de réélire PricewaterhouseCoopers Sàrl, Luxembourg comme commissaire aux comptes

dont le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour THOMSON TRAVEL HOLDINGS S.A.
Signature

Référence de publication: 2007095518/267/18.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2007, réf. LSO-CH01435. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070107019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2007.

K Alpha S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 121.968.

Suivant résolution signée en date du 14 mars 2007, le conseil d'administration a pris les décisions suivantes:
1. acceptation de la démission de Monsieur Yann Duchesne avec adresse au 43bis, boulevard Victor Hugo, F-92200

Neuilly sur Seine, de son poste d'administrateur DH, avec effet au 9 mars 2007;

2. cooptation de Monsieur Graeme Stening avec adresse au 135 Mac Donald Road The Gables, SW1K 9XZ Lightwater,

Royaume-Uni, au poste d'administrateur DH, avec effet au 9 mars 2007 et pour une période venant à échéance lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2012 et qui se tiendra
en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007095520/581/18.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2007, réf. LSO-CH02046. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070107045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2007.

96247

UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 103.341.

Suite aux démissions de Monsieur Patrizio Braccioni avec effet au 26 février 2007 et de Monsieur Carlo Giausa avec

effet au 26 mars 2007 de leurs fonctions respectives de Vice-Président et d'administrateur du Conseil d'Administration,
le Conseil d'Administration a décidé lors de sa réunion du 4 juillet 2007, de coopter en remplacement des démissionnaires
Monsieur Dario Prunotto, professionnellement domicilié 21, Via Arsenale, I-10121 Turin (Italie), à la fonction de Vice
Président, et Monsieur Marcello Mancini professionnellement domicilié au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
à la fonction d'administrateur. De plus, lors de la même réunion le Conseil d'Administration a décidé de coopter Monsieur
Philipp Waldstein professionnellement domicilié 3,Via San Protaso, I-20121 Milan (Italie) à la fonction d'administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007095528/5387/18.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2007, réf. LSO-CH01824. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070107156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2007.

Admy Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2841 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 15.534.

Le bilan 28 février 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2007.

Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2007095540/560/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2007, réf. LSO-CH02385. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070107523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2007.

Orion Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 73.862.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 20 avril 2007

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Madame Evelyne Cadillon et Messieurs Alain-Daniel Couttenier, Jean- Michel Gelhay, Alain Léonard et

Régis Léoni en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2008,

2. de réélire KPMG AUDIT S.à r.l. en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire en 2008.

Luxembourg, le 24 juillet 2007.

<i>Pour ORION SICAV
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / <i>Fondé de Pouvoir Principal

Référence de publication: 2007095557/34/22.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2007, réf. LSO-CH02028. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070107424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2007.

96248

UnionCSO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 95.245.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2007

- Sont nommées administrateurs de la société Mme Anja Lakoudi, employée privée, résidant professionnellement au

2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg et M. Olivier Laurent Christophe Jarny, employée privée, résidant
professionnellement  au  2,  boulevard  Konrad  Adenauer  à  L-1115  Luxembourg  en  remplacement  des  administrateurs
démissionnaires M. Tom Karel Odile Verheyden et M. Vincent de Rycke.

- Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012

statuant sur les comptes annuels de 2011.

Luxembourg, le 23 avril 2007.

<i>Pour le conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2007094772/1463/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2007, réf. LSO-CH01562. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070106387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

Dinya S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 84.422.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juillet 2007 que:
- AUSTIN EQUITIES SA, ayant son siège à Panama, Mossfon Building, East 54th Street a été nommé Commissaire en

remplacement de MAYFAIR TRUST S.à.r.l, démissionnaire.

Luxembourg, le 5 juillet 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007094779/5878/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2007, réf. LSO-CH00736. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

Gesilux-Gestion d'Investissement Luxembourgeois S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 44.579.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire des obligataires réunie à Luxembourg le 15 juin 2007 a pris la résolution suivante:
- Le remboursement anticipé du solde, soit un montant de CHF 2.252.333,33 y inclus les intérêts échus, de l'emprunt

obligataire non convertible émis par la société en date du 2 avril 2003 d'un montant total de deux millions francs suisses
(CHF 2.000.000,-), représenté par 1 certificat d'obligation d'une obligation d'une valeur nominale de CHF 666.666,- et 2
certificats d'obligations chacun d'une obligation d'une valeur nominale de CHF 666.667,-.

Lesdits certificats d'obligations au porteur no. 1, 2 et 3 seront remis au Conseil d'Administration qui procédera à leur

annulation.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007094735/693/19.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2007, réf. LSO-CG04769. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

96249

Pardus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 111.922.

- L'associée unique, la société PARDUS EUROPEAN SPECIAL OPPORTUNITIES MASTER FUND L.P., avec siège

social à c/o WALKERS SPV LIMITED, Walker House, Mary Street, PO Box 908 GT, Georgetown, Grand Cayman, Iles
Caïman, inscrite auprès du «Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands» sous le numéro WK-15496, a
changé de dénomination en date du 17 mai 2007 en PARDUS SPECIAL OPPORTUNITIES MASTER FUND L.P.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2007.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PARDUS INVESMTENTS S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007094752/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09297C. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070106755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

CEB Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 111.493.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2007

- Sont nommées administrateurs de la société Mme Anja Lakoudi, employée privée, résidant professionnellement au

2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg et M. Olivier Laurent Christophe Jarny, employée privée, résidant
professionnellement  au  2,  boulevard  Konrad  Adenauer  à  L-1115  Luxembourg  en  remplacement  des  adminsitrateurs
démissionnaires M. Tom Karel Odile Verheyden et M. Vincent de Rycke.

- Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012

statuant sur les comptes annuels de 2011.

Luxembourg, le 22 mars 2007.

<i>Pour le conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2007094776/1463/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2007, réf. LSO-CH01551. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

Principe SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 88.946.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juillet 2007 que:
- AUSTIN EQUITIES SA, ayant son siège à Panama, Mossfon Building, East 54th Street a été nommé Commissaire en

remplacement de MAYFAIR TRUST S.à.r.l, démissionnaire.

Luxembourg, le 5 juillet 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007094778/5878/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2007, réf. LSO-CH00737. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

96250

LSF IV Euro Properties, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.341.940,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 86.883.

EXTRAIT

Il résulte de décisions prises par les associés de LSF IV EURO PROPERTIES (la Société) du 25 juin 2007 que M. Per-

Magnus Andersson a démissionné de sa fonction de gérant de la Société. Il résulte également de ces résolutions que M.
Benjamin D. Velvin III, ayant son adresse professionnelle au 717, North Harwood Street, 75201 Dallas, Texas, USA, a été
nommé en tant que gérant indépendant.

Pour extrait sincère et conforme
<i>LSF IV EURO PROPERTIES
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007094781/5499/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2007, réf. LSO-CH01547. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070106294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

LSF IV Euro LT Properties, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.596.980,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 86.885.

EXTRAIT

Il résulte de décisions prises par les associés de LSF IV EURO LT PROPERTIES (la Société) du 25 juin 2007 que M.

Per-Magnus Andersson a démissionné de sa fonction de gérant de la Société. Il résulte également de ces résolutions que
M. Benjamin D. Velvin III, ayant son adresse professionnelle au 717, North Harwood Street, 75201 Dallas, Texas, USA,
a été nommé en tant que gérant indépendant.

Pour extrait sincère et conforme
<i>LSF IV EURO LT PROPERTIES
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007094782/5499/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2007, réf. LSO-CH01546. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

WAGON Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 267.257.400,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 75.430.

Il résulte d'un courrier du 13 juillet 2007 que Monsieur Andrew Fitchford a démissionné de son poste de gérant avec

effet immédiat au 13 juillet 2007.

Pour extrait
<i>WAGON GROUP S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007094783/5499/16.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2007, réf. LSO-CH01544. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

96251

AFET (Poland) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J-F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 117.820.

RECTIFICATIF

Suite à une erreur matérielle, veuillez prendre note que l'adresse professionnelle de l'administrateur M. Alfardan Fardan

Hassan Ibrahim Hassan est la suivante, 125 Corniche Road, Abu Dhabi, Emirats Arab Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>AFET (POLAND) S.A.
EQUITY TRUST CO. (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Référence de publication: 2007094793/683/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2007, réf. LSO-CH01996. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070106273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

Signum Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard K. Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 119.057.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2007

- Sont nommées administrateurs de la société Mme Anja Lakoudi, employée privée, résidant professionnellement au

2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg et M. Olivier Laurent Christophe Jarny, employée privée, résidant
professionnellement  au  2,  boulevard  Konrad  Adenauer  à  L-1115  Luxembourg  en  remplacement  des  administrateurs
démissionnaires M. Tom Karel Odile Verheyden et M. Vincent de Rycke.

- Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012

statuant sur les comptes annuels de 2011.

Luxembourg, le 24 avril 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007094770/1463/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2007, réf. LSO-CH01566. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

DB Akela Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 114.237.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2007

- Est nommée gérant de la société Mme Anja Lakoudi, employée privée, résidant professionnellement au 2, boulevard

Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire M. Tom Karel Odile Karel Odile
Verheyden.

- Le mandat du nouveau gérant prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012 statuant sur

les comptes annuels de 2011.

Luxembourg, le 20 avril 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007094771/1463/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2007, réf. LSO-CH01564. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

96252

Super Jeci S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 90.463.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2007

- Sont nommées administrateurs de la société Mme Anja Lakoudi, employée privée, résidant professionnellement au

2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg et M. Olivier Laurent Christophe Jarny, employée privée, résidant
professionnellement  au  2,  boulevard  Konrad  Adenauer  à  L-1115  Luxembourg  en  remplacement  des  administrateurs
démissionnaires M. Tom Karel Odile Verheyden et M. Vincent de Rycke.

- Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012

statuant sur les comptes annuels de 2011.

Luxembourg, le 23 avril 2007.

<i>Pour le conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2007094769/1463/19.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2007, réf. LSO-CE06417. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070106450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

T2 Capital Finance Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 124.383.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2007

- Sont nommées administrateurs de la société Mme Anja Lakoudi, employée privée, résidant professionnellement au

2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg et M. Olivier Laurent Christophe Jarny, employée privée, résidant
professionnellement  au  2,  boulevard  Konrad  Adenauer  à  L-1115  Luxembourg  en  remplacement  des  administrateurs
démissionnaires M. Tom Karel Odile Verheyden et M. Vincent de Rycke.

- Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012

statuant sur les comptes annuels de 2011.

Luxembourg, le 23 avril 2007.

<i>Pour le conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2007094768/1463/19.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2007, réf. LSO-CE06447. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

Francesca International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 66.254.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 18 juillet 2007

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société FRANCESCA INTERNATIONAL

S.A., tenue à Luxembourg, le 18 juillet 2007, que:

- décision a été prise d'accepter la démission de Madame Lucile Chevallier comme administrateur avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
M. Claude

Référence de publication: 2007094798/3580/16.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG10006. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

96253

Nicoba S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 29.800.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 29 mai 2007

<i>Résolutions

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
- de nommer Monsieur Joseph Winandy comme Président du Conseil d'Administration.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007094804/1172/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2007, réf. LSO-CH02136. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070106602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

Indowood S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 47.886.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale tenue extraordinairement en date du 18 juin 2007

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009, la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S.

Luxembourg B n 

o

 58.545, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été

nommée commissaire aux comptes, (en remplacement de la société à responsabilité limitée COMMISERV S.à r.l., démis-
sionnaire)

Luxembourg, le 25 juillet 2007.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour INDOWOOD S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007094761/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2007, réf. LSO-CH01483. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

AGD Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 114.858.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 23 mai 2007

Il a été décidé ce qui suit:
- L'Assemblée Générale décide de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Marc Baertz demeurant 11, rue

Dicks, L-6944 Niederanven, pour un terme expirant à l'issue l'Assemblée Générale Annuelle de 2011 en remplacement
de Monsieur Jacques Jourdan, administrateur démissionnaire.

Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit: Messieurs Alain Goujon-Dubois, Denis Stainer et Marc

Baertz.

Pour extrait certifié conforme
Signature
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2007094395/322/19.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2007, réf. LSO-CH01251. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2007.

96254

Michelman International Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8201 Mamer, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 128.438.

<i>Extrait de la résolution circulaire des gérants de la société du 20 juillet 2007

The board of managers of MICHELMAN INTERNATIONAL S.À R.L. hereby notes the resignation of Mrs Cynthia C.

Padilla in her capacity as A manager of MICHELMAN INTERNATIONAL S.À R.L. and resolves to set this item at the
agenda of the next general meeting of the shareholder.

Suit la traduction française:

Le Conseil de gérance de MICHELMAN INTERNATIONAL S.À R.L. acte la démission de Madame Cynthia C. Padilla

en qualité de gérante A de MICHELMAN INTERNATIONAL S.À R.L. et décide de porter ce point à l'ordre du jour de
la plus prochaine assemblée générale de l'associé unique.

Extrait certifié conforme
S. J. Shifman / G. Meilleur

Référence de publication: 2007094820/4933/19.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2007, réf. LSO-CH02154. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070106849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

LeaseFin No 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 122.157.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2007

- Sont nommées administrateurs de la société Mme Anja Lakoudi, employée privée, résidant professionnellement au

2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg et M. Olivier Laurent Christophe Jarny, employée privée, résidant
professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement des directeurs démis-
sionnaires M. Karel Odile Tom Verheyden et M. Vincent de Rycke.

- Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012

statuant sur les comptes annuels de 2011.

Luxembourg, le 28 mars 2007.

<i>Pour le conseil d'administration
Signatures

Référence de publication: 2007094780/1463/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2007, réf. LSO-CH01549. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

Raiffeisen EU Enlargement Fund Participations (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 71.394.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2007

- L'assemblée renouvelle le mandat de L'ALLIANCE REVISION SARL, établie au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxem-

bourg, enregistrée au RCS Luxembourg sous le numéro B 46, comme commissaire aux comptes de la société. Son mandat
expirera lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007094808/263/16.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2007, réf. LSO-CH01542. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

96255

Interlatsco Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 9.472.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 janvier 2007

- L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, de la Société EWA REVISION S.A., ayant

son siège social au 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange (R.C. Luxembourg n 

o

 B 38.937), jusqu'à l'assemblée générale

qui statuera sur le bilan 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007094814/263/16.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2007, réf. LSO-CH01496. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070106722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

Michelman Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8201 Mamer, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 128.078.

<i>Extrait de la résolution circulaire des gérants de la société du 20 juillet 2007

The board of managers of MICHELMAN S.À R.L. hereby notes the resignation of Mrs Cynthia C. Padilla in her capacity

as A manager of MICHELMAN S.À R.L. and resolves to set this item at the agenda of the next general meeting of the
shareholder.

Suit la traduction française:

Le Conseil de gérance de MICHELMAN S.À R.L. acte la démission de Madame Cynthia C. Padilla en qualité de gérante

A de MICHELMAN S.À R.L. et décide de porter ce point à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale de
l'associé unique.

Extrait certifié conforme
S. J. Shifman / G. Meilleur

Référence de publication: 2007094822/4933/19.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2007, réf. LSO-CH02156. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

Parfinance S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 16.425.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 25 avril 2007

<i>Quatrième résolution

Les mandats des membres du Conseil de Surveillance étant arrivés à échéance avec effet rétroactif au 17 avril 2007,

l'Assemblée décide de renouveler les mandats des membres du Conseil de Surveillance de Messieurs Christophe Blon-
deau, employé privé, Nour-Eddin Nijar, employé privé ainsi que de la société HRT REVISION S.à r.l., tous trois avec
adresse professionnelle au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir
en l'an 2013.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Associé-Commandité-Gérant

Référence de publication: 2007094823/565/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2007, réf. LSO-CH01412. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

96256

Alpine Resort Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 130.446.

STATUTS

L'an deux mille sept, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société anonyme MOUNTAIN INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel

Welter,

ici dûment représentée par Monsieur Alexandre Taskiran, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2168

Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'elle déclare

constituer comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est constitué une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ALPINE RESORT PRO-

PERTIES S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité

normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la
disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition de biens immobiliers résidentiels, hôteliers, para-hôteliers et commerciaux.
La société pourra également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères ou acquérir par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi qu'aliéner par vente,
échange ou toute autre manière des titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces. Elle pourra administrer,
développer et gérer son portefeuille.

La société n'exercera pas d'activité industrielle.
La société pourra rendre des prestations de services de toute nature à ses filiales que ces dernières soient détenues

directement ou indirectement. Elle pourra donner des conseils et assister toute société du groupe, ou hors groupe.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours.

La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle

jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EURO), représenté par trois mille

cent (3.100) actions, chacune d'une valeur nominale de dix euro (10,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé de la société est fixé à un million d'euro (1.000.000,- EUR) représenté par cent mille (100.000)

actions, chacune d'une valeur nominale de dix euro (10,- EUR).

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l'acte de constitution au

Mémorial, Recueil Spécial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du
capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime
d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée,

pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette aug-

96257

mentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation
de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son

sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Une résolution du Conseil d'administration peut être prise par écrit. Une telle résolution consistera en un ou plusieurs

documents, contenant les résolutions, et elles seront signées, manuellement ou électroniquement par voie de signature
électronique valable en droit luxembourgeois, par chaque administrateur (résolution circulaire). La date de ladite réso-
lution est celle de la dernière signature.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n'excédant pas six années.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 17.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.

<i>Souscription

Toutes les actions ont été souscrites par la société MOUNTAIN INVESTMENTS S.A., pré-qualifiée.

96258

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euro

(31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille six cent vingt-cinq euro.

<i>Décisions de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire unique, par son représentant susnommé, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, né à Etterbeek (Belgique), le 1 

er

 mai 1971, demeurant profes-

sionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;

- Monsieur Alexandre Taskiran, expert-comptable, né à Karaman (Turquie), le 24 avril 1968, demeurant profession-

nellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;

- Monsieur Thierry Triboulot, employé privé, né à Villers-Semeuse (France), le 2 avril 1973, demeurant profession-

nellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;

- Madame Andréa Dennis, administrateur de sociétés, née à Londres (Angleterre) le 26 juin 1967, demeurant à W1G

8LZ Londres, 25 Harley Place (Angleterre).

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
- La société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2168 Luxembourg, 127, rue

de Mühlenbach, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.995.

4.- Le siège de la société est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans.
6.- Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-

délégué.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante les

présents statuts sont rédigés en français suivis d'une traduction anglaise, à la requête de la même comparante et en cas
de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and seven, on the thirty-first of July.
Before us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The stock company MOUNTAIN INVESTMENTS S.A., having its registered office at L-2730 Luxembourg, 67, rue

Michel Welter,

hereby duly represented by Mr. Alexandre Taskiran, chartered accountant, residing professionally at L-2168 Luxem-

bourg, 127, rue de Mühlenbach,

by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to this deed

for the purpose of registration.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company

which they declare to have established as follows:

Art. 1. A Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of ALPINE RESORT PROPERTIES

S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period.

Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of

Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be deemed

96259

imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Registered Office
of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The purpose of the company is the acquisition of residential, commercial, hotelier and para-hotelier immovable

properties.

The company shall also be engaged in the acquisition of participations, in any form whatsoever in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, admin-
istration, development and management of its portfolio.

The company shall not directly carry out any industrial activity.
The company shall render services of whatsoever nature to direct or indirect subsidiaries, and shall advise and grant

assistance to any group company or even any company beyond the group.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprise

in Luxembourg or abroad and may render such enterprises every.

The company may borrow in any form and may issue bonds and debentures.
In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) represented by three

thousand one hundred (3,100) shares of a par value of ten euro (10.- EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.
The authorized capital is fixed at one million euro (1,000,000.- EUR) to be divided into one hundred thousand (100,000)

shares with a par value of ten euro (10.- EUR) each.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of the publication of the articles of

association in the Mémorial C, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorized
capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue
premium, as the Board of Directors may determine. The Board of Directors is authorized to suppress or to limit the
preferential subscription right of the shareholders.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by the
board of directors within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to
this amendment.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.
The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed

by the old shares.

Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all

action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a matter
for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In
particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant repelvins with or without payment.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

A resolution of the Board of Directors may be passed in writing. Such resolution shall consist of one or several

documents containing the resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is
valid under Luxembourg law, by each and every director (circular resolution). The date of such resolution shall be the
date of the last signature.

96260

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid

down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have
to be shareholders of the Company.

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Directors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the

Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company's business year begins on January 1 and closes on December 31.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the third Wednesday of June at 05.00 p.m. at the Company's Registered

Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will
be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the date

fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a
shareholder himself.

Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides

how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Special dispositions

1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2007.
2) The first General Meeting will be held in the year 2008.

<i>Subscription

All the shares have been subscribed by the company MOUNTAIN INVESTMENTS S.A., prenamed.
All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR)

is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.

<i>Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as

subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand six hundred and twenty-
five euro.

<i>Decisions of the Sole Shareholder

The above named sole shareholder, through his mandatory, has immediately taken the following resolutions.
1.- The number of directors is fixed at four and that of the auditors at one.
2.- The following have been appointed as directors:
- Mr Christian Bühlmann, chartered accountant, born at Etterbeek (Belgium), on the 1st of May 1971, residing pro-

fessionally at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;

- Mr Alexandre Taskiran, chartered accountant, born at Karaman (Turquie), on the 24 of April 1968, residing profes-

sionally at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;

- Mr Thierry Triboulot, private employee, born at Villers-Semeuse (France), on the 2nd of April 1973, residing pro-

fessionally at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;

- Mrs Andréa Dennis, company Director, born in London (England), on the 26th of June 1967, residing at W1G 8LZ

London, 25 Harley Place (England).

3.- The following has been appointed as statutory auditor:
The stock company TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., having its registered office at L-2168 Luxembourg, 127,

rue de Mühlenbach, R.C.S. Luxembourg section B number 86.995.

4.- The Company's registered office shall be at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
5.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.

96261

6.- The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its

members.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in French, followed by an English version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read in the language of the person appearing, known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Signé: A. Taskiran, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 août 2007, Relation GRE/2007/3531. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 10 août 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007096470/231/286.
(070108106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2007.

WCSCF Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 130.445.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the twenty-fifth of June.
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CAVEMONT PTY. LIMITED, an Australian company limited by shares, having its registered office at Level 24 Westfield

Towers, 100 William Street, Sydney, NSW 2011, Australia, registered with the Australian Securities and Investments
Commission under number ACN: 090 0080 601,

represented by Maître Figen Eren, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 25

June 2007.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name . There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

WCSCF FINANCE Sàrl (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by
the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

96262

Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at ten thousand Great Britain Pounds (GBP 10,000.-) represented by

ten thousand (10,000) shares in registered form with a par value of one Great Britain Pounds (GBP 1.-) each, all subscribed
and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of

96263

managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of

any manager of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such
signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board

of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

96264

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular

allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the

Company;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders of

the Company;

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.

VI. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2007.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, CAVEMONT PTY. LIMITED, prenamed and represented as stated above declares to subscribe to ten

thousand (10,000) shares in registered form, with a par value of one Great Britain Pounds (GBP 1.-) each, and to fully
pay them up by way of a contribution in cash amounting to ten thousand Great Britain Pounds (GBP 10,000.-).

The amount of ten thousand Great Britain Pounds (GBP 10,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proved

to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Evaluation

For the purpose of registration, the share capital is valued at fourteen thousand eight hundred seventy-one point sixty-

four Euro (EUR 14,871.64).

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand six hundred Euro (EUR 1,600.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety

of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following person(s) is/are appointed as manager(s) of the Company for an indefinite period:
- Mr Pascal Leclerc, employee, born on 4 December 1966 in Longwy, France, residing professionally at 6, rue Philippe

II, L-2340 Luxembourg.

- Mr Russell Perchard, employee, born on 16 January 1978 in St Helier, Jersey, residing professionally at 6, rue Philippe

II, L-2340 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 6 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

96265

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named

at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CAVEMONT PTY. LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit australien, ayant son siège social au Level

24 Westfield Towers, 100 William Street, Sydney, NSW 2011, Australie, immatriculée auprès de l'«Australian Securities
and Investments Commission» sous le numéro ACN: 090 0080 601,

représentée par Maître Figen Eren, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée le 25 juin 2007.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le représentant du comparant et le notaire ins-

trumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination WCSCF FINANCE

Sàrl (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales

ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime
que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces évè-
nements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée
entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition
et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs
d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.

96266

3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes trans-

actions  se  rapportant  à  la  propriété  immobilière  ou  mobilière,  qui  directement  ou  indirectement  favorisent  ou  se
rapportent à la réalisation de son objet social.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à dix mille livres sterling (GBP 10.000,-), représenté par dix mille (10.000)

parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la

Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de

l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils
constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous
pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,

associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des

gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de

la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de
son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de
la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

96267

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou

représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les procès-verbaux
des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.7. En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-

blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par
lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature individuelle

de chaque gérant de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui
de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,

doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;

96268

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés

de la Société;

(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.

VI. Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2007.

<i>Souscription - Libération

Ces faits exposés, CAVEMONT PTY. LIMITED, prénommée et représentée comme dit ci-dessus, souscrit les dix mille

(10.000) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune et les libérer
entièrement par versement en espèces de dix mille livres sterling (GBP 10.000,-).

La somme de dix mille livres sterling (GBP 10.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire

instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à quatorze mille huit cent soixante-et-onze virgule

soixante-quatre euros (EUR 14.871,64).

<i>Coûts

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille six cents euros (EUR
1.600,-).

<i>Décisions de l'associé unique

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. La/les personne(s) suivante(s) est/sont nommée(s) comme gérant(s) de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Pascal Leclerc, employé privé, né le 4 décembre 1966 à Longwy, France, résidant professionnellement au

6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

- Monsieur Russell Perchard, employé privé, né le 16 janvier 1978 à St Helier, Jersey, résidant professionnellement au

6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante de la comparante, elle a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: F. Eren, J. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, LAC/2007/15357. — Reçu 148,48 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations

Luxembourg, le 18 juillet 2007.

J. Baden.

Référence de publication: 2007096448/7241/416.
(070108104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2007.

96269

Prague 4 Residential (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 130.466.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the ninth day of July.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr David Samuel Hammelburger, company director, born in Manchester (UK) on September 20, 1970, residing at 6th

Floor, Cardinal House, 20, St Mary's Parsonage, Manchester M3 2LG (UK),

here represented by Mr Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, employee, residing professionally at 64, rue Prin-

cipale, L-5367 Schuttrange,

by virtue of a proxy given on June 22nd, 2007.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by

the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Arti-
cles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which it has an direct or indirect interest any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation is anticipated to purchase direct interest in European properties, participate in equal or similar com-

panies  and  to  act  as  a  platform  for  the  pooling  of  various  European  property  investments.  Within  these  limits  the
corporation may carry out all business and tasks necessary or useful in order to fulfil this purpose.

In all the operations indicated here above, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits

established by the law.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name PRAGUE 4 RESIDENTIAL (LUXEMBOURG) S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Schuttrange.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.-euro) represented by

one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five euro (125.- euro) each, all subscribed and fully
paid-up.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders'

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

96270

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the

manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2007.

<i>Subscription-Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said appearing

party, represented as stated here above, declares to subscribe for the one hundred (100) shares and to have them fully
paid up in cash of an amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR).

Proof of such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article

183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

96271

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (1,500.-EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered for an unlimited period by the following managers:
- Mrs Michelle Carvill, employee, born in Down on November 26, 1966, residing professionally at 64, rue Principale,

L-5367 Schuttrange;

- Mr Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, employee, born in S-Gravenhage (The Netherlands) on October 16,

1970, residing professionally at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange.

2) The address of the corporation is fixed at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le neuf juillet.
Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur  David  Samuel  Hammelburger,  administrateur  de  société,  né  à  Manchester  (UK)  le  20  septembre  1970,

demeurant à 6th Floor, Cardinal House, 20, St Mary's Parsonage, Manchester M3 2LG (UK),

ici représentée par Monsieur Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange,

agissant en vertu d'une procuration signée le 22 juin 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité

limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect
tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers, qui pourraient être utiles pour l'accomplissement de son objet.

La société est destinée à acheter des intérêts directs dans des propriétés européennes, à prendre des participations

dans des sociétés similaires ou semblables et agir en tant que plate-forme pour la mise en commun de divers investisse-
ments européens. Dans ces limites, la société peut agir en vue de mettre en œuvre et réaliser toutes les actions nécessaires
ou utiles pour l'accomplissement de son objet.

Dans toutes les opérations indiquées ci-dessus, ainsi que pour toutes ses activités, la société restera dans les limites

prévues par la loi.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: PRAGUE 4 RESIDENTIAL (LUXEMBOURG) S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Schuttrange.

96272

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n'importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les reponsabilités et la rémunération

(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le
capital de la Société.

96273

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007.

<i>Souscription et paiement

La partie comparante précitée, ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a déclaré souscrire aux cent (100) parts

sociales et a déclaré les avoir libérées en espèces à concurrence d'un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,-
EUR).

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ Mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Décision de l'associée unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée illimitée:
- Madame Michelle Carvill, employée privée, née à Down (Irlande) le 26 novembre 1966, demeurant professionnelle-

ment à 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange;

- Monsieur Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, employé privé, né à S-Gravenhage (Pays-Bas) le 16 octobre 16,

1970, demeurant professionnellement à 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange.

2) L'adresse de la Société est fixée à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: A. van Zeeland, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, LAC/2007/17570. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 1 

er

 août 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007096482/220/248.
(070108189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2007.

Preferred Retail S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 121.179.

In the year two thousand and seven, on the 22st day of June.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Was held an Extraordinary General Meeting (the «Meeting») of the shareholders of PREFERRED RETAIL SA, a public

limited liability company («société anonyme») having its registered office in L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange,
registered with the Luxembourg Trade and Company Register under section B number 121.179, incorporated by a deed
enacted by M 

e

 Marc Lecuit, notary, residing in 13, Grand-rue, L-8510 Redange-sur-Attert (Luxembourg).on October

17th, 2006, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated December 19th, 2006, number 2365
(hereinafter referred to as the «Company»)

The Meeting was opened at 16 p.m. with Mr Alain Thill, private employee, with professional address at 3, route de

Luxembourg, L-6130 Junglinster, being in the chair,

96274

The chairman chooses for secretary Mrs Monique Goeres, private employee, with professional address at 3, route de

Luxembourg, L-6130 Junglinster, and for scrutineer Mr Jérôme Bach, attorney at law, with professional address at 24,
avenue Marie-Thérèse, L-1026 Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.-That the agenda of the Meeting is the following
1. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 12,742.05 (twelve thousand and seven

hundred forty-two Euros and five Cents) so as to raise it from its current amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousands
Euros) to EUR 43,742.05 (forty-three thousands seven hundred forty two Euros and five Cents) by issuing 10,194 (ten
thousand and one hundred ninety-four) new shares C with a par value of EUR 1.25 (one Euros and twenty-five cents)
each, having the same rights and obligations of the existing shares, together with a share premium amounting to EUR
3,949,347.55 (three million nine hundred and forty-nine thousand three hundred forty-seven Euros and fifty-five cents).

2. Intervention, subscription and payment;
3. Decision as a consequence of the foregoing statements and resolutions, to amend article 5 first and second para-

graphs of the Articles of association;

4. Decision to add a new paragraph in Articles 6 with the following wording: «The Company's shares are redeemable

under the conditions laid down by the Law, in particular by article 49-8 of the Law»;

5. Decision to amend Article 7 first Paragraph to give it the following wording: «The Company is administered by a

board of directors of not less than three members, shareholders or not. The board is composed of one Director for
each class of shares.

The Directors shall be appointed by the Shareholders at the annual general meeting of Shareholders for a period which

may not exceed six years. One Director shall be elected from a list of candidates proposed by the holders of more than
50% of the «B» Shares (the «B» Directors); one Director shall be elected from a list of candidates proposed by the holders
of more than 50% of the «C» Shares (the «C» Director), one Director shall be elected from a list of candidates proposed
by the holders of more than 50% of the «A» Shares (the «A» Director). They shall hold office until their successors are
elected. Their re-election is authorised. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is
deemed to be elected for 6 years from the date of his election.»

6. Decision to amend Article 8 third Paragraph to give it the following wording: «The board of Directors can only

validly debate and take decision if the majority of them is present or represented, proxies between Directors being
permitted. A Director may be represented by a fellow Director. A Director may only represent one other Director. At
board meeting, each of the Directors shall have one vote. Resolutions of the Board will be passed if more votes are cast
for than against them.»

7. Decision to add a new paragraph in Article 8 with the following wording: «One or more Directors may participate

in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication thus enabling
several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed
equivalent to a physical presence at the meeting. Such meetings shall be considered equivalent as a meeting held at the
registered office of the Company.»

8. Decision to amend Article 12 to give it the following wording: «Towards third Parties, the Company is in all cir-

cumstances committed by the joint signatures of a Director B jointly with the individual signature of a Director A or C
or by the sole signature of the delegate of the board, if any, acting within the limits of his powers.»

9. Decision to insert a new Article 6.1 with the following wording:
6.1. Without prejudice of the provisions stated in other separate agreement if the holders of 50% or more in par value

of the Shares in issue for the time (Selling Shareholders) wish to transfer all of their interest in Shares (Sellers' Shares)
to a bona fide arms' length purchaser (Proposed Buyer), the Selling Shareholders may require all the other holders of
Shares (Called Shareholders) to sell and transfer all their shares to the Proposed Buyer or as the Proposed Buyer directs
in accordance with the provisions of this clause (Drag Along Option).

6.1.a. The Selling Shareholders may exercise the Drag Along Option by giving written notice to that effect (Drag Along

Notice) at any time before the transfer of the Sellers' Shares to the Proposed Buyer. The Drag Along Notice shall specify:

(i) that the Called Shareholders are required to transfer all (and not some only) of their Shares (Called Shares) pursuant

to this clause;

(ii) the person(s) to whom the Called Shares are to be transferred;
(iii) the consideration payable for the Called Shares calculated in accordance with the provision of separate agreements.
(iv) subject to specific provisions in separate agreements, the terms of any warranties, representations or indemnities

given by them to the Proposed Buyer and accordingly also to be provided to the Proposed Buyer by the Called Share-
holders; and

(v) the proposed date of the transfer.
6.1.b. Once issued, a Drag Along Notice shall be irrevocable. However, a Drag Along Notice shall lapse if, for any

reason, the Selling Shareholders have not sold the Sellers' Shares to the Proposed Buyer within 90 days of serving the

96275

Drag Along Notice. The Selling Shareholders may serve further Drag Along Notices following the lapse of any particular
Drag Along Notice.

6.1.c. The Called Shareholders shall sell each Called Share for the amount which they would be entitled to receive if

the total consideration proposed to be paid by the Proposed Buyer were distributed to the holders of the Called Shares
and the Sellers' Shares in accordance with their respective holdings of par value of equity share capital.

6.1.d. No Drag Along Notice shall require a Called Shareholder to agree to any terms except those specifically set out

in this clause or which are not otherwise reasonably incidental to those specifically set out in this clause or a transaction
of the general nature of the sale the subject of the Drag Along Notice.

6.1.e. Completion of the sale of the Called Shares shall take place on the same date as the date proposed for completion

of the sale of the Sellers' Shares unless:

(i) all of the Called Shareholders and the Selling Shareholders agree otherwise; or
(ii) that date is less than 15 days after the Drag Along Notice, in which case completion of the sale shall be delayed

until the 15th day after service of the Drag Along Notice.6.1.f No rights of pre-emption or similar restrictions which may
be set out in the Articles shall apply to any transfer of shares to a Proposed Buyer (or as it may direct) pursuant to a sale
for which a Drag Along Notice has been duly served.

6.1.g. Within 10 days of service of a Drag Along Notice, the Called Shareholders shall deliver stock transfer forms for

the Called Shares, together with the relevant share certificate (or a suitable indemnity for any lost share certificate) to
the Company to be held for the purposes of securing performance of the provisions of this clause. On the expiration of
that period, the Company shall pay the Called Shareholders, on behalf of the Proposed Buyer, the amounts they are due
pursuant to this clause to the extent that the Proposed Buyer has put the Company in the requisite funds. The Company's
receipt for the price shall be a good discharge to the Proposed Buyer. The Company shall hold the amounts due to the
Called Shareholders pursuant to this clause in trust for the Called Shareholders without any obligation to pay interest.

6.1.h. To the extent that the Proposed Buyer has not, on the expiration of the period referred to above, put the

Company in funds to pay the consideration due pursuant to this clause, the Called Shareholders shall be entitled to the
return of the stock transfer form and share certificate (or suitable indemnity) for the relevant Called Shares and the
Called Shareholders shall have no further rights or obligations under this clause in respect of their Shares (except in
connection with any further Drag Along Notices which may be served).

6.1.i.  If  any  Called  Shareholder  does  not,  on  completion  of  the  sale  of  the  Called  Shares  execute  transfer(s)  and

whichever deed or document as may be necessary to give effect to clause 6.1.a.iv or clause 6.1.d in respect of all of the
Called Shares held by it, the defaulting Called Shareholder shall be deemed to have irrevocably appointed any person
nominated for the purpose by the Selling Shareholders to be their agent and attorney to execute all necessary transfer
(s), deeds or documents on his behalf, against receipt by the Company (on trust for such holder) of the consideration
payable for the Called Shares, deliver such transfer(s), deeds or documents to the Proposed Buyer (or as they may direct).
After the Proposed Buyer (or its nominee) has been registered as the holder, the validity of such proceedings shall not
be questioned by any such person. It shall not be an impediment to the registration of shares under this clause that a
share certificate has not been produced.

6.1.j. Following the issue of a Drag Along Notice, on any person becoming a Shareholder of the Company pursuant to

the exercise of a preexisting option to acquire shares in the Company or on the conversion of any convertible security
of the Company (a New Shareholder), a Drag Along Notice shall be deemed to have been served on the New Shareholder
on the same terms as the previous Drag Along Notice. The New Shareholder shall then be bound to sell and transfer all
Shares acquired by it to the Proposed Buyer (or as the Proposed Buyer may direct) and the provisions of this clause shall
apply with the necessary changes to the New Shareholder, except that completion of the sale of the Shares shall take
place immediately on the Drag Along Notice being deemed served on the New Shareholder».

10. acceptation of the resignation of (Mr Stephane Weyders) as Director B and appointment of Mr Ian Quinn as

Director C of the Company and determination of its mandate.

11. Miscellaneous.
II.-That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholders
of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at
the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties, will also remain annexed to the present deed.

III.- That the entire subscribed share capital being represented at the present Meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and good knowledge of the agenda prior to this Meeting, and all
the shareholders present or represented expressly declaring to waive all convening formalities, no convening notices
were necessary.

IV.- That the present Meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the Meeting

unanimously takes the following resolution

96276

<i>First resolution

The Shareholders resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 12,742.05 (twelve

thousand and seven hundred forty-two Euros and five Cents) so as to raise it from its current amount of EUR 31,000.-
(thirty-one thousands Euros) to EUR 43,742.05 (forty-three thousands seven hundred forty-two Euros and five Cents)
by issuing 10,194 (ten thousand and one hundred ninety-four) new shares C with a par value of EUR 1.25 (one Euros and
twenty-five cents) each, having the same rights and obligations of the existing shares, together with a share premium
amounting to EUR 3,949,347.55 (three million nine hundred and forty-nine thousand three hundred forty-seven Euros
and fifty-five cents)

<i>Second resolution

<i>Intervention - Subscription - Payment

All the 10,194 C-shares (ten thousand one hundred ninety-four) shares representing the entire share capital increase

of the Company and the Share Premium have been entirely subscribed and fully paid up in cash as follows:

Shareholder

Number of shares

subscribed

Shares Premium

amount

Iann Quinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,097

1,974,673.775

Enda Quinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,097

1,974,673.775

Therefore the amount of EUR 3,962,090.- (three million nine hundred and sixty-two thousand ninety euros) is as now

at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary by producing a blocked funds certificate
issued by DRESDNER BANK AG, on the 21st June 2007

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it is resolved to amend article 5 first and second

paragraphs of the Articles of association that henceforth will be read as follows:

«The subscribed corporate capital amounts to EUR 43,742.05 (forty-three thousands seven hundred forty-two Euros

and five Cents) It is represented by 34,994 (thirty-four thousand nine hundred ninety-four) shares, with a par value of
EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) each.

The shares are divided into three classes of twelve thousand four hundred (12,400) A-shares, twelve thousand four

hundred (12,400) B-shares and ten thousand one hundred ninety-four (10,194) C-shares».

<i>Fourth resolution

The Shareholders decide to add a new paragraph in Articles 6 with the following wording: «The Company's shares

are redeemable under the conditions laid down by the Law, in particular by article 49-8 of the Law».

<i>Fifth resolution

The Shareholders decide to amend Articles 7 first Paragraph to give it the following wording:
«The Company is administered by a board of directors of not less than three members, shareholders or not. The

board is composed of Director for each class of shares.

The Directors shall be appointed by the Shareholders at the annual general meeting of Shareholders for a period which

may not exceed six years. One Directors shall be elected from a list of candidates proposed by the holders of more than
50% of the «B» Shares (the «B» Directors); one Director shall be elected from a list of candidates proposed by the holders
of more than 50% of the «C» Shares (the «C» Director), one Director shall be elected from a list of candidates proposed
by the holders of more than 50% of the «A» Shares (the «A» Director). They shall hold office until their successors are
elected. Their re-election is authorised. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is
deemed to be elected for 6 years from the date of his election.»

<i>Sixth resolution

The Shareholders decide to amend Articles 8 third Paragraph to give it the following wording:
«The board of Directors can only validly debate and take decision if the majority of them is present or represented,

proxies between Directors being permitted. A Director may be represented by a fellow Director. A Director may only
represent one other Director. At board meeting, each of the Directors shall have one vote. Resolutions of the Board
will be passed if more votes are cast for than against them..»

<i>Seventh resolution

The Shareholders decide to add a new paragraph in Articles 8 with the following wording:
«One or more Directors may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication thus enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. Such meetings shall be
considered equivalent as a meeting held at the registered office of the Company.»

<i>Height resolution

The Shareholders decide to amend Articles 12 to give it the following wording:

96277

«Towards third Parties, the Company is in all circumstances committed by the joint signatures of a Director B jointly

with the individual signature of a Director A or C or by the sole signature of the delegate of the board if any acting within
the limits of his powers.»

The Shareholders decide to insert a new Article 6.1 with the following wording:

<i>Ninth resolution

«6.1 Without prejudice of the provisions stated in other separate agreement if the holders of 50% or more in par

value of the Shares in issue for the time being (Selling Shareholders) wish to transfer all of their interest in Shares (Sellers'
Shares) to a bona fide arms' length purchaser (Proposed Buyer), the Selling Shareholders may require all the other holders
of Shares (Called Shareholders) to sell and transfer all their shares to the Proposed Buyer or as the Proposed Buyer
directs in accordance with the provisions of this clause (Drag Along Option).

6.1.a The Selling Shareholders may exercise the Drag Along Option by giving written notice to that effect (Drag Along

Notice) at any time before the transfer of the Sellers' Shares to the Proposed Buyer. The Drag Along Notice shall specify
that:

(i) that the Called Shareholders are required to transfer all (and not some only) of their Shares (Called Shares) pursuant

to this clause;

(ii) the person(s) to whom the Called Shares are to be transferred;
(iii) the consideration payable for the Called Shares calculated in accordance with the provision of separate agreements.
(iv) subject to specific provisions in separate agreements, the terms of any warranties, representations or indemnities

given by them to the Proposed Buyer and accordingly also to be provided to the Proposed Buyer by the Called Share-
holders; and

(v) the proposed date of the transfer.
6.1.b Once issued, a Drag Along Notice shall be irrevocable. However, a Drag Along Notice shall lapse if, for any

reason, the Selling Shareholders have not sold the Sellers' Shares to the Proposed Buyer within 90 days of serving the
Drag Along Notice. The Selling Shareholders may serve further Drag Along Notices following the lapse of any particular
Drag Along Notice.

6.1.c The Called Shareholders shall sell each Called Share for the amount which they would be entitled to receive if

the total consideration proposed to be paid by the Proposed Buyer were distributed to the holders of the Called Shares
and the Sellers' Shares in accordance with their respective holdings of par value of equity share capital.

6.1.d No Drag Along Notice shall require a Called Shareholder to agree to any terms except those specifically set out

in this clause or which are not otherwise reasonably incidental to those specifically set out in this clause or a transaction
of the general nature of the sale the subject of the Drag Along Notice.

6.1.e Completion of the sale of the Called Shares shall take place on the same date as the date proposed for completion

of the sale of the Sellers' Shares unless:

(i) all of the Called Shareholders and the Selling Shareholders agree otherwise; or
(ii) that date is less than 15 days after the Drag Along Notice, in which case completion of the sale shall be delayed

until the 15th day after service of the Drag Along Notic

6.1.f No rights of pre-emption or similar restrictions which may be set out in the Articles shall apply to any transfer

of shares to a Proposed Buyer (or as it may direct) pursuant to a sale for which a Drag Along Notice has been duly served.

6.1.g Within 10 days of service of a Drag Along Notice, the Called Shareholders shall deliver stock transfer forms for

the Called Shares, together with the relevant share certificate (or a suitable indemnity for any lost share certificate) to
the Company to be held for the purposes of securing performance of the provisions of this clause. On the expiration of
that period, the Company shall pay the Called Shareholders, on behalf of the Proposed Buyer, the amounts they are due
pursuant to this clause to the extent that the Proposed Buyer has put the Company in the requisite funds. The Company's
receipt for the price shall be a good discharge to the Proposed Buyer. The Company shall hold the amounts due to the
Called Shareholders pursuant to this clause in trust for the Called Shareholders without any obligation to pay interest.

6.1.h To the extent that the Proposed Buyer has not, on the expiration of the period referred to above, put the

Company in funds to pay the consideration due pursuant to this clause, the Called Shareholders shall be entitled to the
return of the stock transfer form and share certificate (or suitable indemnity) for the relevant Called Shares and the
Called Shareholders shall have no further rights or obligations under this clause in respect of their Shares (except in
connection with any further Drag Along Notices which may be served).

6.1.i If any Called Shareholder does not, on completion of the sale of the Called Shares execute transfer(s) and which-

ever deed or document as may be necessary to give effect to clause 6.1.a.iv or clause 6.1.d in respect of all of the Called
Shares held by it, the defaulting Called Shareholder shall be deemed to have irrevocably appointed any person nominated
for the purpose by the Selling Shareholders to be their agent and attorney to execute all necessary transfer(s), deeds or
documents on his behalf, against receipt by the Company (on trust for such holder) of the consideration payable for the
Called Shares, deliver such transfer(s), deeds or documents to the Proposed Buyer (or as they may direct). After the
Proposed Buyer (or its nominee) has been registered as the holder, the validity of such proceedings shall not be questioned

96278

by any such person. It shall not be an impediment to the registration of shares under this clause that a share certificate
has not been produced.

6.1.j Following the issue of a Drag Along Notice, on any person becoming a Shareholder of the Company pursuant to

the exercise of a preexisting option to acquire shares in the Company or on the conversion of any convertible security
of the Company (a New Shareholder), a Drag Along Notice shall be deemed to have been served on the New Shareholder
on the same terms as the previous Drag Along Notice. The New Shareholder shall then be bound to sell and transfer all
Shares acquired by it to the Proposed Buyer (or as the Proposed Buyer may direct) and the provisions of this clause shall
apply with the necessary changes to the New Shareholder, except that completion of the sale of the Shares shall take
place immediately on the Drag Along Notice being deemed served on the New Shareholder».

<i>Tenth resolution

The Shareholders accept the resignation of Mr Stephane Weyders as Director B, give him by special vote full discharge

for his mandate and decide to appoint Mr Ian Quinn, as Director C of the Company. Pursuant to Article 52 of the Law
relating to the Commercial companies dated on 10 august 1915, as amended, the new appointed director C will end the
mandate given to the resignated one.

<i>Costs &amp; expenses

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its share capital increase, have been estimated at about forty-three thousand five hundred
Euros (EUR 43,500.-).

There being no further business before the meeting, the latter was thereupon adjourned.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holders of the person appearing, who are known to the notary by his

first and last name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahr zweitausend und sieben, den zweiundzwanzigsten Juni,
Fand vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, niedergelassen in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg,

Eine außerordentliche Hauptversammlung («Hauptversammlung») der Aktionäre der PREFERRED RETAIL S.A., einer

Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société anonyme) mit Sitz in L-2430 Luxemburg, 28, rue Michel Rodange,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 121.179, gegründet am 17. Oktober
2006 mit notarieller Urkunde des Notars Marc Lecuit, niedergelassen in 13, Grand-rue, L-8510 Redange-sur-Attert (Lu-
xemburg), veröffentlicht im Mémorial C der Ausgabe über die Gesellschaften und Vereine vom 19. Dezember 2006,
Nummer 2365 (im Folgenden die «Gesellschaft»), statt.

Die Hauptversammlung wurde um 16 Uhr mit Herrn Alain Thill, Privatbeamter, beruflich niedergelassen in 3, route

de Luxembourg, L-6130 Junglinster, als Vorsitzendem eröffnet.

Der Vorsitzende ernennt Fräulein Monique Goeres, Privatbeamtin, beruflich niedergelassen in 3, route de Luxembourg,

L-6130 Junglinster, zum Sekretär und Herrn Jérôme Bach, Rechtsanwalt, beruflich niedergelassen in 24, avenue Marie-
Thérèse, L-1026 Luxembourg, zum Stimmenzähler.

Nachdem die Besetzung der Hauptversammlung in dieser Weise festgelegt wurde, erklärte und ersuchte der Vorsit-

zende wie folgt:

I. Dass die Tagesordnung der Hauptversammlung wie nachfolgend lautet:
1. Beschluss, das Gesellschaftskapital um EUR 12.742,05 (zwölftausend siebenhundert und zweiundvierzig Euro und

fünf Cent) zu erhöhen, um es von seinem derzeitigen Betrag von EUR 31.000,- (einunddreißig tausend Euro) auf EUR
43.742,05 (dreiundvierzig tausend siebenhundert und zweiundvierzig Euro und fünf Cent) zu bringen durch Ausgabe von
10.194 (zehntausend einhundert und vierundneunzig) C-Aktien mit einem Nennwert von jeweils EUR 1,25 (ein Euro und
fünfundzwanzig Cent) und mit denselben Rechten und Pflichten wie die bereits bestehenden Aktien, zusammen mit einem
Emissionsagio von EUR 3.949.347,55 (drei Millionen neunhundert und neunundvierzig tausend dreihundert und sieben-
undvierzig Euro und fünfundfünfzig Cent);

2. Vermittlung, Zeichnung und Zahlung;
3. auf die vorangehenden Feststellungen und Beschlüsse folgender Beschluss, Artikel 5 der Satzung, erster und zweiter

Absatz, zu ändern;

4. Beschluss, einen neuen Absatz in Artikel 6 der Satzung mit dem folgenden Inhalt einzufügen: «Die Aktien der Ge-

sellschaft  sind  im  Rahmen  der  gesetzlichen  Vorschriften,  insbesondere  nach  der  Vorschrift  des  Artikels  49-8  des
abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften rückkaufbar»;

96279

5. Beschluss, Artikel 7 der Satzung, erster Absatz, zu ändern wie folgt: «Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat

mit nicht weniger als drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre sein müssen, geleitet. Der Verwaltungsrat ist mit einem Ver-
waltungsratsmitglied der Klasse A, einem der Klasse B und einem der Klasse C zu besetzen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären anlässlich der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre

für einen Zeitraum von nicht länger als 6 Jahren ernannt. Ein Verwaltungsratsmitglieder werden von einer Kandidatenliste
gewählt, die von Aktionären vorgeschlagen wurde, die zusammen mehr als 50% der «B»- Aktien halten (die Verwal-
tungsratsmitglieder der Klasse B), ein Verwaltungsratsmitglied wird von einer Kandidatenliste gewählt, die von Aktionären
vorgeschlagen wurde, die zusammen mehr als 50% der «C»- Aktien halten (Verwaltungsratsmitglied der Klasse C), ein
Verwaltungsratsmitglied wird von einer Kandidatenliste gewählt, die von Aktionären vorgeschlagen wurde, die zusammen
mehr als 50% der «A»- Aktien halten (Verwaltungsratsmitglied der Klasse A). Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im
Amt, bis deren Nachfolger bestimmt sind. Ihre Wiederwahl ist möglich. Falls ein Verwaltungsratsmitglied ohne Bezeich-
nung der Dauer seines Mandats ernannt wurde, ist davon auszugehen, dass das Mandat 6 Jahre dauert, beginnend mit dem
Tag der Ernennung.»

6. Beschluss, Artikel 8 der Satzung, dritter Absatz, zu ändern wie folgt: «Der Verwaltungsrat ist abstimmungs- und

beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei die Vertretung von Verwal-
tungsratsmitgliedern  untereinander  oder  durch  Dritte  erlaubt  ist.  Ein  Verwaltungsratsmitglied  kann  nur  ein  weiteres
Verwaltungsratsmitglied vertreten. Bei Versammlungen des Verwaltungsrats haben alle Verwaltungsratsmitglieder eine
Stimme. Beschlüsse des Verwaltungsrats werden bei Stimmenmehrheit verabschiedet.»

7. Beschluss, in Artikel 8 der Satzung einen neuen Absatz mit folgendem Inhalt einzufügen: «Ein oder mehrere Ver-

waltungsratsmitglieder können über eine Konferenzschaltung, eine Videokonferenz oder mittels ähnlicher Kommunika-
tionsmittel  an  der  Versammlung  teilnehmen,  die  es  mehreren  Personen  ermöglicht,  gleichzeitig  miteinander  zu
kommunizieren. Diese Form der Teilnahme steht der physischen Teilnahme an der Versammlung gleich; des Weiteren
steht diese Art der Versammlung einer Versammlung, die am Sitz der Gesellschaft stattfindet, gleich.»

8. Beschluss, Artikel 12 der Satzung abzuändern wie folgt: «Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft durch die ge-

meinsam abzugebenden Unterschriften eines Verwaltungsratsmitglieds der Klasse B und eines Verwaltungsratsmitglieds
der Klasse A oder C verpflichtet, oder, falls ein solches bestimmt ist, durch die Einzelunterschrift des mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitglieds, sofern dieses innerhalb der Grenzen seiner Befugnisse handelt.»

9. Beschluss, einen neuen Artikel 6.1 in die Satzung einzufügen, der den folgenden Inhalt hat:
6.1. Unbeschadet von in separaten Vereinbarungen getroffenen Regelungen können, im Fall, dass eine Anzahl von

Aktionären, die zusammen 50% oder mehr des Gesellschaftskapitals in Form von Nennwertaktien repräsentieren, die zu
dem entsprechenden Zeitpunkt ausgegeben sind (Verkäuferaktionäre) ihre gesamten Gesellschaftsanteile (Verkaufsaktien)
an einen in gutem Glauben handelnden Dritten (Käufer) verkaufen wollen, die Verkäuferaktionäre verlangen, dass die
übrigen Aktionäre (aufgerufene Aktionäre) ihre gesamten Gesellschaftsanteile an den Käufer verkaufen und übertragen
oder nach Vorgabe des Käufer in Übereinstimmung mit den Vorgaben dieser Regelung (Drag Along option; Recht zur
Verkausfverpflichtung).

6.1.a. Die Verkäuferaktionäre können das Recht zur Kaufverpflichtung zu jedem Zeitpunkt vor der Übertragung der

Verkaufsaktien an den Käufer durch schriftliche Mitteilung (Mitteilung über die Verkaufsverpflichtung) ausüben. Die Mit-
teilung über die Verkaufsverpflichtung soll beinhalten:

(i) dass die aufgerufenen Aktionäre aufgefordert werden, ihre gesamten Aktien (geforderte Aktien) in Übereinstirn-

mung mit dieser Regelung zu übertragen;

(ii) die Person(en), an die die geforderten Aktien übertragen werden soll(en);
(iii) der für die geforderten Aktien zu zahlende und auf der Grundlage separater Vereinbarungen zu zahlende Betrag;
(iv) die separaten Vereinbarungen unterliegenden Bedingungen für Zusicherungen, Vertretungen oder Abfindungen,

die dem Käufer gegebenenfalls von den Verkäuferaktionären gewährt werden und entsprechend von den aufgerufenen
Aktionären zu gewähren sind und

(v) der für die Übertragung der Aktien vorgeschlagene Termin.
6.1.b. Die Mitteilung über die Verkaufsverpflichtung ist unwiderrufbar. Demgegenüber erlischt die Mitteilung über die

Verkaufsverpflichtung, wenn die Verkaufsaktien nicht innerhalb von 90 Tagen ab dem Tag der Mitteilung von den Ver-
käuferaktionären an den Käufer verkauft wurden. Die Verkäuferaktionäre können nach jedem Erlöschen einer Mitteilung
über die Verkaufsverpflichtung eine neue Mitteilung dieser Art tätigen.

6.1.c. Die aufgerufenen Aktionäre verkaufen jede der geforderten Aktien zu dem Preis, der ihnen zugestanden hätte,

wenn der von dem Käufer vorgeschlagene Endpreis an die Inhaber der geforderten Aktien und der Verkaufsaktien in
Übereinstimmung mit den entsprechend von ihnen gehaltenen Anteilen am Nennwert des Kapitals ausgezahlt würde.

6.1.d. Eine Mitteilung über die Verkaufsverpflichtung kann einen aufgerufenen Aktionär nicht dazu verpflichten, anderen

Bedingungen außer denen zuzustimmen, die ausdrücklich in dieser Regelung vorgesehen sind oder mit diesen in engem
Zusammenhang stehen oder eine Übertragung der Art, wie sie in der Mitteilung über die Verkaufsverpflichtung enthalten
ist, darstellen.

6.1.e. Der Abschluss des Verkaufs der geforderten Aktien findet am selben Tage statt wie der Verkauf der Verkaufs-

aktien, es sei denn:

96280

(i) dass alle aufgerufenen Aktionäre und Verkäuferaktionäre etwas anderes vereinbaren; oder
(ii) dass für den Verkauf ein Termin innerhalb der ersten 15 Tage nach der Mitteilung über die Verkaufsverpflichtung

vereinbart wurde; in diesem Fall ist der Termin bis zum 15. Tag nach dieser Mitteilung aufzuschieben.

6.1.f. Auf die Übertragung von Aktien an einen Käufer aufgrund einer Mitteilung über eine Verkaufsverpflichtung finden

keinerlei Vorkaufsrechte oder ähnliche Rechte, wie sie in der Satzung vorgesehen sein mögen, Anwendung.

6.1.g. Innerhalb von 10 Tagen nach einer Mitteilung über eine Verkaufspflicht übergeben die aufgerufenen Aktionäre

die Dokumente über den Verkauf der geforderten Aktien zusammen mit den Aktienzertifikaten (oder einen entsprech-
enden Ersatz für jegliches verloren gegangene Aktienzertifikat) an die Gesellschaft, die diese aufbewahrt, um das Vorgehen
in Übereinstimmung mit dieser Regelung sicher zu stellen. Bei Fristablauf zahlt die Gesellschaft den aufgerufenen Aktio-
nären im Namen des Käufers diejenigen Beträge, die nach dieser Regelung zu zahlen sind, unter der Voraussetzung, dass
der Käufer die entsprechenden Beträge zur Verfügung gestellt hat. Die Empfangsbestätigung seitens der Gesellschaft
entlastet den Käufer. Die Gesellschaft nimmt die an die aufgeforderten Aktionäre zu zahlenden Beträge treuhänderisch
für die aufgeforderten Aktionäre an, ohne zur Zahlung von Zinsen verpflichtet zu sein.

6.1.h. Sofern der Käufer die benötigten Finanzmittel zur Auszahlung an die aufgeforderten Aktionäre nicht innerhalb

der oben angegebenen Frist zur Verfügung gestellt hat, können die aufgeforderten Aktionäre die Rückgabe der Dokumente
zur Übertragung der geforderten Aktien und der Aktienzertifikate (oder des entsprechenden Ersatzes) verlangen; die
aufgeforderten Aktionäre haben in diesem Fall keine weiteren Rechte und Pflichten aus dieser Regelung in Bezug auf ihre
Aktien (außer in Bezug auf von anderen Mitteilungen über eine Verkaufspflicht betroffene Aktien).

6.1.i  Im  Fall,  dass  ein  aufgeforderter  Aktionär  im  Zuge  des  Abschlusses  des  Verkaufs  der  geforderten  Aktien  die

Übertragung und den gegebenenfalls bestehenden  Vertrag  oder  jegliche  andere Vereinbarung,  deren  Ausführung zur
Umsetzung von Artikel 6.1.a.iv oder Artikel 6.1.d notwendig ist, nicht hinsichtlich aller von ihm gehaltenen Aktien ausführt,
wird eine zu diesem Zweck von den aufgerufenen Aktionären benannte Person als von diesem Aktionär unwiderruflich
zum Vertreter und Verwalter berufen angesehen, der alle gegenüber dem Käufer notwendigen Übertragungen und Aus-
führungen von Verträgen und anderen Vereinbarungen in ihrem Namen und gegen Annahme der an die aufgerufenen
Aktionäre zu zahlenden Beträge seitens der Gesellschaft (treuhänderisch für die Aktieninhaber) vornimmt.

Ab der Eintragung des Käufers als Aktieninhaber besteht keine Möglichkeit mehr, die Gültigkeit dieser Vorgehensweise

anzugreifen. Das NichtVorliegen eines Aktienzertifikats steht der Eintragung der Aktien nicht entgegen.

6.1.j. Nach der Mitteilung über eine Verkaufspflicht ist in Bezug auf jede Person, die aufgrund einer schon vorher

bestehenden Kaufoption neuer Aktionär der Gesellschaft wird oder in Bezug auf die Umwandlung von umtauschbaren
Wertpapieren eine Mitteilung über die Verkaufspflicht als unter denselben Bedingungen gegenüber dem neuen Aktienin-
haber erfolgt anzusehen. Der neue Aktieninhaber ist in diesem Fall verpflichtet, alle erworbenen Aktien an den Käufer
zu verkaufen und zu übertragen (oder im Sinne des Käufers zu verfahren) und die Voraussetzungen dieser Regelung sind
mit den notwendigen Änderungen auf den neuen Aktieninhaber anzuwenden, außer dass die Durchführung des Verkaufs
der Aktien sofort nach der Mitteilung über die Verkaufspflicht, die als auch gegenüber dem neuen Aktieninhaber bekannt
gegeben gilt, stattfindet.»;

10. Annahme des Rücktritts von Stéphane Weyders als Verwaltungsratsmitglied der Klasse B und Ernennung von Herrn

Ian Quinn als Verwaltungsratsmitglied der Klasse C sowie Festlegung der Dauer seines Mandats;

11. Verschiedenes.
II. Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl

ihrer jeweiligen Aktien aus der Anwesenheitsliste hervorgehen; diese bleibt, unterschrieben von den anwesenden Akti-
onären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und der wie oben angegebenen Besetzung der Hauptversamm-
lung dem vorliegenden Protokoll dauerhaft beigefügt, um mit diesem zusammen einregistriert zu werden. Die schriftlichen
Vollmachten der vertretenen Aktionäre, von den erschienenen Personen ne varietur unterschrieben, bleiben dem vor-
liegenden Protokoll ebenfalls dauerhaft beigefügt.

III. Dass das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft bei dieser Hauptversammlung vertreten ist und alle anwe-

senden und vertretenen Aktionäre erklären, ordnungsgemäß zu dieser Hauptversammlung einberufen worden zu sein
und vorab umfassende Kenntnis von der Tagesordnung dieser Hauptversammlung erlangt zu haben, und dass alle anwe-
senden oder vertretenen Aktionäre ausdrücklich erklären, auf die Einberufungsformalitäten zu verzichten, so dass eine
entsprechende Mitteilung nicht notwendig war.

IV. Dass diese Hauptversammlung, in der das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert ist, ordnungsgemäß durchge-

führt wurde und wirksam über die Tagesordnungspunkte entscheiden kann.

Nach Annahme der Erklärung des Vorsitzenden und nach Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung nimmt

die Hauptversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse an:

<i>Erster Beschluss

Die Aktionäre beschließen die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 12.742,05 (zwölftausend siebenhundert

und zweiundvierzig Euro und fünf Cent), um es von seinem derzeitigen Betrag von EUR 31.000,- (einunddreißig tausend
Euro) auf EUR 43.742,05 (dreiundvierzig tausend siebenhundert und zweiundvierzig Euro und fünf Cent) zu bringen durch
Ausgabe von 10.194 (zehntausend einhundert und vierundneunzig) Aktien mit einem Nennwert von jeweils EUR 1,25
(ein Euro und fünfundzwanzig Cent) und mit denselben Rechten und Pflichten wie die bereits bestehenden Aktien, zu-

96281

sammen  mit  einem  Emissionsagio  von  EUR  3.949.347,55  (drei  Millionen  neunhundert  und  neunundvierzig  tausend
dreihundertsiebenundvierzig Euro und fünfundfünfzig Cent).

<i>Zweiter Beschluss

Alle 10.194 (zehn tausend einhundert und vierundneunzig) C-Aktien, die die gesamte Erhöhung des Gesellschaftska-

pitals einschließlich Aufgeld darstellen, wurden vollständig gezeichnet und in bar eingezahlt wie folgt:

Aktionär

Anzahl gezeichneter Aktien

Emissionsagio

Iann Quinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.097

1.974.673,775

Enda Quinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.097

1.974.673,775

Entsprechend steht der Gesellschaft ab sofort ein Betrag von EUR 3.962.090,- (drei Millionen neunhundert und zwei-

undsechzig tausend neunzig Euro) zur Verfügung, wie es dem unterzeichneten Notar anhand einer Bescheinigung über
die Sperrung dieses Betrages (certificat de blocage), ausgestellt von der DRESDNER BANK AG am 21. Juni 2007 nach-
gewiesen wurde.

<i>Dritter Beschluss

Auf die vorangehenden Erklärungen und Beschlüsse folgend wird Artikel 5 der Satzung, erster und zweiter Absatz,

geändert und hat künftig folgenden Wortlaut:

«Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 43.742.05,- (dreiundvierzig tausend siebenhundert und zweiund-

vierzig Euro und fünf Cent). Es ist aufgeteilt auf 34.994 (vierunddreißig tausend neunhundert und vierundneunzig) Aktien
mit einem jeweiligen Nennwert von EUR 1,25 (ein Euro und fünfundzwanzig Cent).

Die Aktien sind in drei Klassen eingeteilt und bestehen aus 12.400 (zwölf tausend und vierhundert) Aktien der Klasse

A, 12.400 (zwölf tausend und vierhundert) Aktien der Klasse B und 10.194 (zehn tausend und einhundertvierundneunzig)
Aktien der Klasse C.»

<i>Vierter Beschluss

Es wird ein neuer Absatz in Artikel 6 eingefügt, der den folgenden Wortlaut hat:
«Die Aktien der Gesellschaft sind im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach der Vorschrift des

Artikels 49-8 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften rückkaufbar.»

<i>Fünfter Beschluss

Artikel 7 der Satzung, erster Absatz, wird geändert und hat künftig den folgenden Wortlaut:
«Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat mit nicht weniger als drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre sein

müssen, geleitet. Der Verwaltungsrat ist mit einem Verwaltungsratsmitglied der Klasse A, einem der Klasse B und einem
der Klasse C zu besetzen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären anlässlich der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre

für einen Zeitraum von nicht länger als 6 Jahren ernannt. Ein Verwaltungsratsmitglieder werden von einer Kandidatenliste
gewählt, die von Aktionären vorgeschlagen wurde, die zusammen mehr als 50% der «B»- Aktien halten (die Verwal-
tungsratsmitglieder der Klasse B), ein Verwaltungsratsmitglied wird von einer Kandidatenliste gewählt, die von Aktionären
vorgeschlagen wurde, die zusammen mehr als 50% der «C»- Aktien halten (Verwaltungsratsmitglied der Klasse C), ein
Verwaltungsratsmitglied wird von einer Kandidatenliste gewählt, die von Aktionären vorgeschlagen wurde, die zusammen
mehr als 50% der «A»-Aktien halten (Verwaltungsratsmitglied der Klasse A). Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im
Amt, bis deren Nachfolger bestimmt sind. Ihre Wiederwahl ist möglich. Falls ein Verwaltungsratsmitglied ohne Bezeich-
nung der Dauer seines Mandats ernannt wurde, ist davon auszugehen, dass das Mandat 6 Jahre dauert, beginnend mit dem
Tag der Ernennung.»

<i>Sechster Beschluss

Artikel 8 der Satzung, dritter Absatz, wird geändert und hat künftig den folgenden Wortlaut:
«Der Verwaltungsrat ist abstimmungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder ver-

treten  ist,  wobei  die  Vertretung  von  Verwaltungsratsmitgliedern  untereinander  oder  durch  Dritte  erlaubt  ist.  Ein
Verwaltungsratsmitglied kann nur ein weiteres Verwaltungsratsmitglied vertreten. Bei Versammlungen des Verwaltungs-
rats haben alle Verwaltungsratsmitglieder eine Stimme. Beschlüsse des Verwaltungsrats werden bei Stimmenmehrheit
verabschiedet.»

<i>Siebter Beschluss

Es wird ein neuer Absatz in Artikel 8 eingefügt, der den folgenden Wortlaut hat:
«Ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder können über eine Konferenzschaltung, eine Videokonferenz oder mittels

ähnlicher Kommunikationsmittel an der Versammlung teilnehmen, die es mehreren Personen ermöglicht, gleichzeitig
miteinander zu kommunizieren. Diese Form der Teilnahme steht der physischen Teilnahme an der Versammlung gleich;
des Weiteren steht diese Art der Versammlung einer Versammlung, die am Sitz der Gesellschaft stattfindet, gleich.»

<i>Achter Beschluss

Artikel 12 der Satzung wird geändert und hat künftig den folgenden Wortlaut:

96282

«Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft durch die gemeinsam abzugebenden Unterschriften eines Verwaltungsrats-

mitglieds der Klasse B und eines Verwaltungsratsmitglieds der Klasse A oder C verpflichtet, oder, falls ein solches bestimmt
ist, durch die Einzelunterschrift des mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitglieds, sofern
dieses innerhalb der Grenzen seiner Befugnisse handelt.»

<i>Neunter Beschluss

Es wird ein neuer Artikel 6.1 eingefügt, der den folgenden Wortlaut hat:
«6.1 Unbeschadet von in separaten Vereinbarungen getroffenen Regelungen können, im Fall, dass eine Anzahl von

Aktionären, die zusammen 50% oder mehr des Gesellschaftskapitals in Form von Nennwertaktien repräsentieren, die zu
dem entsprechenden Zeitpunkt ausgegeben sind (Verkäuferaktionäre) ihre gesamten Gesellschaftsanteile (Verkaufsaktien)
an einen in gutem Glauben handelnden Dritten (Käufer) verkaufen wollen, die Verkäuferaktionäre verlangen, dass die
übrigen Aktionäre (aufgerufene Aktionäre) ihre gesamten Gesellschaftsanteile an den Käufer verkaufen und übertragen
oder nach Vorgabe des Käufer in Übereinstimmung mit den Vorgaben dieser Regelung (Drag Along option; Recht zur
Verkausfverpflichtung).

6.1.a Die Verkäuferaktionäre können das Recht zur Kaufverpflichtung zu jedem Zeitpunkt vor der Übertragung der

Verkaufsaktien an den Käufer durch schriftliche Mitteilung (Mitteilung über die Verkaufsverpflichtung) ausüben. Die Mit-
teilung über die Verkaufsverpflichtung soll beinhalten:

(i) dass die aufgerufenen Aktionäre aufgefordert werden, ihre gesamten Aktien (geforderte Aktien) in Übereinstimmung

mit dieser Regelung zu übertragen;

(ii) die Person(en), an die die geforderten Aktien übertragen werden soll(en);
(iii) der für die geforderten Aktien zu zahlende und auf der Grundlage separater Vereinbarungen zu zahlende Betrag;
(iv) die separaten Vereinbarungen unterliegenden Bedingungen für Zusicherungen, Vertretungen oder Abfindungen,

die dem Käufer gegebenenfalls von den Verkäuferaktionären gewährt werden und entsprechend von den aufgerufenen
Aktionären zu gewähren sind und

(v) der für die Übertragung der Aktien vorgeschlagene Termin.
6.1.b Die Mitteilung über die Verkaufsverpflichtung ist unwiderrufbar. Demgegenüber erlischt die Mitteilung über die

Verkaufsverpflichtung, wenn die Verkaufsaktien nicht innerhalb von 90 Tagen ab dem Tag der Mitteilung von den Ver-
käuferaktionären an den Käufer verkauft wurden. Die Verkäuferaktionäre können nach jedem Erlöschen einer Mitteilung
über die Verkaufsverpflichtung eine neue Mitteilung dieser Art tätigen.

6.1.c Die aufgerufenen Aktionäre verkaufen jede der geforderten Aktien zu dem Preis, der ihnen zugestanden hätte,

wenn der von dem Käufer vorgeschlagene Endpreis an die Inhaber der geforderten Aktien und der Verkaufsaktien in
Übereinstimmung mit den entsprechend von ihnen gehaltenen Anteilen am Nennwert des Kapitals ausgezahlt würde.

6.1.d Eine Mitteilung über die Verkaufsverpflichtung kann einen aufgerufenen Aktionär nicht dazu verpflichten, anderen

Bedingungen außer denen zuzustimmen, die ausdrücklich in dieser Regelung vorgesehen sind oder mit diesen in engem
Zusammenhang stehen oder eine Übertragung der Art, wie sie in der Mitteilung über die Verkaufsverpflichtung enthalten
ist, darstellen.

6.1.e Der Abschluss des Verkaufs der geforderten Aktien findet am selben Tage statt wie der Verkauf der Verkaufs-

aktien, es sei denn:

(i) dass alle aufgerufenen Aktionäre und Verkäuferaktionäre etwas anderes vereinbaren; oder
(ii) dass für den Verkauf ein Termin innerhalb der ersten 15 Tage nach der Mitteilung über die Verkaufsverpflichtung

vereinbart wurde; in diesem Fall ist der Termin bis zum 15. Tag nach dieser Mitteilung aufzuschieben.

6.1.f Auf die Übertragung von Aktien an einen Käufer aufgrund einer Mitteilung über eine Verkaufsverpflichtung finden

keinerlei Vorkaufsrechte oder ähnliche Rechte, wie sie in der Satzung vorgesehen sein mögen, Anwendung.

6.1.g Innerhalb von 10 Tagen nach einer Mitteilung über eine Verkaufspflicht übergeben die aufgerufenen Aktionäre

die Dokumente über den Verkauf der geforderten Aktien zusammen mit den Aktienzertifikaten (oder einen entsprech-
enden Ersatz für jegliches verloren gegangene Aktienzertifikat) an die Gesellschaft, die diese aufbewahrt, um das Vorgehen
in Übereinstimmung mit dieser Regelung sicher zu stellen. Bei Fristablauf zahlt die Gesellschaft den aufgerufenen Aktio-
nären im Namen des Käufers diejenigen Beträge, die nach dieser Regelung zu zahlen sind, unter der Voraussetzung, dass
der Käufer die entsprechenden Beträge zur Verfügung gestellt hat. Die Empfangsbestätigung seitens der Gesellschaft
entlastet den Käufer. Die Gesellschaft nimmt die an die aufgeforderten Aktionäre zu zahlenden Beträge treuhänderisch
für die aufgeforderten Aktionäre an, ohne zur Zahlung von Zinsen verpflichtet zu sein.

6.1.h Sofern der Käufer die benötigten Finanzmittel zur Auszahlung an die aufgeforderten Aktionäre nicht innerhalb

der oben angegebenen Frist zur Verfügung gestellt hat, können die aufgeforderten Aktionäre die Rückgabe der Dokumente
zur Übertragung der geforderten Aktien und der Aktienzertifikate (oder des entsprechenden Ersatzes) verlangen; die
aufgeforderten Aktionäre haben in diesem Fall keine weiteren Rechte und Pflichten aus dieser Regelung in Bezug auf ihre
Aktien (außer in Bezug auf von anderen Mitteilungen über eine Verkaufspflicht betroffene Aktien).

6.1.i  Im  Fall,  dass  ein  aufgeforderter  Aktionär  im  Zuge  des  Abschlusses  des  Verkaufs  der  geforderten  Aktien  die

Übertragung  und den  gegebenenfalls bestehenden  Vertrag  oder  jegliche  andere  Vereinbarung,  deren  Ausführung zur
Umsetzung von Artikel 6.1.a.iv oder Artikel 6.1.d notwendig ist, nicht hinsichtlich aller von ihm gehaltenen Aktien ausführt,

96283

wird eine zu diesem Zweck von den aufgerufenen Aktionären benannte Person als von diesem Aktionär unwiderruflich
zum Vertreter und Verwalter berufen angesehen, der alle gegenüber dem Käufer notwendigen Übertragungen und Aus-
führungen von Verträgen und anderen Vereinbarungen in ihrem Namen und gegen Annahme der an die aufgerufenen
Aktionäre zu zahlenden Beträge seitens der Gesellschaft (treuhänderisch für die Aktieninhaber) vornimmt.

Ab der Eintragung des Käufers als Aktieninhaber besteht keine Möglichkeit mehr, die Gültigkeit dieser Vorgehensweise

anzugreifen. Das NichtVorliegen eines Aktienzertifikats steht der Eintragung der Aktien nicht entgegen.

6.1.j Nach der Mitteilung über eine Verkaufspflicht ist in Bezug auf jede Person, die aufgrund einer schon vorher

bestehenden Kaufoption neuer Aktionär der Gesellschaft wird oder in Bezug auf die Umwandlung von umtauschbaren
Wertpapieren eine Mitteilung über die Verkaufspflicht als unter denselben Bedingungen gegenüber dem neuen Aktienin-
haber erfolgt anzusehen. Der neue Aktieninhaber ist in diesem Fall verpflichtet, alle erworbenen Aktien an den Käufer
zu verkaufen und zu übertragen (oder im Sinne des Käufers zu verfahren) und die Voraussetzungen dieser Regelung sind
mit den notwendigen Änderungen auf den neuen Aktieninhaber anzuwenden, außer dass die Durchführung des Verkaufs
der Aktien sofort nach der Mitteilung über die Verkaufspflicht, die als auch gegenüber dem neuen Aktieninhaber bekannt
gegeben gilt, stattfindet.»

<i>Zehnter Beschluss

Die Aktionäre nehmen den Rücktritt von Stéphane Weyders als Verwaltungsratsmitglied der Klasse B an und befreien

ihn von allen Pflichten des Mandats. Ian Quinn, wird zum Verwaltungsratsmitglied der Klasse C ernannt. Gemäß Artikel
52 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften beendet das neu ernannte Verwal-
tungsratsmitglied der Klasse C das Mandat des zurücktretenden Verwaltungsratsmitglieds.

<i>Kosten &amp; Gebühren

Die Kosten, Gebühren und sonstigen Auslagen jeglicher Art, die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer

Kapitalerhöhung zu bezahlen sind oder dieser in Rechnung gestellt werden, werden auf drei und vierzig tausend fünf
hundert Euro (43.500,- Euro) geschätzt.

Nachdem keine weiteren Punkte zu erörtern waren, wurde die Hauptversammlung geschlossen.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass das vorliegende Dokument auf den

Wunsch der erschienenen Person in englischer Sprache abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf
den weiteren Wunsch derselben erschienenen Person wird erklärt, dass im Fall von Abweichungen zwischen der engli-
schen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Worüber die vorliegende Urkunde, in Luxemburg und an dem oben angegebenen Tag erstellt wurde.
Das vorliegende Dokument wurde den Bevollmächtigten der erschienenen Person vorgelesen, die dem Notar mit Vor-

und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt sind; dieser unterzeichnete mit Uns, dem Notar, das vorliegende
Originaldokument.

Gezeichnet: A. Thill, M. Goeres, J. Bach, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 juillet 2007. Relation GRE/2007/2899. — Reçu 39.620,90 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 7 août 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007096473/231/571.
(070108427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2007.

GE Healthcare European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.736.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 58.866.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société (l'Assemblée Générale)

<i>du 22 mai 2007

L'Assemblée Générale nomme comme gérants de la Société:
- Roeland P. Pels, né le 28 août 1949 à Hilversum, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636

Luxembourg;

- Stephen M. Parks, né le 23 février 1958 à Illinois, Etats-Unis, avec adresse professionnelle au 3135, Easton Turnpike,

Fairfield, CT 06431;

- Marlin Risinger, né le 8 décembre 1954 à Louisiana, Etats-Unis, avec adresse professionnelle au 6, Agar Street, WC2N

4HR, Londres, Angleterre; et

96284

- Boris Eric Pierre Henry, né le 18 septembre 1970 à Hermalle-sous-Argenteau, Belgique, demeurant au 1, Clos des

Sources, B-4130 Tilff, Belgique.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007096472/2460/25.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2007, réf. LSO-CH02777. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070108008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2007.

Courtain Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 82.553.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 25 juillet 2007, que l'Assemblée

a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 4

juin 2007 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le
Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur
Salvatore Desiderio, en qualité d'Administrateur et décide de nommer les Administrateurs suivants:

- Monsieur Davide Murari, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président

du Conseil d'Administration;

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé

au 31 décembre 2010.

L'Assemblée décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, la société FIDUCIAIRE MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau,

L-1449 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé

au 31 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2007.

COURTAIN HOLDING S.A.
M. La Rocca / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2007096451/43/31.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2007, réf. LSO-CH01563. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070107813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2007.

Nori S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Strassen, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 94.326.

L'an deux mille sept, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NORI S.A., ayant son siège

social à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 94.326, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niede-
ranven, en date du 17 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 821 du 7 août 2003,
dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch,
en date du 2 février 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 585 du 17 juin 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Pascoal Da Silva, demeurant professionnellement à L-2138

Luxembourg, 24, rue St. Mathieu.

96285

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Salin, demeurant professionnellement à L-2138 Lu-

xembourg, 24, rue St. Mathieu.

L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Marta Cotas, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg,

24, rue St. Mathieu.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.-  Qu'il  appert  de  cette  liste  de  présence  que  toutes  les  actions  représentant  l'intégralité  du  capital  social,  sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Transférer le siège de la société du 117, route d'Arlon, L-8009 Strassen au 24, rue St Mathieu, L-2138 Luxembourg.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon à L-2138 Lu-

xembourg, 24, rue St Mathieu et en conséquence de modifier l'article 2, 1 

er

 paragraphe des statuts pour y refléter le

changement apporté suite au transfert de siège social ci-dessus, et de lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: S. Salin, P. Da Silva, M. Cotas, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2007, Relation: LAC/2007/16811. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations

Luxembourg, le 30 juillet 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007096496/242/50.
(070108426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2007.

Tele2 Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 72.203.

Il résulte des décisions prises à l'unanimité par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de TELE2 SERVICES

LUXEMBOURG S.A. (la «Société»), tenue le 18 juin 2007 à 11.00 heures au siège social que:

1. Le renouvellement des mandats des administrateurs suivants a été confirmé jusqu'à l'assemblée générale des ac-

tionnaires devant se prononcer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2007, soit en 2008:

- M. Francesco D'Angelo, demeurant à L-2440 Luxembourg, 40, rue du Rollingergrund,
- M. Lars-Johan Jarnheimer, demeurant à S-18147 Lidingö, Elfviksvägen 40 et

- M. Anders Olsson, demeurant à S-11328 Stockholm, Heimdalsgatan 3, 5 

e

 étage.

2. L'assemblée décide de:
ne pas renouveler le mandat de M. Simon Falk et de M. Christophe Lambot comme commissaires aux comptes de la

société, et

de nommer Mme Delphine Lorho, demeurant à 25, rue de Cessange L-3347 Leudelange et Mme Nadia Dziwinsky,

demeurant à 18, rue Waltzing L-8478 Eischen comme commissaires aux comptes de la société, jusqu'à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires devant se prononcer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2007, soit en 2008.

96286

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2007096480/1053/25.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11982. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070108114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2007.

Green Side Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 46.501.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 12 juin 2007

Les démissions de Marc Muller et Pascale Loewen, Administrateurs ont été acceptées. Frédéric Muller et Laurent

Muller ont été nommés Administrateurs en leurs remplacements et leurs mandats viendront à échéance à l'issue de
l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012.

La démission de Jean-Marc Faber, Commissaire aux comptes, a été acceptée. La société KLOPP &amp; BOUR CONSEILS

S.A. a été nommée Commissaire aux comptes en son remplacement et son mandat viendra à échéance à l'issue de
l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012.

Le mandat de Tom Faber, Administrateur, est reconduit pour une période de six années jusqu'à l'Assemblée Générale

qui se tiendra en 2012.

Par conséquent, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012 se com-

pose comme suit:

- Frédéric Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,

- Laurent Muller, employé privé, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg

- Tom Faber, économiste, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg

Le commissaire aux comptes nommé jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012 est:

- La société KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
<i>GREEN SIDE HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007096424/717/30.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2007, réf. LSO-CH00242. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070108238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2007.

Iberian Opportunities Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 45.940.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social le 24 Avril 2007 a adopté les décisions suivantes:

1. L'assemblée a ré-élu Dr Joao Rendeiro (résident à Lisbonne, Portugal), Messrs Allan Conway (résident à Londres,

Angleterre), Hareb Al Darmaki (résident à Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis) Rui Manuel Machete (résident à Lisbonne,
Portugal) aux fonctions d'administrateurs pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2008.

2. L'assemblée a ré-élu PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. à la fonction de réviseur du fonds pour une période d'un an

se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2008.

96287

<i>For IBERIAN OPPORTUNITIES FUND
HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007096429/41/19.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2007, réf. LSO-CH02729. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070108096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2007.

Cameron (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 86.003.350,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 90.441.

EXTRAIT

Le conseil de gérance de COOPER CAMERON (LUXEMBOURG) SARL a décidé, par résolution circulaire du 8 mai

2006, d'accepter la démission de Mme Julie MacLemore de sa fonction de délégué la gestion journalière de la Société avec
effet au 31 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour COOPER CAMERON (LUXEMBOURG) SARL
B. S. Steichen

Référence de publication: 2007094795/275/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2007, réf. LSO-CH02001. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

Fidessa Business Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 120.405.

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société du 27 juillet 2007

que la démission de Monsieur John Dercksen, en tant que gérant de la Société est acceptée avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

P. Leclercq
<i>Gérant

Référence de publication: 2007094815/7178/16.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2007, réf. LSO-CH01693. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

Armauric-Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R.C.S. Luxembourg B 108.324.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour 

<i>ARMAURIC-LUX S.A.

Signature

Référence de publication: 2007094831/597/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2007, réf. LSO-CH01257. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070106402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

96288


Document Outline

Admy Holding S.A.

AFET (Poland) S.A.

AGD Consulting S.A.

AIM Fund SICAV

Alpine Resort Properties S.A.

Armauric-Lux S.A.

Cameron (Luxembourg) Sàrl

Carlson Wagonlit Luxembourg S.à r.l.

CEB Capital S.A.

Courtain Holding S.A.

DB Akela Sàrl

Design Lardo S.A.

Dinya S.A.

EDL Partners S.A.

Euro Haus + Lufttechnik S.à r.l.

Fidessa Business Services S.à r.l.

Francesca International S.A.

GE Healthcare European Holdings S.à r.l.

Gesilux-Gestion d'Investissement Luxembourgeois S.A.

Green Side Holding S.A.

H51 S.A.

Iberian Opportunities Fund

Immobilière de l'Europe S.A.

Indowood S.A.

Interlatsco Holding S.A.

Iplink S.àr.l.

I.S.C. - International Sponsoring Corporation S.A.

K Alpha S.A.

LeaseFin No 1 S.A.

L'Orchidea S.à.r.l.

LSF IV Euro LT Properties

LSF IV Euro Properties

MHP S.A.

Michelman International Sàrl

Michelman Sàrl

Nicoba S.A.

Nori S.A.

O-Mega Finance S.A.

Orion Sicav

Pardus Investments S.à r.l.

Parfinance S.C.A.

Prague 4 Residential (Luxembourg) S.à r.l.

Preferred Retail S.A.

Principe SA

Raiffeisen EU Enlargement Fund Participations (Luxembourg) S.A.

Restevent Group S.A.

Sanpaolo Immobilière S.A.

Signum Holdings 1 S.à r.l.

S.P.I. Aero S. à r.l.

S.P.I. Aerospace S.à r.l.

Super Jeci S.A.

T2 Capital Finance Company S.A.

Tele2 Services Luxembourg S.A.

The Carlyle Group (Luxembourg) JV

Thomson Travel Holdings S.A.

UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

UnionCSO S.A.

Unité Finance S.à r.l.

Velox Bidco S.à r.l.

Velox Holdco S.à r.l.

WAGON Group S.à r.l.

WCSCF Finance Sàrl

Winpro International S.A.