logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1890

5 septembre 2007

SOMMAIRE

Aletta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90674

American Pacific S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90683

Atos Origin Luxembourg PSF S.A.  . . . . . .

90677

Bambi Continental S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

90685

Beltrust S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90679

Caret SHSG S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90710

Chabana S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90678

CMS Management Services S.A. . . . . . . . . .

90682

CMS Management Services S.A. . . . . . . . . .

90681

Continental Pac Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

90677

Cortines S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90684

Cotrel Investissements  . . . . . . . . . . . . . . . . .

90697

De Bird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90680

De Bird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90681

EPS - Economical Power Systems S.A.  . . .

90680

Erisider Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90674

Fell Informatique S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

90682

Finagi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90719

Flagstone Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90705

GenixWorks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90719

GH (N4) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90690

Global Capital Corporation Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90720

Global Group AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90680

IFI Estates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90680

JPMorgan European Property Holding Lu-

xembourg 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90720

Kauri Capital 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90678

Kubis Software S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90674

LBREP III Dame S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

90712

Luxembourg Corporation Company S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90683

MCI Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90674

ONEX TWG Holdings II Limited  . . . . . . . .

90679

Opera - Participations 2  . . . . . . . . . . . . . . . .

90719

Opera - Participations Sca  . . . . . . . . . . . . . .

90718

Parkridge Holdings Russia Warehouses S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90684

Participations et Financements Extérieurs

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90676

PDP Professionals in Data Processing In-

ternational S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90685

Polyfilms Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90684

Presidential Holdings Ferdinand II  . . . . . . .

90686

Rearden L Holdings 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

90712

Santa Caterina S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90678

S.à r.l. IMMOBILIERE Carlo FISCHBACH

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90685

Scantrust Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

90676

Scantrust Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

90675

Scantrust Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

90676

Scantrust Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

90677

Scantrust Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

90675

Scantrust Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

90676

Scantrust Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

90675

Schwarzwaldhaus S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

90685

Seculux Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90682

Selenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90719

SL Software_Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

90677

Société Immobilière Nice S.A.  . . . . . . . . . .

90720

Solardaach Al Schmelz I Société Civile . . .

90678

Stahlbeteiligungen Holding S.A.  . . . . . . . . .

90679

Talden Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90681

Werner S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90720

Werner S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90682

Werner S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90683

WQ International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90675

WQ International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90679

Wurth-Strotz S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90684

90673

Aletta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 53.842.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007088606/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09622. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070098846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Kubis Software S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 55.773.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007088619/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09624. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070098853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

MCI Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 43.892.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007088620/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09628. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070098857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Erisider Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 98.109.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007088973/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2007, réf. LSO-CG07168. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070099743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.

90674

Scantrust Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 31.115.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2007088625/7343/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09895. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070098625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Scantrust Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 31.115.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

<i>Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2007088629/7343/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09869. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070098636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Scantrust Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 31.115.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

<i>Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2007088627/7343/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09875. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070098629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

WQ International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 96.749.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007089294/1152/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2007, réf. LSO-CG05487. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070099920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.

90675

Scantrust Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 31.115.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2007088623/7343/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09890. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070098620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Scantrust Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 31.115.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2007088624/7343/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09897. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070098623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Scantrust Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 31.115.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

<i>Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2007088628/7343/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09872. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070098633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Participations et Financements Extérieurs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 48.938.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007088968/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2007, réf. LSO-CG07166. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070099731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.

90676

SL Software_Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 56.789.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007088621/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09629. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070098861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Scantrust Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 31.115.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

<i>Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2007088630/7343/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09865. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070098640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Continental Pac Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 64.149.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007088604/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09620. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070098840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Atos Origin Luxembourg PSF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 37.048.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007088978/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2007, réf. LSO-CG08818. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070099724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.

90677

Solardaach Al Schmelz I Société Civile, Société Civile.

Siège social: L-8414 Steinfort, rue Collart.

R.C.S. Luxembourg E 2.848.

<i>Extrait des décisions prises par le conseil d'administration

1) L'assemblée décide nommer à la fonction de gérant de la société Monsieur Gleis Roger demeurant au 6, rue Tesch-

waasser à Hagen, 6 et Madame Decker Karin demeurant au 2, rue du Pinson à Steinfort et ce avec effet immédiat.

Fait à Steinfort, le 18 juin 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Le gérant

Référence de publication: 2007088897/7963/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09882. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070098212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.

Chabana S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 34.721.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007088971/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2007, réf. LSO-CG07172. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070099738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.

Santa Caterina S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 68.283.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007088974/802/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG10052. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070099754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.

Kauri Capital 3, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 119.753.

Le bilan au 31 décembre 2006, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007089002/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09279. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070099408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.

90678

ONEX TWG Holdings II Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.810.650,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 124.202.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2007088977/6312/16.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09214. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070099712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.

Stahlbeteiligungen Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 14.849.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007088969/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2007, réf. LSO-CG07162. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070099733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.

WQ International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 96.749.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007089298/1152/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2007, réf. LSO-CG05485. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070099918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.

Beltrust S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 17.837.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007088985/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2007, réf. LSO-CG07767. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070099365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.

90679

EPS - Economical Power Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 48.879.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007088600/756/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09619. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070098833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

IFI Estates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 84.151.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007088982/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2007, réf. LSO-CG08894. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070099729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.

Global Group AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 81.848.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007089305/1152/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2007, réf. LSO-CG05490. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070099910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.

De Bird, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 21.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 114.749.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des associés le 14 juin 2007

L'assemblée générale des associés accepte la démission du gérant de la société M. Paul Muschter, ayant son adresse

professionnelle aux Pays-Bas, à 20-II Olympiakjade, NL-1076 XR Amsterdam, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 juin 2007.

Pour avis
Signature

Référence de publication: 2007088121/4175/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2007, réf. LSO-CF07968. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070097762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.

90680

De Bird, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 21.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 114.749.

Suite à la notification de la cession de 60 Parts sociales effectuée en date du 20 mai 2007 par M. van Roijen, à la société

UCOR BV, ayant son siège social aux Pays-Bas, à Horsterweg 18C, 6199 AC Maastricht - Airport, le capital de la société
DE BIRD, société à responsabilité limitée, est désormais détenu comme suit:

- Mme Tanja van Roijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 parts sociales
- M. Sibrand van Roijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 parts sociales
- UCOR BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 parts sociales

Luxembourg, le 14 juin 2007.

Pour avis
Signature

Référence de publication: 2007088122/4175/19.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2007, réf. LSO-CF07971. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070097762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.

CMS Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 81.525.

<i>Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 28 juin 2007

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. (la «Société») tenue

extraordinairement il a été décidé comme suit:

- de nommer Mr Phillip Williams ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en

qualité d'administrateur de la société avec effet au 1 

er

 juillet 2007;

Son mandat sera renouvelé lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 28 juin 2007.

D. Van Der Molen
<i>Administrateur Délégué

Référence de publication: 2007088574/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04134. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070098384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Talden Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 98.267.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 31 janvier 2005 a remplacé le commissaire aux comptes:
ROTHLEY COMPANY LIMITED, P.O. Box 3186 Abbot Bldg, Main Street, Road Town, Tortola British Virgin Islands;
par le nouveau commissaire aux comptes: LUX-AUDIT REVISION S.à r.l, 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2007.

<i>Pour TALDEN HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007088699/1021/17.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2007, réf. LSO-CG07759. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070098790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

90681

Seculux Sàrl, Société à responsabilité limitée,

(anc. Fell Informatique S.à r.l.).

Siège social: L-6650 Wasserbillig, 16-18, rue des Vignes.

R.C.S. Luxembourg B 87.913.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 août 2007.

E. Schlesser
<i>Notaire

Référence de publication: 2007091331/227/13.
(070101817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2007.

CMS Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 81.525.

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 28 juin 2007

Au Conseil d'Administration de CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
De nommer Valerie Cooke en tant que Fondé de Pouvoirs B avec effet au 1 

er

 juillet 2007.

De nommer Paul Lefering, Claudine Schinker et Patricia Schon en tant que Fondés de Pouvoirs A avec effet au 1 

er

juillet 2007.

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:
- Le Conseil d'Administration est composé de:
Doeke Van Der Molen, Luc De Vet, Michel Van Krimpen.
- L'Administrateur-délégué est:
Doeke Van Der Molen.
- Les Fondés de Pouvoirs A sont:
Séverine Canova, Alexandra Petitjean, Alan Botfield, Fabrice Geimer, Doeke Van Der Molen, Hille-Paul Schut, Ton

Zwart, Marc Torbick, Thijs Van Ingen, Mark Beckett, Laetitia Ambrosi, Davy Beaucé, Martina Schumann, Paul Lefering,
Claudine Schinker, Patricia Schon.

- Les Fondés de Pouvoirs B sont:
Gilles Lecomte, Richard Browne, Audrey Raphael, Valérie Ingelbrecht, François Cottong, Jacques De Patoul, Candida

Gillespie, Mattia Danese, Corinne Muller, Valerie Cooke.

Luxembourg, le 28 juin 2007.

D. Van Der Molen
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2007088550/710/29.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04142. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070098372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Werner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 32.093.

Le bilan au 31 décembre 1999 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007089537/6102/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09442. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070099170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.

90682

Luxembourg Corporation Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 37.974.

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 28 juin 2007

Au Conseil d'Administration de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

De nommer Valerie Cooke en tant que Fondé de Pouvoirs B avec effet au 1 

er

 juillet 2007.

De nommer Paul Lefering, Claudine Schinker et Patricia Schon en tant que Fondés de Pouvoirs A avec effet au 1 

er

juillet 2007.

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:
- Le Conseil d'Administration est composé de:
Doeke Van Der Molen, Robert Kimmels, Michel Van Krimpen.
- L'Administrateur délégué est:
Doeke Van Der Molen.
- Les Fondés de Pouvoirs A sont:
Séverine Canova, Alexandra Petitjean, Fabrice Geimer, Hille-Paul Schut, Ton Zwart, Marc Torbick, Thijs Van Ingen,

Mark Beckett, Laetitia Ambrosi, Davy Beaucé, Martina Schumann, Paul Lefering, Claudine Schinker, Patricia Schon.

- Les Fondés de Pouvoirs B sont:
Gilles Lecomte, Audrey Raphael, Valérie Ingelbrecht, François Cottong, Jacques De Patoul, Candida Gillespie, Mattia

Danese, Corinne Muller, Valerie Cooke.

Luxembourg, le 28 juin 2007.

D. Van Der Molen
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2007088560/710/29.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2007, réf. LSO-CG04141. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070098374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Werner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 32.093.

Le bilan au 31 décembre 2000 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007089538/6102/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09440. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070099171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.

American Pacific S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 101.291.

Les comptes annuels pour la période du 4 juin 2004 au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007091215/723/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2007, réf. LSO-CG09389. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

90683

Wurth-Strotz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7451 Lintgen, 24, rue Knepel.

R.C.S. Luxembourg B 32.028.

Les documents de clôture de l'année 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour WURTH-STROTZ S.à r.l.
AREND &amp; PARTNERS S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007091205/568/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11414. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070102335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

Cortines S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 97.650.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007092344/635/12.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2007, réf. LSO-CG06892. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070095249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2007.

Parkridge Holdings Russia Warehouses S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 121.245.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 23 juillet 2007.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Pour Maître J. Seckler, Notaire
M. Goeres

Référence de publication: 2007091346/231/14.
(070101246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2007.

Polyfilms Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 113.561.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 30 juillet 2007.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Pour Maître J. Seckler, Notaire
I. Colamonico

Référence de publication: 2007091572/231/14.
(070102196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

90684

Bambi Continental S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 75, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 110.869.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 juillet 2007.

B. Moutrier
<i>Notaire

Référence de publication: 2007091324/272/12.
(070101535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2007.

PDP Professionals in Data Processing International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8311 Capellen, 81, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 109.736.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2007.

SOFINTER S.A.
Signature

Référence de publication: 2007091199/820/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10239. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

S.à r.l. IMMOBILIERE Carlo FISCHBACH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 298, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 31.790.

Les documents de clôture de l'année 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour S.à r.l. IMMOBILIERE CARLO FISCHBACH
AREND &amp; PARTNERS S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007091178/568/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11430. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

Schwarzwaldhaus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7595 Reckange sur Mersch, 47, rue de Septfontaines.

R.C.S. Luxembourg B 87.310.

Les documents de clôture de l'année 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SCHWARZWALDHAUS S.à r.l.
AREND &amp; PARTNERS S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007091200/568/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11395. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070102338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2007.

90685

Presidential Holdings Ferdinand II, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 122.942.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirteenth day of December.
Before Us Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

The private liability company PRESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED having its registered office at 146, Wickhams Cay

1, Road Town, Tortola British Virgin Islands (British Virgin Islands 177616 Register of companies)

here represented by Mrs. Sonja Limbach, employee, residing in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, by virtue of a

proxy given in Luxembourg, on December 11th, 2006.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and theundersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it

has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially

the law of August 10th, 1915 on commercial companies such as amended.

Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,

whether furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in
real estate, and those concerning the placement and management of money.

The object of the Company is also to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,

commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any  activities  in  whatsoever  form,  as  well  as  the  management  and  development,  permanently  or  temporarily,  of  the
portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a financial participations company according to
the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The private limited liable Company is incorporated under the name of PRESIDENTIAL HOLDINGS FERDI-

NAND II.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by one hundred

(100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euros (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid
up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance

or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are

transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of
the capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior
approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial

companies, the value of a share is based on average balance sheet of the last three financial years and, in case the Company
counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last financial year or of those
of the last two financial years.

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the

sole member or, as the case may be, the members.

90686

The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to

third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either members

or not.

Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the sole signature of any manager.

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the foresaid

law of August 10th, 1915.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the

meeting.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company's financial year runs from the first of October to the thirtieth of September of the next year.

Art. 11. Each year, on the thirtieth day of September, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal

reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason
whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual contribution shall be
resumed until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary
reserve.

Title VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The
liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of
debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of
Incorporation, the members shall refer to the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and payment

All the shares have been entirely subscribed by the private liable company PRESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED,

prenamed. They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred
euros (EUR 12,500.-) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary
who expressly bears witness to it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on September 30th 2007.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,500.- EUR.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital, acting as foresaid, has passed the following resolutions:

1) The following is appointed manager of the Company for an unlimited period:
Mrs. Claudia Daxelhoffer, residing in CH-8942 Oberrieden, Feldstrasse8, who can bind the company towards third

parties by her sole signature.

2) The Company shall have its registered office at L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins.

90687

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation. Upon request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahr zweitausendsechs, den dreizehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED, mit Sitz in 146, Wickhams Cay 1,

Road Town, Tortola British Virgin Islands (British Virgin Islands 177616 Register of companies)

hier vertreten durch Frau Sonja Limpach, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy, auf

Grund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg am 11. Dezember 2006.

Welche Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den instrumentierenden Notar, ge-

genwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorgenannt, beschlossen hat eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter

Haftung gründen zu wollen gemäss folgender Satzung:

Titel I.- Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das abgeäderte

Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Erschließung, der Verkauf und die Vermietung von

jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen welche Immobilien betreffen,
mit Ausnahme derjenigen welche einem Immobilienhändler vorbehalten sind und welche die Platzierung von Geld und
die Vermögensverwaltung betreffen.

Zweck der Gesellschaft sind außerdem, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle irgendwelche industriellen,

kommerziellen, finanziellen, beweglichen oder unbeweglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Gründung,
Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaften,
unter welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung, sei es permanent
oder vorübergehend, des somit zweckmäßigen geschaffenen Wertpapierbestands, sofern die Gesellschaft nach den Be-
stimmungen betreffend die «Société de Participations Financières» betrachtet wird.

Die Gesellschaft kann sich namentlich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften mit

einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder
nützlich sind.

Art. 3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gegründet unter dem Namen PRESIDENTIAL HOLDINGS

FERDINAND II.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.

Titel II.- Kapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euros (12.500,- EUR), eingeteilt in einhun-

dert (100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euros (125,-EUR), alle voll gezeichnet und
vollens eingezahlt.

Art. 7. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von

Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen

unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigs-
tens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich. Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur
mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile
vertreten, übertragen werden.

Im Falle einer Übertragung im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften, wird der Wert eines Anteils auf der Basis der Durchschnittsbilanz der letzten drei Ge-
schäftsjahre berechnet und, falls die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre zählt, wird er auf der Basis der Bilanz
des letzten oder der beiden letzten Geschäftsjahre berechnet.

90688

Titel III.- Geschäftsführung

Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,

verwaltet. Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.

Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt und haben die ausgedehntesten Vollmachten gegen-

über Drittpersonen.

Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Bevoll-

mächtigte, die nicht Gesellschafter sein müssen, erteilt werden.

Gegenüber Drittpersonen wird die Gesellschaft in jedem Fall durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers

rechtskräftig verpflichtet.

Titel IV.- Entscheidungen des einzigen Gesellschafters - Gemeinsame Entscheidungen mehrerer Gesell-

schafter

Art. 9. Der einzige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche durch das vorbenannte Gesetz vom 10. August

1915, der Versammlung der Gesellschafter vorbehalten sind.

Demzufolge werden alle Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer überschreiten, vom

einzigen Gesellschafter getroffen.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, werden die Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäfts-

führer überschreiten, durch die Gesellschafterversammlung getroffen.

Titel V.- Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Oktober und endet am dreißigsten September des nächsten Jahres.

Art. 11. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per dreißigsten September, wird durch die Geschäftsführung ein Inventar

der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung
aufgestellt.

Der Saldo dieses Kontos, nach Abzug der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist der

Nettogewinn der Gesellschaft.

Von diesem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Reserve der Gesellschaft

zugeführt, solange bis die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem gegebenen Augenblick und
aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Reserve unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals fallen, so muss die jährliche
Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden bis das ein Zehntel Verhältnis wieder hergestellt ist.

Der Restbetrag wird dem einzigen Gesellschafter zugeteilt oder, je nachdem, unter den Gesellschaftern verteilt, wobei

dieser oder diese, handelnd laut den gesetzlichen Bestimmungen, entscheiden kann oder können, dass der Restbetrag,
nach Abzug jeglicher Reserven, auf das folgende Jahr übertragen oder auf einer außergesetzlichen Reserve zugeführt wird.

Titel VI.- Auflösung

Art. 12. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die notorische Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche

Entmündigung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im

Amt oder von einem oder mehreren Liquidatoren, vom einzigen Gesellschafter oder von der Generalversammlung der
Gesellschafter ernannt, ausgeführt. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung
der Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.

Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, dem einzigen Gesellschafter zugeteilt, oder, je nachdem,

unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile aufgeteilt.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 13. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden

ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle Anteile wurden gezeichnet durch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRESIDENTIAL PROPERTIES LIMI-

TED, vorgenannt, und vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von zwölftausendfünfti-
undert Euros (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies
ausdrücklich bestätigt.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 30. September 2007.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.500,- EUR.

90689

<i>Beschlüsse

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter welcher das Gesamtkapital vertritt, folgende

Beschlüsse gefasst:

1) Es wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:
Frau Claudia Daxelhoffer, wohnhaft in CH-8942 Oberrieden, Feldstrasse, 8, welche die Gesellschaft gegenüber dritten

durch ihre alleinige Unterschrift rechtskräftig vertreten kann.

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1313 Luxemburg, 2a, rue des Capucins.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass der Text der vorliegenden

Satzung auf Wunsch der Erschienenen in englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, dass es der Wunsch der Erschienenen ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text der englische Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung und Erklärung an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Limbach, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 87, case 6. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 19 décembre 2006.

P. Decker.

Référence de publication: 2007010426/206/237.
(070001614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.

GH (N4) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 129.972.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-seventh day of the month of June.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

GH HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.àr.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guil-

laume Kroll, L-1015 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade Register («RCS»),

represented by M 

e

 Susanne Goldacker, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 27 June

2007,

which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of incorporation of a limited liability company GH (N4) S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby established
as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name GH (N4) S.à r.l. (the

«Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The
Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad. The Company may invest directly
or indirectly in real estate, in intellectual property rights, or in any other movable or immovable property of any kind.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to

companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies
to which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

90690

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500)

divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (€ 1) each. The capital of the
Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amend-
ment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution
of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent
of the Company's capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-

holders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board
by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty four (24) hours at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers

and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company

(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions,  may  be  conclusively  certified  or  an  extract  thereof  may  be  issued  under  the  individual  signature  of  any
manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of any of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be

90691

validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of representation).
In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by any one of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and
one class B manager acting together (including by way of representation).

Art. 8. Liability Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As

agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words «claim», «action», «suit» or «proceeding» shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words «liability»
and «expenses» shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by

the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this Article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes

equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder Meeting. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed

by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred per cent (100%) of the issued share capital.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1st October of each year and ends on 30th September of

the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 30th
September 2008.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

90692

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five per cent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August 1915 on commercial companies;
in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has

subscribed and entirely paid-up the twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (€
1).

Evidence of the payment of the subscription price of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500) has been given to

the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately 1,900 Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The single shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at:
5, rue Guillaume Kroll, L-1015 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the

articles of association of the Company:

Mr Frank Przygodda, director, born in Bochum (Germany) on 28 February 1968, residing professionally at 5, rue

Guillaume Kroll, L-1015 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-septième jour du mois juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GH HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social situé au 5, rue Guil-

laume Kroll, L-1015 Luxembourg, pas encore inscrite auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg,

représentée par M 

e

 Susanne Goldacker, Rechtsanwältin, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée

du 27 juin 2007,

qui sera enregistrée avec le présent acte.
La partie comparante, agissant ès qualités, a requis le notaire soussigné d'arrêter les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée GH (N4) S.à r.l., qui est constituée par les présentes comme suit:

90693

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite

associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GH (N4) S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie
par les présents statuts et la législation applicable.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi qu'auprès d'autres entités commerciales, l'acquisition par achat, par souscription
ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de
créances, de titres et d'autres valeurs de toutes espèces, et la possession, l'administration, le développement et la gestion
de son portefeuille. La Société pourra également détenir des participations dans d'autres sociétés et exercer son activité
à travers ses filiales au Luxembourg ou à l'étranger. La Société peut investir directement ou indirectement sur le marché
de l'immobilier, dans les droits de propriété intellectuelle ou dans toute autre propriété mobilière ou immobilière de
toute sorte.

La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à travers des placements privés à l'émission d'obligations

et autres titres de créances.

D'une manière générale, la Société pourra octroyer assistance (au moyen de prêts, avances, garanties ou sûretés ou

par tout autre moyen) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a des participations ou; qui font
partie intégrante du groupe de sociétés auquel la Société appartient (y inclus vers le haut ou horizontalement), prendre
toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au déve-
loppement de son objet.

Finalement, la Société peut accomplir toute opération commerciale, technique et financière ou toute autre opération,

en relation directe ou indirecte avec le champ d'application de son objet, afin de faciliter l'accomplissement de celui-ci.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution prise par l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions requises pour une modification des statuts.

L'adresse du siège social pourra être transférée à l'intérieur de la ville de Luxembourg par décision du gérant ou, le

cas échéant, du conseil de gérance.

La Société pourra établir des succursales et des filiales, tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Dans l'hypothèse où le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires,

d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la
communication aisée du siège social avec des personnes à l'étranger se seraient produits ou serait imminents, il pourrait
transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces
mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant tout transfert provisoire du
siège, restera une société luxembourgeoise. De telles mesures temporaires seront prises et notifiées par le gérant ou, le
cas échéant, par le conseil de gérance à toute personne intéressée.

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500) divisé en

douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur au pair de un euro (€ 1) chacune. Le capital de la Société
pourra être augmenté ou réduit par une résolution prise par les associés délibérant dans les conditions requises pour
une modification des présents statuts et la Société peut procéder au rachat de ses autres parts sociales sur base d'une
résolution de ses associés.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

Art. 6. Transfert des Parts Sociales. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. Sauf disposition

contraire de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément des associés représentant au
moins soixante-quinze pourcent du capital de la Société.

Art. 7. Gestion de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise à la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle

détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont élus pour une durée
indéterminée. Les gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum)
à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires per-
mettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les
unes avec les autres. Une réunion du conseil de gérance pourra être tenue uniquement par l'intermédiaire d'une confé-
rence téléphonique. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique à
une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil
par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter. Une convo-
cation écrite à toute réunion du conseil de gérance devra être donnée au gérant au moins vingt-quatre (24) heures à
l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les raisons de l'urgence

90694

devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque gérant donné
par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu déterminés
dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de

classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal
de l'assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la

Société (y inclus par voie de représentation). Cependant, au cas où l'assemblée générale des associés aurait nommé
différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de
gérance ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B (qui pourra être représenté).

Le conseil de gérance pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires

par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication
similaire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment exécutés l'existence de la résolution.
Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis
sous la signature individuelle de tout gérant.

La Société sera engagée par la signature individuelle d'un seul gérant, le cas échéant, et en cas d'un conseil de gérance,

par la signature individuelle de chacun des gérants, étant entendu cependant que si l'assemblée générale des associés a
nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera
valablement engagée que par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B (y inclus par voie
de représentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s)
à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par un ou plusieurs gérants ou, en cas de classes de gérants, par un
gérant de classe A et un gérant de classe B, agissant ensemble (y inclus par voie de représentation).

Art. 8. Responsabilité des gérants. Le(s) gérant(s) ne sont pas tenus personnellement responsables pour les dettes de

la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables pour la performance de leurs obligations.

Sous réserve des exceptions et limitations prévues à ci-dessous, toute personne qui est, ou a été, un gérant ou un

fondé de pouvoir de la Société, sera indemnisée par la Société dans la mesure la plus large permise par la loi pour la
responsabilité et toutes les dépenses raisonnables supportées ou payées par celui-ci en relation avec une prétention,
action, poursuite ou procédure judiciaire qui le rend insolvable en tant que partie ou autrement en vertu du fait qu'il est
ou a été Gérant ou fondé de pouvoir. Il sera également indemnisé pour tous les montants qu'il aurait payés ou supportés
afin de régler les faits mentionnés ci-dessus. Les termes «prétention», «action», «poursuite» ou «procédure judiciaire»
s'appliqueront à toute prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire (civiles, pénales ou autres, y compris les
appels) actuels ou possibles et les termes «responsabilité» et «dépenses» incluront sans limitation les honoraires d'avocat,
les coûts, jugements, montants payés en vertu d'une transaction et autres montants dus par la Société.

Aucune indemnisation ne sera due à un Gérant ou à un fondé de pouvoir:
(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir,

de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement de ses devoirs découlant de sa fonction;

(ii) Pour toute affaire dans le cadre de laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans

l'intérêt de la Société; ou

(iii) En cas de transaction, à moins que la transaction n'ait été approuvée par une cour d'une juridiction compétente

ou par le conseil de gérance.

Le droit d'être indemnisé tel que prévu par le présent article appartient à chaque gérant et n'affectera pas tout autre

droit dont un gérant ou fondé de pouvoir pourrait bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard d'une
personne ayant cessé d'être gérant ou fondé de pouvoir et se transmettra aux héritiers, exécuteurs testamentaires et
administrateurs de cette personne. Les dispositions de cet article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait
bénéficier le personnel de la Société, en ce compris les Gérants et fondés de pouvoir en vertu d'un contrat ou autrement
en vertu de la loi.

Les dépenses supportées en relation avec la préparation d'une défense et la représentation dans le cadre d'une pré-

tention, action, poursuite ou procédure judiciaire telles que décrites dans cet article seront avancées par la Société avant
toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour compte du
fondé de pouvoir ou le Gérant de rembourser ce montant s'il est finalement décidé qu'il n'aurait pas eu droit à une
indemnisation conformément au présent article.

Art. 9. Droit de vote des associés. Chaque associé pourra prendre part aux décisions collectives. Il a un nombre de

voix égal au nombre de parts sociales qu'il détient et pourra valablement agir à toute assemblée des associés au moyen
d'une procuration spéciale.

Art. 10. Assemblées des associés. Les décisions des associés sont prises selon les formes et aux majorités prescrites

par la loi luxembourgeoise sur les sociétés par écrit (dans les cas prévus par la loi) ou lors d'assemblées. Toute assemblée

90695

régulièrement constituée des associés de la Société ou toute résolution écrit régulière (le cas échéant) représentera
l'intégralité des associés de la Société.

Les assemblées seront convoquées par une notice de convocation adressée par lettre recommandée aux associés à

leur adresse telle qu'elle apparaît sur le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de
tenue de cette assemblée. Si l'intégralité du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée pourra
être tenue sans convocation préalable.

En cas de résolutions écrites, le texte de telles résolutions sera adressé aux associés à leur adresse telle qu'elle figure

sur le registre des associés tenu par la Société huit (8) jours au moins avant que la date proposée pour la résolution ne
devienne effective. Les résolutions deviendront effectives après l'approbation de la majorité telle que prévue par la loi en
ce qui concerne les décisions collectives (ou conformément à la satisfaction des exigences de majorité, à la date fixée ci-
après). Les résolutions écrites prises à l'unanimité pourront être prises à tout moment sans convocation préalable.

Sauf disposition contraire prévue par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si

elles ont été approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si une telle majorité n'est pas
atteinte lors de la première réunion ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés
une deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des votes exprimés, peu
importe la portion du capital représentée. (ii) Cependant, les décisions concernant la modification des Statuts sont prises
(x) à la majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions qui changent
la nationalité de la Société sont prises par les associés représentant 100% du capital social émis.

Art. 11. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 octobre de chaque année pour se terminer

le 30 septembre de la même année, sauf en ce qui concerne la première année sociale, qui commencera à la date de la
constitution de la Société et se terminera le 30 septembre 2008.

Art. 12. Comptes annuels. Chaque année à la fin de l'année comptable, les comptes annuels sont établis par le gérant

ou le cas échéant, par le conseil de gérance.

Les comptes annuels sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il sera prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pourcent (10%) du capital social émis de la
Société.

Les associés pourront décider de verser des dividendes intérimaires sur base des relevés de compte préparés par le

gérant, ou le cas échéant par le conseil de gérance, démontrant que des fonds suffisants sont disponibles pour permettre
une distribution, étant entendu que le montant distribué ne pourra excéder les profits réalisés depuis la fin du dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et
sommes devant être affectées à la réserve légale.

Le solde pourra être distribué aux associés après une décision de l'assemblée générale des associés.
Le compte prime d'émission pourra être distribué aux associés après décision de l'assemblée générale des associés.

L'assemblée  générale  des  associés  pourra  décider  d'allouer  un  montant  quelconque  du  compte  prime  d'émission  au
compte réserve légale.

Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou plusieurs

liquidateurs qui seront des associés ou non et qui sont nommés par l'assemblée générale des associés qui déterminera
leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 15. Associé unique. Si, et aussi longtemps qu'un associé détient toutes les parts sociales de la Société, la Société

existera en tant que société unipersonnelle, conformément à l'article 179(2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autre, de la même loi, sont applicables.

Art. 16. Loi applicable. Pour tout ce qui n'aura pas été prévu dans les présents statuts, les associés se réfèreront à la

législation applicable.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement payé les douze

mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (€ 1) chacune.

Preuve  du  paiement  du  prix  de  souscription  de  douze  mille  cinq  cents  Euros  (€12.500)  a  été  donnée  au  notaire

instrumentant.

<i>Dépenses et frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges quelconque que ce soit incombant la Société du fait de sa constitution,

sont à évaluer à environ 1.900 €.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique a aussitôt pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 5, rue Guillaume Kroll, L-1015 Luxembourg

90696

2. La personne suivante est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts de la

Société:

Monsieur Frank Przygodda, administrateur, né à Bochum (Allemagne) le 28.02.1968, demeurant professionnellement

à 5, rue Guillaume Kroll, L-1015 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même personne
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état et

demeure, la comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Goldacker, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, LAC/2007/17117. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations

Luxembourg, le 26 juillet 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007089884/242/389.
(070100538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2007.

Cotrel Investissements, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 130.046.

STATUTS

L'an deux mille sept, le quinze juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Yves Régis Cotrel, né le 13 janvier 1952 à Berck (France), résidant 8, avenue George V, 75008 Paris

(France)

2.- Monsieur Emmanuel Cotrel, né le 3 février 1981 à Abbeville (France), résidant 8, avenue George V, 75008 Paris

(France)

3.- Monsieur Yves-Alexandre Cotrel, né le 26 février 1978 à Abbeville (France), résidant 8, avenue George V, 75008

Paris (France)

4.- Monsieur Sébastien Cotrel, né le 24 décembre 1981 à Abbeville (France), résidant 8, avenue George V, 75008 Paris

(France),

tous les quatre ici représentés par Madame Raymonde Jallon, ayant son adresse professionnelle au 6, rue Adolphe

Fischer, L-1520 Luxembourg,

en vertu de quatre procurations données à Luxembourg, le 07 juin 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I - Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination COTREL INVESTIS-

SEMENTS (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 Août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège Social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales

ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime

90697

que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces évé-
nements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée
entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participation, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes les sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition
et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit. De plus, elle pourra participer ou investir dans l'acquisition de tous biens mobiliers et œuvres d'art, directement
ou indirectement, de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs
d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou toute autre société dans
laquelle elle détient un intérêt direct ou indirect, dans la limite de ce qui est permis par la loi luxembourgeoise. La Société
pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés
sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements
de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La société pourra acheter, vendre, échanger, financer, louer, améliorer, démolir, construire pour son propre

compte, développer, diviser et gérer tous biens immobiliers. Elle pourra en outre effectuer tous travaux de rénovations
et de transformations ainsi que la maintenance de ces biens.

3.5. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes trans-

actions  se  rapportant  à  la  propriété  immobilière  ou  mobilière,  qui  directement  ou  indirectement  favorisent  ou  se
rapportent à la réalisation de son objet social.

Art 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant l'un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts

sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les co-propriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle aura été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi ou il

pourra être consulté par chaque associé.

90698

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la

Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l'assemblée générale des

associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de
gérance. Le(s) gérant(s) n'(ne) est(sont) pas nécessairement associé(s).

7.2. Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum (sans aucune raison).

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du conseil de gérance, lequel aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,

associés ou non, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des

gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de

la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de
son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de
la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou

représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les procès-verbaux
des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.7. En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-

blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par
lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe

d'un gérant de la classe A avec celle d'un gérant de la classe B, ou, par la signature de toute personne à qui de tels pouvoirs
de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2 des présents Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent, en raison de leur mandat, aucune obligation person-

nelle relativement à tout engagement valablement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure ou un tel engagement
est en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne ou entité comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique envoyé(e)s par
lettre ou téléfax.

90699

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,

doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui
sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'assemblée générale des associés de la Société;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers identifiés de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

VI. Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2007.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit:

1) Yves Régis Cotrel, deux cent soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
2) Emmanuel Cotrel, soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

3) Yves-Alexandre Cotrel, soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

4) Sébastien Cotrel, soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de douze mille cinq cents

euros (€ 12.500) est dès à présent à l'entière et libre disposition de la Société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Coûts

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille neuf cents euros.

90700

<i>Décisions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social

souscrit ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre de gérants de la Société est fixé à cinq pour une durée indéterminée
2) Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société:

<i>Gérants de Classe A:

Monsieur Yves Régis Cotrel, résidant 8, avenue George V, 75008 Paris (France);
Monsieur Yves Alexandre Cotrel, résidant 8, avenue George V, 75008 Paris (France);
Monsieur Emmanuel Cotrel, résidant 8, avenue George V, 75008 Paris (France);
Monsieur Sébastien Cotrel, résidant 8, avenue George V, 75008 Paris (France);

<i>Gérant de Classe B:

Monsieur John Kleynhans, résidant 6, rue Dicks, L-5521 Remich.
3) Le siège social de la Société est fixé au 6, rue Adolphe Fisher, L-1520 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise, et qu'en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais,
le texte français fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date spécifiée en tête des présents Statuts.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Suit la traduction du texte qui précède:

In the year two thousand seven, on the fifteenth day of June.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1.- Mr Yves Régis Cotrel, born on 13 January 1952 in Berck (France), residing at 8, avenue George V, 75008 Paris

(France)

2.- Mr Emmanuel Cotrel, born on 3 February 1981 in Abbeville (France), residing at 8, avenue George V, 75008 Paris

(France)

3.- Mr Yves-Alexandre Cotrel, born on 26 February 1978 in Abbeville (France), residing at 8, avenue George V, 75008

Paris (France)

4.- Mr Sébastien Cotrel, born on 24 December 1981 in Abbeville (France), residing at 8, avenue George V, 75008 Paris

(France)

all four here represented by Mrs Raymonde Jallon, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe

Fischer, L-1520 Luxembourg,

by virtue of four proxies under private seal given on 7 June 2007.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

COTREL INVESTISSEMENTS (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular
by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities

90701

of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of  patents  or  other  intellectual  property  rights  of  any  nature  or  origin  whatsoever.  Furthermore  the  Company  can
participate or invest in the acquisition of any movable properties and work of art, directly or indirectly, regardless their
kind or origin.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies in which it has a direct or indirect interest to the extent permitted under Lux-
embourg law. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and
undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may buy, sell, exchange, finance, lease, improve, demolish, construct for its own account, develop,

divide and manage any real estate. It may further execute all works of renovations and transformations as well as the
maintenance of these assets.

3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

90702

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any

manager of class A signing with the manger of Class B of the Company or by the signature of any persons to whom such
signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

90703

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board

of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing all the Company's
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular

allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the

Company;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the general meeting of shareholders of the Company;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the known creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

VI. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2007.

<i>Subscription - Payment

The shares have been entirely subscribed as follows:

1) Yves Régis Cotrel two hundred and seventy-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
2) Emmanuel Cotrel seventy-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

3) Yves-Alexandre Cotrel seventy-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

4) Sébastien Cotrel seventy-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

All the shares have been fully paid up in cash, so that from now on the amount of twelve thousand five hundred euro

(€ 12,500) is at the free and entire disposal of the Company.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the appearing parties, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

1) The number of managers of the Company is set at five for an unlimited period of time

90704

2) The following persons are appointed as manager of the Company

<i>Managers of class A:

Mr Yves Régis Cotrel, residing at rue 8, avenue George V, 75008 Paris (France),
Mr Yves Alexandre Cotrel, residing at rue 8, avenue George V, 75008 Paris (France),
Mr Emmanuel Cotrel, residing at rue 8, avenue George V, 75008 Paris (France),
Mr Sébastien Cotrel, residing at rue 8, avenue George V, 75008 Paris (France),

<i>Manager of class B:

Mr John Kleynhans, residing at 6, rue Dicks, L-5521 Remich.
3) The registered office of the Company is fixed at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in French followed by an English version and in case of divergences between the French
and the English text, the French version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Signé: R. Jallon, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2007, Relation: LAC/2007/13856. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007090826/242/440.
(070101820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2007.

Flagstone Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 118.871.

In the year two thousand and seven, on the thirteenth of June.
Before the undersigned Maître Francis Kesseler, notary public, residing in Esch-sur-Alzette.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of FLAGSTONE FINANCE S.A. (société anonyme),

having its registered office in L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse, registered with the trade register in
Luxembourg under the number B 118.871, originally incorporated in form of private limited liability company under the
name FLAGSTONE FINANCE S.à r.l by deed passed before the notary André Schwachtgen, residing in Luxembourg, on
the 22nd August 2006, published in the Mémorial C number 1771 dated on 21st September 2006.

The articles of incorporation were amended on several occasions at for the last time by deed of the notary Henri

Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on the 7th June 2007, not yet published in the Memorial C.

The meeting was opened at 11 a.m.
Mr. Mathieu Gangloff, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,

being in the chair.

The chairman appointed as secretary of the meeting Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing in

Differdange.

The meeting appointed as scrutineer Miss Claudia Rouckert, private employee, residing in Rodange.
The chairman declared and requested the notary to act:
I. The agenda of the meeting is the following:
1.- Increase of the corporate capital by an amount of seven million eight hundred and thirty-nine thousand seven

hundred seventy-five Euro (€ 7,839,775.-) so as to raise it from its present amount of three million four hundred and
seventy-one thousand, eight hundred and twenty-five Euro (€ 3,471,825.-) to eleven million three hundred eleven thou-
sand six hundred Euro (€ 11,311,600.-) by the creation and issue of three hundred and thirteen thousand five hundred
and ninety-one (313,591) new shares having a par value of twenty-five Euro (€ 25.-) each, together with the payment of
an aggregate share premium amounting globally to twenty-three million three hundred five thousand nine hundred fifty-
seven Euro (€ 23,305,957.-) the whole to be paid by contribution in kind.

2.- Subscription of the three hundred and thirteen thousand five hundred and ninety-one (313.591) new shares by

FLAGSTONE (GIBRALTAR) LIMITED and payment by contribution in kind.

90705

3.- Cancel the one hundred thirty-eight thousand eight hundred seventy-three (138,873) ordinary shares in the capital

of the Company and held by the Company in treasury after having taken the resolutions on point 1 and 2 of the agenda,
and consequently decrease the subscribed capital of the Company by three million four hundred seventy-one thousand
eight hundred and twenty-five Euro (EUR 3,471,825.-).

4.- Amendment of article 5.1 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
5.- Miscellaneous matters, expressly limited to such matters as may be necessary and required to complete and give

effect to Items 1-3 above.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or

represented declaring that they have been duly convoked and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly delib-

erate on all items of the agenda.

After approval of the foregoing, the general meeting, upon deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of seven million eight hundred and thirty-nine

thousand seven hundred seventy-five Euro (€ 7,839,775.-), so as to raise it from its present amount of three million four
hundred and seventy-one thousand eight hundred and twenty-five Euro (€ 3,471,825.-) to eleven million three hundred
eleven thousand six hundred Euro (€ 11,311,600.-) by the issue of three hundred and thirteen thousand five hundred and
ninety-one (313,591) new shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, issued at an aggregate share
premium of EUR 23,305,957.-.

<i>Second resolution

The meeting decides to admit to the subscription of the three hundred and thirteen thousand five hundred and ninety-

one (313,591) new shares: FLAGSTONE (GIBRALTAR) LIMITED, a corporation existing under the Laws of Gibraltar,
with its registered office address at Suite 1, Burns House, 19 Town Range, Gibraltar, here represented by Mathieu Gangloff,
prenamed, by virtue of a proxy under private seal given at Gibraltar, on 12 June 2007, which proxy, signed ne varietur by
all  the  appearing  persons  and  the  undersigned  notary,  will  remain  annexed  to  the  present  deed  for  the  purpose  of
registration.

<i>Contributor's Intervention - Subscription - Issue Premium - Contributions - Payment

Thereupon intervene the aforenamed subscribing company FLAGSTONE (GIBRALTAR) LIMITED, prenamed, here

represented as stated here-above by Mr. Mathieu Gangloff, prenamed, which declared to subscribe all the three hundred
and thirteen thousand five hundred and ninety-one (313,591) ordinary new shares and to pay them up fully as well as the
issue premium through a contribution in kind consisting of ail its assets and liabilities as defined in Article 4-1 of the law
of 29 December 1971, as modified by the law of 3 December 1986, which provides for capital duty exemption.

<i>Description of the contribution

All these assets and liabilities contributed (entire property) are documented in the balance sheet of the contributed

company FLAGSTONE (GIBRALTAR) LIMITED, prenamed, which balance sheet, signed ne varietur by all the appearing
persons  and  the  undersigned  notary,  will  remain  annexed  to  the  present  deed  for  the  purpose  of  registration.  The
contribution is as follows:

1. Contribution assets:
-  the  total  amount  of  cash  available  on  the  Contributor's  bank  account  on  13  June  2007  (amounting  to  EUR

50,026,986.-); and

- shareholding in FLAGSTONE FINANCE S.A. namely 138,873 shares with a par value of EUR 25.- each, together with

an aggregate share premium of EUR 10,394,439.-.

2. Contribution liabilities:
- invoice for legal fees in the sum of GBP 1,200.- (EUR 1,740.-);
- loan in the sum of EUR 12,500.- payable to FLAGSTONE REINSURANCE LIMITED; and
- loan in the sum of EUR 32,733,278.- payable to FLAGSTONE REINSURANCE LIMITED.

<i>Evaluation

The total net value of this contribution in kind is evaluated at € 31,145,732.- (thirty-one million one hundred forty-

five thousand seven hundred thirty-two Euro).

90706

<i>Report of the auditor

In compliance with article 32-1 of the Law on Commercial Companies, the contribution in kind has been subject to

the report of CROWN AUDIT, having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, Registered
Auditors in Luxembourg represented by Philipp van der Westhuizen, Partner, who concludes:

«Based on the verification procedures applied, nothing has come to our attention that causes us to believe that the

overall value of the contribution described above is not at least equal to the number of shares to be issued at par value
in the amount of 7,839,775 and the share premium of EUR 23,305.957.-.»

This report signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration remain here annexed signed ne varietur by the appearing parties.

<i>Effective implementation of the contribution

FLAGSTONE (GIBRALTAR) LIMITED, contributor here represented as stated here above, expressly declares that all

formalities in any concerned country in relation with the transfer in favour of FLAGSTONE FINANCE S.A. of any element
composing its assets and liabilities will be carried out within the best delays in each country as far as it will be concerned
in order to duly formalize the property's transmission of and to render it effective anywhere and toward any third party.
The society gives discharge of full and entire responsibility to the instrumenting notary.

The issue of the new shares is also subject to payment of a total share premium amounting to twenty-three million

three hundred five thousand nine hundred fifty-seven Euro (EUR 23,305,957.-), to be allocated to a distributable share
premium account.

The general meeting records that new shares and the total share premium have been fully paid up through a contri-

bution in kind consisting of all the assets and liabilities (entire property) belonging to the subscriber including of the
wholeness of its assets and liabilities evaluated to the net value of its net assets.

<i>Evidence of the contribution's existence:

Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary by a trade register extract and by its

balance sheet.

The contribution in kind is at the disposal of FLAGSTONE FINANCE S.A. as it appears from the annexed Contribution

Agreement.

<i>Fixed rate tax exemption request

Considering that it concerns an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg company by a contribution

in kind consisting in ail the assets and liabilities (entire property), nothing withheld or excepted. of a company incorporated
in the European Union, the company refers to Article 4.1 of the law of December 29 1971 as modified by the law of
December 3 1986 which provides for capital fixed rate tax exemption.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to cancel the one hundred thirty-eight thousand eight hundred seventy-three (138,873)

ordinary shares in the capital of the Company and now held by the Company in treasury, and to reduce the share premium
account of the Company by an amount of EUR 10,394,439.-.

Consequently the general meeting decides to decrease the subscribed capital of the Company by three million four

hundred seventy-one thousand eight hundred and twenty-five Euro (EUR 3,471,825.-).

<i>Fourth resolution

The meeting decides to amend article 5.1 of the articles of association of the Company, so as to read as follows:
« Art. 5. Capital.
5.1- The Company has an issued capital of seven million eight hundred and thirty-nine thousand seven hundred seventy-

five Euro (€ 7,839,775.-) represented by three hundred and thirteen thousand five hundred and ninety-one (313,591)
shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (€ 25.-) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately six thousand Euro (6,000.-).

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.

90707

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille sept, le treize juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FLAGSTONE FINANCE S.A.,

avec siège social à L-2320 Luxembourg 92, boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg section B numéro 118.871, constituée originairement sous forme de société à responsabilité limitée
dénommée FLAGSTONE FINANCE S.à r.l. aux termes d'un acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de rési-
dence à Luxembourg, en date du 22 août 2006, publié au Mémorial C numéro 1771 en date du 21 septembre 2006.

Les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx,

de résidence à Luxembourg, en date du 7 juin 2007, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures.
L'assemblée est présidée par Monsieur Mathieu Gangloff, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 6, rue

Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Dif-

ferdange.

L'assemblée désigne comme scrutateur Mademoiselle Claudia Rouckert, employée privée, demeurant à Rodange.
Le Président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de sept millions huit cent trente-neuf mille sept cent

soixante-quinze euros (€ 7.839.775,-) pour le porter de son montant actuel de trois millions quatre cent soixante et onze
mille huit cent vingt-cinq euros (€ 3.471.825,-) à onze millions trois cent onze mille six cents euros (€ 11.311.600,-) par
l'émission de trois cent treize mille cinq cent quatre-vingt-onze (313.591) actions nouvelles d'une valeur nominale de
vingt-cinq euros (€ 25,-) chacune, moyennant paiement d'une prime d'émission globale de vingt-trois millions trois cent
cinq mille neuf cent cinquante-sept euros (€ 23.305.957,-), l'ensemble étant à libérer par apport en nature.

2.- Souscription des trois cent treize mille cinq cent quatre-vingt-onze (313.591) actions nouvelles par FLAGSTONE

(GIBRALTAR) LIMITED et paiement par apport en nature.

3.- Annuler cent trente-huit mille huit cent soixante-treize (138.873) actions de la Société détenues par la Société dans

son portefeuille, après avoir pris les résolutions suivant les points 1 et 2 de l'ordre du jour, et en conséquence réduire
le capital social de la Société à concurrence de trois millions quatre cent soixante et onze mille huit cent vingt-cinq euros
(EUR 3.471.825,-).

4.- Modification afférente de l'article 5.1 des statuts.
5.- Divers sujets, expressément limités aux sujets qui peuvent être nécessaires ou requis pour compléter ou donner

effet aux points 1 

er

 à 3 ci-dessus.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de sept millions huit cent trente-neuf mille sept cent

soixante-quinze euros (€ 7.839.775,-), pour le porter de son montant actuel de trois millions quatre cent soixante et
onze mille huit cent vingt-cinq euros (€ 3.471.825,-) à onze millions trois cent onze mille six cents euros (€ 11.311.600,-),
par l'émission de trois cent treize mille cinq cent quatre-vingt-onze (313.591) actions nouvelles d'une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, émises avec une prime d'émission globale de EUR 23.305.957,-.

90708

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des trois cent treize mille cinq cent quatre-vingt-onze (313.591) actions

nouvelles: FLAGSTONE (GIBRALTAR) LIMITED, une société établie à Gibraltar, avec siège social à Suite 1, Burns House,
19 Town Range, Gibraltar, ici représentée par Mathieu Gangloff, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé
délivrée à Gibraltar, le 12 juin 2007, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire
soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

<i>Intervention de l'apporteur - Souscription - Prime d'émission - Apports - Libération

Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée FLAGSTONE (GIBRALTAR) LIMITED, dûment représentée

par Mathieu Gangloff, prénommé, comme dit ci-avant, laquelle a déclarée souscrire les trois cent treize mille cinq cent
quatre-vingt-onze (313.591) actions nouvelles et les libérer intégralement ainsi que la prime d'émission par l'apport en
nature constitué de la totalité de son patrimoine actif et passif, tel que défini à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971,
telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

<i>Description de l'apport

Tous ces actifs et passifs apportés (intégralité de patrimoine) sont documentés sur le bilan de la société apportée

FLAGSTONE (GIBRALTAR) LIMITED, prénommée, lequel bilan après avoir été signé ne varietur par tous les comparants
et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation. L'apport se compose comme suit:

1. Apport d'actifs:
- le montant total du cash disponible sur le compte bancaire de FLAGSTONE (GIBRALTAR) LIMITED au 13 juin 2007

(EUR 50.026.986,-); et

- actionnariat dans FLAGSTONE FINANCE S.A. consistant en 138.873 actions d'une valeur nominale de EUR 25,-

chacune, ainsi qu'une prime d'émission de EUR 10.394.439,-.

2. Apport de passifs:
- facture pour les frais légaux d'un montant de GBP 1.200,- (EUR 1.740,-);
- prêt d'un montant de EUR 12.500,- payable à FLAGSTONE REINSURANCE LIMITED; et
- prêt d'un montant de EUR 32.733.278,- payable à FLAGSTONE REINSURANCE LIMITED.

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 31.145.732,- (trente et un millions cent quarante-cinq mille

sept cent trente-deux euros).

<i>Rapport du Réviseur d'Entreprises

Conformément à l'article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, cet apport en nature a fait l'objet d'une vérifi-

cation  par  CROWN  AUDIT,  avec  siège  social  à  L-2449  Luxembourg,  25A,  boulevard  Royal,  Réviseur  d'Entreprises
indépendant à Luxembourg, représenté par Philipp van der Westhuizen, gérant, et son rapport conclut comme suit:

<i>Conclusion

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale

des apports décrits ci-dessus ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en
contrepartie pour un montant total de 7.839.775,- euros, augmenté de la prime d'émission de 23.305.957,- euros»

Ce rapport après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, restera annexé aux

présentes aux fins de formalisation.

<i>Réalisation effective de l'apport

FLAGSTONE (GIBRALTAR) LIMITED, prénommée, apporteur ici représentée comme dit ci-avant, déclare que toutes

formalités dans tout pays concerné en relation avec le transfert en faveur de FLAGSTONE FINANCE S.A., de chacun
des éléments composant l'intégralité de tous ses actifs et passifs seront menées à bien dans les meilleurs délais en tout
pays concerné afin d'y formaliser valablement la transmission du patrimoine et de le rendre opposable et effectif en tous
lieux et vis-à-vis de tous tiers. Elle en donne décharge de responsabilité pleine et entière au notaire instrumentant.

L'émission des actions nouvelles est également soumise au paiement d'une prime d'émission d'un montant total de

vingt-trois millions trois cent cinq mille neuf cent cinquante-sept euros (EUR 23.305.957,-) qui sera allouée à un compte
distribuable de prime d'émission.

L'assemblée générale prend acte que les actions nouvelles et le montant total de la prime d'émission ont été entière-

ment  payés  par  un  apport  en  nature  consistant  en  tous  les  actifs  et  passifs  (l'ensemble  des  biens)  appartenant  au
souscripteur, y compris l'intégralité de ses actifs et passifs évalués à la valeur net de ses actifs.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par un extrait du registre de commerce et par

un bilan.

L'apport en nature est à la disposition de FLAGSTONE FINANCE S.A., ainsi que cela résulte du «Contribution Agree-

ment» en annexe.

90709

<i>Requête en exonération des droits proportionnels

Compte tenu qu'il s'agit de l'augmentation du capital social d'une société luxembourgeoise par apport en nature de

tous les actifs et passifs (universalité de patrimoine), rien réservé ni excepté, d'une société de capitaux ayant son siège
dans l'Union Européenne, la société requiert sur base de l'article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée
par la loi du 3 décembre 1986, l'exonération du droit proportionnel d'apport.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'annuler cent trente-huit mille huit cent soixante-treize (138.873) actions de la Société

détenues actuellement par la Société dans son portefeuille, et de réduire le compte de prime d'émission de la Société
d'un montant de EUR 10.394.439,-.

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de réduire le capital social de la Société à concurrence

de trois millions quatre cent soixante et onze mille huit cent vingt-cinq euros (€ 3.471.825,-).

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent. L'assemblée décide de modifier l'article

5.1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Capital Social.
5.1- Le capital social souscrit de la société est fixé à sept millions huit cent trente-neuf mille sept cent soixante-quinze

euros (€ 7.839.775,-), représenté par trois cent treize mille cinq cent quatre-vingt-onze (313.591) actions d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (€ 25,-) chacune.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de l'augmentation

de capital sont estimés à environ six mille euros (€ 6.000,-).

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Gangloff, S. Afonso-Da Chao Conde, C. Rouckert, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juin 2007, Relation: EAC/2007/6573. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 15 juin 2007.

F. Kesseler.

Référence de publication: 2007090083/219/289.
(070100648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2007.

Caret SHSG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 115.276.

In the year two thousand and six, on the eighth day of December.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CARET PROPERTIES S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) under Luxembourg Law

incorporated by deed of the undersigned notary on 15th March 2006, having its registered office in L-1528 Luxembourg,
5, boulevard de la Foire, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 115.334, here
represented by Mrs. Sylvie Lexa, companies director, residing professionally in Senningerberg, by virtue of a proxy, given
under private seal,

The said proxy, initialled ne varietur by the attorney in fact of the appearing person and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, acting in its capacity as sole shareholder (the «Sole Share-

holder«) of CARET SHSG S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered

90710

office at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 115276 (the «Company»), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg pursuant
to a deed of the undersigned notary on 16th day of March 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations on 12th day of June 2006 number 1134, has required the undersigned notary to state its resolutions as
follows:

<i>Resolutions

The sole partner decides to transfer the registered office of the company with effect as of 1st September 2006 from

L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire to 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg and to amend article 5 of
the articles of incorporation as follows:

« Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven. It may be transferred

to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad».

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall borne by the Company as a result

of the modification of its articles of incorporation are estimated at one thousand euro (EUR 1,000.-).

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person represented as stated hereabove and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the attorney of the person appearing known to the notary by her name, first name,

civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille six, le huit décembre,
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

CARET PROPERTIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée par le notaire

instrumentant en date du 15 mars 2006, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 115.334, ici représentée par Madame Sylvie
Lexa, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Senningerberg, en vertu d'une procuration sous seing
privé lui délivrée.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, agissant en sa qualité d'associé unique (l'«Associé Unique») de

CARET SHSG, S.à r.l. une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de
la Foire, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.276 (la «Société»),
constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire instrumentant en date du 16 mars 2006,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 12 juin 2006 numéro 1.134, a requis le notaire
soussigné de constater les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société avec effet au premier septembre 2006 de L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts comme suit:

« Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven. Il peut être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou suc-
cursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ mille euros ( EUR
1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante représentée comme

dit ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante
et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

90711

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par

nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Lexa, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 80, case 4. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 18 décembre 2006.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007013909/202/80.
(070005805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2007.

LBREP III Dame S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 118.151.

EXTRAIT

Il ressort d'une convention de cession de parts sociales exécutée en date du 3 mai 2007 entre DOGE BERMUDA

HOLDINGS LP et LBREP III EUROPE HOLDINGS Sàrl que les 500 parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de €
25,- chacune représentant ensemble la totalité du capital social de la Société, sont détenues dès à présent par LBREP III
EUROPE HOLDINGS Sàrl.

A compter du 3 mai 2007, les 500 parts de la sociétés sont détenues par LBREP III EUROPE HOLDINGS Sàrl, une

société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1B Heienhaff L-1736 Senningerberg et enregistrée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.959.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 28 juin 2007.

Pour extrait conforme
ATOZ
Signature

Référence de publication: 2007088118/4170/23.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2007, réf. LSO-CG02101. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070097740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.

Rearden L Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 559.025,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 123.032.

In the year two thousand and seven, on the twentieth day of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders (the Shareholders) of REARDEN L

HOLDINGS 1 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered
office at 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 123.032 incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, then residing in Mersch, on De-
cember 8, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) under number 234 on
22 February 2007 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) were amended pursuant to
a deed of the undersigned notary, then residing in Mersch, on December 19, 2006, published in the Mémorial under
number 636 on April 4, 2007, and pursuant to a deed of the undersigned notary, on January 25, 2007, not yet published
in the Mémorial.

There appeared the Shareholders being:

1) RHÔNE PARTNERS III L.P., a limited partnership formed under the laws of the State of Delaware, with registered

office at c/o THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
New Castle County, Delaware 19801, U.S.A., registered with the Delaware Secretary of State under number 4661796,

hereby represented by Ms Caroline Notté, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy;

90712

2) RHÔNE OFFSHORE PARTNERS III L.P., a limited partnership formed under the Delaware Revised Uniform Limited

Partnership Act, with registered office at M&amp;C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309GT, Ugland House, South
Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

hereby represented by Ms Caroline Notté, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy;
3) RHÔNE COINVESTMENT III L.P., a limited partnership formed under the laws of the State of Delaware, with

registered office at c/o THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, U.S.A., registered with the Delaware Secretary of State under number
4265732,

hereby represented by Ms Caroline Notté, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy;
4) DAISY 16 LLC, a limited company formed in the state of Delaware, having its business address at 888 7th Avenue

New York, NY 10106,

hereby represented by Ms Caroline Notté, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy;
5)  AETNA  LIFE  INSURANCE  COMPANY,  a  corporation  formed  under  the  laws  of  Connecticut  with  registered

address at 151 Farmington Avenue RC21, Hartford, CT 06156, USA,

hereby represented by Ms Caroline Notté, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy;
6) INDUSTRY CORPORATE FINANCE LTD, a private limited corporation, existing under the laws of England, having

its registered office at 259 Old Marylebone Road, London NW1 5RA, United Kingdom,

hereby represented by Ms Caroline Notté, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy;
which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the  undersigned  notary,  shall  remain  attached  to  the  present  deed  to  be  filed  with  such  deed  with  the  registration
authorities.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:
The appearing parties, represented as stated hereabove, represent the entire issued and outstanding share capital of

the Company, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been
duly informed, and have requested the undersigned notary to record the following:

I. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
II. The agenda of the meeting is the following:
1. Waiver of the convening notices;
2. With reference to the notarial deed enacting the resolutions taken at the general meeting of the Shareholders of

the Company held on January 25, 2007 before the undersigned notary, to rectify a material error under the second
resolution and the fourth resolution of such deed regarding the amount of the increase of the share capital of the Company,
which shall be rectified as follows:

<i>«Second Resolution

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of 41,100

(forty-one thousand one hundred euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 495,200.-
(four hundred ninety-five thousand two hundred euro), to EUR 536,300.- (five hundred thirty-six thousand three hundred
euro) by way of the issue of 1,644 (one thousand six hundred and forty-four) new shares of the Company, having a par
value of EUR 25.- (twenty-five euro) each.»

<i>«Fourth resolution

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR

22,725.- (twenty-two thousand seven hundred and twenty-five euro) in order to bring the share capital from its present
amount of EUR 536,300.- (five hundred thirty-six thousand three hundred euro), to EUR 559,025.- (five hundred fifty-
nine thousand and twenty-five euro) by way of the issuance of 909 (nine hundred and nine) new Class B Shares of the
Company, with a nominal value of EUR 25.- each.»

3. As a result of the above resolution, to rectify the registration of the subscription for and payment of the share capital

increases specified in the rectified resolutions 2 and 4;

4. As a result of the above resolutions, to rectify the acknowledgment of the current shareholding;
5. As a result of the first resolution, to rectify the subsequent amendment of article 5.1 of the Articles which shall be

rectified as follows:

«5.1. The Company's corporate capital is fixed at EUR 559,025.- (five hundred fifty-nine thousand and twenty-five

euro), represented by 21,452 (twenty-one thousand four hundred and fifty-two) Class A Shares, and 909 (nine hundred
and nine) Class B Shares, all in registered form with a par value of EUR 25.- (twenty- five euro) each, all subscribed and
fully paid up.»

6. In order to reflect the above resolutions and rectifications, to rectify the registration in the share register of the

Company with power and authority given to any manager of the Company to proceed on behalf of the Company with
such registration;

7. Miscellaneous.

90713

III. That the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves, with reference to the notarial deed enacting the resolutions taken at the general meeting of the

Shareholders of the Company held on January 25, 2007 before the undersigned notary, to rectify a material error under
the second resolution and the fourth resolution of such deed regarding the amount of the increase of the share capital
of the Company, which shall be rectified as follows:

<i>«Second Resolution

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of 41,100

(forty-one thousand one hundred euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 495,200.-
(four hundred ninety-five thousand two hundred euro), to EUR 536,300.- (five hundred thirty-six thousand three hundred
euro) by way of the issue of 1,644 (one thousand six hundred and forty-four) new shares of the Company, having a par
value of EUR 25.- (twenty-five euro) each.»

<i>«Fourth resolution

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR

22,725.- (twenty-two thousand seven hundred and twenty-five euro) in order to bring the share capital from its present
amount of EUR 536,300.- (five hundred thirty-six thousand three hundred euro), to EUR 559,025.-(five hundred fifty-nine
thousand and twenty-five euro) by way of the issuance of 909 (nine hundred and nine) new Class B Shares of the Company,
with a nominal value of EUR 25.- each.»

<i>Third resolution

As a result of the above resolution, the Meeting resolves to rectify the registration of the subscription to and full

payment of the share capital increases as rectified under the second resolution above and as confirmed by each of the
Shareholders, represented by Ms Caroline Notté, Avocat à la Cour, prenamed, by virtue of the respective proxy which
shall remain here attached, as follows:

<i>«Intervention - Subscription - Payment

I. RHÔNE PARTNERS III L.P., prenamed, declares to subscribe for 894 (eight hundred ninety-four) new class A shares

and further declares to fully pay them up by way of a contribution in cash in the aggregate amount of EUR 22,350.- (twenty-
two  thousand  three  hundred  and  fifty  euro),  evidence  of  which  has  been  given  to  the  undersigned  notary,  who
acknowledges it.

Such contribution in an aggregate amount of EUR 22,350.- (twenty-two thousand three hundred and fifty euro), made

to the Company is to be allocated to the share capital account of the Company; and

II. RHÔNE OFFSHORE PARTNERS III L.P., prenamed, declares to subscribe for 750 (seven hundred and fifty) new

class A shares and further declares to fully pay them up by way of a contribution in cash in the aggregate amount of EUR
18,750.- (eighteen thousand seven hundred and fifty euro), evidence of which has been given to the undersigned notary,
who acknowledges it.

Such contribution in an aggregate amount of EUR 18,750.- (eighteen thousand seven hundred and fifty) made to the

Company is to be allocated to the share capital account of the Company; and

III. DAISY-16, LLC, prenamed, declares to subscribe for 413 (four hundred and thirteen) new Class B shares and further

declares to fully pay them up by a contribution in cash in the aggregate amount of EUR 41,300.- (forty-one thousand three
hundred euro), evidence of which has been given to the undersigned notary, who acknowledges it.

Such contribution in an aggregate amount of EUR 41,300.- (forty-one thousand three hundred euro) made to the

Company is to be allocated as follows:

- EUR 10,325.- (ten thousand three hundred and twenty-five euro) to the share capital account of the Company; and
- EUR 30,975.- (thirty thousand nine hundred and seventy-five euro) to the Class B shares premium account of the

Company.

IV. AETNA LIFE INSURANCE COMPANY, a corporation formed under the laws of Connecticut with registered

address at 151 Farmington Avenue RC21, Hartford, CT 06156, U.S.A, declares to subscribe for 496 (four hundred and
ninety-six) new Class B shares and further declares to fully pay them up by a contribution in cash in the aggregate amount
of EUR 49,600.- (forty-nine thousand six hundred euro), evidence of which has been given to the undersigned notary,
who acknowledges it.

Such contribution in an aggregate amount of EUR 49,600.- (forty-nine thousand and six hundred euro) made to the

Company is to be allocated as follows:

- EUR 12,400.- (twelve thousand and four hundred euro) to the share capital account of the Company; and

90714

- EUR 37,200.- (thirty-seven thousand and two hundred euro) to the Class B shares premium account of the Company».

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolution, the Meeting resolves to rectify the acknowledgment of the current shareholding

in the Company is, further to the increases in capital as rectified herein, as follows:

RHÔNE PARTNERS III L.P., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,621 Class A shares
RHÔNE OFFSHORE PARTNERS III L.P., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,731 Class A shares

RHÔNE COINVESTMENT III L.P., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 Class A shares

INDUSTRY CORPORATE FINANCE LTD, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83 Class A shares

DAISY-16, LLC, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

413 Class B shares

AETNA LIFE INSURANCE COMPANY, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

496 Class B shares

<i>Fifth resolution

As a result of the first resolution, the Meeting resolves to rectify the subsequent amendment of article 5.1 of the

Articles which shall be rectified as follows:

«5.1. The Company's corporate capital is fixed at EUR 559,025.- (five hundred sixty-one thousand and two hundred

euro), represented by 21,452 (twenty-one thousand four hundred and fifty-two) Class A Shares, and 909 (nine hundred
and nine) Class B Shares, all in registered form with a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, all subscribed and
fully paid up.»

<i>Sixth resolution

In order to reflect the above resolutions and rectifications, the Meeting resolves to rectify the registration in the share

register of the Company with power and authority given to any manager of the Company to proceed on behalf of the
Company with such registration.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,000.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingtième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de REARDEN L HOLDINGS 1 S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de Luxembourg, avec siège social au 12-14, rue Léon Thyes,
L-2636 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.032
(la Société), constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, le 8 décembre
2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) sous le numéro 234, le 22 février 2007.
Les statuts de la Société (les Statuts) furent modifiés suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence
à Mersch, le 19 décembre 2006, publié au Mémorial C sous le numéro 636 le 4 avril, 2007, et suivant un acte reçu par le
soussigné notaire le 25 janvier 2007, non encore publié au Mémorial.

Ont comparu:

1) RHÔNE PARTNERS III L.P., un Limited Partnership constitué et organisé selon les lois de l'état du Delaware, avec

siège social à CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New
Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis, immatriculée auprès du secrétaire de l'Etat du Delaware sous le numéro
4661796

représenté par M 

e

 Caroline Notté, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration,

2) RHÔNE OFFSHORE PARTNERS III L.P., un Limited Partnership constitué et organisé selon le Delaware Revised

Uniform Limited Partnership Act, avec siège social à M&amp;C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309GT, Ugland
House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman,

représenté par M 

e

 Caroline Notté, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration,

90715

3) RHÔNE COINVESTMENT III L.P., un Limited Partnership constitué et organisé selon les lois de l'état du Delaware,

avec siège social à CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis, immatriculée auprès du Delaware Secretary of State sous le numéro
4265732,

représenté par M 

e

 Caroline Notté, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration,

4) DAISY 16 LLC, une limited liability company constituée et organisée selon les lois de l'état du Delaware, avec son

siège social au 888 7th Avenue New York, NY 10106, Etats-Unis,

représentée par M 

e

 Caroline Notté, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration,

5) AETNA LIFE INSURANCE COMPANY, une société constituée et organisée selon les lois du Connecticut, avec son

siège social au 151 Farmington Avenue RC21, Hartford, CT 06156, Etats-Unis,

représentée par M 

e

 Caroline Notté, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration,

6) INDUSTRY CORPORATE FINANCE LTD, une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les

lois de l'Angleterre, avec son siège social au 259 Old Marylebone Road, London NW1 5RA, Royaume-Uni,

représentée par M 

e

 Caroline Notté, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration,

lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci auprès de l'enregis-
trement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, détiennent toutes les parts sociales dans le capital

social de la Société, afin que les participants puissent prendre les décisions relatives à l'ordre du jour pour lequel les
associés ont été dûment informés, et ont requis la présence du soussigné notaire d'acter:

I. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:
II. L'ordre du jour est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. En référence à l'acte documentant les résolutions prises lors de l'assemblée générale des Associés de la Société qui

s'est tenue le 25 janvier 2007 devant le soussigné notaire, rectifier une erreur matérielle sous la deuxième résolution et
la quatrième résolution dudit acte relative au montant de l'augmentation du capital de la Société, qui doit être rectifiée
comme suit:

<i>«Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant de EUR

41.100,- (quarante et un mille cent euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 495.200,- (quatre
cent quatre-vingt-quinze mille deux cents euros) à EUR 536.300,- (cinq cent trente-six mille trois cents euros) par l'émis-
sion de 1.644 (mille six cent quarante-quatre) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR
25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

<i>«Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant de EUR

22.725,- (vingt-deux mille sept cent vingt-cinq euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 536.300,-
(cinq cent trente six mille et trois cents euros) à EUR 559.025,- (cinq cent cinquante-neuf mille et vingt-cinq euros) par
l'émission de 909 (neuf cent neuf) nouvelles parts sociales de classe B de la Société, ayant une valeur nominale de EUR
25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

3. En conséquence de la première résolution, rectification de la souscription à et paiement des augmentations de capital

mentionnées aux résolutions 2 et 4 telles que modifiées ci-dessus;

4. En conséquence des résolutions ci-dessus, modification subséquente de la reconnaissance de l'allocation actuelle du

capital social;

5. En conséquence de la première résolution, rectification de la modification subséquente de l'article 5, premier pa-

ragraphe, des Statuts, qui sera modifié comme suit:

«5.1 Le capital social de la Société est fixé à EUR 559.025,- (cinq cent cinquante-neuf mille vingt-cinq euros), représenté

par EUR 21.452,- (vingt et un mille quatre cent cinquante-deux) parts sociales de classe A, et 909 (neuf cent neuf) parts
sociales de classe B, sous forme nominative, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.»

6. Afin de refléter les résolutions ci-dessus, modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer

les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, de procéder au nom de la Société à
l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

90716

7. Divers.
III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, les associés se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide, en référence à l'acte exécutant les résolutions prises lors de l'assemblée générale des Associés

de la Société qui s'est tenue le 25 janvier 2007 devant le soussigné notaire, de rectifier une erreur matérielle sous la
deuxième résolution et la quatrième résolution d'un tel acte relative au montant de l'augmentation du capital de la Société,
qui doit être rectifiée comme suit.

<i>«Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant de EUR

41.100,- (quarante et un mille cent euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 495.200,- (quatre
cent quatre-vingt quinze mille deux cents euros) à EUR 536.300,- (cinq cent trente-six mille trois cents euros) par l'émis-
sion de 1.644 (mille six cent quarante-quatre) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR
25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

<i>«Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant de EUR

22.725,- (vingt-deux mille sept cent vingt-cinq euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 536.300,-
(cinq cent trente-ix mille trois cents euros) à EUR 559.025,- (cinq cent cinquante-neuf mille vingt-cinq euros) par l'émission
de 909 (neuf cent neuf) nouvelles parts sociales de classe B de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-
cinq euros) chacune.»

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de rectifier l'enregistrement de la souscription et la

libération intégrale des augmentations de capital telles que modifiées sous la deuxième résolution ci-dessus et telle que
confirmées par chacun des Associés, représentés par M 

e

 Caroline Notté, Avocat à la Cour, en vertu de procurations

annexées au présent acte, comme suit:

<i>«Intervention - Souscription - Paiement

I. RHÔNE PARTNERS III L.P., susmentionnée, déclare souscrire à 894 (huit cent quatre-vingt-quatorze) nouvelles

parts sociales de classe A de la Société, et déclare les payer intégralement par la voie d'un apport en numéraire d'un
montant total de EUR 22.350,- (vingt-deux mille trois cent cinquante euros) dont la preuve a été rapportée au notaire
instrumentant, qui déclare le reconnaître;

Cet apport d'un montant total de EUR 22.350,- (vingt-deux mille trois cent cinquante euros) fait à la Société sera

affecté au compte capital social de la Société.

II. RHÔNE OFFSHORE PARTNERS III L.P., susmentionnée, déclare souscrire à 750 (sept cent cinquante) nouvelles

parts sociales de classe A de la Société, et déclare les payer intégralement par la voie d'un apport en numéraire d'un
montant total de EUR 18.750,- (dix-huit mille sept cent cinquante euros) dont la preuve a été rapportée au notaire
instrumentant, qui déclare le reconnaître;

Cet apport d'un montant total de EUR 18.750,- (dix-huit mille sept cent cinquante euros) fait à la Société sera affecté

au compte capital social de la Société.

III. DAISY-16 LLC, susmentionnée, déclare souscrire à 413 (quatre cent treize) nouvelles parts sociales de classe B de

la Société, et déclare les payer intégralement par la voie d'un apport en numéraire d'un montant total de EUR 41.300,-
(quarante  et  un  mille  trois  cents  euros),  dont  la  preuve  a  été  rapportée  au  notaire  instrumentant,  qui  déclare  le
reconnaître.

Cet apport d'un montant total de EUR 41.300,- (quarante et un mille trois cents euros) fait à la Société sera alloué

comme suit:

- EUR 10.325,- (dix mille trois cent vingt-cinq euros) au compte capital social de la Société; et
- EUR 30.975,- (trente mille neuf cent soixante-uinze euros) au compte de réserve de primes d'émissions des parts

sociales de classe B de la Société.

IV. AETNA LIFE INSURANCE COMPANY, une société constituée selon le droit du Connecticut, avec siège social à

151 Farmington Avenue RC21, Hartford, CT 06156, Etats-Unis, déclare souscrire à 496 (quatre cent quatre-vingt-seize)
nouvelles parts sociales de classe B de la Société, et déclare les payer intégralement par la voie d'un apport en numéraire
d'un montant total de EUR 49.600,- (quarante-neuf mille six cents euros), dont la preuve a été rapportée au notaire
instrumentant, qui déclare le reconnaître.

90717

Cet apport d'un montant total de EUR 49.600,- (quarante-neuf mille six cents euros) fait à la Société sera alloué comme

suit:

- EUR 12.400,- (douze mille quatre cents euros) au compte capital social de la Société; et
- EUR 37.200,- (trente-sept mille deux cents euros) au compte de réserve de primes d'émissions des parts sociales de

classe B de la Société».

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide d'acter que le capital social de la Société, à la suite

des augmentations de capital tels que modifiées sous la première résolution, est détenu comme suit:

RHÔNE PARTNERS III L.P., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.621 parts sociales de classe A
RHÔNE OFFSHORE PARTNERS III L.P., susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.731 parts sociales de classe A
RHÔNE COINVESTMENT III L.P., susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 parts sociales de classe A

INDUSTRY CORPORATE FINANCE LTD, susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83 parts sociales de classe A

DAISY-16, LLC, susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

413 parts sociales de classe B

AETNA LIFE INSURANCE COMPANY, susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

496 parts sociales de classe B

<i>Cinquième résolution

En conséquence de la première résolution, l'Assemblée décide de rectifier la modification subséquente de l'article 5,

premier paragraphe, des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

«5.1. Le capital social de la Société est fixé à EUR 559.025,- (cinq cent cinquante-neuf mille vingt-cinq euros), représenté

par 21.452 (vingt et un mille quatre cent cinquante-deux) parts sociales de classe A et 909 (neuf cent neuf) parts sociales
de classe B, sous forme nominative, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées.»

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des Associés de la Société dans le but de refléter les changements sus-

mentionnés et donne pouvoir et autorise tout gérant de la Société de procéder au nom de la Société à l'inscription des
nouvelles parts émises dans le registre des Associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.000,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête des mêmes parties et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec nous, le notaire,

l'original du présent acte.

Signé: C. Notté, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2007, Relation: LAC/2007/15128. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007090053/242/341.
(070100201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2007.

Opera - Participations Sca, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 78.701.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007088535/1142/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2007, réf. LSO-CG08543. - Reçu 60 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070098998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

90718

Finagi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 114.389.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007088539/1142/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2007, réf. LSO-CG08214. - Reçu 44 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070098991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Opera - Participations 2, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 100.610.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007088537/1142/12.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2007, réf. LSO-CG08550C. - Reçu 50 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070098996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

GenixWorks, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 83, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 95.224.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007088521/824/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2007, réf. LSO-CG08349. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070098889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Selenia, Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 95.257.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 9 juillet 2007

Le Conseil d'Administration a décidé:
- de nommer Monsieur Brian Schwartz, Directeur, demeurant 21 Green Way, Allendale, NJ 07401 USA en tant que

représentant permanent de VESTAR-AIV MANAGERS Ltd;

- de nommer Monsieur Patrick Shattenkirk, Directeur, demeurant 80 Old Boston Post Road, New Rochelle, NY 10801

USA en tant que représentant permanent de VESTAR-AIV MANAGERS II Ltd.

Luxembourg, le 16 juillet 2007.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2007088117/1005/18.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2007, réf. LSO-CG08691. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070097647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.

90719

Global Capital Corporation Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 55.874.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 6 mars 2007 et conformément aux dispositions de la

loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer:

GORDALE MARKETING LIMITED, 4, Andrea Zakou Egkomi, P.C. 2404 Nicosia, Cyprus
aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de TOWERBEND LIMITED démissionnaire, avec effet

au 3 décembre 2006.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 6 mars 2007.

<i>Pour GLOBAL CAPITAL CORPORATION HOLDING S.A.
Signature

Référence de publication: 2007089676/744/18.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG02809. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070099739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.

Werner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 32.093.

Le bilan au 31 décembre 1996 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007089534/6102/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09807. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070099167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.

JPMorgan European Property Holding Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 106.899.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 23 juillet 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007089989/239/12.
(070100174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2007.

Société Immobilière Nice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Steinfort, 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 107.588.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007088508/824/13.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2007, réf. LSO-CG08366. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070098905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

90720


Document Outline

Aletta S.A.

American Pacific S.A.

Atos Origin Luxembourg PSF S.A.

Bambi Continental S.à r.l.

Beltrust S.A.

Caret SHSG S.à r.l.

Chabana S.A.

CMS Management Services S.A.

CMS Management Services S.A.

Continental Pac Holding S.A.

Cortines S.A.

Cotrel Investissements

De Bird

De Bird

EPS - Economical Power Systems S.A.

Erisider Lux S.A.

Fell Informatique S.à r.l.

Finagi S.A.

Flagstone Finance S.A.

GenixWorks

GH (N4) S.à r.l.

Global Capital Corporation Holding S.A.

Global Group AG

IFI Estates S.A.

JPMorgan European Property Holding Luxembourg 3 S.à r.l.

Kauri Capital 3

Kubis Software S.A.

LBREP III Dame S.à r.l.

Luxembourg Corporation Company S.A.

MCI Holding S.A.

ONEX TWG Holdings II Limited

Opera - Participations 2

Opera - Participations Sca

Parkridge Holdings Russia Warehouses S.à r.l.

Participations et Financements Extérieurs S.A.

PDP Professionals in Data Processing International S.A.

Polyfilms Group S.A.

Presidential Holdings Ferdinand II

Rearden L Holdings 1 S.à r.l.

Santa Caterina S.A.

S.à r.l. IMMOBILIERE Carlo FISCHBACH

Scantrust Holding S.A.

Scantrust Holding S.A.

Scantrust Holding S.A.

Scantrust Holding S.A.

Scantrust Holding S.A.

Scantrust Holding S.A.

Scantrust Holding S.A.

Schwarzwaldhaus S.à r.l.

Seculux Sàrl

Selenia

SL Software_Consult S.A.

Société Immobilière Nice S.A.

Solardaach Al Schmelz I Société Civile

Stahlbeteiligungen Holding S.A.

Talden Holding S.A.

Werner S.A.

Werner S.A.

Werner S.A.

WQ International S.A.

WQ International S.A.

Wurth-Strotz S.à r.l.