This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1866
3 septembre 2007
SOMMAIRE
Alceos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89561
Aprovia Management GUN . . . . . . . . . . . . .
89554
ArcelorMittal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89540
Aresa Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89556
Aton S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89563
Auto-Sport Shop s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
89564
Blamar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89555
Brasserie Georges VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
89563
Bugatti International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
89557
Business Go Asia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89563
Café Eselsstiffchen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
89557
Chauffage-Sanitaire Schmit Nico Sàrl . . . .
89566
Clear Vision International S.A. . . . . . . . . . .
89563
Commerc' Printing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
89562
CSC Computer Sciences Luxembourg SA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89562
Delta Investment AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89562
Doba S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89553
EPD Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
89557
European Logistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89561
Financière Wolf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89558
Gallo Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89561
Gerard Klopp S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89562
Hawaii Invest S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89565
Initiatives Céramiques S.à r.l. . . . . . . . . . . .
89566
Investor Services House S.A. . . . . . . . . . . . .
89555
Juharfa Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89558
Kaalk Production S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
89564
Logistic Investment Holding S. à r.l. . . . . .
89560
LUX-Montage SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89565
Luxpatates S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89554
Luxspreng S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89567
Maraton International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
89565
Merkur Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
89564
MPC Global Maritime Opportunities S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89522
Naxo S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89565
Oceni Opportunities S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
89564
Oraxys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89560
Pépinière Martin Wahl S.e.n.c. . . . . . . . . . .
89554
Perignon Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . .
89568
Plutonite Stone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89559
Pobeier & Co S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89558
Pool Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89553
Pyrolux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89567
Raiffeisen-Markt-Echternach s.à r.l. . . . . . .
89568
Resort Development AG . . . . . . . . . . . . . . . .
89559
Romafi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89558
ROYAL REAL ESTATE International . . . .
89559
Sanolux G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89568
S.C.O.N.A. Holding S.A.H. . . . . . . . . . . . . . .
89567
SDG Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89560
Service Center Schmit Nico S.à r.l. . . . . . .
89567
SO Bois, Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89566
Starlife S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89556
Teixeira Construction Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
89559
89521
MPC Global Maritime Opportunities S.A., Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 130.602.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the seventh of August.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
MPC MÜNCHMEYER PETERSEN CAPITAL AG, with registered office in Palmaille 67, D-22767 Hamburg,
here represented by Mrs Britta Weickgenannt, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given in Hamburg on 1st August 2007.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a public limited company (société anonyme, S.A.) in form of an investment company with variable capital
qualifying as a specialised investment fund (société d'investissement à capital variable - Fonds d'Investissement Spécialisé,
SICAV-FIS) and the articles of incorporation of which shall be as follows:
Except otherwise implied by the context, the capitalized terms used in these Articles shall have the same meaning as
in the placement memorandum of the Company (the «Memorandum»).
Art. 1. Name. There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of the shares
of the Company hereafter issued (the «Shares»), a public limited company (société anonyme, S.A.) in form of an investment
company with variable capital qualifying as a specialised investment fund (société d'investissement à capital variable - fonds
d'investissement spécialisé, SICAV-FIS) under the name of MPC GLOBAL MARITIME OPPORTUNITIES S.A. (the «Com-
pany»).
The Company shall be governed by the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds (SIF) (the
«Law of 13 February 2007»).
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-Strassen, Grand Duchy
of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by a decision of the board of directors of the Company (the «Board of Directors»). Within the same borough,
the registered office may be transferred through simple resolution of the Board of Directors.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social events have
occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg
corporation.
Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
In the event that no initial public offering on a recognised and liquid stock market other than the Luxembourg EuroMTF,
which leads to a free float of at least 25% of the Company's equity of the final closing (as determined by the Board of
Directors and described in the Memorandum), is achieved and with all shares permitted for trading within 2 years after
the first closing (as determined by the Board of Directors and described in the Memorandum), the Board of Directors
will ensure that all assets are sold within the next three years (plus extension options) and the capital is distributed to
the Shareholders. The requirement to dispose the assets can be postponed for two periods of two years each period
requiring a 75% majority approval of the general meeting of Shareholders.
The Board of Directors will furthermore ensure that all assets are sold and the capital is distributed to the Shareholders
in certain cases of underperformance of the Company, as described in more detail in the Memorandum.
Art. 4. Purpose. The Company intends to invest in opportunistic transactions in the shipping industry. The Company
will be highly return focussed on the basis of a well diversified portfolio of vessels and/or companies owning, operating
or developing vessels. The Company will invest across all shipping sectors, segments and vessel types as well as apply
various employment strategies. The Company will mainly seek to make control-oriented equity, equity-related and, on
an ancillary basis, investments in debt securities. The investments and businesses acquired by the Company may exercise
all kind of entrepreneurial activity in the shipping markets. The Company will seek to optimize each investment with
respect to both operations and financial structure.
The Company will invest primarily in assets that are linked to commercial shipping including but not limited to vessels,
companies owning and operating vessels, building contracts for vessels and other contractual rights on vessels, charter
89522
income from vessels and freight rates, but excluding shipyards. In «Special Situations» the Company will also invest into
assets and companies related to the shipping industry such as terminals, containers, ports infrastructure & logistics. For
the latter, the Shareholder Representative will have a veto right (as described in article 19). These assets can be acquired
and held either directly or through Investment Structures.
Investment Structures own, operate, develop, manage or support shipping related assets in the form of share trans-
actions - listed as well as unlisted -, taking private strategies, acquiring family-run non-listed businesses as well as via joint
ventures or partnerships. Investments can be over single assets as well as on the basis of a portfolio of assets. For hedging
purposes, the Company and Investment Structures may invest up to 10% of the Company's aggregate Commitments in
derivatives related (forward freight agreements, «FFA») and not related (Interest & Currency Hedging) to shipping assets.
Without prejudice to the previous paragraph, the Company may further invest the funds available to it in assets
permitted to an specialised investment fund under the provisions of the Law of 13 February 2007.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the Law of 13 February 2007.
Art. 5. Determination of the investment objectives and policies. The Board of Directors shall determine the investment
objectives and policies of the Company as well as the course of conduct of the management and the business affairs of
the Company in relation thereto, as set forth in the Memorandum, in compliance with applicable laws and regulations.
Art. 6. Share Capital. (a) The capital of the Company shall be represented by Shares of no par value and shall at any
time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 12 hereof. The minimum capital of the Company,
which must be achieved within twelve (12) months after the date on which the Company has been authorized as a
specialised investment fund (SIF) under Luxembourg law, is the equivalent to one million two hundred and fifty thousand
euro (EUR 1,250,000.-).
The Board of Directors may create Classes of Shares in accordance with the provisions and subject to the requirements
of the law dated 10 August 1915 on commercial companies.
(b) The Company has been incorporated with a subscribed share capital of two hundred and fifty thousand US Dollars
(USD 250,000.-) divided into one Share of no par value. Upon incorporation, the Share was fully paid-up.
(c) The Board of Directors is authorized to issue, in accordance with Article 9 hereof and the provisions of the
Memorandum, an unlimited number of Shares to be created without reserving to the existing Shareholders a preferential
right to subscribe for the Shares to be issued until 31. October 2007, and with reserving to the existing Shareholders a
preferential right to subscribe for the Shares for any Shares to be issued thereafter.
(d) In addition, the Company may issue warrants on Shares in accordance with the procedure determined by the Board
of Directors in the Memorandum.
Art. 7. Shares. (a) Shares are exclusively restricted to Eligible Investors within the meaning of article 2 of the Law of
13 February 2007.
(b) All Shares shall be issued in registered form.
All issued Shares of the Company shall be registered in the register of shareholders (the «Register»), which shall be
kept by the Company or by a person designated therefore by the Company, under its sole responsibility and the Register
shall contain the name of each Shareholder, his residence, registered office or elected domicile, the number and Class of
Shares held by him, the amount paid in on each such Share and banking references. Until notices to the contrary shall
have been received by the Company, it may treat the information contained in the Register as accurate and up to date
and may in particular use the inscribed addresses for the sending of notices and announcements and the inscribed banking
references for the making of any payments.
The inscription of the Shareholder's name in the Register evidences his right of ownership of such registered Shares.
Share certificates in registered form may be issued at the discretion of the Board of Directors.
(c) Fractional Shares may be issued up to three decimal places and shall carry rights in proportion to the fraction of a
Share they represent but shall carry no voting rights, except to the extent their number is so that they represent a whole
Share, in such a case they confer a voting right.
(d) Each Share grants the right to cast one vote at every meeting of Shareholders and at separate Class meetings of
the holders of Shares of each of the Classes issued.
(e) The Company recognizes only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the
ownership of such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint one single attorney
to represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights
attached to such Share(s).
Art. 8. Transfer of Shares. Transfers of Shares shall be effected by inscription of the transfer to be made in the Register
upon delivery to the Company of the transfer form along with other instruments of transfer satisfactory to the Company
and if Share certificates have been issued, the relevant Share certificates.
Transfers of fully paid Shares are free, it being understood however that (i) the transferee has to qualify as an Eligible
Investor and (ii) the transferor will remain subject to all contingent liabilities towards the Company, including in particular
89523
the obligation to subscribe and fully pay further Shares in accordance with the transferor's Share subscription commitment
towards the Company unless the transferee can demonstrate to the satisfaction of the Board of Directors that it has
sufficient funds at its disposal to meet the unpaid Share subscription commitments. Notwithstanding the foregoing, a
Shareholder may transfer the unpaid portion of its Share subscription commitment to an existing Shareholder or to a
third party subject to prior approval from the Board of Directors.
The Company will not give effect to any transfer of Shares to any investor who may not be considered as an Eligible
Investor within the meaning of article 2 of the Law of 13 February 2007.
Art. 9. Issue of Shares. Existing Shareholders and potential Shareholders shall be proposed to subscribe to Shares on
one or more dates or periods as determined by the Board of Directors (each a «Closing») and which shall be indicated
and more fully described in the Memorandum.
Payments for subscriptions to Shares shall be made in whole or in part on a Closing or on any other date as determined
by the Board of Directors and as indicated and more fully described in the Memorandum. The modes of payment in
relation to such subscriptions shall be determined by the Board of Directors and specified and fully described in the
Memorandum.
The Board of Directors may determine any other subscription conditions such as minimum subscription on Closings,
default interests or restrictions on ownership. Such other conditions shall be disclosed and more fully described in the
Memorandum.
Shareholders shall not have any priority rights to subscribe for new Shares to be issued until final Closing. Thereafter
Shareholders shall have priority rights to subscribe for new Shares to be issued.
The Board of Directors may delegate, under its responsibility, to any Director, manager, officer or other duly au-
thorised agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the price of the new Shares to be issued and to
deliver the new Shares.
The Company may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities or other assets in
compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a special report from
the auditor of the Company and provided that such securities or other assets comply with the investment objectives and
strategy of the Company. All fees and costs linked to such contribution in kind shall be exclusively assumed by such
contributor in kind.
Art. 10. Penalties. Any investor that defaults (a «Defaulting Investor») with respect to any payment of its required
Share subscription commitment or other amounts shall be subject to certain consequences, which may, at the discretion
of the Board of Directors, include any of the following:
- The Defaulting Investor will become liable to the Company for interest on such unfunded portion at a rate of the 1-
Month US-Dollar LIBOR plus 4 percentage points per annum, calculated on a period lasting from the due date of the
payment of the required subscribed amount until the effective payment of such amounts (including such accrued interest),
and for additional indemnities (e.g. if as a result of the default of the Defaulting Investor the Company is in turn defaulting
with respect to a payment in relation to its investments); the liability of the Defaulting Investor for additional indemnities
shall be limited to the amount of its Share subscription commitment)
- The Shares held by the Defaulting Investor may be redeemed compulsorily by the Company. In taking the relevant
redemption decision, the Board of Directors shall act reasonably, taking into consideration the relevant circumstances.
Furthermore, the Shares held by the Defaulting Investor will not be redeemed compulsorily unless the investor is still in
default following the expiry of a grace period of ten Business Days from the date the payment was originally required to
be made. The Defaulting Investor will be entitled to 50% of his payment on its Shares less effected distributions, if any,
and additional indemnities (e.g. if as a result of the default by the Defaulting Investor the Company is in turn defaulting
with respect to a payment in relation with its investments), if any, but not more than the Net Asset Value of his Shares.
This compensation shall be paid in one or several instalments, due at the same time when distributions to the Shareholders
are effected, but not before it is definitely confirmed that no such additional indemnities have to be paid. Each instalment
amounts to the sum which the Defaulting Investor had received if his Shares had not been redeemed compulsorily by the
Company. No interests will be paid on the compensation. The compulsorily redeemed Shares may be offered to other
Shareholders and/or new investors and sold at the best price;
- The Defaulting Investor will forego any future income or gains realized after the default and such income and gains
will be distributed on a pro rata basis to the other Shareholders;
- The Defaulting Investor will lose the right to vote at the general meeting of Shareholders.
Art. 11. Redemption of Shares. The Company is a closed company and thus unilateral redemption requests by the
Shareholders may be refused by the Company.
Subject to the approval of the majority of Shareholders, Shares may be redeemed upon proposition of the Board of
Directors, on a pro rata basis from all existing Shareholders according to the terms and conditions provided for in the
Memorandum.
In addition thereto, the Shares may be redeemed compulsorily if a Shareholder ceases to be or is found not to be an
Institutional Investor, a Professional Investor or a Well-informed Investor within the meaning of article 2 of the Law of
89524
13 February 2007. Furthermore, the Shares may be redeemed compulsorily if an investor has become a Defaulting In-
vestor. Such compulsory redemption shall be made under the conditions set forth in the Memorandum.
The Company shall have the right to satisfy payment of the redemption price to any Shareholder who agrees in specie
by allocating to the Shareholder investments from the portfolio of assets of the Company equal to the value of the Shares
to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable
basis and without prejudicing the interests of the other Shareholders of the Company and the valuation used shall be
confirmed by a special report of the auditor of the Company. The costs of any such transfers shall be borne by the
transferee.
Art. 12. Determination of the Net Asset Value. The net asset value of each Class (the «Net Asset Value»), will be
determined by the corporate agent under the responsibility of the Board of Directors in the Company's reference cur-
rency (as determined in the Memorandum) on each Valuation Day as further defined in the Memorandum.
In determining the Net Asset Value per Share, income and expenditure are treated as accruing daily.
The valuation of the Company's assets and liabilities shall be determined in accordance with generally accepted valuation
principles in compliance with article 28 (4) of the Law of 13 February 2007:
Assets shall be valued in accordance with the valuation principles as set forth by the INTERNATIONAL PRIVATE
EQUITY and VENTURE CAPITAL VALUATION GUIDELINES and with recognised valuation methods for commercial
vessels. Furthermore, the valuation will be subject to the annual audit. An international audit company has been consulted
about the valuation methods, involving their specialists for the valuation of companies and commercial vessels.
Investments of the Company, which may be characterised predominantly as an independent company, shall be valued
according to the Discounted Cash flow Method («DCF Method») or according to acknowledged valuation multiples.
Those investments which may be characterised predominantly as investments in material assets (e.g. investments in
vessels) shall be valued in a first step according to the net present value, i.e. DCF Method. The net present value shall be
calculated based on the present value of estimated future cash flows at the relevant Valuation Day while applying a discount
rate which is adequate to the relevant asset. Current assets (stocks, claims, liquid assets) shall be valued at their book
value or market value if a market price is directly available. In a second step, the present value of the debt shall be deducted.
For the valuation of investments in vessels under construction, the continued acquisition and construction costs and
expenses shall be considered. Investments in vessels will be valuated according to the DCF Method from that time on,
at which there is a basis for the determination of the future cash flows from the chartering out, usually, this will be the
time of the conclusion of the charter agreement.
The values determined according to the DCF Method shall continuously be compared to the observable fair market
values of charter free vessels. In doing so, the values of vessels will be examined separately from the influence on value
of advantageously or disadvantageously running charter agreements. However, the DCF method shall prevail.
Furthermore, independent experts may be charged regularly with the valuation of single assets of the Company.
Other fair valuation methods may be used if the Board of Directors considers that another method better reflects the
value of the assets if circumstances and market conditions so warrant and provided that such other methods aim at the
valuation of the assets on the basis of the reasonably and foreseeable sales price determined prudently and in good faith.
The Net Asset Value per each Class as of any Valuation Day shall be made available to the Shareholders at the registered
office of the Company within a period of time following the relevant Valuation Day as disclosed in the Memorandum.
Art. 13. Suspension of the Determination of the Net Asset Value. The Board of Directors may suspend the determi-
nation of the Net Asset Value:
a) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Board of Directors
as a result of which disposals or valuation of assets owned by the Company would be impracticable;
b) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any
of the investments of the Company or the current price or value on any stock exchange or other market price in respect
of the assets of the Company;
c) if restrictions on foreign exchange or with regard to capital transactions prevent the settlement of transactions on
behalf of the Company;
d) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company cannot promptly or accurately
be ascertained;
Any request for subscription shall be irrevocable except in the event of a suspension of the determination of the Net
Asset Value per Share.
Art. 14. Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members,
who do not need to be Shareholders of the Company.
The members of the Board of Directors shall be elected for a term not exceeding six years. The Directors shall be
elected by the Shareholders at a general meeting of Shareholders; the latter shall further determine the number of
Directors, their remuneration and the term of their office.
89525
Any Director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general
meeting of Shareholders. The Founding Shareholder shall have the right to suggest a new Director replacing the one
revoked.
In the event of a vacancy in the office of a Director, the remaining Directors may temporarily fill such vacancy; the
Shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting.
Art. 15. Board Meetings. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman. It may choose a
secretary who need not be a Director and who shall write and keep the minutes of the meetings of the Board of Directors
and of the Shareholders. The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or any two Directors, at the place
indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at the meetings of the Directors and of the Shareholders. In his absence, the Shareholders
or the board members shall decide by a majority vote that another Director, or in case of a Shareholders' meeting, that
any other person shall be in the chair of such meetings.
The Board of Directors may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as
well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such
appointments may be cancelled at any time by the Board of Directors. The officers need not be Directors or Shareholders
of the Company. Unless otherwise stipulated by the present articles of incorporation, the officers shall have the rights
and duties conferred upon them by the Board of Directors.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least forty eight hours prior
to the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telefax, electronic mails
or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places
fixed in a resolution adopted by the Board of Directors.
Any Director may act at any meeting by appointing in writing, by telefax, electronic mails or any other similar means
of communication another Director as his proxy. A Director may represent several of his colleagues.
Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of commu-
nications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. The Directors may not bind the
Company by their individual signatures, except if specifically authorized thereto by resolution of the Board of Directors.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the Directors, or any other number
of Directors that the Board of Directors may determine, are present or represented.
Resolutions of the Board of Directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or by any
two Directors. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly
signed by the chairman of the meeting or any two Directors.
Resolutions are taken by a majority vote of the Directors present or represented at such meeting. In the event that
at any meeting the number of votes for or against a resolution is equal, the chairman of the meeting shall have a casting
vote. Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions voted at the
Directors' meetings; each Director shall approve such resolution in writing, by telefax, electronic mails or any other
similar means of communication.
Art. 16. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all
acts of administration and disposition within the purpose of the Company.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of incorporation to the general meeting of Share-
holders are in the competence of the Board of Directors.
When taking any investment decisions the Board of Directors will take into account the recommendations of the
Investment Committee in the manner described in Article 19 below.
Art. 17. Signatory Authority. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two
Directors or by the joint or single signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Board
of Directors in accordance with article 18.
Art. 18. Delegation of Power. The Board of Directors of the Company may delegate under its responsibility its powers
to conduct the daily management and affairs of the Company (including the right to act as authorised signatory for the
Company) and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical
persons or corporate entities, which need not be members of the board, who shall have the powers determined by the
Board of Directors and who may, if the Board of Directors so authorises, sub-delegate their powers.
The Board of Directors may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
The Board of Directors may also consult any advisor; in particular, the Board of Directors may appoint MPC MÜNCH-
MEYER PETERSEN CAPITAL AG as an investment advisor (the «Investment Advisor»). If, at any time, no investment
advisory agreement with the Founding Shareholder or its affiliates is in force, the Founding Shareholder may require the
89526
Board of Directors to convene a general meeting of Shareholders with the purpose to change the name of the Company
into a name without the abbreviation MPC.
Any decision to enter or terminate a long term investment advisory agreement as well as any decision on the assess-
ment of a potential underperformance of a long term investment advisor is subject to the approval of the general meeting
of Shareholders with a 75% majority. On such termination decision, the Founding Shareholder and its affiliates shall not
have any voting rights.
Unless for termination with cause, underperformance of the Company being no such cause, the Board of Directors
may only terminate such long term investment advisory agreements in accordance with the following procedure: Every
three years, the general meeting of Shareholders will assess the performance of the investment advisors. The first as-
sessment will be carried out in the annual meeting following the third financial year of the Company after the initial public
offering on a recognised and liquid stock market other than the Luxembourg EuroMTF. The decision will be taken with
a 75% majority of the Shareholders (excluding the Founding Shareholder and its affiliates). If the Shareholders are dissat-
isfied with the performance, Board of Directors will be asked to present a proposal, that is to be developed based on
the advice of the investment advisors, to an extraordinary general meeting of Shareholders within a month after the
annual meeting time to improve the situation. The proposal will provide for target figures that have to be fulfilled within
11 months. The extraordinary general meeting of Shareholders will vote on the proposal. If the Shareholders agree with
the proposal, the Investment Advisors have 11 months following the extraordinary general meeting of Shareholders to
support the Board of Directors to improve the situation. If the Shareholders do not approve the proposal or if the
Shareholders decide on an additional extraordinary meeting after 11 months that the situation has not improved in
accordance with the proposal, the investment advisors will be required to support the Board of Directors in the immediate
disposal of all investments that have been purchased on the basis of their involvement as investment advisors. The Share-
holders shall decide on the period in which such disposal is to be executed. When the disposal is concluded, the investment
advisory agreements shall be terminated forthwith.
Art. 19. Investment Committee. The Company shall put in place an investment committee (the «Investment Com-
mittee»), which shall provide the Company with recommendations and advice with respect to the Company's investment
objective and strategy as described in the Memorandum. The Investment Committee will review the investment recom-
mendations prepared by the Investment Advisor and other investment advisors which have been forwarded to the
Investment Committee by the Board of Directors. If the Investment Commitee agrees with the relevant recommenda-
tions, it will approve the recommendations vis-à-vis the Board of Directors. However, the investment committee is not
authorized to take any investment decisions. The Board of Directors remains free to approve or to reject investment
recommendations by the Investment Committee at its discretion; it is only authorized to approve and execute such
recommendations which have been previously approved by the Investment Committee.
The Investment Committee shall be composed of no less than three members. Two members of the Investment
Committee may be nominated by the Founding Shareholder. A Shareholder Representative shall be the third member of
the Investment Committee. The initial Shareholder Representative will be named in the Memorandum. The Shareholder
Representative can be revoked and/or replaced by the general meeting of Shareholders at any time with a 75 % majority.
No person can be appointed as Shareholder Representative, who (i) is a board member, employee and other represen-
tative of, or (ii) holds a significant interest in a competitor of the Founding Shareholder (i.e. an investor or affiliate of an
investor having operational shipping interests. A Shareholder Representative who has been elected by the general meeting
of Shareholders can only be revoked and/or replaced by the general meeting of Shareholders with 75% majority vote.
The Founding Shareholder shall have no voting right on decisions according to this paragraph.
Additional Investment Committee members may be added, subject to unanimous consent of all existing Investment
Committee members. The rights of such additional members (e.g. a possible veto right) will be determined by the existing
Investment Committee members at the time of appointment of a new member.
Investment Committee members do not have any liability towards the Company or the Shareholders for investment
decisions. Whilst the Shareholder Representative will act in good faith in what he believes to be the best interests of the
Company and the shareholders as a whole, the Shareholder Representative shall not have any liability whatsoever to any
investor in the Company. The Shareholder Representative is entitled to be indemnified out of the assets of the Company.
It should be noted that the Shareholder Representative is not required to, and should be assumed not to, have any
specialised knowledge of the shipping sector. Furthermore the Shareholder Representative will not be required to use
information made available to him through sources other than the Company or the Investment Advisor for benefit of
Company.
Resolutions are taken by a majority vote of the members of the Investment Committee. The Shareholder Represen-
tative, if any, has the right to veto any decision to provide the Board of Directors with a recommendation relating to (i)
a purchase of minority stakes, (ii) any investment in a Special Situation, (iii) sizeable transactions (i.e. transactions repre-
senting 15% or more of the aggregate Share subscription commitments), (iv) any transactions with another account
managed by the Directors or an affiliate of such other account, the Founding Shareholder and/or its affiliated companies,
and/or the members of the Investment Committee, as well as (v) investments having as a result that 40% or more of the
aggregate Share subscription commitments are held in a single segment (i.e. Container Vessels, Dry Bulk Vessels etc.).
Each Investment Committee member may invite one observer to the Investment Committee meetings.
89527
Art. 20. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors, members of the Investment Committee
or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or
firm.
Any Director, member of the Investment Committee or officer of the Company who serves as a director, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any
matters with respect to such contract or other business.
In the event that, in any transaction of the Company, any Director, member of the Investment Committee or officer
of the Company may have an interest opposite to the interests of the Company, such Director, member of the Investment
Committee or officer shall make known to the Board of Directors such opposite interest and shall not consider or vote
on any such transaction, and such transaction and such Director's, member of the Investment Committee's or officer's
interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of Shareholders.
The term «opposite interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without
interest in any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be
determined by the Board of Directors in its discretion.
Art. 21. Indemnification of Directors. The Company shall indemnify any Director, member of the Investment Com-
mittee or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection
with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or
member of the Investment Committee or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the
Company is a Shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct;
in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 22. Depositary. The Company will enter into a depositary agreement with a Luxembourg bank (the «Depositary»)
which meets the requirements of the Law of 13 February 2007.
In compliance with usual bank practices, the Depositary may under its responsibility and in good faith, entrust part or
all of the assets that are placed under its custody to other banking institutions or financial intermediaries.
The Company's securities, cash and other permitted assets will be held in custody by or in the name of the Depositary,
which will fulfil the obligations and duties provided for by the Law of 13 February 2007.
If the Depositary desires to withdraw, the Company shall use its best efforts to find a successor Depositary within
two months of the effectiveness of such withdrawal. Until the Depositary is replaced, which must happen within such
period of two months, the Depositary shall take all necessary steps for the good preservation of the interests of the
Shareholders of the Company.
The Company may terminate the appointment of the Depositary but shall not remove the Depositary unless and until
a successor Depositary shall have been appointed to act in the place thereof.
The duties of the Depositary shall respectively cease:
a) in the case of voluntary withdrawal of the Depositary or of its removal by the Company; until it is replaced, which
must happen within two months, the Depositary shall take all necessary steps for the good preservation of the interests
of the Shareholders of the Company;
b) where the Depositary or the Company have been declared bankrupt, have entered into a composition with cred-
itors, have obtained a suspension of payment, have been put under court controlled management or have been the subject
of a similar proceedings or have been put into liquidation;
c) where the Luxembourg Supervisory Authority withdraws its authorization of the Company or the Depositary.
Art. 23. Corporate Agent. The Company will appoint a corporate agent (the «Corporate Agent») responsible for all
administrative duties required by Luxembourg law, and in particular for the book-keeping and calculation of the Net Asset
Value of the Shares, for all and any secretarial and administrative tasks, for handling the processing of subscription for -
and redemption of - Shares, and accepting transfers of funds, for the safe keeping of the register of Shareholders and the
corporate documents of the Company, providing the administrative support for the meetings of the Board of Directors
and the meetings of the Investment Committee, providing and supervising the mailing of statements, reports, notices and
other documents to the Shareholders. Furthermore, the Corporate Agent will be responsible for controlling that Share-
holders qualify as Eligible Investors within the meaning of article 2 of the Law of 13th February 2007.
Art. 24. General Meeting of Shareholders. The general meeting of Shareholders shall represent all the Shareholders
of the Company. Its resolutions shall be binding upon all Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers
to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
General meetings of Shareholders shall be convened by the Board of Directors.
It may also be called upon the request of Shareholders representing at least one tenth of the share capital.
89528
The annual general meeting shall be held on the third Wednesday of the month April at 12.00h at the registered office
or at a place specified in the notice of meeting. If such day is not a Business Day, the annual general meeting shall be held
on the next following Business Day.
Other meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of
meeting.
General meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda and sent by registered
letter at least ten (10) days prior to the meeting to each Shareholder at the Shareholder's address recorded in the register
of registered shares. The giving of such notice to registered Shareholders does not need to be justified to the meeting.
The agenda shall be prepared by the Board of Directors except in the instance where the meeting is called on the written
demand of the Shareholders in which instance the Board of Directors may prepare a supplementary agenda.
If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, general meetings may take place without notice of meeting.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders in order to attend
any meeting of Shareholders.
The business transacted at any meeting of the Shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
Each share of whatever Class is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and the present articles of
incorporation.
A Shareholder may act at any general meeting by giving a written proxy to another person, who need not be a
Shareholder and who may be a Director of the Company.
Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote
of the Shareholders present or represented.
Any resolution of a meeting of Shareholders to the effect of amending the present articles of incorporation must be
passed with (i) a presence quorum of fifty (50) per cent of the Share capital and if such a quorum is not obtained at a first
meeting there shall be no quorum requirement at the adjourned meeting and (ii) the approval of a majority of at least
two-thirds (2/3) of the Shareholders present or represented at any meeting.
Art. 25. Fiscal Year. The Company's fiscal year commences on the first of January of each year and ends on the thirty-
first of December of the same year.
Art. 26. Annual Report. The Company shall publish one annual report within a period of six (6) months as of the end
of the fiscal year concerned.
Art. 27. Distributions. The rights to dividends or distributions attached to any Class of Shares are determined by the
Board of Directors and further described in the Memorandum.
Art. 28. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of
10 August 1915 on commercial companies and the Law of 13 February 2007 as such laws have been or may be amended
from time to time.
Art. 29. Definitions.
«Articles» The articles of incorporation of the Company.
«Board of Directors» The board of directors of the Company.
«Business Day» A day on which banks are generally open for business in Luxembourg.
«Class» Each class of Shares of the Company.
«Company» MPC GLOBAL MARITIME OPPORTUNITIES S.A.-, which is organised as a société d'investissement à
capital variable - fonds d'investissement specialise, SICAV-FIS and registered on the official list of specialised investment
funds in Luxembourg.
«Directors» The directors of the Company.
«Eligible Investors» Directors, Institutional Investors, Professional Investors or Well-informed Investors within the
meaning of article 2 of the Law of 13 February 2007.
«Founding Shareholder» MPC MÜNCHMEYER PETERSEN CAPITAL AG.
«Institutional Investors» Investors who qualify as institutional investors according to the Luxembourg laws and regu-
lations.
«Investment Structure» Investment vehicles of any kind and nature, having the legal personality or not, whether listed
or unlisted, being regulated or not and based in any jurisdiction in which the Company intends to invest in order to pursue
its investment objective and strategy as described in the Memorandum.
«Memorandum» The placement memorandum of the Company as amended from time to time.
«Net Asset Value» The net asset value per Share of the relevant Class as determined pursuant to Article 12 and the
section «Net Asset Value» of the Memorandum.
«Law of 13 February 2007» Law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds («SIF»).
89529
«Professional Investors» Investors who qualify as professional investors under Annex II of Directive 2004/39/EC on
markets in financial instruments as amended.
«Reference Currency» The currency of calculation of the Net Asset Value as determined under the section «Net
Asset Value».
«Shareholder» A registered holder of Shares.
«Shareholder Representative» A member of the Investment Committee as further described in article 19.
«Shares» Shares issued by the Company.
«Special Situation» A situation, in which the Company may also invest either directly or via Investment Structures into
assets and companies related to the shipping industry which may include, but are not limited to, terminals, containers,
ports infrastructure & logistics.
«Well-informed Investors» Investors who (i) adhere in writing to the status of well-informed investors and (ii) either
invest a minimum of € 125,000.- in the Company or benefit from an assessment made by a credit institution within the
meaning of Directive 2006/48/EC, by an investment firm within the meaning of Directive 2004/39/EC or by a management
company within the meaning of Directive 2001/107/CE stating that their expertise, experience and knowledge in ade-
quately appraising an investment in the Company.
<i>Subscription and paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
Name of Subscriber
Number of
subscribed
shares
MPC MÜNCHMEYER PETERSEN CAPITAL AG, prequalified . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . one Share
Upon incorporation, the Share was fully paid-up up, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first fiscal year shall start as from the incorporation of the Company and shall end on 31 December 2007.
The first general annual meeting of Shareholders shall be held in 2008.
The first annual report of the Company will be dated 31 December 2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately seven thousand euro.
<i>Resolution of the Sole Shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole Shareholders has resolved that:
I. The following are elected as Directors for a term to expire at the close of the annual general meeting of Shareholders
which shall deliberate on the annual accounts of the Company as at 2007.
- Gregory de Ruiter, maritime engineer, professionally residing in Palmaille 67, D-22767 Hamburg, Germany, born on
27 November 1963 in Hengelo Ov, the Netherlands.
- Tobias Müller, banker, professionally residing in Palmaille 67, D-22767 Hamburg, Germany, born on 26 March 1972
in Lüneburg, Germany.
- Bernhard Singer, banker, professionally residing in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg, born on 29 April 1941
in Saarbrücken, Germany.
- Claude Niedner, Lawyer, professionally residing in 14, rue Erasme, L-2010 Luxembourg, born on 15th October 1966
in Karlsruhe, Germany.
II. The registered office of the Company shall be at 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen.
III. The independent auditor for the Company shall be ERNST & YOUNG, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
The term of office of the auditor shall expire at the close of the annual general meeting of Shareholders approving the
accounts as of 2007.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by name, first name, civil status and
residence, said person signed together with the notary the present deed.
Follows the German translation:
Im Jahre zweitausend und sieben, am siebenten August.
Vor dem unterschriebenen Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.
89530
Ist erschienen:
MPC MÜNCHMEYER PETERSEN CAPITAL AG, mit Sitz in Palmaille 67, D-22767 Hamburg,
hier vertreten durch Frau Britta Weickgenannt, Rechtsanwältin, beruflich ansässig in Luxemburg gemäß privatschrift-
licher Vollmacht, ausgestellt in Hamburg, am 1. August 2007.
Die erteilten Vollmachten, ordnungsgemäß durch die Erschienene und den Notar unterzeichnet, bleiben diesem Do-
kument beigefügt, um mit demselben bei den für Registrierungen zuständigen Behörden eingereicht zu werden.
Die Erschienene hat in Ausführung ihrer Vertretungsbefugnis den Notar gebeten, die Satzung einer Aktiengesellschaft
(société anonyme, S.A.) in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital als spezialisierter Investmentfonds
(Société d'investissement à capital variable - Fonds d'Investissement Spécialisé, SICAV-FIS) wie folgt zu beurkunden:
Sofern der Zusammenhang dies nicht anders vorgibt, haben die Begriffe in dieser Satzung dieselbe Bedeutung wie im
Verkaufsprospekt (der «Verkaufsprospekt»).
Art. 1. Name. Zwischen dem Unterzeichneten und allen, welche Inhaber von nachfolgend ausgegebenen Aktien («Ak-
tien») werden, besteht eine Aktiengesellschaft (Société anonyme) in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem
Kapital als spezialisierter Investmentfonds (Société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé,
SICAV-FIS) unter dem Namen MPC GLOBAL MARITIME OPPORTUNITIES S.A. (die «Gesellschaft»).
Die Gesellschaft soll dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (SIF) (das «Gesetz vom
13. Februar 2007») unterliegen.
Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg-Strassen, Großherzogtum Luxemburg.
Zweigstellen, Tochtergesellschaften oder andere Büros können durch Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft
(«Verwaltungsrat») innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg errichtet werden. Innerhalb desselben
Verwaltungsbezirks kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden.
Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereig-
nisse stattgefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an
ihrem Sitz oder die Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Sitz zeitweilig und bis
zur völligen Normalisierung der Lage in das Ausland verlagert werden. Solche provisorischen Maßnahmen werden auf die
Staatszugehörigkeit der Gesellschaft keinen Einfluss haben; die Gesellschaft wird eine Luxemburger Gesellschaft bleiben.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Im Falle, dass keine öffentliche Erstemission auf anderen anerkannten und liquiden Aktienmärkten als dem Luxemburger
EuroMTF erreicht wird, welche zu einem Streubesitz von mindestens 25 % des Eigenkapitals der Gesellschaft beim letzten
Zeichnungsschluss führt, und alle Aktien zum Handel innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten Zeichnungsschluss
zugelassen sind, (so wie vom Verwaltungsrat bestimmt und im Verkaufsprospekt beschrieben), wird der Verwaltungsrat
sicherstellen, dass alle Aktien innerhalb der nächsten drei Jahre verkauft werden (plus Erweiterungsoptionen) und das
Vermögen an die Aktionäre ausgezahlt wird. Die Anforderung, die Vermögenswerte zu verkaufen, kann mit einer Mehrheit
von 75% der Generalversammlung der Aktionäre für zwei Perioden von jeweils zwei Jahren aufgeschoben werden.
Der Verwaltungsrat wird ferner sicherstellen, dass in bestimmten Fällen von «underperformance» der Gesellschaft
alle Vermögenswerte verkauft und das Vermögen an die Aktionäre verteilt wird, so wie es im Verkaufsprospekt detailliert
beschrieben ist.
Art. 4. Gesellschaftszweck. Die Gesellschaft beabsichtigt opportunistische Investitionen in der Schiffsindustrie zu ver-
folgen. Die Gesellschaft wird auf Basis eines breit gestreuten Portfolios von Schiffen und/oder Gesellschaften, die Schiffe
besitzen, betreiben oder entwickeln in hohem Maße ertragsorientiert ausgerichtet sein. Die Gesellschaft wird in alle
Sektoren, Segmente und Typen von Schiffen anlegen, sowie verschiedene Beschäftigungsstrategien verfolgen. Die Gesell-
schaft wird hauptsächlich Investitionen in Gesellschaftsanteile oder vergleichbare eigenkapitalorientierte Beteiligungsfor-
men verfolgen, die eine Kontrollausübung auf die Investments erlauben. Untergeordnet wird auch in Schuldverschrei-
bungen investiert. Die von der Gesellschaft erlangten Anlagen und Unternehmen können jede Art unternehmerischer
Tätigkeit auf dem Schifffahrtsmarkt ausüben. Die Gesellschaft wird die Optimierung jeder Anlage in operativer und fi-
nanzieller Hinsicht anstreben.
Die Gesellschaft wird vorwiegend in Vermögenswerte anlegen, die mit Handelsschiffen verknüpft sind, einschließlich
aber nicht ausschließlich in Schiffe, Gesellschaften, die Schiffe besitzen und betreiben, Bauverträge und andere Vertrags-
rechte an Schiffen, Chartererträge für Schiffe und Frachtraten, nicht aber in Schiffsbauwerften. In «Sondersituationen»
wird die Gesellschaft auch in Vermögenswerte und Gesellschaften anlegen, die mit der Schifffahrtsindustrie verknüpft sind
wie z.B. Terminals, Container, Hafeninfrastruktur und Logistik. Für letzteres hat der Aktionärsvertreter ein Vetorecht
(wie in Artikel 19 beschrieben). Diese Vermögenswerte können direkt oder durch Anlagestrukturen erworben und
gehalten werden.
Anlagestrukturen besitzen, betreiben, entwickeln, verwalten und unterstützen mit Schiffen verbundene Vermögens-
werte in Form von UnternehmensanteilenAktientransaktionen - börsenorientiert oder nicht börsenorientiert -, durch
Übernahmen von börsennotierten Gesellschaften, Erwerb von nicht börsenorientierten Privatunternehmen, sowie durch
Joint Ventures und Partnerschaften. Anlagen können auf der Basis von Einzelvermögenswerten sowie auf der Basis von
Portfolios aus Vermögenswerten durchgeführt werden. Im Rahmen von Sicherungsgeschäften werden die Gesellschaft
89531
und Anlagestrukturen bis zu 10 % der gesamten Zeichnungsverpflichtungen in mit Schifffahrtsvermögenswerten verbun-
dene Derivate (forward freight agreements, «FFA») und nicht verbundene Derivate (Zins- & Währungsabsicherung)
anlegen.
Unbeschadet des Voranstehenden kann die Gesellschaft in nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 für spezialisierte
Investmentfonds vorgesehene Vermögenswerte anlegen.
Überdies kann die Gesellschaft solche Maßnahmen ergreifen und solche Geschäfte durchführen, die sie für die Erfüllung
und Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks für angebracht erachtet und die im Sinne des Gesetzes vom 13. Februar 2007
in seiner weitesten Auslegungsmöglichkeit zulässig sind.
Art. 5. Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen. Der Verwaltungsrat wird die Anlagepolitik und Anlagestrategien der
Gesellschaft sowie die Verwaltung und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft unter Berücksichtigung der anwendbaren Ge-
setze und Verordnungen bestimmen.
Art. 6. Gesellschaftsvermögen. (a) Das Gesellschaftsvermögen wird durch Aktien ohne Nennwert repräsentiert und
entspricht zu jeder Zeit dem Nettoinventarwert aller Aktien der Gesellschaft gemäß Artikel 12 dieser Satzung. Das
Mindestgesellschaftsvermögen entspricht einer Million zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000,-) und muss in-
nerhalb von zwölf Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem die Gesellschaft als spezialisierter Investmentfonds nach
Luxemburger Recht zugelassen wurde, erreicht werden.
Der Verwaltungsrat kann im Einklang mit den Bestimmungen und Anforderungen des Gesetzes vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften Aktienklassen ausgeben.
(b) Die Gesellschaft wurde gegründet mit einem Gründungskapital in Höhe von zweihundertundfünfzigtausend US
Dollars (USD 250.000,-). Dieses teilt sich auf in eine Aktie ohne Nennwert. Das Gründungskapital wurde vollständig
eingezahlt.
c) Der Verwaltungsrat ist berechtigt, in Übereinstimmung mit Artikel 9 dieser Satzung und den Vorschriften des
Verkaufsprospekts, eine unbegrenzte Anzahl von Aktien auszugeben ohne den bestehenden Aktionären ein vorrangiges
Zeichnungsrecht für Aktien, die bis zum 31. Oktober 2007 ausgegeben werden, einzuräumen. Für nach diesem Zeitpunkt
ausgegebene Aktien erhalten die bestehenden Aktionäre ein vorrangiges Zeichnungsrecht.
d) Zusätzlich kann die Gesellschaft im Einklang mit dem vom Verwaltungsrat im Verkaufsprospekt bestimmten Ver-
fahren Optionsscheine auf Aktien ausgeben.
Art. 7. Aktien. (a) Die Aktien sind ausschließlich Sachkundigen Anlegern im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes vom 13.
Februar 2004 vorbehalten.
(b) Das Gesellschaftsvermögen wird ausschließlich durch Namensaktien repräsentiert.
Alle ausgegebenen Aktien der Gesellschaft werden in das Aktionärsregister («Register») eingetragen, welches bei der
Gesellschaft oder unter Verantwortung der Gesellschaft bei einer hierfür von der Gesellschaft bezeichneten Personen
geführt wird, und dieses Register wird die Namen jedes Aktionärs, seinen ständigen oder gewählten Wohnsitz oder seinen
Sitz, die Zahl der von ihm gehaltenen Aktien, die auf diese Aktien eingezahlte Summe und Bankverbindungen enthalten.
Solange der Gesellschaft nichts Gegenteiliges bekannt wird, gelten die im Register enthaltenen Informationen als richtig
und zeitaktuell. Insbesondere werden die eingetragene Adresse des Aktionärs für den Versand von Mitteilungen und
Bekanntmachungen und die Bankdaten für Zahlungen verwendet.
Der Eintrag des Namens des Aktionärs in das Aktionärsregister dient als Nachweis der Berechtigung des Aktionärs
an solchen Namensaktien. Aktienzertifikate können nach dem Ermessen des Verwaltungsrates ausgestellt werden.(c) Die
Gesellschaft kann Aktienbruchteile bis zur dritten Dezimalzahl ausgeben und Rechte zu dem dementsprechenden Akti-
enbruchteil übertragen. Aktienbruchteile geben aber kein Stimmrecht, es sei denn, sie repräsentieren eine gesamte Aktie,
in diesem Falle geben sie ein Stimmrecht.
(c) Die Gesellschaft kann Aktienbruchteile bis zur dritten Dezimalzahl ausgeben. Aktienbruchteile berechtigen zur
Teilnahme an den Ausschüttungen der Gesellschaft im Verhältnis zum vertretenen Aktienbruchteil, geben aber kein
Stimmrecht, es sei denn sie vertreten eine gesamte Aktie, in diesem Falle gewähren sie ein Stimmrecht.
(d) Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht bei der Generalversammlung sowie bei unabhängigen Versammlungen der
Aktionäre einer Aktienklasse.
(e) Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Sofern eine oder mehrere Aktien im Eigentum einer
oder mehrerer Personen stehen oder sofern das Eigentum an den Aktien strittig ist, müssen alle Personen, welche eine
Berechtigung an den Aktien behaupten, einen einzigen Vertretungsberechtigten ernennen, welcher gegenüber der Ge-
sellschaft diese Aktien vertritt. Sofern dies nicht erfolgt, werden alle mit einer solchen Aktie/solchen Aktien verbundene
Rechte suspendiert.
Art. 8. Übertragung von Aktien. Die Übertragung von Aktien erfolgt durch Eintragung der Übertragung in dem Register
nachdem das Übertragungsformular an die Gesellschaft, gemeinsam mit den anderen Übertragungspapieren zur Zufrie-
denheit der Gesellschafter an die Gesellschaft ausgehändigt wurde. Falls Aktienzertifikate ausgegeben wurden, müssen
auch diese der Gesellschaft übergeben werden.
Die Übertragung voll eingezahlter Aktien ist frei, vorausgesetzt, dass (i) der Erwerber als Sachkundiger Anleger qua-
lifiziert ist und (ii) dass der Abtretende allen eventuellen Verbindlichkeiten der Gesellschaft unterworfen bleibt, darunter
89532
insbesondere der Verpflichtung, weitere Aktien zu zeichnen und einzuzahlen, im Einklang mit der vom Abtretenden
gegenüber der Gesellschaft eingegangenen Zeichnungsverpflichtung, es sei denn der Erwerber kann zur Zufriedenheit des
Verwaltungsrats nachweisen, dass ihm genügend Geldmittel zur Verfügung stehen, um die unbezahlten Aktienzeichnungs-
verpflichtungen zu befriedigen. Unbeschadet des Voranstehenden kann ein Aktionär dennoch den unbezahlten Anteil
seiner Zeichnungsverpflichtung an einen bestehenden Aktionär oder einen Dritten übertragen, vorausgesetzt dass der
Verwaltungsrat dem zuvor zustimmt.
Die Übertragung von Aktien an einen nicht sachkundigen Anleger im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes vom 13. Februar
2007 ist unwirksam.
Art. 9. Ausgabe von Aktien. Bestehende wie auch potentielle Aktionäre können Aktien nur innerhalb bestimmter
Zeichnungsperioden zeichnen. Diese werden durch den Verwaltungsrat - wie im Verkaufsprospekt dargestellt - festgelegt.
Der Ausgabepreis der Aktien ist bei Ausgabe der Aktien gänzlich oder teilweise zu einem Zeichnungsschluss oder
einem anderen Datum auf die Weise zu entrichten, wie es der Verwaltungsrat bestimmt und im Verkaufsprospekt genannt
und ausführlich beschrieben hat. Die Zahlungsmodalitäten bezüglich des Ausgabepreises der Aktien werden vom Ver-
waltungsrat bestimmt und im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben.
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, zusätzliche Zeichnungsbedingungen zu bestimmen, wie beispielsweise das Erreichen
von Mindestzeichnungsbeträgen innerhalb der Zeichnungsperiode(n), die Zahlung von Verzugszinsen oder das Bestehen
von Eigentumsbeschränkungen. Diese Bedingungen werden im Verkaufsprospekt genannt und ausführlich beschrieben.
Aktionäre haben kein Vorrecht für die Zeichnung neuer Aktien die bis zum 31. Oktober 2007 ausgegeben werden.
Danach haben Aktionäre ein Vorrecht, neue Aktien zu zeichnen.
Der Verwaltungsrat kann jedem Mitglied des Verwaltungsrates oder Generalbevollmächtigten sowie jedem anderen
ordnungsgemäß hierzu Ermächtigten die Aufgabe übertragen, Zeichnungsanträge und Zahlungen auf den Ausgabepreis
neu auszugebender Aktien entgegenzunehmen, sowie die neuen Aktien an die entsprechenden Zeichner auszuliefern.
Die Gesellschaft kann im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts, welche insbesondere ein Bewer-
tungsgutachten durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zwingend vorsehen, Aktien gegen Lieferung von Wertpa-
pieren ausgeben, sofern eine solche Lieferung von Wertpapieren den Anlagezielen und der Anlagestrategie der
Gesellschaft entspricht. Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktien gegen Lieferung von Wertpa-
pieren sind von den betreffenden Aktionären zu tragen.
Art. 10. Verzug. Jeder Investor, der hinsichtlich einer Zahlung seiner Aktienzeichnungsverpflichtung in Verzug gerät
(«säumiger Investor»), unterliegt gewissen Konsequenzen, die nach dem Ermessen des Verwaltungsrats die folgenden
umfassen können:
- Der säumige Investor haftet gegenüber der Gesellschaft für den Anteil des ungedeckten Teils zu einer 1-Monats US-
Dollar-LIBOR Rate plus 4 Prozentpunkte pro Jahr, berechnet für einen Zeitraum beginnend mit dem Fälligkeitsdatum des
geforderten gezeichneten Betrags bis zur wirksamen Bezahlung dieses Betrages (inklusive der angefallenen Zinsen) und
er haftet auch für zusätzliche Schäden (zum Beispiel wenn die Gesellschaft aufgrund des Verzugs des Investors selbst mit
Zahlungen, die im Zusammenhang mit ihren Anlagen stehen, in Verzug gerät; die Haftung des säumigen Investors für
zusätzliche Schäden ist auf die Höhe seiner Zeichnungsverpflichtung begrenzt).
- Die von dem säumigen Investor gehaltenen Aktien können zwangsweise von der Gesellschaft zurückgenommen
werden. Bei der maßgeblichen Rücknahmeentscheidung hat der Verwaltungsrat unter Berücksichtigung aller relevanten
Umstände vernünftig zu handeln. Ansonsten können von dem säumigen Investor gehaltene Aktien nicht zwangsweise
zurückgenommen werden, es sei denn der säumige Investor ist nach Ablauf einer Frist von 10 Arbeitstagen nach dem
ursprünglichen Zahlungsdatum noch in Verzug. Der säumige Investor erhält insgesamt 50% der von ihm geleisteten Zahl-
ungen auf seine Aktien, gemindert um gegebenenfalls bereits erfolgte Ausschüttungen sowie eventuelle zusätzliche
Schadensersatzansprüche (z.B. wenn die Gesellschaft aufgrund des Verzug des Investors selbst mit Zahlungen, die in
Zusammenhang mit ihren Anlagen stehen, in Verzug gerät), maximal jedoch den Nettoinventarwert seiner Aktien. Diese
Abfindung ist zahlbar in Raten. Die einzelnen Raten sind jeweils zur Zahlung fällig zu den Zeitpunkten, zu denen die
Gesellschaft Ausschüttungen an die übrigen Aktionäre vornimmt, jedoch nicht, bevor nicht sicher feststeht, dass keine
derartigen zusätzlichen Schadensersatzansprüche gezahlt werden müssen. Jede einzelne Rate beläuft sich höchstens auf
denjenigen Betrag, den der säumige Investor erhalten hätte, wenn er nicht ausgeschieden wäre. Die einzelnen Raten sind
unverzinslich. Die eingezogenen Aktien können anderen Aktionären und/oder neuen Investoren angeboten und zum
bestmöglichen Preis verkauft werden.
- Der säumige Investor verzichtet auf den nach dem Verzug realisierten Gewinn, welcher auf einer pro rata Basis auf
die übrigen Aktionäre verteilt wird;
- Der säumige Investor verliert sein Stimmrecht bei der Generalversammlung der Aktionäre.
Art. 11. Rücknahme und Rückkauf von Aktien. Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft des geschlossenen Typs;
der Verwaltungsrat ist dementsprechend berechtigt, ein einseitiges Verlangen des Aktionärs auf Rücknahme oder Um-
tausch von Aktien zurückzuweisen.
Unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Mehrheit der Aktionäre können Aktien auf Vorschlag des Verwaltungsrats
auf einer pro rata Basis von allen bestehenden Aktionären zu den im Verkaufsprospekt angegebenen Bedingungen zu-
rückgenommen werden.
89533
Zusätzlich kann der Verwaltungsrat eine zwangsweise Rücknahme der Aktien eines Aktionärs beschließen, wenn es
sich bei dem betroffenen Aktionär nicht oder nicht mehr um einen Anleger im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes vom
13. Februar 2007 handelt. Überdies können Aktien zurückgenommen werden, wenn ein Aktionär in Verzug geraten ist.
Derartige zwangsweise Rücknahmen erfolgen nach den Bedingungen des Verkaufsprospekts.
Sofern der Verwaltungsrat dies entsprechend beschließt, soll die Gesellschaft berechtigt sein, den Rücknahmepreis an
jeden Aktionär, der dem zustimmt, unbar auszuzahlen, indem dem Aktionär aus dem Portfolio der Vermögenswerte,
entsprechend dem Wert der zurückzunehmenden Aktien zugeteilt werden. Natur und Art der zu übertragenden Ver-
mögenswerte werden in einem solchen Fall auf einer angemessenen und sachlichen Grundlage und ohne Beeinträchtigung
der Interessen der anderen Aktionäre der Gesellschaft bestimmt und die angewandte Bewertung wird durch einen ge-
sonderten Bericht des Wirtschaftsprüfers bestätigt. Die Kosten einer solchen Übertragung trägt der Zessionar.
Art. 12. Berechnung des Nettoinventarwertes. Der Nettoinventarwert der Aktien der Gesellschaft wird von der
Zentralverwaltungsstelle für jede Aktienklasse unter der Verantwortung des Verwaltungsrates an jedem Bewertungstag,
wie definiert in dem Verkaufsprospekt in der Referenzwährung der Gesellschaft (wie im Verkaufsprospekt bestimmt)
ermittelt.
Bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts pro Aktie werden Erträge und Ausgaben als täglich anfallend behandelt.
Die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft soll nach allgemein anerkannten Grund-
sätzen im Einklang mit Artikel 28 (4) des Gesetzes vom 13. Februar 2007 erfolgen.
Die Bewertung erfolgt sowohl nach den Maßgaben der INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY and VENTURE CAPITAL
VALUATION GUIDELINES als auch unter Berücksichtigung von Methoden zur Verkehrswertermittlung von Hochsee-
schiffen. Die Bewertung ist ferner Gegenstand der Jahresabschlussprüfung. Die Bewertungsmethodik wurde vor Gründung
der Gesellschaft mit einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unter Einbeziehung deren Spezialisten für die
Bewertung von Unternehmen und Hochseeschiffen abgestimmt.
Investitionen der Gesellschaft, die überwiegend den Charakter eines eigenständigen Unternehmens haben werden
entweder durch das Discounted Cashflow Verfahren (DCF Verfahren) oder aber durch anerkannte Bewertungsmultipli-
katoren bewertet.
Bei Investitionen der Gesellschaft, die überwiegend den Charakter einer Sachinvestition (z.B. Schiffsanlage) haben, wird
in einem ersten Schritt der Zeitwert der einzelnen Vermögenswerte ermittelt. Dieser errechnet sich aus dem Barwert
der voraussichtlichen zukünftigen Zahlungsüberschüsse zum jeweiligen Bewertungsstichtag unter Anwendung eines den
jeweiligen Vermögenswerten angemessenen Diskontierungszinssatzes. Die übrigen Vermögenswerte des Umlaufvermö-
gens (Vorräte, Forderungen, Liquide Mittel) werden mit Ihrem Buchwert angesetzt. Im zweiten Schritt wird von den
Vermögenswerten der Zeitwert der Verbindlichkeiten abgezogen, um das Nettofondsvermögen zu ermitteln.
Zur Ermittlung des Zeitwertes der noch im Bau befindlichen Schiffsanlagen werden die fortgeführten Anschaffungs-
und Herstellungskosten herangezogen. Die Bewertung der Schiffsanlagen mit dem DCF-Verfahren erfolgt ab dem
Zeitpunkt, an dem eine Grundlage für die Ermittlung der zukünftigen Cash Flows aus der Vercharterung gegeben ist.
Dieser Zeitpunkt entspricht gewöhnlich dem Zeitpunkt des Abschlusses des Chartervertrags.
Die auf Grundlage des DCF Verfahrens ermittelten Wertansätze der Schiffe werden laufend mit den am Markt be-
obachtbaren Verkehrswerten von Schiffen auf charterfreier Basis verprobt. Dabei sind die Werte der Schiffe von den
Werteinflüssen ggf. günstiger oder ungünstiger langfristiger Charterverträge getrennt zu untersuchen. Die DCF Methode
soll jedenfalls vorherrschen.
Darüber hinaus können selektiv externe Sachverständige mit einer gutachterlichen Bewertung einzelner Vermögens-
gegenstände der Gesellschaft beauftragt werden.
Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Maßgabe der vorstehenden Regeln als dauerhaft
undurchführbar oder ungenau, ist der Verwaltungsrat berechtigt, andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewer-
tungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Gesellschaftsvermögens zu erzielen.
Der Nettoinventarwert jeder Klasse eines jeden Bewertungstages wird den Aktionären am Gesellschaftssitz in einer
auf den relevanten Bewertungstag folgenden Zeitspanne, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, mitgeteilt.
Art. 13. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes. Der Verwaltungsrat kann für die Gesellschaft zeitweilig
die Berechnung des Nettoinventarwertes aussetzen,
(a) in Notfällen, wenn nach Einschätzung des Verwaltungsrates die Verfügung über Vermögenswerte oder die Bewer-
tung von Vermögenswerten der Gesellschaft nicht vorgenommen werden können;
(b) während eines Zusammenbruchs von Kommunikationswegen, welche normalerweise im Zusammenhang mit der
Bestimmung des Preises oder des Wertes von Vermögenswerten der Gesellschaft oder im Zusammenhang mit der Kurs-
oder Wertbestimmung an einer Börse oder an einem sonstigen Markt im Zusammenhang mit Vermögenswerten der
Gesellschaft Verwendung finden;
c) wenn Einschränkungen des Devisen- oder Kapitalverkehrs die Abwicklung der Geschäfte für Rechnung der Gesell-
schaft verhindern;
(d) sofern aus anderen Gründen die Preise von Vermögensanlagen der Gesellschaft nicht zeitnah und genau festgestellt
werden können;
89534
Jeder Zeichnungsantrag ist unwiderruflich, außer in den Fällen einer Aussetzung der Berechnung des Nettoinventar-
wertes.
Art. 14. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitglie-
dern besteht, welche nicht Aktionär der Gesellschaft sein müssen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Frist von höchstens sechs Jahren gewählt. Der Verwaltungsrat wird
von den Aktionären anlässlich der Generalversammlung gewählt; die Generalversammlung beschließt außerdem die Zahl
der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihrer Amtszeit.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss der Gene-
ralversammlung der Aktionäre abberufen oder ersetzt werden. Der Gründungsaktionär hat das Recht, ein neues
Verwaltungsratsmitglied vorzuschlagen, welches das Abberufene ersetzt.
Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes werden die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates
die fehlende Stelle zeitweilig ausfüllen; die Aktionäre werden bei der nächsten Generalversammlung eine endgültige Ent-
scheidung über die Ernennung treffen.
Art. 15. Verwaltungsratssitzung. Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen. Er
kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der die Protokolle der Verwal-
tungsratssitzungen und Generalversammlungen erstellt und verwahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Ver-
waltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusammen.
Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Generalversammlungen. In seiner Abwe-
senheit können die Aktionäre oder die Mitglieder des Verwaltungsrates ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates oder
im Falle der Generalversammlung eine andere Person mit der Leitung beauftragen.
Der Verwaltungsrat kann leitende Angestellte, einschließlich eines Geschäftsführers und beigeordnete Geschäftsführer
sowie sonstige Angestellte, welche die Gesellschaft für erforderlich hält, für die Ausführung der Geschäftsführung und
Leitung der Gesellschaft ernennen. Diese Ernennungen können jederzeit vom Verwaltungsrat rückgängig gemacht werden.
Die leitenden Angestellten müssen nicht Mitglieder des Verwaltungsrates oder Aktionär der Gesellschaft sein. Vorbe-
haltlich anderweitiger Bestimmungen durch die Satzung haben die leitenden Angestellten die Rechte und Pflichten, welche
ihnen vom Verwaltungsrat übertragen wurden.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens achtundvierzig Stunden vor
dem entsprechenden Datum schriftlich eingeladen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der
Einladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telefax oder E-Mail oder andere,
ähnliche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine eigene Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu
Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich mit schriftlich, durch Telefax oder E-Mail oder ein ähnliches Kommu-
nikationsmittel erteilte Vollmacht durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmit-
glied kann mehrere seiner Kollegen vertreten. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung
im Wege einer telephonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass
sämtliche Teilnehmer an der Sitzung einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen
Teilnahme an dieser Sitzung gleich.
Der Verwaltungsrat kann nur auf ordnungsgemäß - gemäß den Bestimmungen dieser Satzung - einberufenen Verwal-
tungsratssitzungen handeln. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Gesellschaft nicht durch Einzelunterschriften
verpflichten, außer im Falle einer ausdrücklichen entsprechenden Ermächtigung durch einen Verwaltungsratsbeschluss.
Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die
Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder oder eine andere Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, die vom Verwaltungsrat
bestimmt worden ist, anwesend oder vertreten sind.
Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsrats-
sitzung oder zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Kopien und Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweiszwecken in gerichtlichen oder sonstigen Verfahren
erstellt werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern rechtsgültig
zu unterzeichnen.
Beschlüsse werden mit Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung das entscheidende Stimmrecht zu.
Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet sind,
stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich. Die unterzeichneten Beschlüsse können durch Telefax oder E-
Mail oder ähnliche Kommunikationsmittel übermittelt werden.
Art. 16. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs-
und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Generalversammlung vorbe-
halten sind, können durch den Verwaltungsrat wahrgenommen werden.
89535
Bei Anlageentscheidungen berücksichtigt der Verwaltungsrat die Empfehlungen des Anlageausschusses in der in Artikel
19 beschriebenen Art und Weise.
Art. 17. Zeichnungsbefugnis. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinschaftliche Un-
terschrift zweier Mitglieder des Verwaltungsrates oder durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift von
Personen, welche hierzu vom Verwaltungsrat gemäß Artikel 18 ermächtigt wurden, verpflichtet.
Art. 18. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen
Geschäftsführung der Gesellschaft (einschließlich der Berechtigung, als Zeichnungsberechtigter für die Gesellschaft zu
handeln) und seine Befugnisse zur Ausführung von Handlungen im Rahmen der Geschäftspolitik und des Gesellschafts-
zwecks unter Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Erfordernisse im Einklang mit der Luxemburger
Finanzaufsicht CSSF an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen. Diese Personen müssen nicht
Mitglieder des Verwaltungsrates sein und haben die Befugnisse, welche vom Verwaltungsrat bestimmt werden und können
diese Befugnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrates, weiter delegieren.
Der Verwaltungsrat kann auch Einzelvollmachten durch notarielle oder privatschriftliche Urkunde übertragen.
Der Verwaltungsrat kann auch einen Berater konsultieren; insbesondere kann der Verwaltungsrat die MPC MÜNCH-
MEYER PETERSEN CAPITAL AG als Anlageberater (der «Anlageberater») bestellen. Wenn zu irgendeiner Zeit keine
Anlageberatungsvereinbarung mit dem Gründungsaktionär oder seinen verbundenen Unternehmen in Kraft ist, kann der
Gründungsaktionär vom Verwaltungsrat verlangen, eine Generalversammlung der Aktionäre mit dem Ziel einzuberufen,
den Namen der Gesellschaft in einen Namen ohne das Kürzel MPC zu ändern.
Jede Entscheidung, die den Beginn oder die Beendigung eines langfristigen Anlageberatungsvertrages zum Gegenstand
hat sowie jede Entscheidung über die Bewertung einer eventuellen «underperformance» eines langfristigen Anlagebera-
ters, unterliegt der Genehmigung der Generalversammlung mit einer Mehrheit von 75 %. In Bezug auf diese Beendi-
gungsentscheidung haben der Gründungsaktionär und dessen verbundene Unternehmen kein Stimmrecht.
Mit Ausnahme einer Kündigung aus wichtigem Grund, wobei eine «underperformance» keinen wichtigen Grund dar-
stellt, kann der Verwaltungsrat diese Anlageberatungsverträge nur in Einklang mit dem folgenden Verfahren aufheben:
Alle drei Jahre bewertet die Generalversammlung der Aktionäre die Performance der Anlageberater. Die erste Bewertung
findet bei der ersten jährlichen Generalversammlung statt, die auf das dritte Geschäftsjahr der Gesellschaft nach der
öffentlichen Erstemission auf einem anderen anerkannten und liquiden Aktienmärkten als dem Luxemburger EuroMTF
folgt. Die Entscheidung wird mit einer Mehrheit von 75 % der Aktionäre (mit Ausnahme des Gründungsaktionärs und
dessen verbundenen Unternehmen) getroffen. Sind die Aktionäre mit der Ausführung unzufrieden, wird der Verwal-
tungsrat gebeten, innerhalb eines Monats nach der Jahresgeneralversammlung einen Vorschlag zur Verbesserung der
Situation auf einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zu unterbreiten, welcher mit Beratung durch
die Anlageberater zu entwickeln ist. Der Vorschlag wird Sollzahlen berücksichtigen, die innerhalb von 11 Monaten zu
erfüllen sind. Die außerordentliche Generalversammlung wird über den Vorschlag abstimmen. Wenn die Aktionäre mit
dem Vorschlag einverstanden sind, haben die Anlageberater im Anschluß an die außerordentliche Generalversammlung
11 Monate Zeit, den Verwaltungsrat zu unterstützen, die Situation zu verbessern. Wenn die Aktionäre den Vorschlag
nicht genehmigen oder auf einer weiteren außerordentlichen Generalversammlung nach 11 Monaten feststellen, dass sich
die Situation nicht gemäß dem Vorschlag verbessert hat, wird von den Anlageberatern verlangt werden, den Verwal-
tungsrat dabei zu unterstützen, alle Anlagen, die auf der Basis ihrer Einbindung als Anlageberater erworben wurden,
umgehend zu veräußern. Die Aktionäre entscheiden über den Zeitraum, in dem der Verkauf ausgeführt werden soll.
Wenn der Verkauf abgeschlossen ist, sind die Anlageberatungsverträge mit sofortiger Wirkung beendet.
Art. 19. Anlageausschuss. Die Gesellschaft wird einen Anlageausschuss bestellen (der «Anlageausschuss»), der die
Gesellschaft in besonderem Maße mit Empfehlungen und Rat im Sinne des Anlageziels und der Anlagestrategie der Ge-
sellschaft wie im Verkaufsprospekt beschrieben, unterstützt. Der Anlageausschuss wird die vom Anlageberater und
anderen Anlageberatern vorbereiteten Empfehlungen, die vom Verwaltungsrat an den Anlegeausschuss gesandt wurden,
überprüfen. Wenn der Anlageausschuss mit den entsprechenden Empfehlungen einverstanden ist, wird er diese gegenüber
dem Verwaltungsrat genehmigen. Der Anlageausschuss ist jedoch nicht berechtigt, Anlageentscheidungen zu treffen. Es
steht dem Verwaltungsrat frei, Anlageempfehlungen des Anlageausschusses nach freiem Ermessen zu genehmigen oder
zurückzuweisen; er ist nur berechtigt, Empfehlungen zu genehmigen und auszuführen, die zuvor vom Anlageausschuss
genehmigt wurden.
Der Anlageausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Zwei Mitglieder des Anlageausschusses werden vom
Gründungsaktionär ernannt. Ein Aktionärsvertreter wird das dritte Mitglied des Anlageausschusses sein. Der erste Ak-
tionärsvertreter wird im Verkaufsprospekt benannt. Der erste Aktionärsvertreter kann zu jeder Zeit durch die Gene-
ralversammlung mit einer Mehrheit von 75 % abberufen und/oder ersetzt werden. Als Aktionärsvertreter kann nicht
bestellt werden, wer (i) ein Verwaltungsratsmitglied, Angestellter oder anderer Vertreter eines Konkurrenten ist, oder
(ii) ein bedeutendes Interesse an einem Konkurrenten des Gründungsaktionärs hat (zum Beispiel ein Anleger oder an ein
mit einem Anleger verbundenes Unternehmen mit Schiffsgeschäftsinteressen). Ein von der Generalversammlung gewähl-
ter Aktionärsvertreter kann nur durch die Generalversammlung mit einer Stimmenmehrheit von 75 % abberufen und/
oder ersetzt werden. Der Gründungsaktionär hat hinsichtlich der in diesem Absatz benannten Entscheidungen kein
Stimmrecht.
89536
Zusätzliche Mitglieder des Anlageausschusses können mit Einverständnis aller bestehenden Mitglieder des Anlageaus-
schusses hinzugefügt werden. Die Rechte der zusätzlichen Anlageausschussmitglieder (zum Beispiel ein eventuelles
Vetorecht) werden von den bestehenden Anlageausschussmitgliedern zum Zeitpunkt des Hinzufügens des neuen Mitglieds
bestimmt.
Mitglieder des Anlageausschusses haften gegenüber der Gesellschaft oder den Aktionären nicht für Anlageentschei-
dungen (zum Beispiel im Hinblick auf «Due-diligence-Analysen»). Während der Aktionärsvertreter in gutem Glauben und
mit dem Willen handelt, das Beste im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre als Ganzes zu erreichen, haftet er
gegenüber den Anlegern in die Gesellschaft in keiner Weise. Der Aktionärsvertreter ist befugt, aus den Vermögenswerten
der Gesellschaft entschädigt zu werden. Es wird festgehalten, dass von dem Aktionärsvertreter keine besonderen Kennt-
nisse im Schiffsbereich erwartet werden. Überdies wird vom Aktionärsvertreter nicht erwartet, die ihm von anderen als
der Gesellschaft oder der Anlageberater zugänglich gemachten Informationen zu Gunsten der Gesellschaft zu verwenden.
Entscheidungen werden durch eine Mehrheitswahl der Mitglieder des Anlageausschusses getroffen. Der Aktionärs-
vertreter hat gegebenenfalls das Recht gegen eine Entscheidung sein Veto einzulegen, die dem Verwaltungsrat eine
Empfehlung ausspricht im Hinblick auf (i) den Erwerb von Minderheitsbeteiligungen, (ii) Anlagen in einer Sondersituation,
(iii) beträchtliche Transaktionen (zum Beispiel Transaktionen, die 15% oder mehr der Aktienzeichnungsverpflichtungen
entsprechen), (iv) Jede Transaktion auf ein anderes von den Verwaltungsräten, dem Gründungsaktionär und seinen ver-
bundenen Unternehmen und/oder den Mitgliedern des Anlageausschusses verwaltetes Konto oder mit einem solchen
Konto verbundene Unternehmen, sowie (v) Anlagen, in deren Folge 40 % oder mehr der Aktienzeichnungsverpflichtungen
in einem Sektor (zum Beispiel Kontainer- und Trockengutschiffe etc.), gehalten werden.
Jedes Anlageausschussmitglied kann einen Beobachter zu den Anlageausschusstreffen einladen.
Art. 20. Interessenkonflikt. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft
oder Unternehmung werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder mehrere Verwaltungs-
ratsmitglieder oder Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung ein persönliches
Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter sind.
Jedes Verwaltungsratsmitglied und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, der als Verwaltungsratsmitglied, leiten-
der Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder Unternehmung, mit welcher die Gesellschaft
Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit dieser anderen Ge-
sellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen
Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.
Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem
Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird
dieses Verwaltungsratsmitglied oder dieser leitende Angestellte dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetzte persönliche
Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an Beratungen oder Abstimmungen teilneh-
men, und dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieder oder leitenden
Angestellten der nächstfolgenden Generalversammlung berichtet.
«Entgegengesetztes Interesse» entsprechend der vorstehenden Bestimmungen bedeutet nicht eine Verbindung mit
einer Angelegenheit, Stellung oder einem Geschäftsvorfall, welcher eine bestimmte Person, Gesellschaft oder Unterneh-
mung umfasst, wie der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit nach seinem Ermessen bestimmt.
Art. 21. Entschädigung des Verwaltungsrates. Die Gesellschaft wird jedes Mitglied des Verwaltungsrates, des Anlage-
ausschusses, oder jeden leitenden Angestellten ebenso wie dessen Erben, Vollstreckungsbevollmächtigte und Verwalter
von angemessenen Auslagen freihalten, welche ihm im Zusammenhang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmaßnahme
oder einem Verfahren entstanden sind, an welchen er aufgrund seiner Stellung als Verwaltungsratsmitglied oder leitender
Angestellter der Gesellschaft beteiligt ist. Dies gilt auf Antrag der zu entschädigenden Person auch für Klagen, Rechts-
verfolgungsmaßnahmen oder Verfahren, die aufgrund einer Stellung als Mitglied des Verwaltungsrats, des Anlageaus-
schusses oder leitender Angestellter einer anderen Gesellschaft, an welcher die Gesellschaft als Anteilinhaber beteiligt
ist oder bei welcher die Gesellschaft Gläubiger ist, sofern die zu entschädigende Person keine Entschädigung von dieser
anderen Gesellschaft erhält. Vorstehendes gilt nicht in Fällen, in welchen die betroffene Person aufgrund solcher Klagen,
Rechtsverfolgungsmaßnahmen oder Verfahren wegen grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhaltens endgültig verurteilt
wird. Im Falle eines Vergleiches erfolgt eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, welche von
dem Vergleich abgedeckt werden und sofern die Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt bekommt, dass die zu
entschädigende Person keine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung begangen hat. Das vorstehende Recht
auf Entschädigung schließt andere Ansprüche nicht aus.
Art. 22. Depotbank. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer
Luxemburger Bank, die den Anforderungen des Gesetzes vom 13. Februar 2007 entspricht, abschließen.
Die Depotbank kann die bei ihr verwahrten Vermögenswerte der Gesellschaft unter ihrer Verantwortung ganz oder
teilweise anderen Bankinstitutionen oder Finanzintermediären anvertrauen; diese wird die Depotbank nach Treu und
Glauben auswählen.
89537
Die Sicherheiten der Gesellschaft, Bargeld und andere zulässige Vermögenswerte werden in Verwahrung der Depot-
bank gegeben, die ihre Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen wird, wie dies im Gesetz vom 13. Februar
2007 vorgesehen ist.
Sofern die Depotbank sich aus ihrer Stellung zurückziehen möchte, wird der Verwaltungsrat sich nach Kräften bemü-
hen, eine Nachfolgedepotbank innerhalb von zwei Monaten nach Wirksamwerden der Beendigung der Depotbankbe-
stellung zu finden. Bis zur Bestellung einer neuen Depotbank, die innerhalb von zwei Monaten erfolgen muss, wird die
bisherige Depotbank zur Wahrung der Interessen der Aktionäre ihren Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkom-
men.
Der Verwaltungsrat kann die Ernennung der Depotbank zurücknehmen, er kann jedoch die Depotbank nicht entlassen,
solange keine Nachfolgedepotbank bestellt wurde.
Die Aufgaben der Depotbank enden jeweils:
a) im Falle des Ausscheidens der Depotbank auf eigene Veranlassung oder auf Veranlassung der SICAV; bis zu ihrer
Ersetzung, die innerhalb von zwei Monaten erfolgen muss, ist die Verwahrstelle verpflichtet, sämtliche erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um die angemessene Wahrnehmung der Interessen der Aktionäre zu gewährleisten;
b) im Falle der Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der SICAV oder der Depotbank sowie im Falle
der Eröffnung des Vergleichsverfahrens, der Gewährung von Zahlungsaufschub, der Anordnung der Zwangsverwaltung
oder einer vergleichbaren Maßnahme oder der Liquidation der SICAV oder der Verwahrstelle;
c) Wenn die Luxemburger Aufsichtsbehörde der SICAV oder der Depotbank die Zulassung entzieht.
Art. 23. Gesellschaftsagent. Die Gesellschaft wird einen Gesellschaftsagenten (den «Gesellschaftsagenten») bestellen,
der für alle nach Luxemburger Recht erforderlichen administrativen Tätigkeiten zuständig ist, insbesondere für die Buch-
führung und die Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktien, für alle Sekretariats- und administrativen Tätigkeiten,
die Abwicklung des Zeichnungs- und Rücknahmeverfahrens, die Annahme von Geldern, die Aufbewahrung des Aktio-
närsregisters und der Gesellschaftsdokumente, die Bereitstellung der administrativen Mittel für Verwaltungsratssitzungen
und die Sitzungen des Anlageausschusses, die Bereitstellung und Überwachung der Übermittlung von Stellungnahmen,
Berichten, Mitteilungen und anderer Dokumente an die Aktionäre. Der Gesellschaftsagent überprüft zudem, dass Anleger
sachkundig im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 sind.
Art. 24. Generalversammlung. Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft.
Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Ge-
schäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen.
Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren,
zusammentreten.
Die jährliche Generalversammlung soll am dritten Mittwoch des Monats April um 12.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder
einem in der Einladung angegebenen Ort abgehalten. Wenn dieser Tag ein gesetzlicher oder Bankfeiertag in Luxemburg
ist, wird die jährliche Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag abgehalten.
Andere Generalversammlungen können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten werden, wie dies in der
entsprechenden Einladung angegeben wird.
Die Aktionäre treten auf Einladung des Verwaltungsrates, welche die Tagesordnung enthält und wenigstens acht Tage
(8) vor der Generalversammlung an jeden Inhaber von Namensaktien an dessen in dem Aktionärsregister eingetragene
Adresse versandt werden muss, zusammen. Die Mitteilung an die Inhaber von Namensaktien muss auf der Versammlung
nicht nachgewiesen werden. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die
Versammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt, in welchem Falle der Verwaltungsrat eine zusätzliche
Tagesordnung vorbereiten kann.
Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die
Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung ohne Einladung stattfinden.
Der Verwaltungsrat kann sämtliche sonstigen Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an
einer Generalversammlung erfüllt werden müssen.
Auf der Generalversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind
(die Tagesordnung wird sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten) sowie Vorgänge, welche zu solchen
Vorgängen gehören.
Jede Aktie berechtigt unabhängig von der Aktienklasse zu einer Stimme im Einklang mit den Vorschriften des Luxem-
burger Rechts und dieser Satzung.
Aktionäre können ihre Stimme persönlich abgeben oder sich aufgrund einer schriftlichen Vollmacht durch eine andere
Person, welche kein Aktionär sein muss, aber ein Mitglied des Verwaltungsrates sein kann, vertreten lassen.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz oder diese Satzung werden die Beschlüsse auf der Ge-
neralversammlung durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Ein Beschluss der Generalversammlung mit dem Vorhaben die vorliegenden Vorschriften der Satzung zu ändern, er-
fordert (i) die Anwesenheit von fünfzig (50) % des Aktienkapitals; sofern dieses Anwesenheitsquorum bei der ersten
89538
Generalversammlung nicht erreicht wird, gibt es kein Anwesenheitserfordernis bei der vertagten Versammlung; und (ii)
die Genehmigung von mindestens zwei Dritteln (2/3 ) der anwesenden oder vertretenen Aktionäre.
Art. 25. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31.
Dezember desselben Jahres.
Art. 26. Jahresbericht. Die Gesellschaft soll einen Jahresbericht das Ende des Geschäftsjahres betreffend innerhalb
einer sechs (6) Monatsfrist erstellen.
Art. 27. Ausschüttungen. Die Rechte am Gewinnanteil und an den Ausschüttungen, die mit den jeweiligen Aktienklassen
verbunden sind, werden vom Verwaltungsrat bestimmt und im Verkaufsprospekt beschrieben.
Art. 28. Anwendbares Recht. Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und das Gesetz vom 13. Februar 2007 in ihrer jeweils
gültigen Fassung geregelt.
Art. 29. Definitionen.
«Satzung» Die Satzung der Gesellschaft.
«Verwaltungsrat» Der Verwaltungsrat der Gesellschaft.
« Geschäftstag» Ein Tag, an dem Banken in Luxemburg in der Regel zum Geschäftsverkehr geöffnet sind.
«Aktienklasse» Jede Aktienklasse der Gesellschaft.
«Gesellschaft» MPC GLOBAL MARITIME OPPORTUNITIES S.A. ist als société d'investissement à capital variable -
fonds d'investissement spécialisé, SICAV-FIS organisiert und auf der offiziellen Liste der spezialisierten Investmentfonds
(SIF) in Luxemburg eingetragen.
«Verwaltungsratsmitglieder» Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft.
«Sachkundige Anleger» Verwaltungsratsmitglieder, Institutionelle Anleger, Professionelle Anleger oder sonstige Sach-
kundige Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Februar 2007.
«Gründungsaktionär» MPC CAPITAL AG
«Institutionelle Anleger» Anleger, die nach den Luxemburger Gesetzen und Vorschriften als institutionelle Anleger
qualifiziert sind.
«Anlagestruktur» Anlagevehikel jeder Art und Weise, mit oder ohne Rechtspersönlichkeit, börsenorientiert oder nicht
börsenorientiert, reguliert oder unreguliert und mit Sitz in jedweder Rechtsordnung, in welche die Gesellschaft zu in-
vestieren gedenkt, um ihr Anlageziel und ihre Anlagestrategie wie im Verkaufsprospekt beschrieben, zu verfolgen.
«Verkaufsprospekt» Der Verkaufsprospekt der Gesellschaft, in seiner jeweils aktuellen Fassung.
«Nettoinventarwert» Der Nettoinventarwert pro Aktie der relevanten Kategorie, gemäß seiner Bestimmung in Artikel
12 im Abschnitt «Nettoinventarwert».
«Gesetz vom 13. Februar 2007» Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds»
«Professionelle Anleger» Anleger, die nach der Richtlinie 2004/39 über Märkte für Finanzinstrumente als professionelle
Anleger qualifiziert sind.
«Referenzwährung» Die Referenzwährung zur Berechnung des
Nettoinventarwerts, so wie sie unter dem Abschnitt «Nettoinventarwert» bestimmt ist.
«Aktionär» Ein eingetragener Aktieninhaber.
«Aktien» Von der Gesellschaft ausgegebene Aktien.
«Sondersituation» Eine Situation, in welcher die Gesellschaft zusätzlich sowohl direkt oder mittels Anlagestrukturen
in Vermögenswerte und Gesellschaften, die mit der Schiffsindustrie verbunden sind, anlegen kann, einschließlich aber nicht
ausschließlich Terminals, Kontainer, Hafeninfrastruktur und Logistik.
«Sonstige Sachkundige Anleger» Anleger, die (i) schriftlich ihre Zustimmung zum Status eines sachkundigen Anlegers
erklärt haben und (ii) mindestens 125.000,- EUR in die Gesellschaft anlegen oder über eine Beurteilung eines Kreditins-
tituts im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, eines Wertpapier-unternehmens im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder einer
Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2001/107/EG verfügt, die seine Expertise, Erfahrung und Kenntnis bestätigt,
um auf angemessene Weise eine Anlage in die Gesellschaft beurteilen zu können.
<i>Zeichnung und Zahlung des Gründungskapitalsi>
Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:
Name des Zeichners
Anzahl der
gezeichneten
Aktien
MPC MÜNCHMEYER PETERSEN CAPITAL AG, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eine Aktie
Die Einzahlung des gesamten Gründungskapitals wurde dem unterzeichneten Notar ordnungsgemäß nachgewiesen.
89539
<i>Übergangsvorschrifteni>
Das erste Geschäftsjahr soll mit Gründung der Gesellschaft beginnen und am 31. Dezember 2007 enden.
Die erste Jahresgeneralversammlung soll im Jahre 2008 stattfinden.
Der erste Jahresbericht der Gesellschaft soll auf den 31. Dezember 2007 datieren.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Abgaben in jeder Form, die der Gesellschaft mit der Gründung entstehen,
werden auf siebentausend Euro geschätzt.
<i>Gründungsversammlung der Gesellschafti>
Die Aktionäre haben nach der Gesellschaftsgründung unverzüglich folgendes beschlossen:
I. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates für einen Zeitraum, der am Ende der Jahresgeneralversammlung, die den Jah-
resabschluss des Jahres 2007 genehmigt, enden soll, werden ernannt:
- Gregory de Ruiter, Schifffahrtsingenieur, beruflich ansässig in Palmaille 67, D-22767 Hamburg, Deutschland, geboren
am 27. November 1963 in Hengelo OV, Niederlande,
- Tobias Müller, Banker, beruflich ansässig in Palmaille 67, D-22767 Hamburg, Deutschland , geboren am 26. März 1972
in Lüneburg, Deutschland,
- Bernhard Singer, Banker, beruflich ansässig in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg, geboren am 29. April 1941
in Saarbrücken, Deutschland,
- Claude Niedner, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in 14, rue Erasme, L-2010 Luxemburg, geboren am 15. Oktober
1966 in Karlsruhe, Deutschland.
II. Sitz der Gesellschaft ist 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen.
III. Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt:
ERNST & YOUNG S.A., 7, Parc d'Activite Syrdall, L-5365 Munsbach.
Das Mandat des Wirtschaftsprüfers soll mit dem Ende der Jahresgeneralversammlung, die den Jahresabschluss 2007
genehmigt, enden.
Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Antrag der oben angegebenen
Person, der vorliegende Vertrag in Englisch abgefasst wird und ihm eine deutsche Übersetzung beigefügt wird. Im Falle
von Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Version Geltung haben.
Und nach Vorlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Erschienenen, welche dem unterzeichneten Notar nach
Namen, Zivilstand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben die gegenwärtigen Urkunden mit dem Notar unter-
schrieben.
Gezeichnet: B. Weickgenannt, J.-J. Wagner.
Einregistriert in Esch an der Alzette, am 10. August 2007, Relation: EAC/2007/9851. — Erhalten 1.250 Euro.
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): Santioni.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Beles, den 14. August 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007092128/239/1068.
(070110454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2007.
ArcelorMittal, Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 102.468.
In the year two thousand and seven, on the twenty-eighth of August
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg
There appeared:
Mittal Steel Company N.V., a Dutch <i>naamloze vennootschapi> , having its corporate seat in Rotterdam, The Netherlands
and its address at Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, The Netherlands, registered with the Trade Registry of the Chamber
of Commerce for Rotterdam, The Netherlands, under number 24275428 («Mittal Steel Company N.V.»),
represented by Renata Jokubauskaite, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given on August 27, 2007.
The aforementioned proxy, after having been signed «ne varietur» by the proxyholder and the undersigned notary
shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
89540
The appearing party is the sole shareholder of ArcelorMittal, a <i>société anonymei> , having its registered office in 19,
Avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-
Bonnevoie, dated August 13, 2004 published in the Mémorial C number 1085 of October 27, 2004 (the «Company»).
The Articles of Association of the Company have been amended by two deeds of undersigned notary, dated April 26,
2007, published in the Mémorial C number 1333 of July 3, 2007 and June 21, 2007, published in the Mémorial C number
1634 of August 3, 2007.
The appearing proxyholder declares and requests the undersigned notary to state Mittal Steel Company N.V.'s reso-
lutions on the following agenda:
<i>I. Agenda:i>
1. Approval of the merger whereby Mittal Steel Company N.V. shall merge into the Company by way of absorption
by the Company of Mittal Steel Company N.V. and without liquidation of Mittal Steel Company N.V. (the «Merger»)
(hereinafter: Mittal Steel Company N.V. and the Company being referred to as the «Merging Companies») as contem-
plated by (i) the merger proposal as filed, together with the applicable documents, with the Trade Registry of the Chamber
of Commerce at Rotterdam, the Netherlands and with the Luxembourg Register of Trade and Companies («RCSL») and
as published in the <i>Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associationsi> of June 29, 2007 (the «Mémorial») and in the Dutch State
Gazette ( <i>Staatscouranti> ) of July 3, 2007 and (ii) the explanatory memorandum to the aforementioned merger proposal,
as deposited, together with the applicable documents, at the offices of each of the Merging Companies on June 29, 2007;
2. Decision to increase the share capital of the Company by the issue of a maximum of 1,419,342,499 (one billion four
hundred and nineteen million three hundred and forty-two thousand four hundred and ninety-nine) new shares with no
designation of nominal value to be reduced by the number of treasury shares of Mittal Steel Company N.V. as at August
28, 2007 (the «Merger Shares») in consideration for the transfer by operation of law of all assets and liabilities of Mittal
Steel Company N.V. to the Company; conversion with effect on the day of publication of the notarial deed in the Mémorial
of the stock options of Mittal Steel Company N.V. into stock options of the Company (the «Company Stock Options»);
3. Allocation of the Merger Shares to the shareholders of Mittal Steel Company N.V. and allocation of the Company
Stock Options to the holders of stock options of Mittal Steel Company N.V. with effect on the day of publication of the
notarial deed in the Mémorial;
4. Decision to cancel with effect on the day of publication of this notarial deed in the Mémorial the three million one
hundred thousand (3,100,000) Company shares held by Mittal Steel Company N.V. and transferred to the Company
pursuant to the Merger and consequently to reduce the Company's share capital to the extent of thirty-one thousand
euro (€ 31,000) and for the difference between their book value in Mittal Steel Company N.V.'s accounts and their
accounting par value by reducing the merger premium account;
5. Subsequent amendment of Article 5, first paragraph, of the Articles of Association of the Company to reflect the
above capital increase and capital reduction;
6. Decision to authorize the Board of Directors of the Company to issue Company's shares within the limits of the
authorized capital for delivery upon exercise or conversion, as applicable, of the Company's stock options and other
equity-based awards granted under any Company employee incentive or benefit plan;
7. Decision to authorize the Board of Directors of the Company and the corporate bodies of the other companies in
the group referred to in Article 49bis of the Luxembourg law on commercial companies dated August 10, 1915 as amended
to acquire and sell shares in the Company, under the conditions set forth in the Luxembourg law on commercial companies
dated August 10, 1915 as amended;
8. Approval of the resignation of the existing directors effective August 28, 2007;
9. Appointment of new directors effective August 28, 2007;
10. Appointment of Deloitte S.A. as independent auditor of the Company;
11. Effectiveness of the Merger as well as of the other items on the agenda (with the exception of items 8 and 9) on
September 3, 2007, the day of the publication of the notarial deed in the Mémorial.
II. The provisions of the Luxembourg law on commercial companies dated August 10, 1915 as amended (the «LSC»)
relating to mergers have been respected as follows:
1. The merger proposal as jointly drawn up by the Boards of Directors of the Merging Companies and as signed by all
the members of the Boards of Directors of the Merging Companies on June 25, 2007, has been filed with the RCSL and
has been published in the Mémorial and in the Dutch State Gazette ( <i>Staatscouranti> ) at least one month before the date
of the extraordinary general meeting of the shareholders of Mittal Steel Company N.V. convened to resolve upon the
Merger and the date hereof.
2. An explanatory memorandum has been jointly drawn up by the Board of Directors of the Merging Companies and
has been signed by all the members of the Boards of Directors of the Merging Companies on June 25, 2007, describing
the reasons for the Merger, the exchange ratios, the anticipated consequences for the respective activities of each of the
Merging Companies and any legal, economic and social related implications of the Merger. A copy of this explanatory
memorandum, after having been signed «ne varietur» by the proxyholder and the undersigned notary shall remain annexed
to the present deed to be filed with the registration authorities.
89541
3. The Board of Directors of the Company has appointed Mazars S.A. («Mazars Luxembourg») as independent auditor
who has issued a written report ( <i>un rapport écrit destiné aux actionnairesi> ) and Mazars Paardekooper Hoffman N.V. («Mazars
Netherlands») who has issued a written auditors' declaration ( <i>accountants-verklaringi> ) and a written auditors' report
( <i>accountantsverslagi> ). The Board of Directors of Mittal Steel Company N.V. has appointed AGN Daamen & Van Sluis as
independent auditor who has issued a written auditors' declaration ( <i>accountantsverklaringi> ) and a written auditors' report
( <i>accountantsverslagi> ). A copy of these reports and of these declarations, after having been signed «ne varietur» by the
proxyholder and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration
authorities.
4. The explanatory memorandum, together with the respective documents required pursuant to Article 267 of the
LSC, have been deposited at the registered office of each of the Merging Companies, for inspection by the shareholders
and those persons having special rights against any of the Merging Companies, at least one month prior to the date hereof
and the date of the extraordinary general meeting of shareholders of Mittal Steel Company N.V. An attestation from each
of the Merging Companies certifying as to the availability of these documents, after having been signed «ne varietur» by
the proxyholder and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration
authorities.
III. It results from a certificate which after having been signed «ne varietur» by the proxyholder and the undersigned
notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities, established on August 28,
2007 by Marcel Dirk Pieter Anker, civil law notary at Amsterdam that:
- the provisions of the Dutch Civil Code («DCC») relating to mergers have been respected as follows:
1. The merger proposal as well as an explanatory memorandum has been drawn up by the Board of Directors of Mittal
Steel Company N.V. and the Board of Directors of the Company, dated as of June 25, 2007 and has been signed by all
the members of the Board of Directors of Mittal Steel Company N.V. and all the members of the Board of Directors of
the Company.
2. The above mentioned merger proposal has been filed together with the documents referred to in Articles 2:314
(1) and 2:328 (1) of the DCC with the Trade Registry of the Chamber of Commerce at Rotterdam, the Netherlands on
June 28, 2007.
3. On June 29, 2007, (i) the Merging Companies published a notice in Trouw (a Dutch newspaper), in accordance with
the provisions of Article 2:314(3) of the DCC, that all required documents pursuant to the DCC had been filed with the
Trade Registry of the Chamber of Commerce at Rotterdam, the Netherlands and deposited at the offices of each of the
Merging Companies.
4. On August 28, 2007, the chairman of the extraordinary general meeting of shareholders of Mittal Steel Company
N.V. which was held in Amsterdam recorded that at least 50% of the issued share capital was present or represented
and that the majority of the votes had been cast in favour of the proposal to effect the Merger as contemplated by the
merger proposal and the explanatory memorandum and that the proposal to effect the Merger has been adopted.
- save for the execution of the Dutch law governed notarial deed of merger, the execution of which is scheduled for
September 2, 2007, the procedural requirements laid down in Chapter 2 of Title 7 of Book 2 of the DCC (which includes
the general provisions in respect of mergers) and laid down in Chapter 3 of Title 7 of Book 2 of the DCC (which includes
the special provisions for mergers of public limited liability companies and private limited liability companies) and under
the articles of association of Mittal Steel Company N.V., to effectuate the Merger have been duly complied with.
IV. The following resolutions are taken by the appearing party:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder, after having reviewed the merger proposal dated June 25, 2007 and the explanatory memoran-
dum to the merger proposal dated June 25, 2007, both jointly drawn up by the Boards of Directors of the Merging
Companies in accordance with Article 265 of the LSC, and the written report of Mazars Luxembourg, drawn up in
accordance with Article 266 of the LSC dated June 25, 2007, the written auditors' report and the written auditors'
declaration of Mazars Netherlands dated June 25, 2007 drawn up in accordance with Article 2:328 of the DCC and the
written auditors' report and the written auditors' declaration of AGN Daamen & Van Sluis drawn up in accordance with
Article 2:328 of the DCC dated June 25, 2007, approves, with effect from the day of the publication of this notarial deed
in the Mémorial, the Merger as contemplated by the merger proposal published in Luxembourg in the Mémorial and in
the Netherlands in the Dutch State Gazette ( <i>Staatscouranti> ) and the explanatory memorandum to the merger proposal.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder confirms that it results from a certificate which after having been signed «ne varietur» by the
proxyholder and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration
authorities, issued by Mittal Steel Company N.V. on August 28, 2007, that on August 28, 2007 the number of Mittal Steel
Company N.V. shares held in treasury amounts to two million one hundred and thirty-five thousand two hundred and
forty-six (2,135,246) shares. Consequently, the sole shareholder decides to increase the share capital of the Company
by fourteen million one hundred and seventy-two thousand seventy-two euro and fifty-three cent (€ 14,172,072.53) in
order to bring it from thirty-one thousand euro (€ 31,000) to fourteen million two hundred and three thousand seventy-
two euro and fifty-three cent (€ 14,203,072.53) by the issue of one billion four hundred and seventeen million two hundred
89542
and seven thousand two hundred and fifty-three (1,417,207,253) new shares with no designation of nominal value fully
paid up (the «Merger Shares») in consideration for the transfer by operation of law of all assets and liabilities of Mittal
Steel Company N.V. to the Company, it being understood that the Company takes over for its own account all operations
of Mittal Steel Company N.V. and all liabilities of Mittal Steel Company N.V. from September 3, 2007. The sole shareholder
hereby expressly acknowledges that the Company will take over the liability resulting from the dividend distribution
decided by the annual general meeting of shareholders of Mittal Steel Company N.V. on June 12, 2007.
The net patrimony of Mittal Steel Company N.V. is valuated at US$ 42.1 billion as results from the audited statutory
accounts of Mittal Steel Company N.V. for the accounting year ended December 31, 2006 and the written report of
Mazars Luxembourg.
The difference between the net patrimony of Mittal Steel Company N.V. contributed to the Company and the amount
of the share capital increase in the Company shall be allocated to a «merger premium» account.
The written report drawn up by Mazars Luxembourg, the independent auditor to the Company, on June 25, 2007 in
order to verify, in accordance with the LSC, the share exchange ratios, concluded that:
«Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention, which causes us to believe that the merger proposal does
not give a relevant and reasonable view of the exchange ratios and that the evaluation methods used to determine the
exchange ratios are not adequate.»
The auditors' declaration and the auditors' report drawn up by Mazars Netherlands, independent auditor to the
Company on June 25, 2007 pursuant to Article 2:328 of the DCC concluded that:
Conclusion of the auditors' declaration
«Based upon our examination, in our opinion:
1. the exchange ratio included in the merger proposal for the class A shares and class B shares, as referred to in Section
2:326 of the Dutch Civil Code, taking into account, the documents that are attached to the merger proposal, are rea-
sonable; and
2. the shareholders' equity of the disappearing company, Mittal Steel Company N.V. at December 31, 2006, on the
basis of valuation methods generally accepted in The Netherlands at least corresponds to the accounting par value of the
aggregate number of shares in ArcelorMittal to be received by the shareholders of Mittal Steel Company N.V. in the
merger, that is approximately EUR 14,035,703.71 (which number may change between the date of this auditors' decla-
ration and the effective date of the merger between Mittal Steel Company N.V. and ArcelorMittal as a result of changes
in Mittal Steel Company N.V.'s issued and outstanding share capital due, among others, to the exercise of stock options,
the sale or transfer of shares held by or for the account of Mittal Steel Company N.V. or its subsidiaries (treasury shares),
the repurchase of shares or the issuance of new shares).»
Conclusion of the auditors' report
«In our opinion the information disclosed by the Board of Directors of ArcelorMittal and the Board of Directors of
Mittal Steel Company N.V. in the explanatory memorandum concerning the following matters meets the relevant statutory
requirements:
a. the method(s) used to determine the proposed exchange ratio for the class A shares and class B shares;
b. the adequacy of the method(s) used;
c. the values arrived by using such method(s);
d. whether the relative importance attributed to the valuation method(s) applied may be considered generally accept-
able in The Netherlands;
e. description of any special valuation difficulties that have arisen in the valuation and the determination of the exchange
ratio.»
The auditors' declaration and the auditors' report drawn up by AGN Daamen & Van Sluis, independent auditor to
Mittal Steel Company N.V., on June 25, 2007, pursuant to Article 2:328 of the DCC concluded that:
Conclusion of the auditors' declaration
«Based upon our examination, in our opinion:
1. the exchange ratio included in the merger proposal for the class A shares and class B shares, as referred to in Section
2:326 of the Dutch Civil Code, taking into account, the documents that are attached to the merger proposal, are rea-
sonable; and
2. the shareholders' equity of the disappearing company, MITTAL STEEL COMPANY N.V., at December 31, 2006, on
the basis of valuation methods generally accepted in The Netherlands at least corresponds to the accounting par value
of the aggregate number of shares in ArcelorMittal to be received by the shareholders of MITTAL STEEL COMPANY
N.V. in the merger, that is approximately € 14,035,703.71 (which number may change between the date of this auditors'
declaration and the effective date of the merger between MITTAL STEEL COMPANY N.V. and ArcelorMittal as a result
of changes in MITTAL STEEL COMPANY N.V.'s issued and outstanding share capital due, among others, to the exercise
of stock options, the sale or transfer of shares held by or for the account of MITTAL STEEL COMPANY N.V. or its
subsidiaries (treasury shares), the repurchase of shares or the issuance of new shares).»
89543
Conclusion of the auditors' report
«In our opinion the information disclosed by the Board of Directors of ArcelorMittal and the Board of Directors of
MITTAL STEEL COMPANY N.V. in the explanatory memorandum concerning the following matters meets the relevant
statutory requirements:
a. the method(s) used to determine the proposed exchange ratio for the Class A shares and Class B shares (as defined
in the explanatory memorandum);
b. the adequacy of the method(s) used;
c. the values arrived by using such method(s);
d. whether the relative importance attributed to the valuation method(s) applied may be considered generally accept-
able in The Netherlands; and
e. description of any special valuation difficulties that have arisen in the valuation and the determination of the exchange
ratio.»
Following the assumption by the Company of all liabilities of Mittal Steel Company N.V., the sole shareholder states
that with effect on the day of publication of this notarial deed in the Mémorial stock options of Mittal Steel Company
N.V. are converted into stock options of the Company (the «Company Stock Options») as follows:
1. each Company Stock Option granted to the holders of Mittal Steel Company N.V. stock options shall give right to
the subscription or acquisition, as the case may be, of one (1) Company share;
2. the exercise price of the Company Stock Options granted to the holders of Mittal Steel Company N.V. stock options
shall be equal to the exercise price of the corresponding Mittal Steel Company N.V. stock options; and
3. the Company Stock Options shall be governed by terms and conditions similar to those of the stock option plan of
Mittal Steel Company N.V. dated September 15, 1999 as amended from time to time (subject to any changes necessary
to reflect the effectiveness of the Merger).
The sole shareholder decides to grant the widest powers to the Board of Directors to implement this decision. It has
been noted that the number of Mittal Steel Company N.V. outstanding stock options represents a maximum of thirteen
million five hundred thousand (13,500,000).
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder decides to allocate the Merger Shares to the shareholders of Mittal Steel Company N.V. in
proportion to their holding in Mittal Steel Company N.V. with effect on the day of publication of this notarial deed in the
Mémorial.
The sole shareholder requests the Board of Directors to allocate the Merger Shares between the shareholders of
Mittal Steel Company N.V. on the effective date of the Merger as follows:
- one (1) Merger Share for each one (1) Mittal Steel Company N.V.'s Class A share to the holders of Mittal Steel
Company N.V.'s Class A shares existing at such time and one (1) Merger Share for each one (1) Mittal Steel Company
N.V.'s Class B share to the holders of Mittal Steel Company N.V.'s Class B shares existing at such time.
The Merger Shares shall be entitled to any distribution made on the shares in the Company as of the effectiveness of
the Merger.
The sole shareholder requests the Board of Directors to allocate, with effect on the day of publication of this notarial
deed in the Mémorial, the Company Stock Options to the holders of Mittal Steel Company N.V. stock options as follows:
- one (1) Company Stock Option for every one (1) Mittal Steel Company N.V. stock option.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder decides to cancel with effect on the day of publication of this notarial deed in the Mémorial the
three million one hundred thousand (3,100,000) Company shares owned by Mittal Steel Company N.V. and transferred
to the Company pursuant to the Merger, in accordance with Article 49 (3) of the LSC and consequently to reduce the
Company's share capital to the extent of thirty-one thousand euro (€ 31,000) so as to bring it to fourteen million one
hundred and seventy-two thousand seventy-two euro and fifty three cent (€ 14,172,072.53) and for the difference be-
tween the book value of the shares in Mittal Steel Company N.V.'s accounts and their accounting par value to reduce the
merger premium account.
<i>Fifth resolutioni>
In accordance with the foregoing resolutions the sole shareholder decides to amend Article 5, first paragraph, of the
Articles of Association of the Company to read as follows:
The issued corporate capital amounts to fourteen million one hundred and seventy-two thousand seventy-two euro
and fifty-three cent (€ 14,172,072.53). It is represented by one billion four hundred and seventeen million two hundred
and seven thousand two hundred and fifty-three (1,417,207,253) shares, without nominal value, fully paid up.
<i>Sixth resolutioni>
The sole shareholder states that Article 5.5 of the Articles of Association of the Company authorizes the Board of
Directors of the Company to issue Company's shares within the limits of the authorized capital, namely for delivery upon
89544
exercise or conversion of the Company's stock options and other equity-based awards granted under any Company
employee incentive or benefit plan and that consequently no further authorization is required.
<i>Seventh resolutioni>
The sole shareholder decides to authorize, with effect on the day of publication of this notarial deed in the Mémorial,
the Board of Directors of the Company, with option to delegate, and the corporate bodies of the other companies in
the group referred to in Article 49bis of the LCS to acquire and sell shares in the Company, under the conditions set
forth in the LCS.
Such purchases and sales may be carried out for any purpose authorized or which would come to be authorized by
the laws and regulations in force and in particular to enter into off-market and over the counter transactions and to
acquire shares in the Company through derivative financial instruments.
In accordance with the applicable laws transposing Directive 2003/6/EC of 28 January 2003 and EC Regulation
2273/2003 of 22 December 2003, acquisitions, disposals, exchanges, contributions and transfers of securities can be
carried out by all means, on or off the market, including by a public offer to buy back shares or by the use of derivatives
or option strategies. The fraction of the capital acquired or transferred in the form of a block of securities could amount
to the entire program. Such transactions can be carried out at any time, including during a tender offer period, in ac-
cordance with the applicable regulations.
The authorization is valid for a period of eighteen (18) months or until the date of its renewal by a resolution of the
general meeting of shareholders if such renewal date is prior to such period.
The maximum number of shares that can be acquired is the maximum allowed by the LCS in such a manner that the
accounting par value of the Company's shares held by the Company (or other group companies referred to in Article
49bis of the LCS) cannot in any event exceed 10 % of its subscribed share capital.
The purchase price per share to be paid in cash shall not represent more than 125% of the price on the New York
Stock Exchange, Euronext Amsterdam by NYSE Euronext, Euronext Brussels by NYSE Euronext, Euronext Paris by NYSE
Euronext, the Luxembourg Stock Exchange or the stock exchanges of Barcelona, Bilbao, Madrid and Valencia, depending
on the market on which the transactions are made, and no less than the par value of the share at the time of repurchase.
For off market transactions, the maximum purchase price shall be 125% of the price of Euronext Paris by NYSE Euronext.
The price on the New York Stock Exchange or Euronext Amsterdam by NYSE Euronext, Euronext Brussels by NYSE
Euronext, Euronext Paris by NYSE Euronext, the Luxembourg Stock Exchange or the stock exchanges of Barcelona,
Bilbao, Madrid and Valencia will be deemed to be the higher of the average of the final listing price per share on the
relevant stock exchange during 30 consecutive days on which the relevant stock exchange is open for trading preceding
the 3 trading days prior to the date of repurchase. In the event of a share capital increase by incorporation of reserves
or issue premiums and the free allotment of shares as well as in the event of the division or regrouping of the shares, the
purchase prices indicated above shall be adjusted by a coefficient multiple equal to the ratio between the number of shares
comprising the share capital prior to the transaction and such number following the transaction.
The total amount allocated for the Company's share repurchase program cannot in any event exceed the amount of
the Company's available equity.
All powers are granted to the Board of Directors, with delegation powers, in view of ensuring the performance of this
authorization.
<i>Eighth resolutioni>
The sole shareholder approves the resignation of the existing members of the Board of Directors of the Company,
Mr. Bhikam Agarwal, Mr. Albert Rinnen, Mr. Armand Gobber, Mr. Henk Scheffer and Mr. Claude Witry effective August
28, 2007.
<i>Ninth resolutioni>
The sole shareholder decides to appoint the following persons as members of the Board of Directors of the Company
effective August 28, 2007:
1) Lakshmi N. Mittal, born in Sadulpur (India) on June 15, 1950, residing professionally at Berkeley Square House,
Berkeley Square, GB-W1J 6DA London, United Kingdom;
2) Joseph J. Kinsch, born in Esch sur Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg) on May 2, 1933, residing professionally at
19, Avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
3) José Ramón Álvarez-Rendueles Medina, born in Giron (Spain) on June 17, 1940, residing at 3, Calle Albacete, E-28027
Madrid, Spain;
4) Edmond Pachura, born in Oignies (France) on January 31, 1934, residing at 65, Avenue Victor Hugo, F-75116 Paris,
France;
5) HRH Prince Guillaume de Luxembourg, born in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) on May 1, 1963,
residing at 53, rue des Prés, L-5316 Contern, Grand Duchy of Luxembourg;
6) Sergio Silva de Freitas, born in Rio De Janeiro (Brasil) on January 16, 1943, residing at 7076, Av. Eng. Armando
Arrunda Pereira, BR-04344902 São Paulo, Brasil;
89545
7) Jean-Pierre Hansen, born in Athus (Belgium) on April 25, 1948, residing at 1, Place du Trône, B-1000 Brussels,
Belgium;
8) Vanisha Mittal Bhatia, born in Surabaja (Indonesia) on August 23, 1980, residing professionally at Berkeley Square
House, Berkeley Square, GB-W1J 6DA London, United Kingdom;
9) Wilbur L. Ross, born in Weehawken (USA) on November 28, 1937, residing at 600, Lexington Avenue (19th Floor),
NY 10022 New York, USA;
10) Lewis Kaden, born in Perth Amboy (USA) on March 24, 1942, residing at 399 Park Avenue (2nd Floor), NY 10022
New York, USA;
11) François H.J. Pinault, born in Champs Giraud (France) on August 21, 1936, residing at 12, rue François 1
er
, F-75008
Paris, France;
12) Narayanan Vaghul, born in Ulundurpet, Tamil Nadu (India) on August 4, 1936, residing at 63, First Main Road, IND-
RA Puram (Chennai) 600028, India;
13) Georges T.N. Schmit, born in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) on April 19, 1953, residing professionally
at 6, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
14) Antoine R. Spillmann, born in Solothurn (Switzerland) on April 4, 1963, residing at 7/11, Avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
15) Romain C.L. Zaleski, born in Paris (France) on February 7, 1933, residing at 74, Ottava Strada, I-20090 San Felice
di Segrate, Italy;
16) John O. Castegnaro, born in Differdange (Grand-Duchy of Luxembourg), on November 3, 1944, residing at 25,
rue St Joseph, L-3736 Rumelange, Grand Duchy of Luxembourg;
17) Michel A. Marti, born in Castellon (Spain) on July 6, 1947, residing at 14, Impasse Paul Gauguin, F-77190, Broye,
France;
18) Manuel Fernandéz López, born in Mieres (Spain) on June 8, 1947, residing at 25, Avenida de America, E-28002
Madrid, Spain.
Their mandate will expire at the third annual general meeting following the date of their appointment.
<i>Tenth resolutioni>
The sole shareholder decides to appoint Deloitte S.A. with registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg as independent auditor of the Company. The mandate of the independent auditor will expire at the annual general
meeting of shareholders resolving on the annual accounts for the accounting year ending December 31, 2007.
<i>Eleventh resolutioni>
The sole shareholder states that the Merger and all other matters referred to in the foregoing resolutions shall become
effective on September 3, 2007, the date of publication of this notarial deed in the Mémorial except for the resolutions
relating to the resignation and the appointment of the directors.
<i>Declarationi>
In accordance with Article 271 (2) of the LSC, the undersigned notary declares having verified and certifies the existence
and validity, under Luxembourg law, of the legal acts and formalities imposed on the Company in order to realize the
Merger.
It results furthermore from a certificate, which is annexed to the present deed, issued on August 28, 2007 by Marcel
Dirk Pieter Anker, civil law notary residing in Amsterdam, that, save for the execution of the Dutch law governed notarial
deed of merger, the signing of which is fixed on September 2, 2007, the procedural requirements laid down in Chapter
2 of Title 7 of Book 2 of the DCC (which includes the general provisions in respect of mergers) and laid down in Chapter
3 of Title 7 of Book 2 of the DCC (which includes the special provisions for mergers of public limited liability companies
and private limited liability companies) and the articles of association of Mittal Steel Company N.V. to effectuate the
Merger have been complied with. It results furthermore from the mentioned certificate that the day following the exe-
cution of the Dutch law governed notarial deed of merger, the Merger will become effective under Dutch law.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges, in any form whatsoever, resulting from the present deed, are estimated
approximately at 20,000 €.
The contribution of all the assets and liabilities of Mittal Steel Company N.V. is being made within the provisions of
article 4.1 of the law of December 29, 1971, as amended, which provides for a capital tax exemption.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that at the request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French version, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder appearing, known to the notary by her surname, given name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
89546
Follows the French version:
L'an deux mille sept, le vingt-huit août
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg
A comparu:
Mittal Steel Company N.V., une <i>naamloze vennootschapi> de droit néerlandais, ayant son siège social à Rotterdam, Pays-
Bas et son adresse à Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, Pays-Bas, enregistrée auprès du Registre de Commerce de la
Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas, sous le numéro 24275428 («Mittal Steel Company N.V.»),
ici représentée par Renata Jokubauskaite, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 27 août 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire ins-
trumentant, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant est l'actionnaire unique d'ArcelorMittal, une <i>société anonymei> , ayant son siège social au 19, Avenue de
la Liberté, L-2930 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-
Bonnevoie, en date du 13 août 2004, publié au Mémorial C numéro 1085 du 27 octobre 2004 (la «Société»).
Les Statuts de la Société ont été modifiés suivant deux actes reçus par le notaire soussigné, en date du 26 avril 2007,
publié au Mémorial C numéro 1333 du 3 juillet 2007 et du 21 juin 2007, publié au Mémorial C numéro 1634 du 3 août
2007.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ses résolutions portant sur l'ordre du jour suivant:
<i>I. Ordre du Jour:i>
1. Approbation de la fusion par laquelle Mittal Steel Company N.V. va fusionner avec la Société par voie d'absorption
de Mittal Steel Company N.V. par la Société et sans liquidation de Mittal Steel Company N.V. (la «Fusion») (Mittal Steel
Company N.V. et la Société étant désignées ci-après comme les «Sociétés Fusionnantes») conformément (i) au projet de
fusion tel que déposé avec les documents requis auprès du Registre de Commerce de la Chambre de Commerce de
Rotterdam, Pays-Bas et auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg («RCSL») et tel que publié au
<i>Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associationsi> du 29 juin 2007 (le «Mémorial») et dans le Journal Etatique néerlandais
( <i>Staatscouranti> ) du 3 juillet 2007 et (ii) au rapport écrit détaillé sur le projet de fusion, tel que déposé avec les documents
requis au siège social de chacune des Sociétés Fusionnantes en date du 29 juin 2007;
2. Décision d'augmenter le capital social de la Société par l'émission d'un maximum de 1.419.342.499 (un milliard quatre
cent dix-neuf millions trois cent quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf) actions nouvelles sans désignation
de valeur nominale à réduire par le nombre d'actions de trésorerie de Mittal Steel Company N.V. au 28 août 2007 (les
«Actions de Fusion») en contrepartie du transfert de plein droit de tous les actifs et passifs de Mittal Steel Company N.V.
à la Société; conversion avec effet au jour de la publication de l'acte notarié au Mémorial des options sur actions de Mittal
Steel Company N.V. en options sur actions de la Société (les «Options sur Actions de la Société»);
3. Attribution des Actions de Fusion aux actionnaires de Mittal Steel Company N.V. et attribution des Options sur
Actions de la Société aux détenteurs des options sur actions de Mittal Steel Company N.V. avec effet au jour de la
publication de l'acte notarié au Mémorial;
4. Décision d'annuler avec effet au jour de la publication de cet acte notarié au Mémorial les trois millions cent mille
(3.100.000) actions de la Société détenues par Mittal Steel Company N.V. et transférées à la Société suite à la Fusion et
de réduire par conséquent le capital social de la Société à concurrence de trente et un mille euros (€ 31.000) et pour la
différence entre leur valeur comptable dans les comptes de Mittal Steel Company N.V. et leur pair comptable par ré-
duction du compte de prime de fusion;
5. Modification subséquente de l'Article 5, premier paragraphe, des Statuts de la Société afin de refléter l'augmentation
et la réduction de capital ci-dessus;
6. Décision d'autoriser le Conseil d'Administration de la Société à émettre des actions de la Société dans les limites
du capital autorisé pour délivrance suite à l'exercice ou à la conversion, selon le cas, des options sur actions de la Société
et d'autres allocations d'actions octroyées dans le cadre de tout plan destiné aux salariés, à caractère incitatif ou visant
à attribuer des avantages, mis en place par la Société;
7. Décision d'autoriser le Conseil d'Administration de la Société et les organes sociaux des autres sociétés du groupe
au sens de l'Article 49bis de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, à
acquérir et à vendre des actions de la Société, aux conditions prévues dans la loi luxembourgeoise sur les sociétés
commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée;
8. Approbation de la démission des administrateurs existants avec effet au 28 août 2007;
9. Nomination de nouveaux administrateurs avec effet au 28 août 2007;
10. Nomination de Deloitte S.A. en tant que réviseur d'entreprises de la Société;
11. Prise d'effet de la Fusion et des autres points à l'ordre du jour (à l'exception des points 8 et 9) le 3 septembre
2007, date de la publication de l'acte notarié au Mémorial.
89547
II. Les dispositions de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la
«LSC») relatives aux fusions ont été respectées comme suit:
1. Le projet de fusion tel qu'établi conjointement par les Conseils d'Administration des Sociétés Fusionnantes et tel
que signé par tous les membres des Conseils d'Administration des Sociétés Fusionnantes le 25 juin 2007 a été déposé
auprès du RCSL et a été publié au Mémorial et dans le Journal Etatique néerlandais (Staatscourant) un mois au moins
avant la date de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Mittal Steel Company N.V. convoquée afin de
décider la Fusion et la date de cet acte.
2. Un rapport écrit détaillé a été établi conjointement par les Conseils d'Administration des Sociétés Fusionnantes et
a été signé par tous les membres des Conseils d'Administration des Sociétés Fusionnantes le 25 juin 2007, décrivant les
raisons de la Fusion, les rapports d'échange, les conséquences prévisibles pour les activités respectives de chacune des
Sociétés Fusionnantes et toutes conséquences juridiques, économiques et sociales de la Fusion. Une copie de ce rapport
écrit détaillé restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
3. Le Conseil d'Administration de la Société a nommé Mazars S.A. («Mazars Luxembourg») comme expert indépendant
qui a émis un rapport écrit destiné aux actionnaires et Mazars Paardekooper Hoffman N.V. («Mazars Pays-Bas») qui a
émis une déclaration écrite d'expert ( <i>accountantsverklaringi> ) et un rapport écrit d'expert ( <i>accountantsverslagi> ). Le Conseil
d'Administration de Mittal Steel Company N.V. a nommé AGN Daamen & Van Sluis comme expert indépendant qui a
émis une déclaration écrite d'expert ( <i>accountantsverklaringi> ) et un rapport écrit d'expert ( <i>accountantsverslagi> ). Une copie
de ces rapports et de ces déclarations restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et
le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
4. Le rapport écrit détaillé et les documents respectifs exigés par l'Article 267 de la LSC ont été déposés au siège
social de chacune des Sociétés Fusionnantes, en vue de leur consultation par les actionnaires et les personnes ayant des
droits spéciaux à l'égard de chacune des Sociétés Fusionnantes, un mois au moins avant la date de cet acte et la date de
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Mittal Steel Company N.V. Une attestation de chacune des So-
ciétés Fusionnantes certifiant la disponibilité de ces documents restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
du comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enre-
gistrement.
III. Il résulte d'un certificat, qui restera après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire
instrumentaire annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement, établi en date du 28
août 2007 par Marcel Dirk Pieter Anker, notaire de droit civil à Amsterdam que:
- les dispositions du Code Civil néerlandais («DCC») relatives aux fusions ont été respectées comme suit:
1. Le projet de fusion ainsi qu'un rapport écrit a été établi par le Conseil d'Administration de Mittal Steel Company
N.V. et le Conseil d'Administration de la Société daté du 25 juin 2007 et a été signé par tous les membres du Conseil
d'Administration de Mittal Steel Company N.V. et tous les membres du Conseil d'Administration de la Société.
2. Le projet de fusion mentionné ci-dessous a été déposé ensemble avec les documents mentionnés aux Articles 2:314
(1) et 2:328 (1) du DCC auprès du Registre de Commerce de la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas le 28
juin 2007.
3. Le 29 juin 2007, (i) les Sociétés Fusionnantes ont publié un avis dans Trouw (un journal néerlandais), conformément
aux dispositions de l'Article 2:314(3) du DCC, que tous les documents exigés par le DCC ont été déposés auprès du
Registre de Commerce de la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas et déposés au siège social de chacune des
Sociétés Fusionnantes.
4. Le 28 août 2007, le président de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Mittal Steel Company N.V.
qui a été tenue à Amsterdam a acté qu'au moins 50% du capital social émis a été présent ou représenté et que la majorité
des votes a été émise en faveur de la proposition d'effectuer la Fusion telle qu'envisagée par le projet de fusion et le
rapport écrit détaillé et que la proposition d'effectuer la Fusion a été approuvée.
- hormis la signature de l'acte notarié de fusion régi par le droit néerlandais, dont la signature est prévue le 2 septembre
2007, les exigences procédurales prévues par le Chapitre 2 du Titre 7 du Livre 2 du DCC (qui incluent les dispositions
générales applicables aux fusions) et le Chapitre 3 du Titre 7 du Livre 2 du DCC (qui incluent les dispositions applicables
aux fusions des sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée) et par les statuts de Mittal Steel Company N.V.,
afin d'effectuer la Fusion ont été dûment observées.
IV. Les résolutions suivantes sont prises par le comparant:
<i>Première résolutioni>
L'actionnaire unique, après avoir revu le projet de fusion daté du 25 juin 2007 et le rapport écrit détaillé sur le projet
de fusion daté du 25 juin 2007, tous les deux établis conjointement par les Conseils d'Administration des Sociétés Fu-
sionnantes conformément à l'Article 265 de la LSC, et le rapport écrit de Mazars Luxembourg, établi conformément à
l'Article 266 de la LSC daté du 25 juin 2007, le rapport écrit d'experts et la déclaration écrite d'experts de Mazars Pays-
Bas daté du 25 juin 2007 établis conformément à l'Article 2:328 du DCC et le rapport écrit d'experts et la déclaration
écrite d'experts de AGN Daamen & Van Sluis établi conformément à l'Article 2:328 du DCC daté du 25 juin 2007,
approuve, avec effet à la date de publication du présent acte notarié au Mémorial, la Fusion telle qu'envisagée par le projet
89548
de fusion publié à Luxembourg au Mémorial et aux Pays-Bas dans le Journal Etatique néerlandais ( <i>Staatscouranti> ) et le
rapport écrit détaillé sur le projet de fusion.
<i>Deuxième résolutioni>
L'actionnaire unique confirme qu'il résulte d'un certificat qui après avoir été signé ne varietur par le mandataire du
comparant et le notaire instrumentant restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'en-
registrement, émis par Mittal Steel Company N.V. en date du 28 août 2007 qu'à la date du 28 août 2007 le nombre
d'actions auto-détenues de Mittal Steel Company N.V. s'élève à deux millions cent trente-cinq mille deux cent quarante-
six (2.135.246) actions. Par conséquent, l'actionnaire unique décide d'augmenter le capital social de quatorze millions cent
soixante-douze mille soixante-douze euros cinquante-trois centimes (14.172.072,53 €) afin de le porter de trente et un
mille euros (31.000 €) à quatorze millions deux cent trois mille soixante-douze euros cinquante-trois centimes
(14.203.072,53 €) par l'émission de un milliard quatre cent dix-sept millions deux cent sept mille deux cent cinquante-
trois (1.417.207.253) nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées (les «Actions de
Fusion») en échange du transfert de plein droit de tous les actifs et passifs de Mittal Steel Company N.V. à la Société,
étant précisé que la Société reprend à son compte toutes les opérations de Mittal Steel Company N.V. et tous les passifs
de Mittal Steel Company N.V. à partir du 3 septembre 2007. L'actionnaire unique reconnaît expressément que la Société
reprendra à son compte le passif résultant de la distribution de dividendes décidée par l'assemblée générale annuelle des
actionnaires de Mittal Steel Company N.V. le 12 juin 2007.
La valeur nette du patrimoine de Mittal Steel Company N.V. est évaluée à US$ 42.1 milliards tel qu'il résulte des
comptes annuels audités de Mittal Steel Company N.V. pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2006 et du
rapport écrit de Mazars Luxembourg.
La différence entre la valeur nette du patrimoine de Mittal Steel Company N.V. apporté à la Société et le montant de
l'augmentation du capital social de la Société sera affectée à un compte de prime de fusion.
Le rapport écrit établi par Mazars Luxembourg, l'expert indépendant de la Société, le 25 juin 2007 afin de vérifier,
conformément à la LSC, les rapports d'échange conclut que:
«Conclusion
Sur base de notre examen, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse penser que le projet de fusion ne
donne pas une vue pertinente et raisonnable des rapports d'échange et que les méthodes d'évaluation utilisées pour
déterminer les rapports d'échange ne sont pas adéquates.
La déclaration d'experts et le rapport d'experts établis par Mazars Pays-Bas, expert indépendant de la Société, le 25
juin 2007 conformément à l'Article 2:328 du DCC conclut que:
Conclusion de la déclaration d'experts
«Sur base de notre examen, à notre avis:
1. le rapport d'échange inclus dans le projet de fusion pour les actions de classe A et les actions de classe B, tel qu'indiqué
à la Section 2:326 du Code Civil néerlandais, prenant en compte les documents annexés au projet de fusion, sont rai-
sonnables; et
2. les capitaux propres de la société qui disparaît, Mittal Steel Company N.V. au 31 décembre 2006, sur base des
méthodes d'évaluation généralement admises aux Pays-Bas correspondent au moins au pair comptable de la totalité du
nombre d'actions d'ArcelorMittal à recevoir dans la fusion par les actionnaires de Mittal Steel Company N.V., soit ap-
proximativement EUR 14.035.703,71 (ce montant peut varier entre la date de cette déclaration d'experts et la date d'effet
de la fusion entre Mittal Steel Company N.V. et ArcelorMittal, suite aux changements dans le capital social émis et en
circulation de Mittal Steel Company N.V. dus, entre autres, à l'exercice d'options sur actions, la vente ou le transfert
d'actions détenus par ou pour le compte de Mittal Steel Company N.V. ou ses filiales (actions de trésorerie), le rachat
d'actions ou l'émission de nouvelles actions).»
Conclusion du rapport d'experts
«A notre avis, l'information révélée par le Conseil d'Administration d'ArcelorMittal et le Conseil d'Administration de
Mittal Steel Company N.V. dans le rapport écrit détaillé concernant les matières suivantes remplit les exigences légales
applicables:
a. la (les) méthode(s) utilisée(s) afin de déterminer le rapport d'échange proposé pour les actions de classe A et les
actions de classe B;
b. le caractère adéquat de la(des) méthode(s) utilisée(s);
c. les valeurs obtenues en utilisant telle(s) méthode(s);
d. le point de savoir si l'importance relative attribuée aux méthodes d'évaluation appliquées peut être considérée
comme étant généralement acceptable aux Pays-Bas;
e. la description de toutes difficultés d'évaluation particulières survenues lors de l'évaluation et de la détermination du
rapport d'échange.»
La déclaration d'experts et le rapport d'experts établis par AGN Daamen & Van Sluis, expert indépendant de Mittal
Steel Company N.V., le 25 juin 2007 conformément à l'Article 2:328 du DCC conclut que:
Conclusion de la déclaration d'experts
89549
«Sur base de notre examen, à notre avis:
1. le rapport d'échange inclus dans le projet de fusion pour les actions de classe A et les actions de classe B, tel qu'indiqué
à la Section 2:326 du Code Civil néerlandais, prenant en compte les documents annexés au projet de fusion, sont rai-
sonnables; et
2. les capitaux propres de la société qui disparaît, Mittal Steel Company N.V. au 31 décembre 2006, sur base des
méthodes d'évaluation généralement admises aux Pays-Bas correspondent au moins au pair comptable de la totalité du
nombre d'actions d'ArcelorMittal à recevoir dans la fusion par les actionnaires de Mittal Steel Company N.V., soit ap-
proximativement EUR 14.035.703,71 (ce montant peut varier entre la date de cette déclaration d'experts et la date d'effet
de la fusion entre Mittal Steel Company N.V. et ArcelorMittal, suite aux changements dans le capital social émis et en
circulation de Mittal Steel Company N.V. dus, entre autres, à l'exercice d'options sur actions, la vente ou le transfert
d'actions détenus par ou pour le compte de Mittal Steel Company N.V. ou ses filiales (actions de trésorerie), le rachat
d'actions ou l'émission de nouvelles actions).»
Conclusion du rapport d'experts
«À notre avis, l'information révélée par le Conseil d'Administration d'ArcelorMittal et le Conseil d'Administration de
Mittal Steel Company N.V. dans le rapport écrit détaillé concernant les matières suivantes remplit les exigences légales
applicables:
a. la (les) méthode(s) utilisée(s) afin de déterminer le rapport d'échange proposé pour les actions de classe A et les
actions de classe B (comme défini dans le rapport écrit détaillé);
b. le caractère adéquat de la (des) méthode(s) utilisée(s);
c. les valeurs obtenues en utilisant telle(s) méthode(s);
d. le point de savoir si l'importance relative attribuée aux méthodes d'évaluation appliquées peut être considérée
comme étant généralement acceptable aux Pays-Bas;
e. la description de toutes difficultés d'évaluation particulières survenues lors de l'évaluation et de la détermination du
rapport d'échange.»
Suite à la prise en charge par la Société de tous les passifs de Mittal Steel Company N.V., l'actionnaire unique reconnaît
qu'avec effet au jour de la publication du présent acte notarié au Mémorial, les options sur actions de Mittal Steel Company
N.V. sont converties en options sur actions de la Société (les «Options sur Actions de la Société») comme suit:
1. chaque Option sur Actions de la Société attribuée aux détenteurs d'options sur actions Mittal Steel Company N.V.
donnera droit à la souscription ou à l'acquisition, suivant le cas, d'une (1) action de la Société;
2. le prix d'exercice des Options sur Actions de la Société attribuées aux détenteurs d'options sur actions Mittal Steel
Company N.V. sera égal au prix d'exercice des options sur actions Mittal Steel Company N.V.; et
3. les Options sur Actions de la Société seront soumises à des termes et conditions similaires à ceux du plan d'options
de Mittal Steel Company N.V. daté du 15 septembre 1999 tel que modifié ultérieurement (sous réserve de toute modi-
fication nécessaire afin de refléter la réalisation de la Fusion).
L'actionnaire unique décide d'accorder les pouvoirs les plus larges au Conseil d'Administration pour la mise en oeuvre
de cette décision. Il a été constaté que le nombre d'options sur actions de Mittal Steel Company N.V. en circulation
représente un maximum de treize millions cinq cent mille (13.500.000).
<i>Troisième résolutioni>
L'actionnaire unique décide d'attribuer les Actions de Fusion aux actionnaires de Mittal Steel Company N.V. propor-
tionnellement à leur participation dans Mittal Steel Company N.V. avec effet au jour de la publication de cet acte notarié
au Mémorial.
L'actionnaire unique charge le Conseil d'Administration de répartir les Actions de Fusion entre les actionnaires de
Mittal Steel Company N.V. à la date d'effet de la Fusion comme suit:
- une (1) Action de Fusion pour une (1) action de Classe A de Mittal Steel Company N.V. aux détenteurs d'actions de
Classe A de Mittal Steel Company N.V. existantes à ce moment-là et une (1) Action de Fusion pour une (1) action de
Classe B de Mittal Steel Company N.V. aux détenteurs d'actions de Classe B de Mittal Steel Company N.V. existantes à
ce moment-là.
Les Actions de Fusion auront droit à toute distribution réalisée sur les actions de la Société à partir de la prise d'effet
de la Fusion.
L'actionnaire unique charge le Conseil d'Administration de répartir, avec effet au jour de la publication du présent acte
notarié au Mémorial, les Options sur Actions de la Société entre les détenteurs d'options sur actions de Mittal Steel
Company N.V. comme suit:
- une (1) Option sur Actions de la Société pour une (1) option sur actions de Mittal Steel Company N.V.
<i>Quatrième résolutioni>
L'actionnaire unique décide d'annuler avec effet au jour de la publication du présent acte notarié au Mémorial, les trois
millions cent mille (3.100.000) actions de la Société détenues par Mittal Steel Company N.V. et transférées à la Société
suite à la Fusion, conformément à l'Article 49 (3) de la LSC et par conséquent de réduire le capital social de la Société à
89550
concurrence de trente et un mille euros (31.000 €) afin de le ramener à quatorze millions cent soixante-douze mille
soixante-douze euros cinquante-trois centimes (14.172.072,53 €) et pour la différence entre la valeur comptable des
actions dans les comptes de Mittal Steel Company N.V. et leur pair comptable de réduire le compte de prime de fusion.
<i>Cinquième résolutioni>
Conformément aux résolutions qui précèdent, l'actionnaire unique décide de modifier le premier paragraphe de l'Ar-
ticle 5 des Statuts de la Société comme suit:
Le capital social souscrit s'élève à quatorze millions cent soixante-douze mille soixante-douze euros cinquante-trois
centimes (14.172.072,53 €). Il est représenté par un milliard quatre cent dix-sept millions deux cent sept mille deux cent
cinquante-trois (1.417.207.253) actions, sans valeur nominale, toutes entièrement libérées.
<i>Sixième résolutioni>
L'actionnaire unique constate que l'Article 5.5 des Statuts de la Société autorise le Conseil d'Administration de la
Société à émettre des actions de la Société dans les limites du capital autorisé notamment pour délivrance lors de l'exercice
ou la conversion des options sur actions de la Société et d'autres allocations d'actions octroyées dans le cadre de tout
plan destiné aux salariés, à caractère incitatif ou visant à attribuer des avantages, mis en place par la Société et que par
conséquent aucune autorisation supplémentaire n'est requise.
<i>Septième résolutioni>
L'actionnaire unique décide d'autoriser, avec effet au jour de la publication du présent acte notarié au Mémorial, le
Conseil d'Administration de la Société, avec pouvoir de délégation, et les organes sociaux des autres sociétés du groupe
au sens de l'Article 49bis de la LSC d'acquérir et de vendre des actions de la Société, aux conditions prévues dans la LSC.
De tels achats et ventes peuvent être réalisés pour tout but autorisé ou qui pourrait venir à être autorisé par les lois
et règlements en vigueur et en particulier pour conclure des opérations hors marché et «over the counter» et acquérir
des actions de la Société au moyen d'instruments financiers dérivés.
Conformément aux lois transposant la Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et le Règlement CE 2273/2003 du 22
décembre 2003, les acquisitions, les cessions, les échanges, les apports et les transferts de valeurs mobilières peuvent
être effectués par tous moyens, sur ou hors marché, en ce compris par une offre publique de racheter des actions ou
par l'utilisation de stratégies de dérivés ou d'options. La part du capital acquis ou transféré sous la forme d'un bloc de
valeurs mobilières peut couvrir l'entièreté du programme. Ces opérations peuvent être réalisées à tout moment, en ce
compris durant une période d'offre d'achat conformément à la réglementation applicable.
L'autorisation est valable pour une période de dix-huit (18) mois ou jusqu'à la date de son renouvellement par décision
de l'assemblée générale des actionnaires si cette date de renouvellement est antérieure à cette période.
Le nombre maximum d'actions qui peut être acquis est le maximum autorisé par la LSC de telle sorte que le pair
comptable des actions de la Société détenues par la Société (ou d'autres sociétés du groupe au sens de l'Article 49bis de
la LSC) ne puisse en aucun cas excéder 10% de son capital social souscrit.
Le prix d'achat par action à payer en numéraire ne devra pas excéder 125% du prix sur la bourse de New York ou
sur le marché d'Euronext Amsterdam par NYSE Euronext, Euronext Bruxelles par NYSE Euronext, Euronext Paris par
NYSE Euronext, le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg ou sur les bourses de Barcelone, Bilbao, Madrid et
Valence, selon le marché sur lequel les opérations sont effectuées, et ne devra pas être inférieur au pair comptable de
l'action au moment du rachat. Le prix d'achat maximum pour les opérations hors marché, sera 125% du prix sur Euronext
Paris par NYSE Euronext. Le prix sur la bourse de New York ou sur le marché d'Euronext Amsterdam par NYSE Euronext,
Euronext Bruxelles par NYSE Euronext, Euronext Paris par NYSE Euronext, le marché réglementé de la Bourse de
Luxembourg ou sur les bourses de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence sera réputé égal au plus élevé de la moyenne du
cours de clôture par action sur le marché concerné au cours des 30 jours consécutifs pendant lesquels le marché concerné
est ouvert aux négociations précédant les 3 jours de bourse avant la date du rachat. Dans le cas d'une augmentation de
capital par incorporation de réserves ou de primes d'émission et de l'attribution gratuite d'actions ainsi que dans le cas
de division ou de regroupement des actions, les prix d'achat indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient égal au
rapport entre le nombre d'actions représentant le capital social avant l'opération et tel nombre suite à l'opération.
Le montant total alloué pour le programme de rachat d'actions de la Société ne peut en aucun cas excéder le montant
des fonds propres disponibles de la Société.
Tous pouvoirs sont octroyés au Conseil d'Administration, avec pouvoirs de délégation, en vue d'assurer la mise en
oeuvre de cette autorisation.
<i>Huitième résolutioni>
L'actionnaire unique approuve la démission des membres actuels du Conseil d'Administration, Messieurs Bhikam
Agarwal, Albert Rinnen, Armand Gobber, Henk Scheffer et Claude Witry avec effet au 28 août 2007.
<i>Neuvième résolutioni>
L'actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes en tant que membres du Conseil d'Administration de
la Société avec effet au 28 août 2007:
89551
1) Lakshmi N. Mittal, né à Sadulpur (Inde) le 15 juin 1950, avec adresse professionnelle à Berkeley Square House,
Berkeley Square, GB-W1J 6DA Londres, Royaume-Uni;
2) Joseph J. Kinsch, né à Esch sur Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) le 2 mai 1933, avec adresse professionnelle
au 19, Avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
3) José Ramón Álvarez-Rendueles Medina, né à Giron (Espagne) le 17 juin 1940, demeurant au 3, Calle Albacete,
E-28027 Madrid, Espagne;
4) Edmond Pachura, né à Oignies (France) le 31 janvier 1934, demeurant au 65, Avenue Victor Hugo, F-75116 Paris,
France;
5) SAR Prince Guillaume de Luxembourg, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 1
er
mai 1963, demeu-
rant au 53, rue des Prés, L-5316 Contern, Grand-Duché de Luxembourg;
6) Sergio Silva de Freitas, né à Rio De Janeiro (Brésil) le 16 janvier 1943, demeurant au 7076, Av. Eng. Armando Arrunda
Pereira, BR-04344902 São Paulo, Brésil;
7) Jean-Pierre Hansen, né à Athus (Belgique) le 25 avril 1948, demeurant au 1, Place du Trône, B-1000 Bruxelles,
Belgique;
8) Vanisha Mittal Bhatia, née à Surabaja (Indonésie) le 23 août 1980, avec adresse professionnelle à Berkeley Square
House, Berkeley Square, GB-W1J 6DA Londres, Royaume-Uni;
9) Wilbur L. Ross, né à Weehawken (Etats-Unis) le 28 novembre 1937, demeurant au 600, Lexington Avenue (19
ième
étage), NY 10022 New York, Etats-Unis;
10) Lewis Kaden, né à Perth Amboy (Etats-Unis) le 24 mars 1942, demeurant au 399 Park Avenue (2
ième
étage), NY
10022 New York, Etats-Unis;
11) François H.J. Pinault, né à Champs Giraud (France) le 21 août 1936, demeurant au 12, rue François 1
er
, F-75008
Paris, France;
12) Narayanan Vaghul, né à Ulundurpet, Tamil Nadu, (Inde) le 4 août 1936, demeurant au 63, First Main Road, IND-
RA Puram (Chennai) 600028, Inde;
13) Georges T.N. Schmit, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 19 avril 1953, avec adresse profes-
sionnelle au 6, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
14) Antoine R. Spillmann, né à Solothurn (Suisse) le 4 avril 1963, demeurant au 7/11, Avenue Pasteur, L-2311 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg;
15) Romain C.L. Zaleski, né à Paris (France) le 7 février 1933, demeurant au 74, Ottava Strada, I-20090 San Felice di
Segrate, Italie;
16) John O. Castegnaro, né à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg), le 3 novembre 1944, demeurant au 25, rue
St Joseph, L-3736 Rumelange, Grand-Duché de Luxembourg;
17) Michel A. Marti, né à Castellon (Espagne) le 6 juillet 1947, demeurant au 14, Impasse Paul Gauguin, F-77190, Broye,
France;
18) Manuel Fernandéz López, né à Mieres (Espagne) le 8 juin 1947, demeurant au 25, Avenida de America, E-28002
Madrid, Espagne.
Leur mandat expirera lors de la troisième assemblée générale annuelle suivant la date de leur nomination.
<i>Dixième résolutioni>
L'actionnaire unique décide de nommer Deloitte S.A. ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg en tant que réviseur d'entreprises de la Société. Le mandat du réviseur d'entreprises expirera à l'assemblée générale
annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2007.
<i>Onzième résolutioni>
L'actionnaire unique constate que la Fusion et tous les autres points objets des résolutions précédentes prendront
effet le 3 septembre 2007, la date de publication du présent acte notarié au Mémorial, à l'exception des résolutions
concernant la démission et la nomination des administrateurs.
<i>Déclarationi>
Conformément à l'Article 271 (2) de la LSC, le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié et attesté l'existence et la
légalité, en droit luxembourgeois, des actes et formalités incombant à la Société en vue de la réalisation de la Fusion.
Il résulte en outre d'un certificat, annexé au présent acte, établi en date du 28 août 2007 par Marcel Dirk Pieter Anker,
notaire de droit civil, demeurant à Amsterdam, qu'hormis l'acte notarié de fusion soumis au droit néerlandais, dont la
signature est fixée le 2 septembre 2007, les exigences procédurales prévues par le Chapitre 2 du Titre 7 du Livre 2 du
DCC (qui incluent les dispositions générales applicables aux fusions) et le Chapitre 3 du Titre 7 du Livre 2 du DCC (qui
incluent les dispositions applicables aux fusions des sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée) et par les
statuts de Mittal Steel Company N.V., afin d'effectuer la Fusion ont été dûment observées. Il résulte en outre du certificat
prémentionné que la Fusion sera effective en vertu du droit néerlandais, le jour suivant la signature de l'acte notarié de
fusion soumis au droit néerlandais.
89552
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison du présent acte, est estimé à 20.000 €.
La contribution de tous les actifs et passifs de Mittal Steel Company N.V. est faite conformément aux dispositions de
l'article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom, état et demeure,
ladite personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Jokubauskaite, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 août 2007. Relation: LAC/2007/24077. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): F. Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 29 août 2007.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007093200/212/720.
(070115557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2007.
Pool Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 77.786.
<i>Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle tenue le 25 mai 2007i>
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Fabio Mazzoni, demeurant
professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg et de Monsieur Antonio Monti, demeurant au 2, via Trevano,
CH-6900 Lugano, Suisse avec effet immédiat.
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes WOOD, APPLETON, OLIVER
EXPERTS-COMPTABLES S.à r.l, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée Générale prend note de la démission de Mr Benoît Georis de son poste d'administrateur de la Société
avec effet immédiat.
L'Assemblée Générale nomme en remplacement Mr José Correia, né le 4 octobre 1971 à Palmeira, Portugal, résidant
professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg au poste d'administrateur de la Société avec effet immédiat.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007087000/587/26.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2007, réf. LSO-CF02235. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2007.
Doba S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 94.316.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 2 mai 2007 que:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale révoque dans leur qualité d'administrateurs:
89553
- Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20.
- Monsieur Edmund Kisters, employé privé, demeurant à L-9992 Weiswampach, Cité Grait, 3.
L'assemblée générale nomme comme nouveaux administrateurs de la société DOBA S.A.:
- Monsieur Zoltán Végh, administrateur, demeurant à H-1155 Budapest, Naspolya u. 16.
- La société WEPAS HOLDING A.G., ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.
- La société EAST WEST CONSULTING COMPANY S.A., ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires se tenant en 2010.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale révoque dans sa qualité d'administrateur délégué:
- Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 2 mai 2007.
<i>Pour la société
i>EURO COMPTES & PARTNERS
Signature
Référence de publication: 2007087307/2602/28.
Enregistré à Diekirch, le 25 juillet 2007, réf. DSO-CG00272. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(070097374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Luxpatates S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7312 Mullendorf, Im Rothfeldchen.
R.C.S. Luxembourg B 45.269.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2007.
<i>Le gérant
i>Signatures
Référence de publication: 2007087309/1019/14.
Enregistré à Diekirch, le 4 juillet 2007, réf. DSO-CG00027. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070096747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Pépinière Martin Wahl S.e.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: L-9365 Eppeldorf, 7, rue Faubourg.
R.C.S. Luxembourg B 102.039.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Gloden
Référence de publication: 2007087310/1019/12.
Enregistré à Diekirch, le 4 juillet 2007, réf. DSO-CG00030. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070096767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Aprovia Management GUN, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 411.075,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 87.902.
Il résulte de plusieurs transferts de parts sociales sous seing privé en date du 14 juin 2007 que sept mille quatre (7.004)
parts sociales de catégorie A de la Société ont été transférées à la société APROVIA GROUP HOLDING S.à r.l, société
89554
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 87.080, comme suit:
1. trois mille cent dix-sept (3.117) parts sociales de catégorie A ont été transférées par M. Philippe Clerget;
2. deux mille quatre cent vingt-neuf (2.429) parts sociales de catégorie A ont été transférées par M. Jean-Léon Van-
doorne;
3. mille quatre cent cinquante-huit (1.458) parts sociales de catégorie A ont été transférées par Mme Laurence Doyen.
Suite à ces transferts, les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:
1. 1 part sociale de catégorie B par THE THIRD CINVEN FUND (N°.1) LIMITED PARTNERSHIP;
2. 1 part sociale de catégorie B par THE THIRD CINVEN FUND (N°.4) LIMITED PARTNERSHIP;
3. 1 part sociale de catégorie B par THE THIRD CINVEN FUND US (N°.2) LIMITED PARTNERSHIP;
4. 2 parts sociales de catégorie B par CARLYLE LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 3, S.à r.l;
5. 2.429 parts sociales de catégorie A par Patricia Berthomier;
6. 2.024 parts sociales de catégorie A par Marc Davisseau;
7. 1.579 parts sociales de catégorie A par Georges Marécaux;
8. 1.458 parts sociales de catégorie A par Henri Loizeau;
9. 972 parts sociales de catégorie A par Caroline Nourry;
10. 972 parts sociales de catégorie A par Eric Faure;
11. 7.004 parts sociales de catégorie A par APROVIA GROUP HOLDING S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2007.
<i>Pour APROVIA MANAGEMENT GUN
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007086996/250/35.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2007, réf. LSO-CG06685. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2007.
Investor Services House S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 54.140.
Le bilan au 29 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007087045/1024/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2007, réf. LSO-CG07824. - Reçu 36 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Blamar S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 62.980.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2007087046/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2007, réf. LSO-CG07914. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2007.
89555
Aresa Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 93.337.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 27 juin 2007 a renouvellé les mandats des administrateurs et
du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean-Yves Nicolas
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2013.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2007086988/693/23.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2007, réf. LSO-CG04809. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2007.
Starlife S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 57.346.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 14 juin 2007 a renouvelé les mandats des administrateurs et
du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Gioacchino Paolo Ligresti, Président, administrateur A, domicilié à Via Balestra 17, 6900 Lugano, Suisse
- Giulia Maria Ligresti, Vice-Présidente, administrateur A, domicilié à Via Locatelli 1, 20121 Milan, Italie
- Giorgio Antonini, administrateur A, domicilié à Via Carona 3, 6900 Lugano, Suisse
- Jean Hoffmann, administrateur B, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg
- Marc Koeune, administrateur B, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg
- Nicole Thommes, administrateur B, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg.
Le commissaire aux compte est FIDIREVISA S.A., avec siège social à Via Pioda 14, 6901 Lugano, Suisse.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2013.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2007086994/693/25.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2007, réf. LSO-CG04835. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2007.
89556
Bugatti International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 26.124.
<i>Beschluss des Verwaltungsrates zum 5. Juni 2007i>
Herr Hans-Georg Melching, wird zum Delegierten des Verwaltungsrates ernannt und in diesem Rahmen mit der
täglichen Geschäftsführung beauftragt.
Zum Vermerk im Luxemburger Amtsblatt Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.
Luxemburg, den 10. Juli 2007.
BUGATTI INTERNATIONAL S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2007086997/250/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06540. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070096396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2007.
Café Eselsstiffchen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9216 Diekirch, 47, rue de la Croix.
R.C.S. Luxembourg B 116.786.
<i>Décisions des associési>
Suite à la démission au 30 juin 2007 de Madame De Lima Vilar Maria Joao, comme gérante technique de la société
CAFE ESELSSTIFFCHEN S.à r.l., les associés de la société ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La démission de Madame De Lima Vilar Maria Joao en sa qualité de gérante technique est acceptée. Madame De Lima
Vilar Maria Joao cesse donc ses activités de gérante technique de la société avec effet au 30 juin 2007.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée nouvelle gérante technique, à partir du 1
er
juillet 2007, avec pouvoir d'engager à elle seule la société avec
sa signature, Madame Lima Dos Santos Maria Orlinda, née le 29 juillet 1962 à Vale Maior (P), demeurant à L-9216 Diekirch,
11, rue de la Croix.
Diekirch, le 28 juin 2007.
C. Fernandes Santos / M.O. Lima Dos Santos
Référence de publication: 2007087321/591/20.
Enregistré à Diekirch, le 18 juillet 2007, réf. DSO-CG00180. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070096730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
EPD Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 128.207.
- Suivant un certificat de changement au certificat de constitution, en date du 26 juin 2007, EPD INC., l'associé unique
de la Société, a changé de dénomination, et portera désormais la dénomination suivante: VEYANCE TECHNOLOGIES,
INC. et le numéro d'immatriculation de l'associé unique de la Société doit être modifié comme suit: 4320494.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2007.
EPD LUXEMBOURG S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007086999/250/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06550. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2007.
89557
Juharfa Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 96.894.
<i>Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 19 juin 2007i>
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Philippe Vanderhoven de son poste d'administrateur de la société avec
effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée nomme Monsieur José Correia, résidant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, au
poste d'administrateur de la société avec effet immédiat.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée prend note du transfert de siège social du Commissaire Aux Comptes de la société, à savoir WOOD,
APPLETON, OLIVER EXPERTS-COMPTABLES S. à r.l, du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet rétroactif au 24 avril 2006.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007087004/587/24.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, réf. LSO-CF10400. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2007.
Financière Wolf S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 108.580.
Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007087047/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2007, réf. LSO-CG07791. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Romafi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 118.507.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2007087037/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2007, réf. LSO-CG07911. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2007.
Pobeier & Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6471 Echternach, 10, rue du Pont.
R.C.S. Luxembourg B 109.125.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
89558
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2007.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007087038/1091/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2007, réf. LSO-CG07288. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Plutonite Stone S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 96.284.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2007.
B. Felten
<i>Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2007089273/500/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10689. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070099984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.
Teixeira Construction Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5770 Weiler-la-Tour, 26A, rue du Schlammestee.
R.C.S. Luxembourg B 106.956.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiler-la-Tour, le 24 juin 2007.
José Goncalves Teixeira
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007089272/500/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10698. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070099986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.
Resort Development AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 107.212.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007089257/1152/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2007, réf. LSO-CG05494. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070099893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.
ROYAL REAL ESTATE International, Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 90.992.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
89559
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007089244/1152/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2007, réf. LSO-CG05493. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070099894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.
Oraxys S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1452 Luxembourg, 52, rue Théodore Eberhard.
R.C.S. Luxembourg B 112.196.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007089242/7478/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2007, réf. LSO-CG11124. - Reçu 101 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070099898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.
SDG Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 108.153.
EXTRAIT
II résulte de trois courriers envoyés à la société SDG HOLDING SARL en date du 9 juillet 2007 que:
- le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat et que la convention de domiciliation conclue entre la société
SDG HOLDING SARL et WILSON ASSOCIATES a également été dénoncée avec effet immédiat;
- Mademoiselle Cindy Reiners et Monsieur Graham J. Wilson ont démissionné en tant que Gérants de la société avec
effet immédiat.
Luxembourg, le 9 juillet 2007.
Pour extrait conforme
Par mandat
Signature
Référence de publication: 2007087662/803/18.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2007, réf. LSO-CG07977. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Logistic Investment Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 102.752.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LOGISTIC INVESTMENT HOLDING S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2007087667/5983/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09878. - Reçu 109 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
89560
Alceos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 116.616.
Constituée suivant acte reçu par M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à L-Junglinster, en date du 12 mai 2006, publié
au Mémorial, Recueil Spécial C n
o
1467 du 31 juillet 2006.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement à L-2450 Luxembourg,
15, boulevard Roosevelt, en date du 18 mai 2007 que:
- le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat au 223, Val Sainte Croix à L-1371 Luxembourg.
- démission d'un administrateur, à savoir:
* Mademoiselle Katia Roti, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe
Fischer.
- démission du commissaire aux comptes, à savoir:
* Monsieur Pascal Bonnet, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
- ont été nommés en remplacement:
<i>au poste d'administrateur:i>
* Mademoiselle Aude Rabemananjara, Etudiante, demeurant à F-92160 Antony, 17, rue de Verdun.
<i>au poste de commissaire aux comptes:i>
* REVILUX S.A. avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223 Val Sainte Croix.
Tous ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.
Luxembourg, le 18 mai 2007.
<i>Pour la société ALCEOS S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2007087668/687/29.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2007, réf. LSO-CG05828. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Gallo Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 50.282.
Le bilan de clôture au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de1 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007087648/604/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06462. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
European Logistics, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 102.727.
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
89561
<i>Pour EUROPEAN LOGISTICS
i>Signature
Référence de publication: 2007087661/6009/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2007, réf. LSO-CG09881. - Reçu 109 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2007.
CSC Computer Sciences Luxembourg SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.901.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration en date du 28 juin 2007i>
1. M. Jean-Michel Marq, né le 26 juin 1951 à Hautes Rivières, France, demeurant 5, rue du Parc, 8031 Strassen, Lu-
xembourg, est nommé en tant que délégué à la gestion journalière, avec pouvoir de co-signature obligatoire avec tout
autre administrateur ou délégué à la gestion journalière avec effet au 3 juillet 2007 pour une durée indéterminée.
2. Le siège social de la Société est transféré du 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg au Goldbell Center, 5, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 2 juillet 2007.
Luxembourg, le 10 juillet 2007.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007087672/631/20.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2007, réf. LSO-CG06691. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Delta Investment AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 97.379.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007089267/1152/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2007, réf. LSO-CG05473. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070099884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.
Commerc' Printing S.A., Société Anonyme,
(anc. Gerard Klopp S.A.).
Siège social: L-3378 Livange, Zone Commerciale, route de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 43.186.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2007.
FIDUCIAIRE HELLERS, KOS & ASOCIES, S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007087207/7262/15.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06182. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
89562
Clear Vision International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 72.155.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2007.
FIDUCIARE HELLERS, KOS & ASSOCIES S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007087213/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06180. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070097044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Brasserie Georges VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 5, place de Paris.
R.C.S. Luxembourg B 30.012.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2007.
FIDUCIARE HELLERS, KOS & ASSOCIES S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007087214/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2007, réf. LSO-CG06178. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Aton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 122.875.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007089260/1152/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2007, réf. LSO-CG05477. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070099887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.
Business Go Asia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 101.088.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007089236/1152/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10337. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070099873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.
89563
Kaalk Production S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 119.315.
Le bilan au 31 décembre 2006 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007089233/4775/13.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10477. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070099832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.
Oceni Opportunities S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 116.835.
Le bilan au 31 décembre 2006 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007089232/4775/13.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10471. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070099833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.
Merkur Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 115.095.
Le bilan au 31 décembre 2006 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007089231/4775/13.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2007, réf. LSO-CG10467. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070099835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007.
Auto-Sport Shop s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9047 Ettelbruck, 32, rue Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 102.138.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 juillet 2007.
<i>Pour la société
i>EURO COMPTES & PARTNERS
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007087194/2602/16.
Enregistré à Diekirch, le 25 juillet 2007, réf. DSO-CG00259. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070097337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
89564
LUX-Montage SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 97.890.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 juillet 2007.
<i>Pour la société
i>EURO COMPTES & PARTNERS
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007087195/2602/16.
Enregistré à Diekirch, le 25 juillet 2007, réf. DSO-CG00270. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(070097340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Hawaii Invest S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 103.965.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 juillet 2007.
<i>Pour la société
i>EURO COMPTES & PARTNERS
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007087196/2602/16.
Enregistré à Diekirch, le 25 juillet 2007, réf. DSO-CG00268. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070097342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Naxo S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 99.809.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 juillet 2007.
<i>Pour la société
i>EURO COMPTES & PARTNERS
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007087197/2602/16.
Enregistré à Diekirch, le 25 juillet 2007, réf. DSO-CG00266. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070097345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Maraton International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 104.318.
Le bilan au 31 décembre 2006, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
89565
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007087048/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2007, réf. LSO-CG07798. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Initiatives Céramiques S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 102.268.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2007.
Signature
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2007087053/535/14.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2007, réf. LSO-CG08424. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070096716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Chauffage-Sanitaire Schmit Nico Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9835 Hoscheid-Dickt, 31, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 104.594.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 juillet 2007.
<i>Pour la société
i>EURO COMPTES & PARTNERS
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007087300/2602/16.
Enregistré à Diekirch, le 25 juillet 2007, réf. DSO-CG00264. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070097360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
SO Bois, Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 62.
R.C.S. Luxembourg B 95.791.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 juillet 2007.
<i>Pour la société
i>EURO COMPTES & PARTNERS
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007087301/2602/16.
Enregistré à Diekirch, le 25 juillet 2007, réf. DSO-CG00262. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070097361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
89566
Luxspreng S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9415 Vianden, 1, route de Bettel.
R.C.S. Luxembourg B 99.946.
Le bilan au 5 avril 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 juillet 2007.
<i>Pour la société
i>EURO COMPTES & PARTNERS
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007087302/2602/16.
Enregistré à Diekirch, le 25 juillet 2007, réf. DSO-CG00261. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Tholl.
(070097363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Pyrolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9160 Ingeldorf, 1bis, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 95.950.
Le bilan au 5 avril 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 juillet 2007.
<i>Pour la société
i>EURO COMPTES & PARTNERS
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007087193/2602/16.
Enregistré à Diekirch, le 25 juillet 2007, réf. DSO-CG00260. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070097335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Service Center Schmit Nico S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9835 Hoscheid-Dickt, 31, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 98.415.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 juillet 2007.
<i>Pour la société
i>EURO COMPTES & PARTNERS
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007087192/2602/16.
Enregistré à Diekirch, le 25 juillet 2007, réf. DSO-CG00254. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
(070097333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
S.C.O.N.A. Holding S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.
R.C.S. Luxembourg B 107.031.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
89567
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 24 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007087412/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2007, réf. LSO-CG07952. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Sanolux G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.
R.C.S. Luxembourg B 95.837.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 24 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007087411/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2007, réf. LSO-CG07953. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070097069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Raiffeisen-Markt-Echternach s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 93.332.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 24 juillet 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007087413/6261/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2007, réf. LSO-CG07951. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Perignon Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 72.008.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinairei>
<i>tenue au siège social en date du 2 janvier 2006i>
La démission de Monsieur Stéphane Best demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg,
avec effet au 30 août 2006, au poste de Commissaire aux Comptes, est acceptée.
La nomination de la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER & Cie S.à.r.l ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg, au poste de Commissaire aux Comptes, avec effet au 1
er
septembre 2006, en remplacement de Monsieur
Stéphane Best est acceptée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
PERIGNON IMMOBILIERE S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007087734/780/21.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2007, réf. LSO-CG08194. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070097042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
89568
Alceos S.A.
Aprovia Management GUN
ArcelorMittal
Aresa Finance S.A.
Aton S.à r.l.
Auto-Sport Shop s.à.r.l.
Blamar S.A.
Brasserie Georges VI S.à r.l.
Bugatti International S.A.
Business Go Asia S.A.
Café Eselsstiffchen S.à r.l.
Chauffage-Sanitaire Schmit Nico Sàrl
Clear Vision International S.A.
Commerc' Printing S.A.
CSC Computer Sciences Luxembourg SA
Delta Investment AG
Doba S.A.
EPD Luxembourg S.à r.l.
European Logistics
Financière Wolf S.A.
Gallo Services S.à r.l.
Gerard Klopp S.A.
Hawaii Invest S.A.H.
Initiatives Céramiques S.à r.l.
Investor Services House S.A.
Juharfa Finance S.A.
Kaalk Production S.à r.l.
Logistic Investment Holding S. à r.l.
LUX-Montage SA
Luxpatates S.àr.l.
Luxspreng S.à r.l.
Maraton International S.A.
Merkur Financière S.A.
MPC Global Maritime Opportunities S.A.
Naxo S.A.H.
Oceni Opportunities S.A.
Oraxys S.A.
Pépinière Martin Wahl S.e.n.c.
Perignon Immobilière S.A.
Plutonite Stone S.A.
Pobeier & Co S.à r.l.
Pool Investment S.A.
Pyrolux S.à r.l.
Raiffeisen-Markt-Echternach s.à r.l.
Resort Development AG
Romafi S.A.
ROYAL REAL ESTATE International
Sanolux G.m.b.H.
S.C.O.N.A. Holding S.A.H.
SDG Holding S.à r.l.
Service Center Schmit Nico S.à r.l.
SO Bois, Sàrl
Starlife S.A.
Teixeira Construction Sàrl