logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1679

8 août 2007

SOMMAIRE

Agence Immobilière Henri GOEDERT S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80589

AGF Life Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . .

80574

Alpha Engineering S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

80568

Arise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80590

ARJUFRA Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

80576

Babet S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80576

Bacur S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80589

BERENGER Investment S.A.  . . . . . . . . . . . .

80588

Bureau Moderne S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80572

Byblos Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

80561

Canalux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80577

Catella Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

80577

Cheryl Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . .

80573

CHLEPAM Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

80576

C.M.W. Canadian Mineral Water Develop-

ment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80592

C.M.W. Canadian Mineral Water Develop-

ment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80591

Colupa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80591

Dolvifra Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80589

EFF Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

80576

Elca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80574

Eurotransnord s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80555

Fendi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80574

FIF Partenariat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80587

Finover S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80577

Geocontrol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80575

Global Insurance & Reinsurance Consul-

tants (G.I.R.C.) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80574

Goedert-Helfent Immobilière S.A. . . . . . . .

80588

Goedert Immobilière S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

80589

Immobilière DUWEL S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

80554

Immobilière Scheergaass S.A.  . . . . . . . . . . .

80554

Immo Leu Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . .

80592

Jucari S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80572

Kauri Capital 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80570

Lexfam S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80575

Leya S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80573

Manuflex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80573

New Zealand Properties S.A.  . . . . . . . . . . .

80592

North Island Properties S.A.  . . . . . . . . . . . .

80592

Oleandri S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80567

Reech AiM Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80575

Reed S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80591

Reed S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80591

Rock Ridge RE 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80555

R & S International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

80572

Sabco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80553

Salvia Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80573

SDB Finanziaria S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80569

Serilux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80554

Sigma Capital Hospitality, Leisure and

Tourism Holding Company S.A. . . . . . . . .

80578

Sobedy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80590

Socamil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80591

Société Générale d'Investissements S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80588

Tafi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80554

Taqui Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80590

TG Leasing (Lux) S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

80546

Tozeur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80567

Universal Sales and Services S.A.  . . . . . . . .

80575

WGRM Holding 7 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80577

80545

TG Leasing (Lux) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 129.267.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the fourteenth day of June.
Before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company GT GLOBAL INVEST (LUX) S.àr.l., a société à responsabilité limitée organized and existing under the

laws of Luxembourg with registered office at 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, registered with the trade register
in Luxembourg under number B 127.042, represented herein by Mr Lorenzo Patrassi, manager, with professional address
at 26, rue Philippe II L-2340 Luxembourg by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg, on
13th June 2007.

The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,

shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the following articles of association (hereafter the

«Articles») of a company which she declares to establish as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of TG

LEASING (LUX) S.àr.l. (hereafter the «Company»), which is governed by the laws of Luxembourg, in particular by the
law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present Articles.

Art. 2. Registered office.
2.1.  The  registered office of the Company is  established  in  Luxembourg-City,  Grand  Duchy  of  Luxembourg.  The

registered office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
board of managers (as used in these Articles, «board of managers» means the sole manager if the said board consists of
a single manager only) of the Company. The registered office may further be transferred to any other place within the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of partners (as used in these Articles,
«general meeting of partners» means the sole partner if there is no more than one partner) adopted in the manner
required for the amendment of these Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers determines that extraordinary
political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would
interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between
such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company
which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Purpose.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies

or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries and/or affiliated companies. It may also
give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
subsidiaries and/or affiliated companies. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise
hypothecate all or some of its assets.

3.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

80546

Art 4. Duration.
4.1. The duration of the Company is unlimited.
4.2  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or other similar event affecting one or more of its partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by

twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed
and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment of the Articles and in accordance with
the Law.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties. If the

Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is being made to articles
189 and 190 of the Law.

6.4. A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the general meeting of

partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of
managers. Manager(s) need not be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time without cause (ad nutum).

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by Law or these Articles to the general meeting of partners shall fall within the

competence of the board of managers, which shall be empowered to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more agents, whether partners or

not, by any manager of the Company.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state that they were duly informed and had full knowledge of the agenda of the
meeting. The notice may be waived by a consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of
each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are valid if approved by a majority of the votes cast. Resolutions of the board of
managers shall be recorded in minutes signed by all managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. Participation in a meeting by such means is deemed to constitute participation in person at such meeting.

80547

9.7. Circular resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple counterparts of identical minutes
and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound in all matters by the sole signature of its single manager, and,

in case of plurality of managers, by the joint signature of any two of the members of the board of managers or by the
joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with
article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company provided that such commitment is in compliance
with these Articles and with applicable Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. If the Company is owned by a sole partner, such partner shall have all powers conferred by Law to the general

meeting of partners.

12.2. Each partner shall have voting rights in proportion to the partner's ownership interest in the Company.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of partners may be taken without a meeting by

circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the resolution. Signatures of partners may appear on a
single document or on multiple counterparts of an identical resolution and may be evidenced by original or facsimile
signature.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than one half of

the share capital of the Company.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and end on the thirty-

first day of December.

Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts shall be established,

and the board of managers shall prepare a balance sheet setting out the Company's assets and liabilities and the profit
and loss account.

14.2. The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted for approval to the general meeting of

partners who shall vote specifically as to whether discharge is given to the board of managers and, if applicable, the
statutory auditors.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company as stated in its annual accounting, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses, shall constitute the Company's net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits
of the Company shall be annually allocated to the statutory reserve, until the reserve is equal to ten per cent (10%) of
the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) Interim accounts are established by at least one manager;
(ii) These interim accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
(iii) The decision to pay interim dividends is taken by general meeting of the partners;
(iv) The above decision is taken after the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the

Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not be partners, appointed by resolution of the general meeting of partners, which will determine the powers and
remuneration of the liquidators. Unless otherwise provided in the resolution of the partner(s) or by law, the liquidators

80548

shall be invested with the broadest powers available under applicable law for the realisation of assets and payment of the
liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company shall be dis-

tributed to the partners in proportion to their share ownership in the Company.

VII. General provision

17. Reference is made to the provisions of applicable Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2007.

<i>Subscription-Payment

The shares in the Company have been subscribed as follows:

The Company GT GLOBAL INVEST (LUX) S.à.r.l., prenamed, twelve thousand five hundred shares . . . . . . 12,500
Total: twelve thousand five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500

The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro

(EUR 12,500.-) is as of now at the free disposal of the Company.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro (EUR 1,700.-).

<i>General meeting of partners

The appearing party, representing the entire subscribed share capital and considering himself as having been duly

convened, immediately proceeded to hold a general meeting of partners of the Company.

Having first verified that it was regularly constituted, she has passed the following resolutions by unanimous vote:
(i) that the number of the members of the board of managers of the Company be set at four (4);
(ii) that there be appointed as members of the board of managers of the Company for an unlimited duration the

following persons:

(a) Mr Tomas Lichy, Manager, born in Ostrava (Czech Republic), on 25th November 1972, whose business address is

26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg;

(b) Mr Iain Macleod, Manager, born in Glasgow (United Kingdom) on 8th August 1955, whose business address is 59,

Cité Millewee, L-8064 Bertrange (Luxembourg);

(c) Mr Thijs van Ingen, Manager, born in Tiel (the Netherlands) on 5th December 1974, whose business address is 20,

rue de la Poste L - 2346 Luxembourg;

(d) Mr Lorenzo Patrassi, Manager, born in Padova (Italy), on 22nd April 1972, whose business address is 26, rue Philippe

II, L-2340 Luxembourg;

(iii) that the address of the registered office of the Company is set at 26, rue Philippe II L-2340 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the above-appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between the
English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said appearing person signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quatorze juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette (Grand-Duché du Luxembourg).

A comparu:

La société GT GLOBAL INVEST (LUX) S.àr.l., une société à responsabilité limitée organisé et constitué sous les lois

du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social à 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 127.042, ici dûment représentée par M. Lorenzo Patrassi,
directeur, demeurant professionnellement au 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg en vertu d'une procuration lui
délivrée en date du 13 juin 2007.

Laquelle procuration demeurera, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisées avec elles.

80549

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts (les

«Statuts») d'une société qu'elle déclare constituer comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination TG LEASING (LUX) S.àr.l.

(la «Société»), qui est régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents Statuts.

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré

dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société (dans ces Statuts, «conseil
de gérance» désigne le gérant si ledit conseil ne se compose que d'un seul gérant). Le siège social peut être transféré en
tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des associés (dans ces Statuts,
«assemblée générale des associés» désigne l'associé unique lorsque la Société n'a qu'un seul associé) délibérant comme
en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Dans les cas où le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires
d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication
aisée entre le siège social et l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provi-
soirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera une
société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, incluant l'acquisition et l'octroi de brevets concernant
de tels droits de propriété intellectuelle, de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder,

par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations,
à ses filiales et/ou sociétés affiliées. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces
personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales et/ou sociétés affiliées. La Société pourra en
outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque crédit, le risque
de change, de fluctuations de taux d'intérêt et tout autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de
son objet social.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l'incapacité, de l'insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents

(12.500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

80550

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers. En cas de pluralité

d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil. Pour toutes autres questions, il est
fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra

être consulté par chaque associé qui le souhaite.

6.5. La société pourra racheter ses parts sociales en conformité avec les dispositions légales applicables.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par résolution de l'assemblée générale des associés

laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s)
gérant(s) ne doivent pas nécessairement être associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opé-
rations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,

associés ou non, par tout gérant de la Société.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des

gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
sera mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit (par courrier ou téléfax
ou tous autres moyens électroniques de communication y compris le courrier électronique).

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou

représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toute circonstance, par la simple signature du gérant unique et,

en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance ou par la ou les signature
(s) simple ou conjointes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués con-
formément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.

80551

12.1. Si la Société est représentée par un associé unique, cet associé exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par

la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit que ce soit par courrier, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique y compris par courrier
électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

sans assemblée par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par
téléfax soit tous autres moyens de communication électronique y compris le courrier électronique. Les associés expri-
meront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou
sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par un original ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant ensemble, au moins les trois quarts du capital social
de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le conseil de gérance prépare un

bilan avec l'indication des valeurs actives et passives de la Société auquel est annexé un sommaire de tous ses engagements
et des dettes du/des gérants et associés à l'égard de la Société et un compte des pertes et profits.

14.2. Le bilan et le compte des profits et pertes seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des associés

qui devront spécialement voter pour donner décharge au conseil de gérance, et, le cas échéant, au commissaire.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net de la société. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la
Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de
la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment sous réserve du respect des conditions

suivantes:

(i) Des comptes intérimaires doivent être établis par au moins un gérant;
(ii) Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

(iii) L'assemblée générale des associés est seule compétente pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes;
(iv) La décision susvisée n'est adoptée que dans la mesure où la Société s'est assurée que les droits des créanciers de

la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition
contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les
plus étendus qui leur sont confiés par la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué

aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales

de la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2007.

<i>Souscription-Libération

Les parts sociales de la Société ont été souscrites comme suit:

80552

La société GT GLOBAL INVEST (LUX) S.àr.l., susmentionnée, douze mille cinq cents parts sociales . . . . . . 12.500
Total: douze mille cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille sept cents euros (eur 1.700,-).

<i>Assemblée générale des associés

La comparante, représentant l'intégralité du capital social souscrit et se considérant comme ayant été dûment con-

voquée, a immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale des associés de la Société.

Après avoir vérifié que celle-ci était régulièrement constituée, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
(i) le nombre des membres du conseil de gérance de la Société est fixé à quatre (4);
(ii) sont nommés comme membres du conseil de gérance de la Société pour une période indéterminée les personnes

suivantes:

(a) M Tomas Lichy, directeur, né à Ostrava (République Tchèque) le 25 novembre 1972, dont l'adresse professionnelle

est située à 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg;

(b) M Iain Macleod, directeur, né à Glasgow (Royaume-Uni), le 8 août 1955, dont l'adresse professionnelle est située

à 59, Cité Millewee, L-8064 Bertrange (Luxembourg);

(c) M Thijs van Ingen, directeur, né à Tiel (Pays-Bas), le 5 décembre 1974, dont l'adresse professionnelle est située à

20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

(d) M Lorenzo Patrassi, directeur, né à Padova (Italie) le 22 avril 1972, dont l'adresse professionnelle est située à 26,

rue Philippe II, L-2340 Luxembourg;

(iii) le siège social de la société est fixé à 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui parle et lit l'anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le présent acte

en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ledit comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Patrassi, F. Kesseler.
Enregistré à Esch/Al., le 18 juin 2007, Relation: EAC/2007/6639. - Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 21 juin 2007.

F. Kesseler.

Référence de publication: 2007080025/219/422.
(070087577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2007.

Sabco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 2, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 15.220.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2007.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Référence de publication: 2007080185/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00302. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

80553

Serilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 15, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 14.642.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2007.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Référence de publication: 2007080186/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00304. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070087933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Immobilière Scheergaass S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 7, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 107.959.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 9 juillet 2007.

FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

Référence de publication: 2007080282/772/14.
Enregistré à Diekirch, le 5 juillet 2007, réf. DSO-CG00059. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070088311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Tafi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.

R.C.S. Luxembourg B 43.833.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 9 juillet 2007.

FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

Référence de publication: 2007080283/772/14.
Enregistré à Diekirch, le 5 juillet 2007, réf. DSO-CG00058. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070088308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Immobilière DUWEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 16-18, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 106.137.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

80554

Wiltz, le 9 juillet 2007.

FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

Référence de publication: 2007080284/772/14.
Enregistré à Diekirch, le 5 juillet 2007, réf. DSO-CG00057. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070088305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Eurotransnord s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9510 Wiltz, 3, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 96.160.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 9 juillet 2007.

FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

Référence de publication: 2007080285/772/14.
Enregistré à Diekirch, le 6 juillet 2007, réf. DSO-CG00074. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070088301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Rock Ridge RE 20, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 129.240.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the twenty-third day May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

FIELD POINT IV S.à r.l, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg,

with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies'
register under number B 119.324,

duly represented by M 

e

 Maÿ N'Diaye, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxem-

bourg.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. This private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») is hereby estab-

lished by the current shareholder and all those who may become shareholders in future, and shall be governed by the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present Articles of Association.

Art. 2. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of

Luxembourg or abroad as well as the management of all operations relating to real estate properties, including the direct
or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may in addition acquire, dispose of and invest in loans, bonds, debentures, obligations, notes, advances,

warrants and other debt instruments and securities secured by real estate.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of ROCK RIDGE RE 20.

80555

Art. 5. The registered office of the Company is established in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital. In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only
be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general
meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares
are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company may be managed by a board of managers, who need not necessarily be

shareholders. The board shall be composed of at least one manager A and at least one manager B.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one manager A and one manager

B.

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légit-

ime»).

Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also

choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
board of managers.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company's object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone conference, videoconference or

by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board
of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entire
set of such circular resolutions will form the minutes giving evidence of the resolution.

80556

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which it

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as it holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of these Articles of Association requires the approval of a majority of shareholders representing at

least three quarters of the share capital.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

Art. 23. The managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by FIELD POINT IV S.à r.l, prenamed, for a total price of twelve

thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date hereof and shall terminate on 31 December 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately 1,900.- Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

80557

1. The registered office of the Company shall be at Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, the Grand

Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as the managers of the Company for an undetermined period:
- Mr. James L. Varley, Manager A, born on 29 July 1965 in Mineola, New York, USA residing at 183 Cedar Shore Drive,

Massapequa, New York 11758;

- Mr. Nicholas Alec Geoffrey Butt, Manager A, born on 28 November 1957 in Oxford, England, residing at 3, St.

Michael's Mews, London SW18JZ, United Kingdom;

- Mr. Thijs van Ingen, Manager B, born on 5 December 1974 in Tiel, the Netherlands, with professional address at 20,

rue de la Poste L-2346 Luxembourg;

- Mr. Pierre Beissel, Manager B, born on 25 April 1973 in Luxembourg, with professional address at 14, rue Erasme,

L-2010 Luxembourg; and

- Mr. Lucien Jacobs, Manager B, born on 6 November 1965 in Bergeyk, The Netherlands, residing at 8, rue de Lux-

embourg, L-8140 Bridel.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, den dreiundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

FIELD POINT IV S.à r.l, eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehend nach dem Recht des Großher-

zogtums Luxemburg, mit Sitz in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
von Luxemburg unter der Nummer B 119.324,

hier vertreten durch M 

e

 Maÿ N'Diaye, maître en droit, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine  Gesellschaft  mit beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb and Verkauf von Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland,

sowie die Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Besitzes von Beteiligungen in
luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften deren Zweck der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, der Ver-
kauf, die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.

Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verkauf und die Beteiligung an Darlehen, Anleihen, Schuldscheinen,

Obligationen, Scheinen, Krediten, Optionsscheinen und anderen Schuldinstrumenten und Wertpapieren, die durch Im-
mobilienvermögen abgesichert sind.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung ROCK RIDGE RE 20.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Filialen
oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.

80558

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25.-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapital bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die

mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft endet nicht mit dem Tod, dem Verlust der Bürgerrechte, dem Konkurs oder der Zahlungs-

unfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensgütern oder

Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen.
Der/Die Geschäftsführer wird/werden von der Hauptversammlung ernannt, die die Dauer seines/ihres Mandats fest-

legt.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat verwaltet, der aus min-

destens einem A Geschäftsführer und mindestens einem B Geschäftsführer besteht.

In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift von einem A Geschäftsführer und

einem B Geschäftsführer verpflichtet.

Vollmachten werden durch den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei Sondervollmachten nur aufgrund

notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner
Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied
zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung. Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder
vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der je-
weiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

80559

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund

auch immer, aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens

drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 23. Die Geschäftsführer können beschließen, Abschlagsdividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines

von den Geschäftsführern erstellten Abschlusses, aus dem hervorgeht, dass ausreichend Mittel zur Ausschüttung zur
Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag selbstverständlich nicht die seit dem Ende des letztes Steuerjahres
erzielten Gewinne überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der verfügbaren Reserven und abzüglich
der übertragenen Verluste und der Summen, die einer gesetzlich oder durch diese Satzung vorgeschriebenen Reserve
zugewiesen werden.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von FIELD POINT IV S.à r.l., vorgenannt, für einen Gesamtpreis

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.

80560

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

1.900,- Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Unverzüglich  nach  Gesellschaftsgründung  hat  der  Gesellschafter,  der  das  gesamte  gezeichnete  Gesellschaftskapital

vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Lu-

xemburg, Großherzogtum Luxemburg.

2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern ernannt:
- Herr James L. Varley, Geschäftsführer A, geboren am 29. Juli 1965 in Mineola, New York, USA, wohnhaft in 183

Cedar Shore Drive, Massapequa, New York 11758;

- Herr Nicholas Alec Geoffrey Butt, Geschäftsführer A, geboren am 28. November 1957 in Oxford, England, wohnhaft

in 3, St. Michael's Mews, London SW18JZ, Vereinigtes Königreich von England.

- Herr Thijs van Ingen, Geschäftsführer B, geboren am 5. Dezember 1974 in Tiel, Niederlande, mit beruflicher Adresse

in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

- Herr Pierre Beissel, Geschäftsführer B, geboren am 25. April 1973 in Luxemburg, mit beruflicher Adresse in 14, rue

Erasme, L-2010 Luxemburg; und

- Herr Lucien Jacobs, Geschäftsführer B, geboren am 6. November 1965 in Bergeyk, Niederlande, wohnhaft in 8, rue

de Luxembourg, L-8140 Bridel.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. N'Diaye, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2007. Relation: LAC/2007/10685. - Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 13. Juni 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007079998/242/335.
(070087235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2007.

Byblos Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 129.273.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty first of May.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr. Tammir Amr, Real Estate Investor, born on August 28, 1970, in Easton, Pennsylvannia, United States of America,

residing at Wybüelstrasse 29, 8702 Zollikon, Switzerland,

here represented by Mr Hubert Janssen, jurist, with professional address at 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on April 18 2007.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the
articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.

80561

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the devel-
opment of such participating interests.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding
of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, pro-
motion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with
its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may be

convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name BYBLOS HOLDINGS S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) represented by five hundred (500)

shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.

Art. 7. The authorised capital of the Company is set at one million Euro (€ 1,000,000.-) divided into forty thousand

(40,000) shares, each share with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-).

The Board of Managers is authorised, during a period ending five (5) years following the date of publication of the

Articles of Association creating the authorised capital in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to increase
the share capital within the limits of the authorised capital in one or several times by issuing shares to the existing holders
of shares or any persons that have been approved by the shareholders at the same quorum and majority requirements
as provided by article 189 paragraph 1 of the Law.

Such shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Board of Managers may determine.
The Board of Managers may in particular determine:
- the time and the number of shares to be subscribed and issued;
- whether a share premium will be paid on the shares to be subscribed and issued and the amount of such share

premium if any; and,

- whether the shares will be paid-in by a contribution in cash or in kind.
The Board of Managers may delegate to any authorised director or officer of the Company or to any other duly

authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

Upon each increase of the share capital of the Company by the Board of Managers within the limits of the authorised

capital, the present article 6 shall be amended accordingly.

Art. 8. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 9. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 10. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 11. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

80562

Art. 12. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 13. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers composed of category A managers and category B managers. The manager(s) need not
to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

Art. 14. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one category A manager and one category

B manager.

The Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy-

holders, selected from its members or not either shareholders or not.

Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers may sub-delegate all or part of his

powers to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented

by proxies and with at least the presence or the representation of one category A manager and one category B manager.
Any decisions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented including
at least the favourable vote of one category A manager and one category B manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the Board of Managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

Art. 16. The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 17. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 18. The Company's accounting year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of

December of each year.

Art. 19. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the Board of Managers (or the

sole manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 20. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 21. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 22. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

80563

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2007.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, Mr. Tammir Amr, prenamed, declared to subscribe the five

hundred (500) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of twelve thousand five hundred
Euro (€ 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available to

the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro (€ 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as managers of the Company for an unlimited period

of time:

<i>Category A manager:

- Mr. Tammir Amr, Real Estate Investor, born on August 28, 1970, in Easton, Pennsylvannia, United States of America,

residing at Wybüelstrasse 29, 8702 Zollikon, Switzerland,

<i>Category B manager:

- Mr. Marcel Stephany, Company Director, born on September 4, 1951 in Luxembourg, residing at 23, Cité Aline

Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-duchy of Luxembourg.

The Company shall be bound by the joint signature of one category A manager and one category B manager.
2) The sole shareholder resolves to fix the registered seat of the Company at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511

Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Tammir Amr, Real Estate Investor, né le 28 août 1970 en Pennsylavie, Etats-Unis d'Amérique, demeurant à

Wybüelstrasse, 8702 Zollikon, Suisse,

ici représenté par Monsieur Hubert Janssen, employé privé, avec adresse professionnelle au 15, côte d'Eich, L-1450

Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 18 avril 2007,
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Un objet social supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de propriétés immobilières dans le Grand-

duché de Luxembourg ou à l'étranger aussi bien que toutes les opérations touchant aux propriétés immobilières, y compris

80564

la détention directe ou indirecte de participations au Luxembourg ou des sociétés étrangères, dont l'objet principal est
l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location des propriétés immobilières.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'autres ins-

truments qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination BYBLOS HOLDINGS S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital autorisé de la Société est fixé à un million d'Euro (€ 1.000.000,-) divisé en quarante mille (40.000,-)

parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.

Le Conseil de Gérance est autorisé, pendant une période prenant fin cinq (5) années après la date de publication dans

le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, des Statuts créant le capital autorisé, à augmenter le capital social
dans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par l'émission de parts sociales au profit des détenteurs de
parts sociales existants ou de toute personne approuvée par les associés aux conditions de quorum et de majorité prévues
à l'article 189, alinéa 1 

er

 , de la Loi.

Ces parts sociales peuvent être souscrites et émises selon les termes et conditions déterminés par le Conseil de

Gérance.

Le Conseil de Gérance peut en particulier déterminer:
- la période et le nombre de parts sociales à souscrire et à émettre;
- si une prime d'émission sera payée sur les parts sociales à souscrire et à émettre, et le montant de cette prime

d'émission, le cas échéant; et

- si les parts sociales seront libérées par un apport en espèce ou en nature.
Le Conseil de Gérance peut déléguer à tout gérant de la Société autorisé ou fondé de pouvoir de la Société ou toute

autre personne dûment autorisée, l'obligation d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement des parts sociales
représentant une partie ou l'entièreté de telles augmentations de capital.

A chaque augmentation du capital social de la Société par le Conseil de Gérance dans les limites du capital autorisé,

le présent article 6 sera modifié en conséquence.

Art. 8. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés, en conformité avec l'article 16 des présents Statuts.

Art. 9. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 10. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 11. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 12. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

80565

Art. 13. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil

de Gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement
associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Art. 14. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et un gérant

de catégorie B.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés

parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.

Art. 15. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie

de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procurations et qu'au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B sont
présents ou représentés. Toute décision du Conseil de Gérance doit être adoptée à la majorité des gérants présents ou
représentés avec au moins le vote affirmatif d'un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne
à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d'un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 17. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la

même année.

Art. 19. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Conseil de Gérance (ou

le gérant unique) prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 20. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être
distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 21. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 22. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2007.

80566

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, Monsieur Tammir Amr, désigné ci-dessus, déclare souscrire aux cinq

cents (500) parts sociales et les libérer intégralement par apport en nature de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-).

Un montant de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à

présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille Euro (€ 2.000,-).

<i>Décision de l'associé unique

1) L'associé unique décide de nommer les personnes suivantes en leur qualité respective de gérants de la Société pour

une durée indéterminée:

<i>Gérant de catégorie A:

-  M.  Tammir  Amr,  Real  Estate  Investor,  né  le  28  août  1970  en  Pennsylavie,  Etats-Unis  d'Amérique,  demeurant  à

Wybüelstrasse, 8702 Zollikon, Suisse,

<i>Gérant de catégorie B:

- M. Marcel Stephany, Administrateur de sociétés, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg, demeurant au 23, Cité Aline

Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-duché de Luxembourg.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et un gérant de

catégorie B.

2) L'associé unique décide de fixer l'adresse du siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2007, Relation: LAC/2007/9946. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007080052/211/323.
(070087625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2007.

Oleandri S.A., Société Anonyme,

(anc. Tozeur S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 127.962.

L'an deux mille sept, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOZEUR S.A., ayant son siège

social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 127.962, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 25 avril 2007, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio Fernandes, em-

ployé privé, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

80567

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société en OLEANDRI S.A.
2.- Modification afférente de l'article 1 

er

 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en OLEANDRI S.A.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article premier des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société de participations financières sous forme de société anonyme et sous la dénomination

de OLEANDRI S.A.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M.-F. Ries-Bonani, A. Fernandes, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 juillet 2007, Relation GRE/2007/2856. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 5 juillet 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007080110/231/52.
(070088162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Alpha Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 36, boulevard de Verdun.

R.C.S. Luxembourg B 26.570.

L'an deux mille sept, le huit mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALPHA ENGINEERING S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte notarié, en
date du 3 septembre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 371 du 19 décembre 1987. La société a été
transformée en société anonyme suivant acte notarié du 17 novembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C,
numéro 93 du 27 février 1993.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gaston Kraus, comptable, demeurant à Bridel.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à

Mersch.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Charles Feyereisen, professeur, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de mise en liquidation de la société.

80568

2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Divers.
II.- Que les actionnaire présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires re-
présentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée aux présentes.

Resteront pareillement annexées les procurations des actionnaires représentés.
III.- Que l'intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée Générale Extraordinaire et que les

actionnaires présents ou représentés reconnaissant avoir été dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu con-
naissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée Générale Extraordinaire, il a pu être fait abstraction des
convocations d'usage.

IV.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement

constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur
Monsieur Gaston Kraus, né à Luxembourg, le 8 mai 1960, demeurant à L-8134 Bridel, 10, rue Henri Hemes.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Kraus, A. Siebenaler, C. Feyereisen, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, Relation: LAC/2007/1925. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007080146/242/58.
(070088003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

SDB Finanziaria S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 45.143.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080286/5878/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2007, réf. LSO-CG00692. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

80569

Kauri Capital 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 119.751.

In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth day in the month of June.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

KAURI CAPITAL PROPERTIES, a company established and existing in Luxembourg under the form of a société à

responsabilité limitée, having its registered office at L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill, recorded with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B, number 119.925,

here represented by Mr Bob Calmes, maître en droit, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 18th June 2007.
The above-mentioned proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary,

shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

The appearing party is the sole shareholder of KAURI CAPITAL 1, a company established and existing in Luxembourg

under the form of a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston
Churchill, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B, number 119.751, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary, on 25 September 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations of 21 October 2006, number 1977 (hereafter the «Company»). The articles of Incorporation have been
modified by the undersigned notary on 27 April 2007, not yet published.

The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of

the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company from its current amount of four hundred ninety-seven thousand six

hundred euro (EUR 497,600.-), represented by nineteen thousand nine hundred and four (19,904) shares with a par value
of twenty-five euro (EUR 25.-) each, up to six hundred ten thousand six hundred fifty euro (EUR 610,650.-), represented
by twenty-four thousand four hundred twenty-six (24,426) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each,
through the issue of four thousand five hundred twenty-two (4,522) shares of the Company, with a par value of twenty-
five euro (EUR 25.-) each.

2. Subsequent modification of article 6 of the articles of association of the Company.
The sole shareholder approved the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred thirteen

thousand and fifty euro (EUR 113,050.-) so as to raise it from its present amount of four hundred ninety-seven thousand
six hundred euro (EUR 497,600.-), represented by nineteen thousand nine hundred and four (19,904) shares with a par
value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, up to six hundred ten thousand six hundred fifty euro (EUR 610,650.-), rep-
resented by twenty-four thousand four hundred twenty-six (24,426) shares with a par value of twenty-five euro (EUR
25.-) each, through the issue of four thousand five hundred twenty-two (4,522) shares of the Company, with a par value
of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

All the four thousand five hundred twenty-two (4,522) new shares of the Company have been subscribed by KAURI

CAPITAL PROPERTIES, prequalified, here represented by Mr Bob Calmes, previously named, by virtue of a proxy given
in Luxembourg on 18th June 2007, at a total price of one hundred thirteen thousand and fifty euro (EUR 113,050.-), out
of which the entirety is allocated to the share capital of the Company.

The subscribed shares have been fully paid up in cash by KAURI CAPITAL PROPERTIES, prequalified, so that the total

amount of one hundred thirteen thousand and fifty euro (EUR 113,050.-) is at the disposal of the Company as it has been
shown to the undersigned notary.

<i>Second resolution

Further the sole shareholder resolved to modify article 6 of the articles of association of the Company which shall

now read as follows:

« Art. 6. The capital is set at six hundred ten thousand six hundred fifty euro (EUR 610,650.-), represented by twenty-

four thousand four hundred twenty-six (24,426) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.»

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to two thousand three hundred euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

80570

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxhyholder of the person appearing known to the notary, such person signed

together with the notary this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-sixième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

KAURI CAPITAL PROPERTIES, une société constituée et existant conformément à la loi luxembourgeoise sous la

forme d'une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B numéro 119.925,

ici représentée par Monsieur Bob Calmes, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

le 18 juin 2007.

Ladite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'associée unique de KAURI CAPITAL 1, une société constituée et existant conformément à la loi

luxembourgeoise sous la forme d'une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au L-1340 Luxembourg, 3-5,
Place Winston Churchill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la Section B numéro
119.751, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 septembre 2006, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations du 21 octobre 2006, numéro 1977 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 avril 2007, non encore publié.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire soussigné de prendre acte que l'ordre

du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société de sa valeur actuelle de quatre cent quatre-vingt-dix sept mille six cents

euros (EUR 497.600-), représenté par dix-neuf mille neuf cent quatre (19.904) parts sociales, avec une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à six cent dix mille six cent cinquante euros (EUR 610.650,-), représenté par
vingt-quatre mille quatre cent vingt-six (24.426) parts sociales, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, à travers l'émission de quatre mille cinq cent vingt-deux (4.522) nouvelles parts sociales de la Société, avec une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale.

2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société.
L'associé unique approuve les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de cent treize mille

cinquante euros (EUR 113.050,-), pour le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-dix sept mille six
cents euros (EUR 497.600,--), représenté par dix-neuf mille neuf cent quatre (19.904) parts sociales, avec une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à six cent dix mille six cent cinquante euros (EUR 610.650,-), représenté
par vingt-quatre mille quatre cent vingt-six (24.426) parts sociales, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, à travers l'émission de quatre mille cinq cent vingt-deux (4.522) nouvelles parts sociales de la Société, avec
une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale.

Toutes les quatre mille cinq cent vingt-deux (4.522) parts sociales ont été entièrement souscrites par KAURI CAPITAL

PROPERTIES, prémentionnée, ici représentée par Monsieur Bob Calmes, prénommé, en vertu d'une procuration donnée
le 18 juin 2007, pour un prix total de cent treize mille cinquante euros (EUR 113.050,-), dont l'intégralité a été versée au
capital social de la Société,

Les parts sociales souscrites ont été entièrement libérées en numéraire par KAURI CAPITAL PROPERTIES, prémen-

tionnée, de façon à ce que le montant total de cent treize mille cinquante euros (EUR 113.050,-) sont à la disposition de
la Société, tel que produit par devant le notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de lui donner le contenu suivant:
« Art. 6. Le capital social est fixé à six cent dix mille six cent cinquante euros (EUR 610.650,-), représenté par vingt-

quatre  mille  quatre  cent  vingt-six  (24.426)  parts  sociales,  avec  une  valeur  nominale  de  vingt-cinq  euros  (EUR  25,-)
chacune.»

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à deux mille trois cents euros.

80571

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant du comparant, connu du notaire instrumentant, ledit

comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Calmes, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 juin 2007, Relation: EAC/2007/7442. — Reçu 1.130,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 4 juillet 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007080149/239/124.
(070088008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

R &amp; S International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 80.978.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007080289/504/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00018. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Jucari S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 38.296.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2007.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007080290/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00017. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Bureau Moderne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 11.958.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2007.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007080291/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00016. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

80572

Cheryl Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 73.159.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2007.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007080292/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00015. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070087780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Manuflex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 66.128.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2007.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007080293/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00014. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Salvia Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 66.133.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2007.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007080294/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00013. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Leya S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 36, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 81.451.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080296/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01995. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

80573

AGF Life Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 37.619.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2007.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007080295/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00012. - Reçu 50 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070087772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Fendi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 76.233.

Les comptes annuels et l'affectation des résultats au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007080297/260/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01972. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Elca S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1738 Luxembourg, 17, rue Luc Housse.

R.C.S. Luxembourg B 100.900.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 27 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080298/3220/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2007, réf. LSO-CE02445. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Global Insurance &amp; Reinsurance Consultants (G.I.R.C.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau.

R.C.S. Luxembourg B 82.611.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 27 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080299/3220/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2007, réf. LSO-CE02429. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

80574

Geocontrol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 104.343.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007080302/1035/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01712. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070087818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Universal Sales and Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 43.085.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 27 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080300/3220/12.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2007, réf. LSO-CE02453. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Reech AiM Group, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 116.129.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080304/1026/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01886. - Reçu 40 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Lexfam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 115.791.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080305/1026/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01882. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

80575

EFF Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 37.767.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2007.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseur d'entreprises
Signatures

Référence de publication: 2007080318/592/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01787C. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070087851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Babet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 115.566.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080306/1026/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01885. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

CHLEPAM Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.908.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080307/1026/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01879. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

ARJUFRA Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 114.949.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080308/1026/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01877. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

80576

Catella Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 112.781.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

REVILUX S.A.
Signature

Référence de publication: 2007082739/687/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2007, réf. LSO-CE05566. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070085598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2007.

Canalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3844 Schifflange, Z.I. Letzebuerger Heck.

R.C.S. Luxembourg B 88.528.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080309/1026/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00354. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

WGRM Holding 7 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 106.510.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080310/1026/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00357. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Finover S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 52.313.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007080311/631/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2007, réf. LSO-CF04301. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

80577

Sigma Capital Hospitality, Leisure and Tourism Holding Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 90.334.

In the year two thousand six, on the fourth day of May.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch,

is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of the public limited liability company

(société anonyme) denominated SIGMA CAPITAL HOSPITALITY, LEISURE AND TOURISM HOLDING COMPANY
S.A., organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg (the Company), incorporated pursuant to a deed of par Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange,
dated November 15, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 84 dated January 28,
2003.

The articles of association of the Company have been amended for the last time on July 16, 2004, by a deed of Maître

Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1030 on October 14, 2004.

The Meeting was opened by Mr. Patrick Van Hees, employee in Mersch, Luxembourg, being in the chair (the Chairman),

who appointed as secretary, Mrs. Annick Braquet, employee in Mersch, Luxembourg.

The Meeting elected as Scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee in Mersch, Luxembourg, (the Chairman, the

Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The general meeting has been duly convened by courrier sent to all the shareholders, all the shares being on registered

form.

II. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that two hundred and

seventy-six (276,000) shares with a par value of ten euro (EUR 10), representing eighty-two point fourteen (82.14) percent
of the Company's share capital are duly represented at this Meeting so that the Meeting can validly decide on all the issues
of the agenda which are known to the shareholders.

III. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list. This attendance list signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the Bureau and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
IV. The agenda of the Meeting is the following:
1. Setting up of the quorum;
2. Amendment and restatement of the articles of association of the Company;
3. Removal of C.A.S. SERVICES S.A., as internal auditor of the Company and discharge for the performance of its

mandate;

4. Ratification of the appointment of PricewaterhouseCoopers as internal auditor of the Company for the accounting

years terminated on December 31, 2003 and December 31, 2004;

5. Ratification of the appointment of ERNST &amp; YOUNG as internal auditor of the Company as of January 1, 2005 until

January 1, 2007;

6. Acknowledgment of the management and audit reports for the accounting years terminated on December 31, 2003,

December 31, 2004 and December 31, 2005;

7. Approval of the accounts for the accounting years terminated on December 31, 2003, December 31, 2004 and

December 31, 2005;

8. Allocation of the results (net profit/loss) of the Company for the accounting years terminated on December 31,

2003, December 31, 2004 and December 31, 2005;

9. Granting of discharge to PricewaterhouseCoopers for the performance of its mandate for the accounting years

terminated on December 31, 2003, December 31, 2004 and to ERNST &amp; YOUNG for the performance of its mandate
for the accounting year terminated on December 31, 2005;

10. Granting of discharge to the directors of the Company for the performance of their mandates for the accounting

years terminated on December 31, 2003, December 31, 2004 and December 31, 2005;

11. Approval of the report of SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, a private limited company

organized and existing under the laws of the British Virgin Islands, with its registered address at Wickhams Cay, PO Box
662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, acting as manager of the Company (the Manager) with regard to the
status of the preparation of SIGMA CAPITAL INVESTMENTS S.A.'s initial public offering, as described in the Advisory
Board minutes dated December 5,2005, the relevant provisions of which were made available to the shareholders (the
IPO), and authorization to continue the preparation of the IPO;

80578

12. Approval of the second amendment to the shareholder and operating agreement dated February 28, 2003 (the

Amendment No. 2 to the Shareholder and Operating Agreement), to be entered into prior to the date of the IPO by
and between the Company, the Manager and the shareholders of the Company;

13. Approval of the amended and restated shareholder and operating agreement (the Amended and Restated Share-

holder and Operating Agreement), to be entered into prior to the date of the IPO (and dated as of May 4, 2006) but to
take effect immediately upon the IPO by and between the Company, the Manager and the shareholders of the Company;

14. Removal of Mr. Ivo Evgeniev from his position as director of the Company, and appointment with immediate effect

of the following directors of the Company: Dr. Georgi Veltchev, Mr. Vesselin Danev and SIGMA CAPITAL INTERNA-
TIONAL MANAGEMENT LTD., as directors of the Company for a new period of six years;

15. Approval of the appointment of SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD., with immediate effect

and for a period of six years, as the managing director of the Company to conduct and manage the daily affairs of the
Company;

16. Approval of the redemption of the shares held by THOMAS COOK AG in the Company and decrease of the

Company's share capital;

17. Approval of the redemption of the bonds held by THOMAS COOK AG in the Company;
18. Granting of a special power of attorney to each employee of CITCO (LUXEMBOURG) S.A., a Luxembourg public

limited liability company (société anonyme) with registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, acting under his/
her sole signature, to validly update the shareholders' register and the bondholders' register of the Company, to certify
said registers and to make certified copies thereof;

19. Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the Meeting takes the following resolutions:

<i>First resolution

Eighty-two point fourteen (82.14) percent of the share capital being represented at the present Meeting, the share-

holders being present or represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the
agenda which has been made available to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to dismiss C.A.S SERVICES S.A., as internal auditor of the Company with immediate effect and

to grant C.A.S SERVICES S.A. full discharge with respect to the execution of its mandate.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to ratify the appointment of PricewaterhouseCoopers as internal auditor of the Company for

the accounting years terminated on December 31, 2003 and December 31, 2004.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to ratify the appointment of Ernst &amp; Young as internal auditor of the Company as of January 1,

2005 until (January 1, 2007) December 31, 2007.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to postpone the approval of the agenda items (6) to and including (10) to a subsequent share-

holder's meeting to be held on July 26, 2006 at the latest.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to approve the report of the Manager with regard to the status of the preparation of SIGMA

CAPITAL INVESTMENTS S. A. 's IPO and to authorise the Manager to continue the preparation of the IPO.

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to approve the Amendment No. 2 to the Shareholder and Operating Agreement.

<i>Eighth resolution

The  Meeting  resolves  to  approve  the  Amended  and  Restated  Shareholder  and  Operating  Agreement  to  become

effective immediately after the IPO.

<i>Ninth resolution

The Meeting resolves to remove Mr. Ivo Evgeniev from his position as director of the Company, and to appoint with

immediate effect the following directors of the Company: Dr. Georgi Veltchev, Mr. Vesselin Danev and SIGMA CAPITAL
INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD., as directors of the Company, for a new period of six years.

<i>Tenth resolution

The Meeting resolves to approval the appointment of SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD.,

with immediate effect and for a period of six years, as the managing director of the Company to conduct and manage the
daily affairs of the Company.

80579

<i>Eleventh resolution

The Meeting resolves to approve the redemption by the Company of (a) the sixty thousand (60,000) shares held by

THOMAS COOK AG in the Company and the immediate decrease of the share capital of the Company by six hundred
thousand euro (EUR 600,000.-) by cancellation of the sixty thousand (60,000) shares held by THOMAS COOK AG in
the Company, so that the share capital of the Company is set at two million seven hundred and sixty thousand euro (EUR
2,760,000.-), divided into two hundred and seventy six thousand (276,000) shares with a par value often (EUR 10.-) each
and (b) the five hundred and forty thousand (540,000) bonds, each of a par value often euro (EUR 10.-) held by THOMAS
COOK AG in the Company, and to pay to THOMAS COOK A.G. the amount agreed upon between the Company and
THOMAS COOK AG in the share purchase agreement dated June 6, 2005, as amended, after the expiry of a period of
30 days following the publication of this shareholders' meeting.

Article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company shall henceforth read as follows:
«The  subscribed  capital  of  the  company  is  fixed  at  two  million  seven  hundred  and  sixty  thousand  euro  (EUR

2,760,000.-), divided into two hundred and seventy-six thousand (276,000) shares with a par value often (EUR 10.-) each».

<i>Twelfth resolution

The Meeting resolves to grant a special power of attorney to each employee of CITCO (LUXEMBOURG) S.A., a

Luxembourg  public  limited  liability  company  (société  anonyme)  with  registered  office  at  L-2519  Luxembourg,  9,  rue
Schiller, acting under his/her sole signature, to validly update the shareholders' register of the Company, to certify said
shareholders register and to make certified copies thereof.

<i>Thirteenth resolution

The Meeting resolves to fully amend and restate the articles of association of the Company which shall henceforth

read as follows:

«Title I. - Denomination, Registered office, Purpose, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of SIGMA CAPITAL HOSPITALITY, LEISURE

AND TOURISM HOLDING COMPANY S.A.

Art. 2. The registered office of the company is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the corporate body of the company which
is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the
development of these participating interests.

It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio

consisting of any securities of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any en-
terprise,  to  acquire  by  way  of  investment,  subscription,  underwriting,  or  by  option  to  purchase,  and  any  other  way
whatever, securities, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and grant to the companies in which
it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The company may take any action to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or

indirectly connected with its purposes and which are likely to further their development or extension.

In all operations indicated hereabove, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits estab-

lished by the law of July 31st, 1929.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at two million seven hundred and sixty thousand euro (EUR

2,760,000.-), divided into two hundred and seventy six thousand (276,000) shares with a par value often euro (EUR 10.-)
each.

Shares may be evidenced at the owners' option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares shall be issued and shall remain in registered form.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Bonds issued by the company must be in a registered form and holders of bonds may not request the conversion of

their registered bonds into bearer bonds.

80580

The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
All bonds shall bear a «Restricted» stamp and can be transferred only in connection with the transfer of shares in the

ratio of nine bonds to one share. If any consent of the company to the transfer of bonds is required pursuant to the terms
and conditions of the issuing documents of the bonds, the board of directors shall be required to grant such consent if
the relevant shares are being transferred by a shareholder simultaneously with the bonds as provided herein. The shares
in the company and any share unit certificates are freely transferable, provided, however, that shares cannot be transferred
unless accompanied by a simultaneous transfer of nine bonds per share to the transferee.

Title III.- Management

Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years by a general meeting of shareholders. They may be re-
elected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders. In the event of

a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which decision has to
be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors may elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at request of not less

than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telefax or document scanned and sent by electronic
mail, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telefax or document scanned and
sent by electronic mail. Resolutions shall require a majority vote.

In case of urgency, resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax or document scanned and sent by electronic mail.

In the case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

compliance with the corporate purpose stated in Article 4 and subject to Article 13 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of shareholders,

shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The company shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole signature

of the managing director or manager, provided that special arrangements have been reached concerning the authorised
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate the day-to-day management of the Company's business, in its widest

sense, to directors or to third persons, who need not be shareholders of the Company.

Delegation of the day-to-day management to one or more directors of the Company, who will be called managing

directors, is subject to prior authorisation by the general meeting of shareholders.

If a managing director is appointed, the Company may be validly represented by the sole signature of the managing

director or the joint signatures of the other two directors.

The board of directors may also delegate the day-to-day management and special powers to one or more non directors,

who will be called managers.

Art. 11. Any litigation involving the company either as plaintiff or as defendant will be handled in the name of the

company by the board of directors, represented by its chairman or manager or by a director delegated for such purpose.

Title IV. - Supervision

Art. 12. The company shall be supervised by one or more internal auditors appointed by a general meeting of share-

holders, which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be re-elected and removed at any time.

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held on the thirtieth day of June of each year at 10.00 a.m.
All meetings of the shareholders shall be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the day and at a time specified in such notice. If all the shareholders are present or represented and
if they declare that they have had knowledge of the agenda, the general meeting may take place without previous convening
of notices. Each share gives the right to one vote.

80581

Shareholders holding a majority of at least 86% of the outstanding shares in the company, either present in person or

represented by proxy, shall constitute a quorum at all meetings of the shareholders for the transaction of business.
Shareholders may also participate in a meeting by means of telephone conference or similar communications equipment
that permits all shareholders present to hear each other.

Unless otherwise provided herein the vote of the shareholders holding a majority of at least 86% of the outstanding

shares in the company present in person or represented by proxy shall decide any question brought before such meeting,
including when the matter for consideration is an amendment to these articles, except when the vote of a greater number
or higher percentage is required by law.

Except with the approval of the shareholders, acting by a majority of at least 86% of the outstanding shares in the

company, (i) the company shall not make any investments or issue any new shares or bonds; (ii) the company shall not
engage in lending of capital to any person; (iii) the manager shall not, and shall make sure that its affiliates shall not, enter
into any transactions with the company (no investment, contract or arrangement may be made by the company, which
may involve any actual or potential conflict of interest with the manager or any of its affiliates without approval by the
shareholders, acting by a majority of at least 86% of the outstanding shares in the company); or (iv) the manager shall not
take actions contrary to or inconsistent with the obligations of the company to the shareholders, specified in an agreement
to which the company and the shareholders are parties, or otherwise.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the company shall begin on the 1 st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the company, the credit balance represents the

net profits of the company. Of such net profit, only to the extent required by applicable law, five percent (5%) shall be
compulsorily appropriated for the legal reserve, such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten
percent (10%) of the capital of the company, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time
and for whatever reason, the legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the company (10%).

The balance of the net profit shall be distributed by the company to the shareholders and/or bondholders (in case of

bondholders, through redemption of bonds or otherwise).

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. The company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be

carried out by one or more liquidators, appointed by the shareholders, which will specify their powers and fix their
remuneration.

Title VIII. - General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

There being no further business on the agenda, the Chairman thereupon closes the meeting.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
This document having been read to the members of the Bureau and the proxyholder of the shareholders, they sign

together with all present and represented shareholders and the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the German text, the

English version will prevail.

German translation to follow:

Vierter Tag des Monats Mai im Jahre zweitausendundsechs.
Vor mir, dem Maître Henri Hellinckx, Notar mit Sitz in Mersch,

wird eine außerordentliche Hauptversammlung (die Versammlung) der Aktionäre der SIGMA CAPITAL HOSPITALI-

TY, LEISURE AND TOURISM HOLDING COMPANY S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht
des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg (die Gesellschaft), gegründet nach Maßgabe
einer Urkunde des Notars Gérard Lecuit mit Sitz in Hesperange vom 15. November 2002 veröffentlicht im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 84 mit Datum vom 28. Januar 2003 abgehalten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal am 16.Juli 2004 durch Urkunde des Notars Gérard Lecuit mit

Sitz in Hesperange, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1030 am 14. Oktober
2004, geändert.

Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Patrick Van Hees Privatbeamter, wohnhaft in Mersch, Luxemburg

(der Vorsitzende),

Frau Annick Braquet, Privatbeamtin, wohnhaft in Mersch, Luxemburg, zum Schriftführerin der Versammlung bestellt.

80582

Zum Stimmenzähler der Versammlung wählt die Versammlung Frau Ariette Siebenaler, Privatbeamtin, wohnhaft in

Mersch, Luxemburg (der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler werden nachstehend gemeinsam das
Bureau genannt).

Nachdem das Bureau somit gebildet wurde, erklärt und bittet der Vorsitzende den Notar wie folgt zu Protokoll zu

nehmen:

I. Die gegenwärtige Generalversammlung wurde einberufen durch Einladung an die Namensaktionäre abgeschickt.
II. Aus einer von den Bureau-Mitgliedern erstellten und bestätigten Anwesenheitsliste geht hervor, dass zweihundert-

sechsundsiebzigtausend (276.000) Aktien mit einem Nennwert von zehn Euro (EUR 10.-), die zusammen zweiundachtzig
komma siebzehn (82,17) Prozent des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft bilden, bei der Versammlung ordnungsgemäß
vertreten sind, so dass die Versammlung wirksam über alle Tagesordnungspunkte einen Beschluss fassen kann, die den
Aktonären bekannt sind.

III. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer

Aktien werden auf einer Anwesenheitsliste gezeigt. Diese Anwesenheitsliste, die von den Aktionären, den Bevollmäch-
tigten der vertretenen Aktionäre, dem Bureau und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wird, wird dieser Urkunde
beigefügt. Die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter bleiben ebenfalls der vorliegenden Urkunde beigefügt.

IV. Die Tagesordnung hat den folgenden Wortlaut:
1. Festlegung des Quorums;
2. Abänderung und Neufassung der Gesellschaftssatzung;
3. Entlassung von C.A.S. SERVICES S.A. als Abschlussprüfer der Gesellschaft und Entlastung für die Ausübung seines

Mandats;

4. Genehmigung der Ernennung von PricewaterhouseCoopers als Abschlussprüfer der Gesellschaft für die am 31.

Dezember 2003 und 31. Dezember 2004 abgelaufenen Geschäftsjahre;

5. Genehmigung der Ernennung von ERNST &amp; YOUNG als Abschlussprüfer der Gesellschaft vom 1. Januar 2005 bis

zum 31. Dezember 2007;

6. Kenntnisnahme von den Geschäftsführungs- und Abschlussberichten für die am 31. Dezember 2003, 31. Dezember

2004 und 31. Dezember 2005 abgelaufenen Geschäftsjahre;

7. Billigung der Abschlussberichte für die am 31. Dezember 2003, 31. Dezember 2004 und 31. Dezember 2005 abge-

laufenen Geschäftsjahre;

8. Verteilung des Gesellschaftsergebnisses (Nettogewinne/-verluste) für die am 31. Dezember 2003, 31. Dezember

2004 und 31. Dezember 2005 abgelaufenen Geschäftsjahre;

9. Entlastung für PricewaterhouseCoopers für die Ausübung seines Mandats für die am 31. Dezember 2003, am 31.

Dezember 2004 abgelaufenen Geschäftsjahre und für ERNST &amp; YOUNG für die Ausübung seines Mandats für die am 31.
Dezember 2005 abgelaufenen Geschäftsjahre;

10. Entlastung für die Direktoren für die Ausübung ihres Mandats für die am 31. Dezember 2003, 31. Dezember 2004

und 31. Dezember 2005 abgelaufenen Geschäftsjahre;

11. Billigung des Berichts von SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, einer Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung nach dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Wickhams Cay, PO Box 662, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft (der Geschäftsführer) im Hinblick auf die
Vorbereitung des Börsengangs von SIGMA CAPITAL INVESTMENTS S.A., wie beschrieben im Sitzungsprotokoll des
Beirats vom 5. Dezember 2005, dessen wesentliche Bestimmungen den Aktionären zugänglich gemacht wurden (die IPO),
und Ermächtigung zur weiteren Vorbereitung des Börsengangs;

12. Billigung der zweiten Abänderung des shareholder and operating agreement vom 28. Februar 2003 (die Abänderung

Nr. 2 zum Shareholder and Operating Agreement), auf die sich vor dem Datum des IPO die Gesellschaft, der Geschäfts-
führer und die Aktionäre der Gesellschaft vertraglich einigen werden;

13. Billigung des abgeänderten und neu gefassten shareholder and operating agreement vom 4. Mai 2006 (das Abge-

änderte und Neu Gefasste Shareholder and Operating Agreement), auf die sich vor dem Datum des IPO die Gesellschaft,
der Geschäftsführer und die Aktionäre der Gesellschaft vertraglich einigen werden, das jedoch unmittelbar zum Zeitpunkt
des IPO wirksam werden soll;

14. Entlassung von Herrn Ivo Evgeniev aus seiner Funktion als Direktor der Gesellschaft und Ernennung der folgenden

Direktoren der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung: Dr. Georgi Veltchev, Herr Vesselin Danev und SIGMA CAPITAL
INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD. als Direktoren der Gesellschaft für einen Zeitraum von sechs Jahren;

15. Billigung der Ernennung von SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD. mit sofortiger Wirkung

und für einen Zeitraum von sechs Jahren als geschäftsführende Direktoren der Gesellschaft zur Leitung und Führung der
tägliche Geschäfte der Gesellschaft;

16. Billigung des Rückkaufs der von THOMAS COOK AG in der Gesellschaft gehaltenen Aktien und Herabsetzung

des Gesellschaftskapitals;

17. Billigung des Rückkaufs der von THOMAS COOK AG in der Gesellschaft gehaltenen Obligationen;

80583

18. Erteilung einer Spezialvollmacht für jeden Angestellten von CITCO (LUXEMBOURG) S.A., einer Aktiengesellschaft

(société anonyme) nach dem Recht von Luxemburg, mit Sitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg, handelnd unter seiner/
ihrer alleinigen Unterschrift, um das Aktien- und Bondregister der Gesellschaft wirksam zu aktualisieren, genannte Re-
gister zu beglaubigen und beglaubigte Abschriften hiervon herzustellen.

19. Verschiedenes.
Nach Genehmigung der Erklärung des Vorsitzenden fasst die Versammlung die folgenden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Da 82,14 Prozent des Gesellschaftskapitals bei der gegenwärtigen Versammlung vertreten sind, betrachten sich die

anwesenden oder vertretenen Aktionäre als wirksam eingeladen und erklären, umfassende Kenntnis von der Tagesord-
nung genommen zu haben, die ihnen zuvor zur Verfügung gestellt wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, C.A.S. SERVICES S.A. als Abschlussprüfer der Gesellschaft zu entlassen und C.A.S. SER-

VICES S.A. volle Entlastung für die Ausübung seines Mandats zu erteilen.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, die Ernennung von PricewaterhouseCoopers als Abschlussprüfer der Gesellschaft für

die am 31. Dezember 2003 und 31. Dezember 2004 abgelaufenen Geschäftsjahre zu genehmigen.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, die Ernennung von ERNST &amp; YOUNG als Abschlussprüfer der Gesellschaft vom 1. Januar

2005 bis zum 31. Dezember 2007 zu genehmigen.

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt, die Billigung von Tagesordnungspunkt (6) bis einschließlich (10) auf eine darauffolgende

Aktionärsversammlung zu verschieben die spätestens am 26. Juli 2006 abzuhalten ist.

<i>Sechster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, den Bericht des Geschäftsführers im Hinblick auf den Status der Vorbereitung des IPO

der SIGMA CAPITAL INVESTMENTS S.A. zu billigen und den Geschäftsführer zu ermächtigen, mit der Vorbereitung des
IPO fortzufahren.

<i>Siebter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, die Abänderung Nr. 2 zum Shareholder and Operating Agreement zu billigen.

<i>Achter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, das Abgeänderte und Neu Gefasste Shareholder and Operating Agreement zu billigen,

das sofort nach dem IPO wirksam wird.

<i>Neunter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, Herrn Ivo Evgeniev aus seiner Funktion als Direktor der Gesellschaft zu entlassen und

die folgenden Direktoren der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung zu ernennen: Dr. Georgi Veltchev, Herr Vesselin Danev
und SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD. als Direktoren der Gesellschaft für einen Zeitraum von
sechs Jahren.

<i>Zehnter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, die Ernennung von SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD. mit

sofortiger Wirkung und für einen Zeitraum von sechs Jahren als geschäftsführende Direktoren der Gesellschaft zur Leitung
und Führung der tägliche Geschäfte der Gesellschaft zu billigen.

<i>Elfter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, den Rückkauf (a) der von THOMAS COOK AG in der Gesellschaft gehaltenen sech-

zigtausend (60.000) Aktien und die sofortige Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um sechshunderttausend Euro (EUR
600.000,-) durch Löschung der von THOMAS COOK AG in der Gesellschaft gehaltenen sechzigtausend (60.000) Aktien
zu billigen, sodass das Gesellschaftskapital auf zwei Millionen siebenhundertundsechzigtausend Euro (EUR 2.760.000,-)
festgelegt wird, eingeteilt in zweihundertsechsundsiebzigtausend (276.000) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro
(EUR 10,-) und (b) der fünfhundertvierzigtausend (540.000) von THOMAS COOK AG in der Gesellschaft gehaltenen
Obligationen mit einem Nennwert von zehn Euro (EUR 10) und an THOMAS COOK AG den zwischen der Gesellschaft
und THOMAS COOK AG in dem Kaufvertrag von 6. Juni 2005 in letzter Fassung vereinbarten Betrag nach Ablauf eines
Zeitraumes von 30 Tagen nach Veröffentlichung dieser Aktionärsversammlung zu bezahlen.

<i>Zwölfter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, eine Spezialvollmacht für jeden Angestellten von CITCO (LUXEMBOURG) S.A., einer

Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht von Luxemburg, mit Sitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg zu

80584

erteilen, handelnd unter seiner/ihrer alleinigen Unterschrift, um das Aktien- und Bondregister der Gesellschaft wirksam
zu aktualisieren, genannte Register zu beglaubigen und beglaubigte Abschriften hiervon erstellen.

<i>Dreizehnter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, die Gesellschaftssatzung umfassend zu ändern und neu zu fassen, die fortan den folgenden

Wortlaut hat:

Titel I. - Bezeichnung, Sitz der Gesellschaft, Gesellschaftszweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine société anonyme unter der Bezeichnung SIGMA CAPITAL HOSPITALITY, LEISURE AND

TOURISM HOLDING COMPANY S.A. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Der Sitz kann innerhalb derselben Gemeinde durch

Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden.

Wenn außergewöhnliche politische oder wirtschaftliche Ereignisse auftreten oder bevorstehen, die die normale Ge-

schäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft, oder den Kommunikationsfluss zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland
beeinträchtigen können, kann der Sitz als vorübergehend ins Ausland verlegt erklärt werden bis zur vollständigen Been-
digung  solcher  außergewöhnlicher  Umstände.  Derartige  vorübergehende  Maßnahmen  haben  keinen  Einfluss  auf  die
Nationalität der Gesellschaft. Die Erklärung der Verlegung des Sitzes und die Mitteilung gegenüber Dritten soll durch
dasjenige Gesellschaftsorgan erfolgen, das unter solchen Umständen hierfür am besten geeignet ist.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Zeit gegründet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb von Eigentumsrechten an Unternehmen jedweder

Form in jedweder Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung solcher Eigentumsrechte.

Sie kann insbesondere seine Gesellschaftsmittel zur Errichtung, Entwicklung und Verfügung über ein Portfolio ver-

wenden,  das  aus  Wertpapieren  jedweden  Ursprungs  besteht,  an  der  Gründung,  Entwicklung  und  Kontrolle  jedes
Unternehmens teilnehmen, im Wege der Investition, Einlage, Zeichnung oder Kaufoption durch auf jede sonstige Weise
Wertpapiere erwerben, diese Wertpapier im Wege des Verkaufs, der Übertragung, des Tauschs oder auf sonstige Weise
veräußern,  und  den  Unternehmen,  an  denen  sie  sich  beteiligt,  Unterstützung,  Darlehen,  Vorschüsse  oder  Garantien
jedweder Art geben.

Die Gesellschaft kann jede Maßnahme ergreifen zur Sicherung ihrer Rechte ergreifen und jede Operation durchführen,

die direkt oder indirekt mit Ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen und die geeignet sind, ihre Entwicklung oder
Ausdehnung zu fördern.

In allen oben bezeichneten Operationen als auch in ihrer gesamten Tätigkeit beachtet die Gesellschaft die Grenzen

des Gesetzes vom 31. Juli 1929.

Titel II. - Gesellschaftskapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital wird auf zwei Millionen siebenhundertsechzigtausend Euro (EUR 2.760.000) festgelegt

und ist eingeteilt in zweihundertsechsundsiebzigtausend (276.000) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR
10,-) pro Aktie.

Nachweis über die Aktien kann nach Wahl des Eigentümers in Zertifikaten, die einzelne Aktien zeigen oder in Zerti-

fikaten, die zwei oder mehr Aktien zeigen, erbracht werden. Aktien sollen in Form von Namensaktien ausgegeben werden
und bleiben.

Die Gesellschaft kann in dem gesetzlich zulässigen Umfang und unter den gesetzlich vorgegebenen Vorraussetzungen

ihre eigenen Aktien kaufen.

Von der Gesellschaft ausgegebene Schuldverschreibungen müssen als Namenspapiere ausgegeben werden und die

Inhaber von Schuldverschreibungen können nicht die Umwandlung ihrer Namenspapiere in Inhaberpapiere verlangen.

Der Verwaltungsrat soll die Natur, den Preis, die Zinsrate, die Ausgabe- und Rückkaufbedingungen und andere Be-

dingungen, die in Zusammenhang mit einer solchen Ausgabe von Schuldverschreibungen stehen, festlegen.

Ein Register der Inhaber von Schuldverschreibungen wird am Sitz der Gesellschaft geführt. Alle Schuldverschreibungen

tragen einen «Eingeschränkt» Stempel und können nur in Verbindung mit der Übertragung von Aktien im Verhältnis von
neun Schuldverschreibungen zu einer Aktie übertragen werden. Wenn die Zustimmung der Gesellschaft zur Übertragung
von Schuldverschreibungen nach den Vertragsbestimmungen der Ausgabedokumente der Schuldverschreibungen erfor-
derlich  ist,  soll  der  Verwaltungsrat  seine  Zustimmung  gewähren,  wenn  die  betreffenden  Aktien  gleichzeitig  mit  den
Schuldverschreibungen wie hier vorgesehen übertragen werden. Die Aktien der Gesellschaft und jede Urkunde hierzu
sind frei übertragbar, jedoch vorausgesetzt, dass Aktien nur bei einer gleichzeitigen Übertragung von neun Schuldver-
schreibungen je Aktie an den Empfänger übertragen werden können.

Titel III. - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

Aktionäre oder Nichtaktionäre sein können und für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren von der Aktionärsver-
sammlung ernannt werden. Sie können wiedergewählt werden und jederzeit von der Aktionär s Versammlung abberufen
werden.

80585

Die Anzahl der Direktoren und ihre Amtszeit werden von der Aktionärsversammlung festgelegt. Bei freigewordenem

Vorstandssitz steht den verbleibenden Vorstandsmitgliedern das Recht zu, für die vorläufige Ersetzung durch ein neues
Vorstandsmitglied Sorge zu tragen. Diese Entscheidung muss durch die nächste Aktionärsversammlung genehmigt werden.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.
Ein Treffen des Verwaltungsrates soll jederzeit auf Verlangen des Vorsitzenden oder von mindestens zwei Direktoren

einberufen werden. Der Verwaltungsrat kann nur wirksam beraten und handeln, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder
anwesend oder vertreten sind, wobei die Erteilung einer Vollmacht mittels Brief, Telegramm, Fax oder eingescanntem
und per e-mail gesendetem Dokument der Direktoren untereinander zulässig ist. Im Falle eines Notfalls können die
Direktoren mittels Brief, Telegramm, Fax oder eingescanntem und per e-mail gesendetem Dokument abstimmen. Be-
schlüsse erfordern eine Mehrheit der Stimmen.

Im Falle der Dringlichkeit sind von allen Direktoren unterzeichnete Beschlüsse ebenso wirksam und verbindlich wie

Beschlüsse, die in einer ordnungsgemäss einberufenen und abgehaltenen Sitzung gefasst wurden. Diese Unterschriften
können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Exemplaren eines gleichlautenden Beschlusses geleistet und
per Brief, Fax oder eingescanntem und per e-mail gesendetem Dokument nachgewiesen werden.

Im Falle eines Patts hat der Vorsitzende das Entscheidungsrecht.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat umfassende Befugnisse, um alle Geschäfte zu tätigen, die in Einklang mit dem in Artikel

4 festgelegten Gesellschaftszweck und vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 13 der Gesellschaftsatzung stehen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch die vorliegende Satzung der Aktionärsversammlung

vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat kann Zwischendividenden
im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen ausschütten.

Art. 9. Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten gegenüber Dritten durch die gemeinschaftliche Unterschrift

zweier Direktoren oder durch die einzelne Unterschrift des geschäftsführenden Direktors oder Managers verpflichtet,
vorausgesetzt, dass besondere Vorkehrungen im Hinblick auf die Unterschriftsermächtigung im Falle der Erteilung einer
von dem Verwaltungsrat gemäß Artikel 10 erteilten Vollmacht getroffen wurden.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft im weitesten Sinne Direktoren oder

Dritten die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, übertragen.

Die Übertragung der tägliche Geschäftsführung an einen oder mehrere Direktoren der Gesellschaft, die geschäftsfüh-

rende Direktoren unterliegt der Einwilligung der Aktionärsversammlung.

Ist ein geschäftsführender Direktor ernannt, so kann die Gesellschaft wirksam durch die einzelne Unterschrift des

geschäftsführenden Direktors oder die gemeinschaftliche Unterschrift der anderen beiden Direktoren vertreten.

Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung und besondere Befugnisse auch an einen oder mehrere Per-

sonen, die nicht Direktoren sind, übertragen und die Manager genannt werden.

Art. 11. Jeder Rechtstreit, in dem die Gesellschaft als Klägerin oder Beklagte auftritt, wird im Namen der Gesellschaft

vom Verwaltungsrat geführt, der von seinem Vorsitzenden oder Manager oder von einem zu diesem Zwecke ermächtigten
Direktor vertreten wird.

Titel IV. - Aufsicht

Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren von der Aktionärsversammlung ernannten Abschlussprüfern über-

wacht, die ihre Anzahl, Vergütung und Amtszeit festlegt. Ihr Amt hat eine Höchstdauer von sechs Jahren.

Sie können wiedergewählt und jederzeit entlassen werden.

Titel V. - Hauptversammlung

Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre wird am dreizehnten Tag des Monats Juli jeden Jahres um

10.00 Uhr abgehalten.

Alle Aktionärsversammlungen finden in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes am in der Einberufungseinladung ange-

gebenen Ort am dort angegebenen Tag und zu der in dieser Einladung festgelegten Zeit statt. Sind alle Gesellschafter
anwesend oder vertreten und erklären, Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, so kann die Hauptversammlung auch
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden. Jede Aktie verleiht ein Stimmrecht.

Aktionäre, die eine Mehrheit von mindestens 85% der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft halten und entweder

persönlich anwesend oder durch Vollmacht vertreten sind, bilden ein Quorum bei allen Aktionärsversammlungen zur
Übertragung des Unternehmens. Die Aktionäre können ebenfalls mittels Telefonkonferenz oder vergleichbaren Kom-
munikationsmitteln an der Versammlung teilnehmen, die allen Aktionären erlauben, einander zu hören.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen der vorliegenden Satzung treffen die Aktionäre, die eine Mehrheit von

mindestens 85% der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft halten und entweder persönlich anwesend oder durch Voll-
macht  vertreten  sind,  über  jede  Frage,  die  der  Versammlung  vorgelegt  wird,  eine  Entscheidung,  einschließlich  der
Entscheidung über eine Satzungsänderung, wobei hiervon die Fälle ausgenommen sind, in denen gesetzlich eine höhere
Stimmenzahl oder ein höherer Prozentsatz erforderlich sind. Außer mit Zustimmung der Aktionäre, die eine Mehrheit
von mindestens 85% der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft vertreten, (i) soll die Gesellschaft keine Investitionen

80586

durchführen oder neue Aktien oder Schuldverschreibungen ausgeben; (ii) keine Darlehen an irgendeine Person vergeben;
(iii) darf der Manager nicht irgendeine Transaktion mit der Gesellschaft vereinbaren und soll sicherstellen, dass deren
Tochtergesellschaften dies ebenfalls nicht tun (keine Investition oder vertragliche Vereinbarung darf durch die Gesellschaft
getroffen werden, die zu einem tatsächlichen oder möglichen Interessenkonflikt mit dem Manager oder einer ihrer Toch-
tergesellschaften führt ohne Zustimmung der Aktionäre, die eine Mehrheit von mindestens 85% der ausgegebenen Aktien
der Gesellschaft halten); oder (iv) darf der Manager nicht den Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber den Aktionären
zuwiderhandeln, die in einem zwischen der Gesellschaft und den Aktionären geschlossenen Vertrag oder auf andere
Weise festgelegt sind.

Titel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten des Dezember

jeden Jahres.

Art. 15. Nach Abzug aller Ausgaben und Amortisierungen der Gesellschaft bildet der Saldo den Nettogewinn der

Gesellschaft. Von diesem Nettogewinn werden fünf Prozent (5%), aber nur in dem gesetzlich erforderlichen Umfang der
gesetzlichen Rücklage zugewiesen. Diese Zuweisung endet, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Ge-
sellschaftskapitals  erreicht  hat,  soll  aber  wieder  aufgenommen  werden,  wenn  zu  irgendeinem  Zeitpunkt  und  aus
irgendeinem Grund, die gesetzliche Rücklage unter die erforderlichen zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals ge-
fallen ist.

Der Saldo des Nettogewinns soll durch die Gesellschaft an die Aktionäre und oder Inhaber von Schuldverschreibungen

verteilt werden (im Falle von Inhabern von Schuldverschreibungen durch Rückkauf der Schuldverschreibungen oder auf
andere Weise).

Titel VII. - Auflösung und Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst werden. Die Liquidation

wird von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die von der Hauptversammlung der Aktionäre bestellt werden,
welche ihre Befugnisse und Vergütung festlegt.

Titel VIII. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Alle Angelegenheiten, die nicht von dieser Gesellschaftsatzung geregelt werden, werden in Übereinstimmung

mit dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und den hierzu erfolgten Gesetzesänderungen inter-
pretiert, ausgelegt und ergänzt.

Da keine weiteren Tagesordnungsangelegenheiten zu besprechen sind, schließt der Vorsitzende die Sitzung.

Die vorliegende Urkunde wurde in Luxemburg am eingangs genannten Tag erstellt.
Nach Verlesung für die Mitglieder des Bureaus und den Bevollmächtigten der Aktionäre wird die vorliegende Origi-

nalurkunde  gemeinsam  mit  allen  bei  der  Versammlung  anwesenden  oder  vertretenen  Aktionären  und  dem  Notar
unterzeichnet.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Wunsch der erschienenen Personen in englischer Sprache verfasst wird und eine deutsche Fassung ange-
schlossen wird.

Auf Wunsch der erschienenen Personen soll die englische Fassung im Falle von Abweichungen zwischen der englischen

und deutschen Version die maßgebliche Fassung sein.

Gezeichnet: P. Van Hees, A. Braquet, A. Siebenaler, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 mai 2006, vol. 436, fol. 64, case 8. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt.

Mersch, den 16. Mai 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007080608/242/543.
(070088731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2007.

FIF Partenariat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 100.521.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

80587

Luxembourg, le 6 juillet 2007.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2007080335/634/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2007, réf. LSO-CG01342. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

BERENGER Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.202.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>BERENGER INVESTMENT S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Référence de publication: 2007080334/24/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01695. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Société Générale d'Investissements S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 31.248.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Référence de publication: 2007080333/24/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01874. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Goedert-Helfent Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 64.191.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
PKF WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseur d'entreprises
Signatures

Référence de publication: 2007080332/592/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01798. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

80588

Dolvifra Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 73.279.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
PKF WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseur d'entreprises
Signatures

Référence de publication: 2007080331/592/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01811. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070087871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Bacur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 90.230.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
PKF WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseur d'entreprises
Signatures

Référence de publication: 2007080317/592/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01790. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Goedert Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 26.235.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
PKF WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseur d'entreprises
Signatures

Référence de publication: 2007080316/592/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01794. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Agence Immobilière Henri GOEDERT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 28.360.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

80589

<i>Pour la société
PKF WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseur d'entreprises
Signatures

Référence de publication: 2007080315/592/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01796. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Arise, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 105.776.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>ARISE S.A.
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST
Y. Cacclin / R. Meister / J.-P. Tran-Phat
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007080314/45/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2007, réf. LSO-CG02324. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Sobedy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 94.507.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2007.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Référence de publication: 2007080187/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2007, réf. LSO-CG00307. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Taqui Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 87.056.

Le bilan au 30 avril 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007080312/631/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2007, réf. LSO-CF07243. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

80590

Colupa, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 28.367.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080337/802/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01975. - Reçu 36 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070087916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Socamil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 54.322.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080336/802/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01966. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Reed S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 82.668.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080326/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01997. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Reed S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 82.668.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080325/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG01999. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

C.M.W. Canadian Mineral Water Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 82.654.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

80591

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080324/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG02002. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

New Zealand Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 83.712.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080322/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG02005. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070087843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Immo Leu Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 83.581.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080321/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG02006. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

C.M.W. Canadian Mineral Water Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 82.654.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080323/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG02003. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

North Island Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 88.250.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007080320/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2007, réf. LSO-CG02007. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070087848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

80592


Document Outline

Agence Immobilière Henri GOEDERT S.à r.l.

AGF Life Luxembourg S.A.

Alpha Engineering S.A.

Arise

ARJUFRA Group S.à r.l.

Babet S.à r.l.

Bacur S.A.

BERENGER Investment S.A.

Bureau Moderne S.A.

Byblos Holdings S.à r.l.

Canalux S.à r.l.

Catella Luxembourg S.à r.l.

Cheryl Investissements S.A.

CHLEPAM Group S.à r.l.

C.M.W. Canadian Mineral Water Development S.A.

C.M.W. Canadian Mineral Water Development S.A.

Colupa

Dolvifra Holding S.A.

EFF Luxembourg S.à r.l.

Elca S.A.

Eurotransnord s.à r.l.

Fendi S.A.

FIF Partenariat S.A.

Finover S.A.

Geocontrol S.A.

Global Insurance &amp; Reinsurance Consultants (G.I.R.C.) S.A.

Goedert-Helfent Immobilière S.A.

Goedert Immobilière S.à r.l.

Immobilière DUWEL S.A.

Immobilière Scheergaass S.A.

Immo Leu Real Estate S.A.

Jucari S.A.

Kauri Capital 1

Lexfam S.à r.l.

Leya S.A.

Manuflex S.A.

New Zealand Properties S.A.

North Island Properties S.A.

Oleandri S.A.

Reech AiM Group

Reed S.A.

Reed S.A.

Rock Ridge RE 20

R &amp; S International S.A.

Sabco S.A.

Salvia Europe S.A.

SDB Finanziaria S.A.

Serilux S.à r.l.

Sigma Capital Hospitality, Leisure and Tourism Holding Company S.A.

Sobedy S.à r.l.

Socamil S.A.

Société Générale d'Investissements S.A.

Tafi S.A.

Taqui Investments

TG Leasing (Lux) S.àr.l.

Tozeur S.A.

Universal Sales and Services S.A.

WGRM Holding 7 S.A.