logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1639

3 août 2007

SOMMAIRE

Actaris Metering Systems . . . . . . . . . . . . . . .

78637

Actaris Metering Systems S.àr.l.  . . . . . . . . .

78637

Akita S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78635

Alicante S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78672

A. Menarini Participations Dresden S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78634

A. Menarini Real Estate Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78631

Anderton Global Energy Limited S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78636

A + P Kieffer Omnitec S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

78627

BPER International Sicav  . . . . . . . . . . . . . . .

78648

CB Richard Ellis Investors S.à r.l.  . . . . . . . .

78627

Censor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78633

CEREP Vivienne S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

78666

Chandela (Management) G.m.b.H.  . . . . . .

78659

Crèche Tiramisu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78658

D.M. Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78658

"Dune" Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78672

EM Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

78637

EuroSignCard Finance 1 S.A. . . . . . . . . . . . .

78647

Finconseil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78626

Fitech S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78631

Flexible Packaging Investments S.à r.l.  . . .

78667

Gelins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78626

Gestair International Council S.à r.l.  . . . . .

78628

Immoc S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78656

Immo G Investissements S.à r.l.  . . . . . . . . .

78630

Infante S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78629

Interlux Asset S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78630

January Storm Investments S.A. . . . . . . . . .

78628

JP Commercial V S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

78649

Karitoë Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78630

Karitoe Participations Sàrl  . . . . . . . . . . . . . .

78631

Katran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78665

Laronde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78628

Ligne Holdco Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

78636

Menarini International Investment S.A. -

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78632

Natursteen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78626

Navitas Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

78631

Newtec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78632

Omnitec Infra S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78627

Prod S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78632

ProLogis France XIV S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . .

78659

ProLogis France XIX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

78629

ProLogis France XXXI S.àr.l.  . . . . . . . . . . .

78629

Railtour Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78635

Rast Développement S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

78632

Royal Logistics Holding S.A. . . . . . . . . . . . . .

78635

Salon de Coiffure Beim Nadine S.à r.l.  . . .

78636

S.C.G.S. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78633

Sedianad S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78633

Sky Broadband S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78648

Société Financière Anigh S.A.  . . . . . . . . . . .

78630

Tarkett Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78634

Tarkett S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78636

Tomasmill  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78656

Tropique S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78635

Un Autre Monde, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

78627

Vadec International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

78633

Varenne Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78658

Venusfin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78626

Wall-Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78634

Yakashi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78634

78625

Finconseil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 44.409.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FINCONSEIL S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Référence de publication: 2007077124/752/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2007, réf. LSO-CF03742. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Natursteen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7245 Luxembourg, 10, rue du Pont.

R.C.S. Luxembourg B 58.747.

Le bilan au 31 décembre 2006 ainsi que le rapport de gestion ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007075812/1801/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2007, réf. LSO-CF04467. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070082107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2007.

Venusfin, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 45.406.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VENUSFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

Référence de publication: 2007077126/24/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2007, réf. LSO-CF09719. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Gelins, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 53.199.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007077125/4685/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2007, réf. LSO-CF10088. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

78626

A + P Kieffer Omnitec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7-9, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 48.224.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour A+P KIEFFER OMNITEC S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Référence de publication: 2007077121/752/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2007, réf. LSO-CF00554. - Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Omnitec Infra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7-9, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 89.817.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour OMNITEC INFRA S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Référence de publication: 2007077120/752/14.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2007, réf. LSO-CF00847. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

CB Richard Ellis Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 94.168.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2007.

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007077357/805/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, réf. LSO-CF10270. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Un Autre Monde, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 106, rue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 97.826.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007077359/3580/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2007, réf. LSO-CF03999. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

78627

Laronde, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 43.492.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 25 mai 2007 a renouvelé les mandats des administrateurs,
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill

L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Jean-Pierre Dupret, Administrateur, administrateur de sociétés, 1, avenue des Mésanges, B-1390 Grez-

Doiceau, Belgique.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.
L'assemblée générale du 25 mai 2007 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster, RCS Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

Luxembourg, le 25 mai 2007.

<i>Pour LARONDE, Société anonyme holding
Signature

Référence de publication: 2007074742/833/23.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2007, réf. LSO-CF06771. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070080553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2007.

January Storm Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 92.934.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

JANUARY STORM INVESTMENTS S.A.
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007077351/2570/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2007, réf. LSO-CF10112. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Gestair International Council S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1257 Luxembourg, 2, rue Nicolas Braunshausen.

R.C.S. Luxembourg B 100.562.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2007.

<i>Pour GESTAIR INTERNATIONAL COUNCIL S.à r.l.
G. de Cugnac Dampierre
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2007077576/565/17.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, réf. LSO-CF10249. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

78628

ProLogis France XIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 74.841.

Le bilan des résultats au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2007.

ProLogis DIRECTORSHIP Sàrl
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

Référence de publication: 2007075817/1127/16.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2007, réf. LSO-CF04852. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070082088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2007.

Infante S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 49.649.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 8 juin 2007 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Maître Tom Loesch, Administrateur, avocat, 35, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Raymond Balsen, Administrateur-Président, administrateur de sociétés, 31, boulevard Prince Henri, L-1724

Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.
L'assemblée générale du 8 juin 2007 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster, RCS Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

Luxembourg, le 8 juin 2007.

<i>Pour INFANTE S.A., Société anonyme
Signature

Référence de publication: 2007074741/833/22.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2007, réf. LSO-CF06785. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070080560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2007.

ProLogis France XXXI S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 80.336.

Le bilan des résultats au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2007.

ProLogis DIRECTORSHIP Sàrl
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

Référence de publication: 2007075818/1127/16.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2007, réf. LSO-CF04834. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070082090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2007.

78629

Interlux Asset S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 125.729.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 1 

er

 juin 2007 que:

Le siège social est transféré de L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2007.

ABROAD FIDUCIAIRE

Référence de publication: 2007077168/6951/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2007, réf. LSO-CF06142. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Karitoë Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 52.215.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 1 

er

 juin 2007 que:

Le siège social est transféré de L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2007.

ABROAD FIDUCIAIRE

Référence de publication: 2007077167/6951/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2007, réf. LSO-CF06145C. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Immo G Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 118.928.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 1 

er

 juin 2007 que:

Le siège social est transféré de L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins, à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2007.

ABROAD FIDUCIAIRE

Référence de publication: 2007077169/6951/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2007, réf. LSO-CF06139. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Société Financière Anigh S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 43.859.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007077339/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2007, réf. LSO-CF08431. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

78630

Fitech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 125.773.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 1 

er

 juin 2007 que:

Le siège social est transféré de L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins, à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2007.

ABROAD FIDUCIAIRE

Référence de publication: 2007077170/6951/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2007, réf. LSO-CF06137. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Karitoe Participations Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 106.694.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 1 

er

 juin 2007 que:

Le siège social est transféré de L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins, à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2007.

ABROAD FIDUCIAIRE

Référence de publication: 2007077166/6951/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2007, réf. LSO-CF06146. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Navitas Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 125.159.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 1 

er

 juin 2007 que:

Le siège social est transféré de L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins à, L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2007.

ABROAD FIDUCIAIRE

Référence de publication: 2007077165/6951/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2007, réf. LSO-CF06148. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

A. Menarini Real Estate Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 113.833.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007077584/3722/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2007, réf. LSO-CG00528. - Reçu 103 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

78631

Menarini International Investment S.A. - Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 66.819.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007077586/3722/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2007, réf. LSO-CG00525. - Reçu 103 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Newtec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 125.152.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 1 

er

 juin 2007 que:

Le siège social est transféré de L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins, à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2007.

ABROAD FIDUCIAIRE

Référence de publication: 2007077164/6951/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2007, réf. LSO-CF06150. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Prod S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 127.344.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 1 

er

 juin 2007 que:

Le siège social est transféré de L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2007.

ABROAD FIDUCIAIRE

Référence de publication: 2007077163/6951/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2007, réf. LSO-CF06155. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Rast Développement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 110.565.

IS résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 1 

er

 juin 2007 que:

Le siège social est transféré de L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins, à L-1661 Luxembourg, 47, Grand Rue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2007.

ABROAD FIDUCIAIRE

Référence de publication: 2007077162/6951/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2007, réf. LSO-CF06159. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

78632

S.C.G.S. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 115.856.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 1 

er

 juin 2007 que:

- Le siège social est transféré de L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2007.

ABROAD FIDUCIAIRE

Référence de publication: 2007077161/6951/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2007, réf. LSO-CF06160. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Sedianad S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 106.575.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 1 

er

 juin 2007 que:

Le siège social est transféré de L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2007.

ABROAD FIDUCIAIRE

Référence de publication: 2007077160/6951/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2007, réf. LSO-CF06161. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Vadec International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 96.978.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007075822/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2007, réf. LSO-CF08026. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070082018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2007.

Censor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 99.374.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2007075758/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2007, réf. LSO-CF08978. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070081923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2007.

78633

Yakashi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 105.038.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2007075759/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2007, réf. LSO-CF08980. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070081925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2007.

Wall-Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 137, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 104.455.

Le bilan au 31 décembre 2006, le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire et le rapport

du Commissaire aux comptes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007075760/1801/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2007, réf. LSO-CF04463B. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070082100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2007.

Tarkett Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9542 Wiltz, 1, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 95.549.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 28 mai 2007.

J.-L. Ehx
<i>Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2007075761/800647/14.
Enregistré à Diekirch, le 20 juin 2007, réf. DSO-CF00211. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070082529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2007.

A. Menarini Participations Dresden S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 116.223.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007077589/3722/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2007, réf. LSO-CG00531. - Reçu 101 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

78634

Railtour Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 14.044.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2007.

M. Buschmann
<i>La Gérante

Référence de publication: 2007077593/2963/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, réf. LSO-CF10561. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Tropique S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.

R.C.S. Luxembourg B 113.229.

Le bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TROPIQUE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007077594/1651/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, réf. LSO-CF10205. - Reçu 36 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Akita S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.

R.C.S. Luxembourg B 40.638.

Le bilan et l'affectation du résultat au 30 juin 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AKITA S.A.
Signature

Référence de publication: 2007077595/1651/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, réf. LSO-CF10206. - Reçu 36 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Royal Logistics Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 48.252.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007075821/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2007, réf. LSO-CF08029. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070082016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2007.

78635

Tarkett S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9779 Lentzweiler, 2, Op der Sang.

R.C.S. Luxembourg B 92.165.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 28 juin 2007.

J.-L. Ehx
<i>Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2007075762/800019/14.
Enregistré à Diekirch, le 20 juin 2007, réf. DSO-CF00218. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070082532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2007.

Ligne Holdco Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 110.378.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007075820/534/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2007, réf. LSO-CF07809. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070082015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2007.

Salon de Coiffure Beim Nadine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5444 Schengen, 13, Hemmeberreg.

R.C.S. Luxembourg B 82.002.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour SALON DE COIFFURE BEIM NADINE SARL
Signature

Référence de publication: 2007075751/597/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2007, réf. LSO-CF07843. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070081898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2007.

Anderton Global Energy Limited S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 124.149.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2007.

<i>Pour ANDERTON GLOBAL ENERGY LIMITED S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007075819/1081/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2007, réf. LSO-CF06769. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070082091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2007.

78636

EM Finance Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 81.492.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2007.

<i>Pour EM FINANCE HOLDING S.A.
HRT REVISION S.à r.l.
<i>Domiciliataire
D. Ransquin

Référence de publication: 2007077582/565/17.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2007, réf. LSO-CF10258. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Actaris Metering Systems S.àr.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Actaris Metering Systems).

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 108.445.

In the year two thousand and seven on the twenty-fifth day of April.
Before us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of ACTARIS METERING SYSTEMS, a

public limited liability company, having its registered office at 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg under number B 108.445 (the Company),
incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, of June 3, 2005, published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C No. 1039, of October 14, 2005. The articles of association of the
Company (the Articles) have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph
Wagner of March 22, 2007, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting is chaired by Ms Claire-Marie Darnand, lawyer, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as Secretary Mr Bernard Beerens, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg.
The Meeting elects as Scrutineer Mr Etienne de Crepy, lawyer, residing in Luxembourg, (the Chairman, the Secretary

and the Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting).

The Bureau formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. It appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that 65,208 (sixty five

thousand two hundred and eight) shares, having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, and representing the
entire share capital of the Company, are duly represented at the Meeting, which is consequently regularly constituted
and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

II. The agenda of the Meeting is the following:
1. Waiver of the convening notices;
2. Change of the Company's legal form from a public company limited liability company (société anonyme) into a private

limited liability company (société à responsabilité limitée);

3. Amendment to the current article 2 of the Articles which will become article 1 of the restated Articles and which

shall read as follows:

Art. 1. There exists a private limited liability company under the name of ACTARIS METERING SYSTEMS S.à r.l.(the

Company), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular by the law of 10th
August 1915, on Commercial Companies as amended (the Law) as well as the present articles of association (the Articles).

4. Amendment to article 3 of the Articles which shall read as follows:
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-

78637

ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and
undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

5. Amendment to articles 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. and

24. of the Articles; subsequent restatement and renumbering of the Articles in their entirety and, to the extent necessary,
insertion or change of heading in the Articles;

6. Confirmation of the appointment of Mr John Holleran, Mr Malcom Unsworth, Mr Christian Kubitza, Mr Vincent

Goy, Mr Jean-Paul Bize, Mrs Laurence Valenduc, and Mr Thierry Pimenta de Miranda as managers of the Company, for
an unlimited period of time.

These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the Meeting, duly represented, unanimously

resolves on the following:

<i>First resolution

The Meeting resolves to waive the convening notices, the shareholder of the Company having been duly convened

and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to change the form of the Company from that of a public limited liability company (société

anonyme) into a private limited liability company (société à responsabilité limitée), such resolution to become effective
immediately after the passing of the following resolutions hereafter.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend the current article 2 of the Articles which will become article 1 of the restated Articles

and which shall read as follows:

« Art. 1. There exists a private limited liability company under the name of ACTARIS METERING SYSTEMS S.à r.l.

(the Company), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular by the law of
10th August 1915, on Commercial Companies as amended (the Law) as well as the present articles of association (the
Articles).

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 3 of the Articles which shall henceforth read as follows:

« Art. 3. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies

or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and
undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.»

78638

<i>Fifth resolution

In addition to the above amendments and as a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to amend

articles 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. and 24. of the Articles,
restate and renumber the Articles in their entirety and, to the extent necessary, insert or change any headings in the
Articles, which will read henceforth, as follows:

I.- Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company under the name of ACTARIS METERING SYSTEMS S.à

r.l. (the Company), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular by the law
of 10th August 1915, on Commercial Companies as amended (the Law) as well as the present articles of association (the
Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder, or as the case may be, the general meeting of
shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and
undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II.- Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at EUR 1,630,200.- (one million six hundred and thirty thousand two

hundred euro) represented by 65,208 (sixty-five thousand two hundred and eight) shares in registered form with a nominal
value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder, or as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

78639

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III.- Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one ore more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of

managers. The manager(s) is /are appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of share-
holders which sets the term of his/their/her office. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The manager(s) may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the single manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters (i) by the single signature

of the manager in case of a single manager, (ii) by the joint signatures of any two members of the board of managers, or
(iii) by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance
with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

78640

IV.- General Meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V.- Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager, or as the case may be, the board

of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The single shareholder, or as the case may be, the general meeting of shareholders has discretionary power to

dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve
or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) Interim accounts are established by at least one manager;
(ii) These interim accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
(iii) The decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder, or as the case may be, the general meeting

of the shareholders;

(iv) The above decision is taken after the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the

Company are not threatened.

VI.- Dissolution - Liquidation

16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.

VII.- General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to confirm the appointment as of the date hereof for an unlimited period of time of the following

managers:  Mr  John  Holleran,  Mr  Malcom  Unsworth,  Mr  Christian  Kubitza,  Mr  Vincent  Goy,  Mr  Jean-Paul  Bize,  Mrs
Laurence Valenduc and Mr. Thierry Pimenta de Miranda, constituting therefore the board of managers of the Company.

78641

There being no further business on the agenda the meeting has been adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party

the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the representatives of the appearing party, they signed together with Us, the notary,

this original notarial deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Rémich.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire de la société anonyme ACTARIS

METERING SYSTEMS (la Société), ayant son siège social à 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 108.445, constituée suivant
acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, du 3 Juin 2005, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, N 

o

 1039, du October 14, 2005. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs

fois et pour la dernière fois selon acte de Maître Jean-Joseph Wagner du 22 mars 2007, non encore publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée est présidée par Melle Claire-Marie Darnand, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme Secrétaire M. Bernard Beerens, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme Scrutateur M. Etienne de Crépy, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, (le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur constituant le Bureau de l'Assemblée).

Le Bureau étant constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- Il ressort de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du Bureau que 65.208 (soixante-cinq mille

deux cent huit) actions, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, et formant l'intégralité du
capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée, de sorte que celle-ci est régulièrement constituée
et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, ci-après reproduits.

II.- L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux convocations à l'Assemblée;
2. Changement de la forme sociale de la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée;
3. Modification de l'actuel article 2 des Statuts qui deviendra l'article 1 

er

 des Statuts coordonnés et qui aura désormais

la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ACTARIS METERING SYSTEMS S.à

r.l. (la Société), qui est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les Sociétés Commerciales telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

4. Modification de l'article 3 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou
des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière,
des sûretés  portant  sur  toute  ou partie  de  ses  avoirs  afin de garantir ses  propres obligations et engagements  et/ou
obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre
société ou personne.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change,
de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

78642

5. Modification des articles 1 

er

 ., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23.

et 24. des Statuts, reformulation subséquente et renumérotation des Statuts dans leur intégralité et, dans la mesure
nécessaire, insertion ou changement de tous titres dans les Statuts;

6. Confirmation de la nomination de M. John Holleran, M. Malcom Unsworth, M. Christian Kubitza, M. Vincent Goy,

M. Jean-Paul Bize, Mme Laurence Valenduc et M. Thierry Pimenta de Miranda en qualité de gérants de la Société, pour
une durée indéterminée.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, l'Assemblée, dûment représentée, décide à l'unanimité ce qui

suit:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de renoncer aux convocations à l'Assemblée, l'actionnaire de la Société ayant été dûment con-

voqué et ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

<i>Seconde résolution

L'Assemblée décide de modifier la forme sociale de la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée,

cette résolution devenant effective immédiatement après l'adoption des résolutions qui suivent.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'actuel article 2 des Statuts, qui deviendra l'article 1 

er

 des Statuts coordonnés et qui

aura désormais la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ACTARIS METERING SYSTEMS S.à

r.l. (la Société), qui est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les Sociétés Commerciales telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 3 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou
des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière,
des  sûretés portant  sur  toute ou  partie  de  ses avoirs  afin de garantir ses  propres obligations et engagements et/ou
obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre
société ou personne.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change,
de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

<i>Cinquième résolution

En sus des modifications mentionnées ci-dessus et comme conséquence des résolutions qui précèdent l'Assemblée

décide de modifier les articles 1 

er

 ., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23.

et 24. des Statuts, de reformuler et rénuméroter entièrement et, dans la mesure nécessaire, d'insérer ou changer tous
titres dans les Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

I.- Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1 

er

 . Nom.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ACTARIS METERING SYSTEMS

S.à r.l. (la Société), qui est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier par la loi du 10 août 1915
sur les Sociétés Commerciales telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

78643

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des

succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou
des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière,
des sûretés  portant  sur  toute  ou  partie  de  ses  avoirs afin de garantir ses propres  obligations et  engagements et/ou
obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre
société ou personne.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change,
de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II.- Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à EUR 1.630.200,- (un million six cent trente mille deux cent euros), représenté par 65.208

(soixante-cinq mille deux cent huit) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi.

78644

III.- Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) sont nommés par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés lequel/laquelle
fixe la durée de leur mandat. Le(s) gérants ne sont pas nécessairement des associé(s).

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum (sans motif).

Art 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,

associés ou non, par le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des

gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d' urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou

représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par i) la seule signature

du gérant en cas de gérant unique, (ii) les signatures conjointes de deux membres du conseil de gérance ou (iii) par les
signatures unique ou conjointe(s) de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués
conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV.- Assemblée Générale des Associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

78645

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V.- Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,

doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde

restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la
réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) Des comptes provisoires est établi par au moins un gérant;
(ii) il ressort de ces comptes provisoires qu'il existe des profits incluant les bénéfices reportés ou transférés à une

réserve extraordinaire;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés;
(iv) la décision qui précède est prise après que la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société

ne sont pas menacés.

VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.

VII.- Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de confirmer la nomination pour une période illimitée à compter de la date des présentes des

gérants suivants: M. John Holleran, M. Malcom Unsworth, M. Christian Kubitza, M. Vincent Goy, M. Jean-Paul Bize, Mme.
Laurence Valenduc et M. Thierry Pimenta de Miranda, constituant ainsi le conseil de gérance de la Société.

Plus rien ne figurant a l'ordre du jour, l'assemblée a été ajournée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la partie comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, à la requête de la même partie comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et lecture faite aux personnes mandataires de la partie comparante, les personnes mandataires ont signé le présent

acte avec Nous, notaire.

Signé: C. M. Darnand, B. Beerens, E. De Crépy, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 27 avril 2007, REM/2007/946. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

78646

Remich, le 31 mai 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007076729/5770/537.
(070083890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

EuroSignCard Finance 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 77.028.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5,

boulevard de la Foire,

«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE e-Commerce, ayant son siège

social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

«le mandant»
en vertu d'une procuration sous seing privé elle délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis

1. Que la société anonyme EuroSignCard FINANCE 1 S.A., R.C.S. Luxembourg B n 

o

 77.028, ayant son siège social à

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 7 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n 

o

 898 du 12

décembre 2000.

2. Que le capital social de la société anonyme EuroSignCard FINANCE 1 S.A. s'élève actuellement à EUR 1.503.500,-

représenté par 150.350 actions de EUR 10,- chacune, entièrement libérées.

3.  Que  son  mandant  est  devenu  successivement  propriétaire  de  la  totalité  des  actions  représentatives  du  capital

souscrit de la société anonyme EuroSignCard FINANCE 1 S.A.

4. Que par la présente, la soussignée prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.
5. Que son mandant, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme EuroSignCard FINANCE 1 S.A., déclare que

tout le passif de ladite société est réglé.

6. Que son mandant requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement

inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, elle déclare irrévocablement assumer solidairement avec la société
l'obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.

7. Que l'activité de la société a cessé; que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il réglera tout passif

éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

8. Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la société.
9. Que le mandataire ou le notaire instrumentant peuvent procéder à l'annulation des actions de la société.
10. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO COMPA-

GNIE FIDUCIAIRE.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Lentz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2007, Relation: LAC/2007/6322. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007077077/211/48.
(070084141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

78647

BPER International Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 61.517.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2007.

<i>Pour BPER INTERNATIONAL SICAV
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
M. Dinklage / A. Trappendreher
<i>Associate Director / <i>Associate Director

Référence de publication: 2007077591/1360/16.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2007, réf. LSO-CF09067. - Reçu 102 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070084616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Sky Broadband S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 118.641.

<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting held on June 7th, 2007

- The resignation of Mr. Patrick Smidts as a Director of the Company with effect as at October 11th, 2006 is accepted.
-  Mr.  Arjen  Berendsen,  company's  director  born  on  January  17th,  1969  in  Groningen,  The  Netherlands,  residing

Karspeldreef 14,1101 CK Amsterdam, The Netherlands is appointed as Director of the Company with effect as at Oc-
tober 11th, 2006. His mandate will lapse at the Annual General Meeting to be held in the year 2012.

- Messrs Elvinger, Berendsen and Sevenig are designated as A Directors of the Company.
- Messrs Gormley and Griffith and Ms Pearce are designated as B Directors of the Company. It is noted that Ms Pearce's

address changed into 77, Sydney Road, London, SW20 8EG, United Kingdom with effect as of February 23rd, 2007.

- The resignation of ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, having its registered office at 7, parc d'Activité Syrdall,

L-5365 Munsbach, as Statutary Auditor is accepted.

- The company DELOITTE S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois, having its registered office at 560, rue de

Neudorf, L-2220 Luxembourg is appointed as Independent Auditor for a term of one year. Its mandate will lapse at the
Annual General Meeting approving the 2007 annual accounts of the company.

For true copy

Suit la traduction en français de ce qui précède:

<i>Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juin 2007

- La démission de Monsieur Patrick Smidts en tant qu'Administrateur de la société avec effet au 11 octobre 2006 est

acceptée.

- Monsieur Arjen Berendsen, Administrateur de sociétés, né le 17 janvier 1969 à Groningen, Pays-Bas, demeurant au

14, Karspeldreef, 1101CK Amsterdam, Pays-Bas est nommé en tant qu'Administrateur de la société avec effet au 11
octobre 2006. Son mandat viendra a échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

- Messieurs Elvinger, Berendsen et Sevenig sont désignés en tant qu'Administrateurs de Catégorie A.
- Messieurs Gormley et Griffith ainsi que Madame Pearce sont désignés en tant qu'Administrateurs de Catégorie B. Il

est noté que Madame Pearce a changé d'adresse en date du 23 février 2007. Elle demeure au 77, Sydney Road, London,
SW20 8EG, Royaume-Uni.

- La démission de ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, ayant son siège social au 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365

Munsbach, en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.

- La société DELOITTE S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 560, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg est nommée en tant que Réviseur d'Entreprises Indépendant pour une période de un an. Le mandat
de DELOITTE S.A. viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.

78648

Certifié sincère et conforme
<i>SKY BROADBAND S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007074687/795/43.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2007, réf. LSO-CF08140. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070081063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2007.

JP Commercial V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 80B, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 129.113.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the twenty-first of May.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing at Remich, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The company JARGONNANT PARTNERS S.à r.l., a company incorporated under Luxembourg law, with registered

office at 80 B, rue Principale, 5367 Schuttrange, Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under section B, number 78.830, duly represented by Ms Verena Zimmermann, maître en droit, residing in
Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Munich, on the 9th of May 2007.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state the articles of

association of a private limited company («société à responsabilité limitée») governed by the relevant laws and the present
articles:

Title I. Name - Duration - Registered office - Purpose

Art. 1. There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future,

Gesellschaft mit begrenzter Haftung which will be governed by the laws in force, namely the Companies' Act of August
10, 1915, such as amended, and by these articles of association, under the name of JP COMMERCIAL V S.à r.l.

Art. 2. The company is established for a limited period of time. The company will exist until 20 May 2017 at the latest.

After this date, the company will only continue to exist for the purpose of its own liquidation.

Art. 3. The registered office of the company is established in the municipality of Schuttrange (Grand Duchy of Lux-

embourg).

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general

meeting of its members. Within the same municipality the registered office may be transferred through resolution of the
manager(s). Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager
(s).

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the nationality of the company. The declaration of the transfer of the registered office will be made
and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under
the given circumstances.

Art. 4. The purpose of the Company is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of real estate

located in Luxembourg or abroad.

The Company may hold ancillary participations in whichever form in domestic and foreign companies and branches,

as well as debt and equity interests in companies the primary object of which is the acquisition, development, promotion,
sale and lease of property, together with interests in properties, rights over properties and furniture.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of partnership or similar entities.

78649

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Title II. Capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by ten thousand

(10,000) shares with a par value of one Euro twenty-five Cents (EUR 1.25) each, which have been fully subscribed.

Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the company shall represent the entire body of members of

the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the
company.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by majority

consent of those present and voting.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member

or by (i) a majority of members (ii) representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may also change
the nationality of the company by a unanimous decision.

If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

The members may also take resolutions in writing without meeting if there are twenty-five (25) members or less.

Art. 7. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the company. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner
or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.

Each share gives right to one fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relationship

with the number of shares in existence.

Art. 8. If the company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
The decisions of the sole member, which are taken in the scope of the first paragraph, are recorded in minutes or

drawn-up in writing.

Also, contracts entered into between the sole member and the company represented by him are recorded on minutes

or drawn-up in writing.

Art. 9. If the company has at least two members, the shares are freely transferable between the members.
The share transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members

representing at least three quarters (3/4) of the company's share capital.

In the case of the death of a member the share transfer to non-members is subject to the consent of owners of shares

representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the
approval is not required if the shares are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.

Art. 10. Bankruptcy or insolvency of one or more of the members will not put an end to the company.

Art. 11. The creditors or legal successors of the members may neither, for whatever reason, affix seal on the assets

or documents of the company, nor interfere in any manner in the management of the company.

Title III. Administration and audit

Art. 12. The company shall be managed by one or several managers, who need not be members of the company.
The manager(s) is/are appointed and removed by a decision of the general meeting of members, which determines

their powers, compensation and duration of their mandates. The manager(s) shall hold office until their successors are
appointed.

The managers may be removed without cause.

Art. 13. The manager(s) may choose from among themselves a chairman. They may also choose a secretary, who needs

not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the managers and of the members.

The managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of

the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram,
telex or telefax of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the managers.

Any manager may act at any meeting of the managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax

another manager as his proxy.

78650

Votes may also be cast in writing or by e-mail, telegram, telex or telefax.
Each manager may take any actions necessary or useful to realise the corporate object, with the exception of those

reserved by law to be decided upon by the members.

Art. 14. The minutes of any meeting of the managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman

pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 15. Each manager may confer all powers and special mandates to any person who need not to be managers, appoint

and dismiss all officers and employees, and fix their remuneration.

Art. 16. The company will be bound by the sole signature of any manager or by any person(s) to whom power has

been delegated or conferred in accordance with Article 15 in relation to the exercise of those powers.

Art. 17. In the execution of their mandate, the manager(s) is/are not held personally liable for the obligations of the

company. However, managers may be liable for acts or omissions in the execution of their duties.

Art. 18. The accounting year of the company shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December

31st of the same year.

Art. 19. The annual accounts are drawn up by the manager(s) as at the end of each fiscal year and will be at the disposal

of the members at the registered office of the company. Each member may inspect at any time the annual accounts and
in general the books of the company at the registered office of the company. The credit balance of the profit and loss
account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the
net profit of the company.

Out of the annual net profits of the company, five percent (5%) shall be allocated to the legal reserve account. This

deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but
will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason this
threshold is not met anymore.

The general meeting of members, upon recommendation of the manager(s), will determine by vote how the annual

net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. The annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by the members;
2. The interim accounts are established by the manager(s);
3. The interim accounts have been reviewed by the auditor, if any;
4. These accounts show sufficient profits, including profits carried forward, or any other distributable reserve;
5. The decision to pay interim dividends is taken by the manager(s).

Art. 20. The financial statements of the company may be audited by one or several statutory or independent auditors.

The general meeting of members shall decide on the opportunity to appoint one or several auditor(s), and shall determine
their number, remuneration and term of office.

Title IV. Winding up - Liquidation

Art. 21. In the event of dissolution of the company, which will take place at the latest immediately after 20 May 2017,

the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed
by the meeting of members effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

When the liquidation is closed, the assets of the company will be distributed to the members proportionally to the

shares they are holding.

Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto.

Art. 23. Any litigation which might occur during the liquidation of the company, either between the members them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the business of the company is concerned,
by arbitration in compliance with the civil procedure.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183

of the law of August 10, 1915 on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Subscription

The ten thousand (10,000) shares have been fully paid-in by JARGONNANT PARTNERS S.à r.l., pre-named, so that

the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the company, as was certified
to the notary executing this deed.

78651

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

<i>General meeting of the member

Immediately after the incorporation of the company, the member representing the entire corporate capital represented

as here above stated, held an extraordinary general meeting and passed the following resolutions:

1) The meeting resolves that the number of managers shall be set at two (2).
2) The following persons are appointed managers of the Company with effect as at today for an unlimited period:
- Karl-Erbo Graf Kageneck, Stollbergstr. 11, D-80539 München, Germany, born 29 July 1947 in Wittlich, Lawyer (LL.M.)
- Daniel Graf von der Schulenburg, Keferstr. 6, D-80802 München, Germany, born 27 January 1961 in Algier, Merchant.
3) The registered office of the Company is at 5367 Schuttrange, 80B, rue Principale, Luxembourg.
4) The first financial year shall start on the day of incorporation and close on 31 December 2007.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

this deed.

Es folgt die deutsche Fassung:

Im Jahre zweitausendundsieben, am einundzwanzigsten Mai.
Vor der unterzeichneten Notarin Martine Schaeffer mit Amtssitz in Remich, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft JARGONNANT PARTNERS S.à r.l., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz

in 80 B, rue Principale, 5367 Schuttrange, Luxemburg, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg,
unter der Sektion B, Nummer 78.830, hier vertreten durch Frau Verena Zimmermann, maître en droit, wohnhaft in
Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in München am 9. Mai 2007.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch die erschienene Person und den unterzeichneten Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersuchte die unterzeichnete Notarin, die Satzung einer Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, die dem geltenden Recht und der vorliegenden Satzung unterliegt, zu beurkunden.

Titel I. Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck

Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, die später Gesellschafter der Gesellschaft wer-

den, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die dem derzeitig geltenden Recht,
nämlich dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung und der folgenden
Satzung unterliegt und die Bezeichnung JP COMMERCIAL V S.à r.l. trägt.

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf beschränkte Dauer gegründet. Die Gesellschaft endet spätestens am 20. Mai 2017. Nach

diesem Datum wird die Gesellschaft ausschließlich zum Zwecke ihrer eigenen Auflösung weiter bestehen.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schuttrange (Großherzogtum Luxemburg).
Der Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der

Gesellschafterversammlung verlegt werden. Innerhalb der Gemeinde kann der Sitz der Gesellschaft durch Beschluss der
Geschäftsführung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland
durch die Geschäftsführung eröffnet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem

Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art gefährdet werden, so kann
der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.
Diese Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung einer Verlegung
an Dritte hat durch das Organ der Gesellschaft zu erfolgen, das unter den gegebenen Umständen hierzu am besten in
der Lage ist.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Wertsteigerung von und die Verfügung über Im-

mobilien in Luxemburg oder im Ausland.

Die Gesellschaft darf sonstige Beteiligungen jedweder Form in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften und

Niederlassungen sowie Anleihen und Kapitalanlagen in Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der Erwerb, die Ent-
wicklung, die Förderung, der Verkauf und die Vermietung von Immobilien ist, zusammen mit Kapitalinteressen in Eigentum,
Eigentumsrechten und Einrichtungen.

78652

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die

der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren, oder sie auf andere
Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann zudem als Komplementär oder Kommanditist mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung

für alle Schulden und Verpflichtungen von Kommanditgesellschaften oder ähnlichen Unternehmensstrukturen handeln.

Die Gesellschaft kann auf eigene Rechnung oder im Namen von Dritten alle Geschäfte betreiben, die der Erreichung

ihres Zweckes förderlich sind oder direkt oder indirekt mit diesem Zweck verbunden sind.

Titel II. Gesellschaftskapital und Gesellschaftsanteile

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in zehn

tausend (10.000) Gesellschaftsanteile zu je einem Euro fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25), die vollständig einbezahlt wur-
den.

Art. 6. Auf jeder ordnungsgemäß zusammengesetzten Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesell-

schafter der Gesellschaft vertreten. Sie hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen in Bezug auf die Geschäfte
der Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.

Sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafter-

versammlung per Beschluss einer einfachen Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.

Das Stammkapital sowie die Artikel dieser Satzung können zu jeder Zeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters

oder per Beschluss (i) einer Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals halten,
geändert werden. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann ebenfalls durch den einstimmigen Beschluss der
Gesellschafter herbeigeführt werden.

Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass

sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung abge-
halten werden.

Gesellschafterbeschlüsse können auch schriftlich und ohne Versammlung gefasst werden, wenn die Gesellschaft fünf-

undzwanzig (25) oder weniger Gesellschafter besitzt.

Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und außerordentlichen Ge-

sellschafterversammlung.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen. Falls ein Geschäftsanteil im Besitz

von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäftsanteils
aufzuheben, bis eine Person als alleiniger Eigentümer in Bezug auf die Gesellschaft benannt wurde. Das gleiche gilt für den
Konfliktfall zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen dem Schuld-
ner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und seinem Gläubiger.

Jeder Geschäftsanteil berechtigt zu einem Anteil an den Vermögensgegenständen und am erzielten Gewinn der Ge-

sellschaft in seinem direkten proportionalen Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Geschäftsanteile.

Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter die Funktion der Gesell-

schafterversammlung aus.

Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, die im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein Pro-

tokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.

Weiterhin werden Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertretenen

Gesellschaft geschlossen werden, schriftlich abgefasst.

Art. 9. Wenn die Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter den Gesell-

schaftern übertragbar.

Die Übertragung von Geschäftsanteile an Nicht-Gesellschafter ist abhängig von der Zustimmung der Gesellschafter,

die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals repräsentieren, in einer Gesellschafterversammlung.

Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von der

Zustimmung der Gesellschafter, die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter
repräsentieren.

In diesem Fall ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte oder den über-

lebenden Lebenspartner erfolgt.

Art. 10. Konkurs und Insolvenz eines oder mehrerer Gesellschafter haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur

Folge.

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Ge-

sellschaftseigentum  oder  Gesellschaftsdokumenten  stellen  noch  in  irgendeiner  Weise  in  die  Geschäftsführung  der
Gesellschaft eingreifen.

78653

Titel III. Geschäftsführung und Prüfung

Art. 12. Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern, die nicht Gesellschafter der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.
Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Befugnisse, die Vergütung und die Dauer des Mandats der Geschäfts-

führer, wobei diese ihr Amt solange ausüben, bis ein Nachfolger bestimmt wurde.

Die Geschäftsführer können ohne Grund abberufen werden.

Art. 13. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen.
Sie kann weiterhin einen Sekretär wählen, der nicht Geschäftsführer sein muss und verantwortlich für die Aufzeichnung

der Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.

Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführer zusammen und zwar

an dem Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.

Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens

vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, außer in dringenden Fällen, in
denen die Art der Dringlichkeit in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss.

Auf die Einberufung kann durch die schriftlich oder per Telefon, Telegramm, Telex oder Fax erteilte Zustimmung eines

jeden  Geschäftsführers  verzichtet  werden.  Gesonderte  Einberufungsschreiben  sind  nicht  notwendig  bei  individuellen
Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten gehalten werden, die aus einem Zeitplan hervorgehen, der vorher durch einen
Geschäftsführungsbeschluss genehmigt wurde.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Telefon, Telegramm,

Telex oder Fax einen anderen Geschäftsführer zum Vertreter bestellt.

Abstimmungen können auch schriftlich oder per E-Mail, Telegramm, Telex oder Fax durchgeführt werden.
Jeder einzelne Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Handlungen zur Erfüllung des

Zweckes der Gesellschaft vorzunehmen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vor-
behalten sind.

Art. 14. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden durch den Vorsitzenden unterzeichnet oder, in

dessen Abwesenheit, durch den stellvertretenden Vorsitzenden.

Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vor-

sitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Art. 15. Jeder Geschäftsführer kann mit dem vorherigen einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung jeg-

liche  Befugnisse  und  Sondervollmachten  an  jede  Person,  die  nicht  unbedingt  Geschäftsführer  sein  muss,  übertragen,
Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Vergütung festsetzen.

Art. 16. Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift eines jeden Geschäftsführers oder durch die Einzelunter-

schrift jeder in Übereinstimmung mit dem Artikel 15 bevollmächtigten Person verpflichtet.

Art. 17. In Ausübung ihres Mandats ist/sind der/die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen

der Gesellschaft. Jedoch können Geschäftsführer für Handlungen oder Unterlassungen in der Ausübung ihrer Pflichten
haftbar gemacht werden.

Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des

gleichen Jahres.

Art. 19. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Jahresabschluss erstellt und den

Gesellschaftern  am  Sitz  der  Gesellschaft  zur  Verfügung  gestellt.  Jeder  Gesellschafter  kann  zu  jeder  Zeit  am  Sitz  der
Gesellschaft Einsicht in den Jahresabschluss und die Bücher der Gesellschaft nehmen.

Das Guthaben der Gewinn- und Verlustbilanz nach Abzug der allgemeinen Kosten, Sozialabgaben, Tilgungen und Pro-

visionen stellt den Gewinn der Gesellschaft dar. Von diesem jährlichen Gewinn der Gesellschaft werden 5% (fünf Prozent)
zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen endet, wenn
die Rücklagen einen Betrag erreicht haben, der 10% (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht, lebt
aber auf bis zur vollständigen Wiederherstellung der Rücklagen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt aus welchen Gründen
auch immer die Rücklagen angegriffen wurden.

Auf Empfehlung der Geschäftsführung entscheidet die Gesellschafterversammlung durch einstimmigen Beschluss über

die Verwendung des jährlichen Gewinnes.

Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
1. Der Jahresabschluss des vorherigen Geschäftsjahres wurde von den Gesellschaftern verabschiedet;
2. Die Geschäftsführer haben einen Zwischenabschluss aufgestellt,
3. Der Zwischenabschluss wurde gegebenenfalls von dem Wirtschaftsprüfer geprüft;

78654

4. Dieser Zwischenabschluss weist ausreichend Gewinne auf, einschließlich der übertragenen Gewinne und der an-

deren freien Reserven;

5. Die Entscheidung, Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren, wird durch die Geschäftsführung getroffen.

Art. 20. Die Prüfung der Finanzunterlagen der Gesellschaft kann durch einen oder mehrere gesetzliche oder unab-

hängige Wirtschaftsprüfer erfolgen. Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Möglichkeit der Ernennung einer
oder mehrerer Wirtschaftsprüfer und legt deren Anzahl, Vergütung und die Dauer ihres Mandates fest.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, die spätestens unmittelbar nach dem 20. Mai 2017 stattfinden wird,

erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die natürliche oder juristische Personen sein können),
die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse
und Vergütungen festlegen wird.

Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft den Gesellschaftern im Verhältnis zu den Ge-

schäftsanteilen, die sie halten, zugeteilt.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung.

Art. 23. Jeder Rechtsstreit, der während der Liquidation der Gesellschaft eintritt, auch zwischen den Gesellschaftern

oder zwischen dem/den Geschäftsführer(n) und der Gesellschaft, unterliegt, sofern es die Geschäftstätigkeit der Gesell-
schaft betrifft, der Entscheidung eines Schiedsgerichtes («arbitrage») gemäß der Zivilprozessordnung.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsge-

sellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass diese erfüllt worden sind.

<i>Zeichnung

Die zehn tausend (10.000) Gesellschaftsanteile wurden vollständig einbezahlt durch JARGONNANT PARTNERS S.à

r.l., vorbenannt, sodass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft zur freien Verfügung
steht, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlass ihrer

Gründung entstehen, werden auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-) geschätzt.

<i>Gesellschafterversammlung

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hielt der Alleingesellschafter, der das gesamte Stammkapital vertritt,

vertreten wie vorbenannt, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ab und fasste folgende Beschlüsse:

1) Die Versammlung beschließt, die Zahl der Geschäftsführer auf zwei (2) festzusetzen.
2)  Die  folgenden  Personen  werden  mit  Wirkung  zum  heutigen  Tage  zu  Geschäftsführern  auf  unbegrenzte  Dauer

ernannt:

- Karl-Erbo Graf Kageneck, wohnhaft in Stollbergstr. 11, 80539 München, Deutschland, geboren am 29. Juli 1947 in

Wittlich, Jurist (LL.M.)

- Daniel Graf von der Schulenburg, wohnhaft in Keferstr. 6, 80802 München, Deutschland geboren am 27. Januar 1961

in Algier, Kaufmann.

3) Der Sitz der Gesellschaft ist in 5367 Schuttrange, 80 B, rue Principale, Luxemburg.
4) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. De-

zember 2007.

Die unterzeichnende Notarin, die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der oben genannten

erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung.  Gemäß  dem  Wunsch  derselben  Partei  und  im  Falle  von  Abweichungen  zwischen  dem  englischen  und  dem
deutschen Text ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, Geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat dieser zusammen mit der Notarin die

vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: V. Zimmermann, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 30 mai 2007, REM/2007/1255. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

78655

Remich, le 30 mai 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007077545/5770/371.
(070084605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Tomasmill, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 117.367.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2007075750/50/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2007, réf. LSO-CF09016. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070081939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2007.

Immoc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 29.911.

In the year two thousand and seven, on the ninth of May.
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

COMMERCES RENDEMENT, a société par actions simplifiée, with a share capital of four million ninety-six thousand

euros (EUR 4,096,000.-), incorporated and existing under the laws of France, registered with the trade and companies'
register of Paris under number 450 850 441, having its registered office at 65/67, avenue des Champs Elysées, F-75008
Paris, France,

here represented by Mr Lars Kemper, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg (the Proxyholder), by virtue of a proxy,

given in Paris, on 27 April 2007.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of IMMOC S.A., a société anonyme having its registered office at 3, rue

du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and
companies' register under number B 29.911, incorporated pursuant to a deed of Maître Frieders, notary residing at 3,
rue des Bains, L-1212 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on January 17, 1989, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations on 24 May 1989, n 

o

 142 (the «Company»). The articles of incorporation have not

been amended since.

The appearing party representing the entire share capital of the Company requested the undersigned notary to enact

the following resolutions:

<i>First resolution

In compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the sole shareholder decides

to dissolve the Company and to put it into liquidation.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder decides to appoint as liquidator the FIDUCIAIRE

PATRICK SGANZERLA S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered address at 17, rue des Jardiniers, L-1835
Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 96.848.

The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 without requesting the authorization of the sole

shareholder in the cases in which it is requested.

78656

The liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights,

preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the prefer-
ential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such

part of its powers it determines and for the period it will fix.

The liquidator may distribute the Company's assets to the sole shareholder in cash or in kind to its willingness.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to EUR 1,000.-.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The deed having been read to the proxyholder acting in his hereabove stated capacities and known to the notary by

his name, first name, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le neuf mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

COMMERCES RENDEMENT, une société par actions simplifiée, avec un capital social de quatre millions quatre-vingt

seize mille euros (EUR 4.096.000,-), constituée et existant selon les lois de la France, enregistrée auprès du registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 450 850 441, ayant son siège social au 65/67, avenue des Champs
Elysées, F-75008, Paris, France,

ici représentée par M. Lars Kemper, Rechtsanwalt, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé

donnée à Paris, le 27 avril 2007.

La procuration signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Cette société est l'associé unique d'IMMOC S.A., une société anonyme ayant son siège social au 3, rue du Fort Rheins-

heim, L-2419 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 29.911, constituée conformément à un acte de Maître Frieders, notaire résidant à 3,
rue des Bains, L-1212 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 17 janvier 1989, publié le 24 mai 1989 dans
le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 142 (la «Société»). Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire soussigné d'instrumenter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'associé unique décide

de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'associé unique décide de nommer comme liquidateur la FIDUCIAIRE

PATRICK SGANZERLA S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 17, rue des Jardiniers, L-1835
Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.848.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 sans demander l'autorisation de l'assemblée générale

dans les cas où cette autorisation serait requise.

Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les

droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes
les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur n'a pas à faire l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs

mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l'étendue et la durée.

Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société à l'associé unique en numéraire ou en nature selon sa volonté.

78657

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à EUR 1.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

Et après lecture faite au mandataire, agissant en cette qualité comme dit ci-avant et connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Kemper, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2007, Relation: LAC/2007/8816. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mai 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007077477/242/104.
(070084470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Crèche Tiramisu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 46, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 112.539.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007077340/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2007, réf. LSO-CF08427. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

D.M. Investments S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 37.550.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007077343/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2007, réf. LSO-CF08424. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Varenne Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 52.677.

Le bilan de la société au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2007077346/304/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2007, réf. LSO-CF08758. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

78658

ProLogis France XIV S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 72.810.

Le bilan des résultats au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2007.

ProLogis DIRECTORSHIP Sàrl
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

Référence de publication: 2007075816/1127/16.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2007, réf. LSO-CF04855. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070082086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2007.

Chandela (Management) G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 129.107.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the first of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

The  company  CLARENCE  INVESTMENTS  LLC,  having  its  registered  office  at  1605  Pebrican  Avenue,  Cheyenne,

WY-82001 (U.S.A.), CID number 2003-00454418

The founder is here represented by Mr Thierry Triboulot, private employee, residing professionally at L-2168 Lux-

embourg, 127, rue de Mühlenbach, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which its

declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed by

the  present articles  of  incorporation  and by current Luxembourg laws,  especially the  laws of  August 10th,  1915  on
commercial companies, including the laws of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à respon-
sabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercices the powers devolved to the General Meeting of partners.

Art. 2. The Company's name is CHANDELA (MANAGEMENT) G.m.b.H.

Art. 3. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio, the direct and indirect acquisition, the lease, rent
or use in any form of real estate property located in Germany or other countries.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The company may borrow in any form.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

78659

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any partner.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances, to

require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of
the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25 (twenty-five euros) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of the

corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more manager's. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers.

The manager(s) need not to be partners. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a

resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another

manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meeting.

78660

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted

by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Partners decisions

Art. 14. Partners decisions are taken by partner's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or decisions

to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a second

meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be

represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of partners

representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of

the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

Financial year - Balance Sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting

of partners together with the balance sheet.

Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the partners.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined by

the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extra-
ordinary reserve.

Winding-Up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the

pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment

of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2007.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by CLARENCE INVESTMENTS

LLC prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) is
as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

78661

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand three hundred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration
- Mr David Heaney, companies' director, born in Birmingham (England), on the 18l of November 1978, residing pro-

fessionally in CH- 1211 Geneva 23, rue du Rhône 78 (Switzerland);

- Mr Martin Pugh, companies' director, born in St Gallen (Switzerland), on the 8th of June 1950, residing professionally

in CH-1211 Geneva 23, rue du Rhône 78 (Switzerland);

- Mr Christian Bühlmann, chartered accountant, born at Etterbeek (Belgium), on the Is' of May 1971, residing profes-

sionally at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;

- Mr Alexandre Taskiran, chartered accountant, born in Karaman (Turkey), on the 24th of April 1968, residing pro-

fessionally in L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;

- Mr Thierry Triboulot, private employee, born at Villers- Semeuse (France), on the 2nd of April 1973, residing pro-

fessionally at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;

2) The Company shall have its registered office at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same
person and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung der gegenwärtigen Urkunde:

Im Jahre zweitausendundsieben, den erste Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

CLARENCE INVESTMENTS LLC hier vertreten durch Herrn Thierry Triboulot, wohnhaft in L-2168 Luxembourg,

127, rue de Mühlenbach, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.

Vorerwähnte Vollmacht, nach ne varietur Paraphieren durch den Komparenten und den amtierenden Notar, bleibt

gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche

er als alleiniger Anteilseigner oder mit zukünftigen Anteilseignern zu gründen beabsichtigt, wie folgt festlegt

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, regiert durch die anwesenden Artikel von

Gruendung und durch jetziges Luxemburg Gesetz, besonders die Gesetze vom 10. August, 1915 auf gewerblichen Ge-
sellschaft, einschließlich der Gesetze vom 18. September, 1933 und vom 28. Dezember, 1992 auf «sociétés à responsabilité
limitée», als ergänzt, und die anwesenden Artikel des Handelsregistereintrag. An irgendeinem Moment kann ein einziger
Partner mit einem oder mehreren Partnern anschließen und im gleichen Weg, können die folgenden Partner die passenden
Maßnahmen annehmen, den unipersonal Charakter von der Gesellschaft wiederherzustellen. Ebenso lang als der Gesell-
schaft Überreste mit einem einzigen Partner, hat er exercices die Kräfte der Generalversammlung der Partner übertragen.

Art. 2. Der Name der Gesellschaft ist CHANDELA (MANAGEMENT) G.m b.H.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung auf jede Art und Weise an luxemburgischen und ausländischen

Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf,
Tausch oder auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten
aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes, der direkte oder indirekte Erwerb, die
Anmietung und Vermietung, sowie die sonstige Nutzung in jeglicher Form von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäu-
deteilen, welche sich in Deutschland oder anderen Ländern befinden.

Die  Gesellschaft  kann  sich  an  der  Gründung  und  Entwicklung  jeder  finanziellen,  industriellen  oder  kommerziellen

Gesellschaft beteiligen und Schwester- und Tochtergesellschaften alle Unterstützung geben, sei es durch Kredite, Ga-
rantien oder auf andere Art.

Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen aufnehmen.
Generell kann die Gesellschaft Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, be-

weglichen und unbeweglichen kommerziellen und industriellen Operationen tätigen, welche sie für notwendig hält zur
Verwirklichung und Förderung ihres Zweckes.

78662

Art. 4. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg.
Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch eine Beschlussfassung von einem

außerordentlichen General, den sich von seinen Partnern trifft, erwägend im Weise geliefert Zusätzen zu den Artikeln.

Die Adresse vom eingetragenen Büro kann innerhalb des Stadtbezirks durch Entscheidung vom Ausschuss der Ge-

schaftfürher übertragen werden.

Die Gesellschaft kann Büros und Zweige, beide in Luxemburg und im Ausland haben.
Im Ereignis, das die Leitung bestimmen soll, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen

stattgefunden haben, oder bevorstehend sind, dass in die normalen Tätigkeiten von der Gesellschaft an seinem eingetra-
genen  Büro  sich  einmischen  würde,  oder  mit  der  Bequemlichkeit  der  Kommunikation  zwischen  solchem  Büro  und
Personen im Ausland, das eingetragene Büro kann vorübergehend im Ausland übertragen werden, bis das vollständige
Ende von diesen abnormen Umständen; solche vorläufigen Maßnahme nicht auf das wirken werden Nationalität von der
Gesellschaft wird der, ungeachtet die vorläufige Übertragung von sein eingetragenes Büro, eine Luxemburg Gesellschaft
bleiben. Solche vorläufigen Maßnahmen werden genommen werden und werden zu irgendeinen interessierten Parteien
durch die Leitung von der Firma benachrichtigt werden.

Art. 5. Die Dauer der- Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 6. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit

eines Gesellschafters.

Art. 7 .  Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und

Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft ein-
schränken könnten, noch in irgendeiner Weise in der Verwaltung von der Gesellschaft zu stören. Sie müssen für die
Übung von ihren Rechten sieht Bilanzen und zu den Entscheidungen von den Versammlungen.

Das Kapital - Die Anteile

Art. 8. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500.-) eingeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25.-) pro Anteil.

Art. 9. Jeder Anteil verleiht ein identisches Abstimmungsrecht zu Zeit der Entscheidungen.

Art. 10. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung an Nichtgesellschafter unterliegt der Zustimmung von mindestens fünfundsiebzig Prozent des Aktien-

kapitals.

Sonst ist es die Vorkehrungen von Artikel 189 und 190 vom Koordinatengesetz auf Handelsfirmen gesehen.
Die Anteile sind unzertrennlich mit Beachtung zur Gesellschaft, die nur einen Eigentümer für jedes von ihnen zugibt.

Die Geschäftsleitung

Art. 11. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet welche keine Gesellschafter sein

müssen und welche von der Generalversammlung bestimmt werden

Die Geschäftsführer können jederzeit, mit oder ohne Ursache, durch eine Beschlussfassung der Partner, mit einer

Mehrheit der Wahlstimmen herausgenommen werden

Gegenüber Drittpersonen haben die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft

zu handeln und hat die Begriffe von diesem Artikel werden sich angehalten.

Alle nicht ausdrücklich gesetzlich reservierten Kräfte oder die anwesenden Artikel zum General, der sich von Partnern

trifft, fällt innerhalb der Befugnis vom Geschäftsführer, oder in der Mehrheit vom Ausschuss der Geschäftsführer.

Die Gesellschaft wird von der einzigen Unterschrift von seinem einzelnen Geschäftsführer, und, in der Mehrheit der

Geschäftsführer, durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Geschäftsführern gebunden.

Der Geschäftsführer, oder in der Mehrheit der Geschäftsführer, kann den seiner für spezifische Aufgaben zu einen

mehreren ad Hoc Agenten betreibt. Der Geschäftsführer, oder in der Mehrheit der Geschäftsführer, wird die Verant-
wortungen dieses Agenten und Entschädigung (wenn irgendein) bestimmen, die Zeitdauer von der Periode von Darstel-
lung und anderen relevanten Bedingungen von seiner Agentur.

In der Mehrheit der Geschäftsführer, wird gültig gehalten werden, vorausgesetzt, dass die Mehrheit der Geschäftsführer

anwesend ist.

In diesem Fall werden die Beschlussfassungen von der Mehrheit von den Managern überreicht, angenommen oder

vertreten werden.

Die Kräfte und die Entschädigungen von irgendeinen Geschäftsführern die vielleicht an einem späteren Datum zuzüglich

oder im Ort von den ersten Geschäftsführern ernannt werden, wird in der Tat der Nominierung bestimmt werden.

Art. 12. Irgendein Geschäftsführer verkürzt in seiner Funktion irgendeine persönliche Verpflichtung betreffend der

Verpflichtungen nicht, die regelmäßig von ihm im Namen von der Gesellschaft genommen werden; als ein erforderliches
das er nur verantwortlich für die Ausführung von seinem Mandat ist.

78663

Art. 13. Geschäftsführerentscheidungen werden von treffen von sich vom Ausschuss der Geschäftsführer genommen.
Irgendein Geschäftsführer kann an irgendeiner Versammlung der Geschäftsführer durch Ernennen schriftlich handeln

oder durch Telefax, Kabel, Telegramm oder teilt fernschreiblich einen anderen Manager seine Vollmacht mit.

Beschlussfassungen haben schriftlich genehmigt werden und haben durch alle Geschäftsführern die gleiche Wirkung

als Beschlussfassungen unterzeichnet wird haben, die an der Geschäftsführer vorbeigegangen an werden, die sich treffen.

In solchen Fällen werden Beschlussfassungen oder Entscheidungen ausdrücklich von gewöhnlicher Post, elektronischer

Post oder telecopier, entweder formuliert durch Schreiben durch Icreisförmigen Weg genommen werden, der gesendet
worden ist, oder durch Telefon, teleconferencing oder andere Datenfernübertragungsmedien.

Aktionärsversammlungen

Art. 14. Entscheidungen werden durch die Versammlungen von Partner getroffen.
Jedoch ist der Besitz der Versammlung nicht obligatorisch, wenn die Partnerzahl weniger als fünfundzwanzig ist.
In solchem Fall kann die Leitung entscheiden, dass jeder Partner den ganzen Text von jeder Beschlussfassung oder

Entscheidungen empfangen wird, genommen zu werden, ausdrücklich gezeichnet auf durch Schreiben, das von gewöhn-
licher Post, elektronischer Post oder telecopier gesendet worden ist.

Art. 15. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden.
Wenn dieses Quorum von eingetragenen Briefen an einer ersten Versammlung nicht erreicht wird, werden die Partner

sofort zu einer zweiten Versammlung einberufen.

An dieser zweiten Versammlung werden Entscheidungen an die Mehrheit von Abstimmungspartnern genommen wer-

den, was auch immer Mehrheit der Hauptstadt vertreten werde.

Jedoch, müssen Entscheidungen betreffend eines Zusatzes von den Artikeln der Vereinigung von einer Mehrheitwahl-

stimme den Partnern vertretend die drei Viertel von der Hauptstadt genommen werden.

Jede Versammlung wird in Luxemburg oder solchem anderen Ort gehalten werden.
Ein einziger Partner übt allein die Kräfte, die zur Versammlung der Partnern durch die Verfügungen von Abschnitt XII

vom Gesetz vom 10. August, 1915 auf sociétés à responsabilité limitée übertragen werden.

Infolgedessen davon, alle Entscheidungen, die die Kräfte von den Managern überschreiten, werden vom einzigen Partner

genommen.

Geschäftsjahr - Bilanzaufstellung

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und schließt am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 17. Jedes Jahr ab den 31. Dezember, wird die Leitung auf die Bilanzaufstellung, die eine Aufzeichnung von den

Eigentümern von der Gesellschaft zusammen mit seinen Schulden und Haftungen enthalten wird, zeichnen und werde
von einem Anhang begleitet, der eine Zusammenfassung von allen seinen Verpflichtungen und den Schulden vom Ge-
schäftsführer (Geschäftsführern) der Gesellschaft enthält.

Gleichzeitig wird die Leitung einen Gewinn und Verlust begründen vorbereiten, der beim General eingereicht wird,

der sich mit Partnern zusammen mit der Bilanzaufstellung trifft.

Art. 18. Jeder Partner kann an der Zentrale das Inventar prüfen, begründen die Bilanzaufstellung und der Gewinn und

der Verlust.

Art. 19. Der Kreditsaldo vom Gewinn und dem Verlustkonto, nach Abzug von den Ausgaben, vertritt Kosten, Tilgung,

Kosten und Vorkehrungen den Nettogewinn von der Firma.

Jedes Jahr fünf Prozent vom Nettogewinn werden auf die vorgeschriebene Reserve übertragen werden.
Dieser Abzug hört auf, obligatorisch, wenn die vorgeschriebene Reserve zu einem zehnten vom ausgegebenen Akti-

enkapital  beträgt,  zu  sein,  aber  muss  bis  den  Reservenfonds  völlig  wenn,  jederzeit  aufgenommen  werden  wieder  ist
rekonstruiert und aus irgendeinem Grund was auch immer, ist es in gebrochen worden.

Das Gleichgewicht ist an der Verfügung von den Partnern.
Der Überfluss ist unter den Partnern verteilt. Jedoch, können die Partner, an die Mehrheitwahlstimme entschlossen

durch die relevanten Gesetze entscheiden, dass der Gewinn, nach Abzug von der Reserve, auf eine außerordentliche
Reserve werde vorgetragen oder hat übertragen entweder.

Der Auflösung - Die Liquidation

Art. 20. Die Liquidation wird von einem Liquidator ausgeführt, welcher kein Gesellschafter sein muss und der von den

Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung festlegen.

Wenn die Liquidation von der Firma geschlossen ist, werden die Vermögenswerte von der Firma zu den Partnern am

Prorata von ihrer Teilnahme in der Anteilhauptstadt von der Firma zugeschrieben werden.

Ein einziger Partner kann entscheiden, die Firma aufzulösen, und zu seiner Liquidation fortzufahren, die persönlich die

Zahlung von allen Vermögenswerten und Haftungen annimmt, bekannt oder unbekannt von der Firma.

78664

Zutreffendes Gesetz

Art. 21. Die Gesetze hier über erwähnt in 1. Artikel wird verwenden in insofern diesen Artikeln dem Handelsregis-

tereintrag nicht liefern das entgegengesetzte.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am letzten Tag des Monats December 2007.

<i>Zeichnung

Die fünfhundert (500) Anteile wurden vom einzigen Gesellschafter CLARENCE INVESTMENTS LLC, vorgenannt,

gezeichnet und eingezahlt zu ihrem vollen Wert in Höhe von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) durch Bar-
einlage, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Kosten

Die Kosten und Lasten, welche der Gesellschaft anlässlich ihrer Gründung entstehen, werden geschätzt auf ein tausend

drei hundert Euros.

<i>Beschlüsse des einzigen Gesellschafters

Sofort nach Gründung der Gesellschaft, hat der einzige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Zum Geschäftsführer mit den in Artikel 12 der Gesellschaftssatzung erwähnten Befugnissen wird ernannt:
- Herr Christian Bühlmann, Wirtschaftsprüfer, geboren in Etterbeek (Belgien), am 1. Mai 1971, beruflich wohnhaft in

L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;

- Herr Alexandre Taskiran, Wirtschaftsprüfer, geboren in Karaman (Türkei), am 24. April 1968, beruflich wohnhaft in

L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;

- Herr Thierry Triboulot, Privatbeamter, geboren in Villers-Semeuse (Frankreich), am 2. April 1973, beruflich wohnhaft

in L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;

- Herr Martin Pugh, Privatbeamter, geboren in St Gallen (Schweiz), am 8. June 19502, beruflich wohnhaft in CH-1211

Geneva 23, rue du Rhône 78;

- Herr David Heaney, Privatbeamter, geboren in Birmingham (England), am 18.November 1978, beruflich wohnhaft in

CH-1211 Geneva 23, rue du Rhône 78;

2.- Der Sitz der Gesellschaft ist L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar die gegenwärtige

Urkunde.

Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass, auf Antrag des Komparenten, gegenwärtige

Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung aufgenommen wurde.

Auf Antrag desselben Komparenten und im Falle von Unterschieden wischen der englischen und der deutschen Fassung,

ist der englische Text vorrangig.

Gezeichnet: T. Triboulot, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2007, Relation: LAC/2007/11502. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, delivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007077062/211/346.
(070084193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Katran, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 71.956.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 22 mai 2007 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Monsieur Franck Chapeaux, Administrateur, directeur, 3, rue du Docteur Alexis Carrel, F-69110 Ste Foy-les-Lyon,

France;

- Madame Nicole Schloter, Administrateur, avocat, The Nursery-Hall Road, SS4 1PD Roachford-Essex, Royaume-Uni;
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur-Président, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxem-

bourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.
L'assemblée générale du 22 mai 2007 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

78665

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster, RCS Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

Luxembourg, le 22 mai 2007.

<i>Pour KATRAN, Société anonyme holding
Signature

Référence de publication: 2007074744/833/23.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2007, réf. LSO-CF02572. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070080532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2007.

CEREP Vivienne S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 102.536.

In the year two thousand and seven, on the thirty-first day of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

CEREP S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B. 83.245 (the «Sole Sharehold-
er»);

in its capacity as Sole Shareholder of CEREP VIVIENNE S.à r.l, a private limited liability company, having its registered

office at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 102.536 and incorporated by deed drawn up on 6 July 2004 by the notary
Maître Joseph Elvinger and whose articles have been published in the Memorial under number 1092, dated 28 October
2004, page 52401 (the «Company»);

hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 200-2 of Luxembourg law

dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the «Law»).

The Sole Shareholder is represented at the meeting by Regis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of

proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the Articles to expressly provide for the possibility of interim dividends and

consequently insert a second paragraph in the article 17 of the Articles, which shall be read as follows:

«The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated
to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's unit capital The balance of the
net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to its/their unitholding in the Company.

The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be
distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and
distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established
by law or by these Articles of Incorporation.»

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall he home by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately 1,800.-Euros.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente et un mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

78666

CEREP S.à r.l., une société à responsabilité limitée, dont le siège social se situe au 30, boulevard Royal, L-2449 Lu-

xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B
83.245, (l'«Associé Unique»);

en qualité d'Associé Unique de CEREP VIVIENNE S.à r.l. une société à responsabilité limitée, dont le siège social se

situe au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 102.536 et constituée en vertu d'un acte du notaire Maître Joseph Elvinger instrumentant
le 6 juillet 2004 et dont les statuts ont été publiés dans le Mémorial sous le marnerò 1092 en date du 28 octobre 2004,
page 52401 (la «Société»);

adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés

commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

L'Associé Unique est représenté par Regis Galiotto, juriste, résidant à Luxembourg, en vertu de la procuration sous

seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être formalisée avec lui.

<i>Résolution unique

L'Associé Unique décide de modifier les Statuts pour prévoir expressément la possibilité de distribution de dividendes

intérimaires et d'insérer en conséquence un deuxième paragraphe à l'article 17 des Statuts, qui doit être lu comme suit:

«Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution de la
réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être
distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires sur la base d'un relevé de comptes préparé

par le conseil de gérance montrant qu'il existe suffisamment de fonds disponibles pour la distribution, étant entendu que
le montant distribuable ne peut être supérieur aux profits réalisés depuis la fin de l'année fiscale précédente, augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et sommes allouées à une réserve
à établir en vertu de la loi ou des présents Statuts.»

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à 1.800,- Euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2007. Relation: LAC/2007/11464. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007076800/211/86.
(070083295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2007.

Flexible Packaging Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 129.105.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the third of April.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich. (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, having its registered office in 30 Warwick Street, London W1B

5AL, United Kingdom, registered at the Trade register of England under the number 3.220.373, here represented by Ms.
Alexandra Fuentes, private employee, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

78667

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its mandatory, intends to incorporate a «one-man limited liability company» (société à

responsabilité limitée unipersonnelle), the Articles of which it has established as follows:

Title I.- Object - Denomination- Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby established a unipersonal limited liability company which will be governed by the laws in effect

and especially by those of August 10th, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, September
18th, 1933 on limited liability companies, as amended, and December 28th, 1992 on unipersonal limited liability companies
as well as by the present statutes.

Art. 2. The denomination of the company is FLEXIBLE PACKAGING INVESTMENTS S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place in

the Grand-Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The
company may borrow in any form.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The company is established for an unlimited period.

Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants do not put an end to the company.

Title II.- Capital - Parts

Art. 7. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR), divided into one

hundred and twenty-five (125) parts of one hundred euro (100.- EUR) each.

Art. 8. The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own parts. Such repurchase

shall be subject to the following conditions:

- any repurchase of parts made by the company may only be made out of the company's retained profits and free

reserves,

- the repurchased parts will be immediately cancelled and the capital reduced as a consequence thereof in accordance

with the legal procedure requirements.

Art. 9. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter

vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters
of the capital.

For all other matters, references is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

Art. 10. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

Title III.- Management

Art. 11. The company is administrated by one or more managers (gérants), who are invested with the broadest powers

to perform all acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate purpose of the company, except those
expressly reserved by law to the general meeting. The manager(s) represent(s) the company towards third parties and
any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by
the manager(s).

They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period.
In case of a single manager the Company shall be validly bound by the sole signature of the manager, and, in case of

plurality of managers, by the joint signature of two managers.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or

not.

78668

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax

or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by conference
call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other,
and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened

and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or telex.

Title IV.- General meetings of participants

Art. 12. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under

section XII of the law of August 10th, 1915 on commercial companies.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall

be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written

consultation at the instigation of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

Title V.- Financial year - Profits - Reserves

Art. 13. The financial year of the company starts on the first of January and ends on the last day of December of each

year.

Art. 14. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company as well as

a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the

provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory

as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the
disposal of the general meeting of participants.

Title VI.- Liquidation - Dissolution

Art. 15. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need

not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law of
August 10th 1915 and of its modifying laws.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the

liabilities.

Title VII.- Varia

Art. 16. The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

<i>Subscription and payment

All the shares have been subscribed by BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, prenamed,
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred (12,500.-) euro is at

the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2007.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand euro (1,000.-).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) Are appointed managers of the Company for an undefinite period:
a) HALSEY S. à r.l., R.C. B Number 50.984, a company with its registered office at 174, route de Longwy, L-1940

Luxembourg,

b) Miss Kristel Segers, company director, born in Turnhout, Belgium, on October 8, 1959, residing at 174, route de

Longwy, L-1940 Luxembourg,

c) Mr. Christophe Gammal, economist, born on August 9, 1967, in Uccle (Belgium), with professional address at 174,

route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

2) The Company shall have its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

78669

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the proxyholder of the appearing party, he signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trois avril.
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, avec siège social au 30 Warwick Street, Londres W1B 5AL, Roy-

aume-Uni, immatriculée au registre des sociétés d'Angleterre sous le numéro 3.220.373, ici représentée par Madame
Alexandra Fuentes, employée privée, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 .- Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 .  II est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les

lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par
celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée par celle du 28 décembre 1992
sur les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2 .  La dénomination de la société sera FLEXIBLE PACKAGING INVESTMENTS S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales
ou affiliées.

La société peut emprunter sous toutes les formes.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, mobilières ou immobilières commerciales et industrielles quelle jugera utiles à l'accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 7. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), divisé en cent vingt-cinq (125) parts

sociales de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Art. 8. La société pourra, sous les conditions et dans les limites prévues par la loi, acquérir ses propres parts. Un tel

rachat sera soumis aux conditions suivantes:

- tout rachat de parts fait par la société pourra uniquement être réalisé avec les profits mis en réserve et les réserves

libres de la société.

- les parts rachetées seront annulées immédiatement et le capital sera réduit en conséquence, conformément aux

prescriptions légales.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles par l'unique associé, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul

associé.

S'il y a plus d'un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre

vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l'agrément préalable donné en assemblée générale par
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

78670

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 10. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créancier d'un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés si les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans
les acte de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Titre III.- Administration

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui disposent des pouvoirs les plus étendus afin d'ac-

complir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, à l'exception de ceux qui
sont réservés par la loi à l'assemblée générale.

Le(s) gérant(s) représentent la société à l'égard des tiers et tout litige dans lequel la société apparaît comme demandeur

ou comme défendeur, sera géré au nom de la société par le(s) gérant(s).

Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée illimitée.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux gérants.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, associés

ou non.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un autre

gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel téléphonique ou
tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

Les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du

conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou
sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

Titre IV.- Assemblée générale des associes

Art. 12. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés, en vertu de la section

XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l'associé unique. Les décisions de

l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises par l'assemblé générale ou par consultation écrite à

l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise aussi longtemps qu'elle n'a pas été adoptée par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.

Titre V.- Année comptable - Profits - Réserves

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi

qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre VI.- Liquidation - Dissolution

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses bis modi-
ficatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Titre VII.- Varia

Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se référent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été toutes souscrites par BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

(12.500,-) euros est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

78671

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille euros (1.000,- EUR).

<i>Résolutions

Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) HALSEY S. à r.l., R.C. B Numéro 50.984, une société avec siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
b) Mademoiselle Kristel Segers, administrateur de sociétés, née à Turnhout, Belgique, le 8 octobre 1959, demeurant

au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

c) Monsieur Christophe Gammal, économiste, né le 9 août 1967, à Uccle (Belgique), avec adresse professionnelle au

174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: A. Fuentes, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 4 avril 2007, REM/2007/736. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 31 mai 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007076711/5770/256.
(070084188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

"Dune" Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 110.593.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 27 juin 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007077566/825/12.
Enregistré à Diekirch, le 26 juin 2007, réf. DSO-CF00275. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(070084612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2007.

Alicante S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 76.363.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2007.

<i>Pour ALICANTE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007077260/744/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2007, réf. LSO-CF08799. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070083522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

78672


Document Outline

Actaris Metering Systems

Actaris Metering Systems S.àr.l.

Akita S.A.

Alicante S.A.

A. Menarini Participations Dresden S.A.

A. Menarini Real Estate Luxembourg S.A.

Anderton Global Energy Limited S.à.r.l.

A + P Kieffer Omnitec S.à r.l.

BPER International Sicav

CB Richard Ellis Investors S.à r.l.

Censor S.A.

CEREP Vivienne S.à r.l.

Chandela (Management) G.m.b.H.

Crèche Tiramisu S.A.

D.M. Investments S.A.

"Dune" Sàrl

EM Finance Holding S.A.

EuroSignCard Finance 1 S.A.

Finconseil S.A.

Fitech S.à r.l.

Flexible Packaging Investments S.à r.l.

Gelins

Gestair International Council S.à r.l.

Immoc S.A.

Immo G Investissements S.à r.l.

Infante S.A.

Interlux Asset S.A.

January Storm Investments S.A.

JP Commercial V S.à r.l.

Karitoë Finances S.A.

Karitoe Participations Sàrl

Katran

Laronde

Ligne Holdco Lux S.à r.l.

Menarini International Investment S.A. - Luxembourg

Natursteen S.à r.l.

Navitas Consulting S.à r.l.

Newtec S.A.

Omnitec Infra S.A.

Prod S.A.

ProLogis France XIV S.à.r.l.

ProLogis France XIX S.à r.l.

ProLogis France XXXI S.àr.l.

Railtour Luxembourg

Rast Développement S.A.

Royal Logistics Holding S.A.

Salon de Coiffure Beim Nadine S.à r.l.

S.C.G.S. S.à r.l.

Sedianad S.A.

Sky Broadband S.A.

Société Financière Anigh S.A.

Tarkett Holding S.A.

Tarkett S.A.

Tomasmill

Tropique S.A.

Un Autre Monde, s.à r.l.

Vadec International S.A.

Varenne Holding S.A.

Venusfin

Wall-Invest S.A.

Yakashi S.A.