logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1170

15 juin 2007

SOMMAIRE

Armeos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56140

Autopolis Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

56159

Autopolis Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

56158

Bomba Grill S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56154

Boortmalt Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

56160

Breba - Cars S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56156

Cartrade-Automobile S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

56124

Club Torreense d'Esch asbl  . . . . . . . . . . . . .

56157

Cody Internet Ventures S.A.  . . . . . . . . . . . .

56132

Corporate Sailing S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

56123

Customer : View S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56158

Eagle 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56115

East Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56132

ECG Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

56153

Elbblick (November) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

56143

Eurocom Beratungs- und Treuhand GmbH

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56150

Evli Bank Plc, Luxembourg Branch  . . . . . .

56151

Finance Agricole S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56153

F.L. Lux Entreprise S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

56160

GEF Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56142

Ginel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56123

Global Garden Products C S.à r.l.  . . . . . . .

56156

Interportfolio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56160

Isaver S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56114

Kadan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56142

KEV Germany 3 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56125

KEV Germany 4 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56133

Lend Lease Europe Real Estate Advisors

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56159

Litoprint S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56156

Luxair Re S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56150

Materis Management Aluminates . . . . . . . .

56151

Moumont S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56142

Piani Developments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

56149

Plasticbase SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56141

Porto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56157

Porto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56157

Porto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56158

Proteactive Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

56141

Radio Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56159

Rainforest Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

56114

Revedaflo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56160

'Roma Société Civile Immobilière' . . . . . . .

56158

Rosa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56140

Rosa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56149

Salon Fashion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56114

Services Généraux de Gestion S.A.  . . . . . .

56155

Shildon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56158

S.I. Umbolt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56153

Société de Développement Agricole - ZE-

VA S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56155

Stars Investissement S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

56141

Sunderland Immo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

56156

Transports CITAL S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

56124

T.S.M. Holding AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56150

Turf Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56153

VMTO S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56157

William Blair SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56124

Winfina S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56152

56113

Salon Fashion, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 11, côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 18.493.

Par la présente j'ai l'honneur de vous présenter ma démission en qualité de gérante technique de la société SALON

FASHION SARL avec effet immédiat.

Esch-sur-Alzette, le 26 mars 2007.

Rita Biagioni.

Référence de publication: 2007053982/2468/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2007, réf. LSO-CD00450. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070054190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2007.

Isaver S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 32.832.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 2007

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Christel Girardeaux, employée privée, avec adresse

professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 4 avril 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007054034/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2007, réf. LSO-CD03656. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Rainforest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 23.528.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 mars 2007

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Pieter van Nugteren, employé privé, avec adresse

professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., ayant
son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX KONZERN S.à r.l., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES
S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui
statuera sur les comptes de l'exercice 2006.

Luxembourg, le 22 mars 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007054043/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01191. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

56114

Eagle 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 127.055.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the eighteenth day of April.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

EAGLE JV S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under

the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste in L-2346 Luxembourg
and in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register.

hereby represented by Christophe Balthazard, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given under private seal

The power of attorney of the appearing party, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf

of the appearing party and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which its acts, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Chapter I. - Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and duration. There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) by the

name of EAGLE 4 S.à r.l. (the Company) which will be governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and
particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by the present
articles of association (the Articles).

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object. The Company may:
- carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shareholdings in any company or firm

in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those shareholdings;

- establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and intellectual property rights (including but not

limited to patents and trademarks) of whatever origin; it may also acquire securities and patents, by way of investment,
subscription, underwriting or option, and realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise; and it may also
grant to or for the benefit of subsidiaries and/or affiliates of the Company any assistance, loan, advance or guarantee;

- take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real

estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;

- borrow from subsidiaries and/or affiliates of the Company and/or any other person or entity in any form and proceed

to the private issue of bonds and debentures.

Art. 3. - Registered office. The Company has its registered office in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of the shareholder(s).

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in the Grand-Duchy

of Luxembourg and abroad.

Chapter II. - Corporate capital

Art. 4. Share capital.
4.1 The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) represented

by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty five Euro) per share.

4.2 The Company's authorised share capital is set at EUR 50,000,000 (fifty million Euro).
The Board of Managers is authorised to issue 1,999,500 (one million nine hundred ninety nine thousand five hundred)

shares and is therefore authorised to bring the subscribed share capital of the Company from its current amount to an
amount of EUR 50,000,000 (fifty million Euro), it being the limit of the authorised share capital.

The Board of Managers is instructed to render effective such increase of the share capital under the authorised capital,

in whole or in part, from time to time, for any authorised shares which have not yet been subscribed.

The Board of Managers will decide to issue shares with or without premium, to be paid up in cash, by contribution in

kind, by conversion of claims or in any other way, and will accept subscriptions for such shares.

56115

Each time Board of Managers will act, or will be required to act, to render effective the increase of capital, as authorised,

this article 4 will be amended so as to reflect the result of such action. The Board of Managers will take or authorise any
person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

Art. 5. Profit sharing. Each share entitles the owner thereof to the corporate assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 6. Transfer of shares. In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must

be authorized by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of
the Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-

quarters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the

Company has sufficient distributable reserves to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of the shareholder(s). The
quorum and majority requirements applicable for amendments to the Articles shall apply.

Chapter III. - Management

Art. 8. Management - Board of Managers.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s), appointed by the general meeting of the shareholder(s)

which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each manager. In case of plurality
of managers, they shall constitute a board of managers (the Board of Managers). The manager(s) need not be shareholder.
The general meeting of the shareholder(s) may at any time and without cause (ad nutum) revoke and replace any manager
(s).

Any reference to the Board of Managers in the Articles shall be a reference to the sole manager of the Company as

long as the Company only has one manager.

8.2 The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the Chairman).
The  Chairman,  if  any  is  appointed,  will  preside  at  all  general  meetings  of  the  shareholder(s)  and  of  the  Board  of

Managers. In case of absence of the Chairman, the general meeting of the shareholder(s) or, as the case may be, the Board
of Managers will appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person
or by proxy at the relevant meeting.

8.3 Meetings of the Board of Managers are convened by the Chairman or by any other two members of the Board of

Managers.

The managers will be convened separately to each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency which

will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two days'
written notice of Board of Managers' meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings are held, as a rule,

in the city of Luxembourg.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex or e-mail transmission of each

manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted
by resolution of the Board of Managers.

8.4 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram

or telex or e-mail transmission another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.
8.5 A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a con-
ference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such
meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

8.6 The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or

represented.

8.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax, telex or e-mail. A meeting held by way of circular resolution will be
deemed to be held in Luxembourg.

8.8 In dealing with third parties, the Board of Managers shall have the powers to act in the name of the Company in

all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's objects and further
provided the terms of this article 8 shall be complied with.

56116

8.9 All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of the shareholder(s) fall within

the scope of the competence of the Board of Managers. In case the Company only has one manager the Company shall
be bound by the sole signature of the sole manager, and in case of plurality of managers the Company shall be bound by
the sole signature of any member of the Board of Managers. The general meeting of the shareholder(s) may appoint from
among the members of the Board of Managers one or several general managers who may be granted the powers to bind
the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the Board of Managers.

8.10 The Board of Managers may delegate part of its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents (either

members of the Board of Managers or not) and may revoke such appointments at any time.

The Board of Managers will determine the agent(s)' responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration

of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.11 The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed

by the Chairman (or the chairman pro tempore as the case may be), by the Secretary or by any two members of the
Board of Managers. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman (or the chairman pro tempore as the case may be), by the Secretary or by any two members of the Board of
Managers.

8.12 The effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall, as a rule, be carried out

in or from Luxembourg.

Art. 9. Liability of the manager(s). The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in

relation  to  any  commitment  validly  made  by  them  in  the  name  of  the  Company,  so  long  as  such  commitment  is  in
compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV. - Secretary

Art. 10. Appointment of a secretary. The Board of Managers may appoint a secretary, either a manager or not, who

shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the Secretary).

The Secretary, if any is appointed, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the Board of Managers

and, to the extent practical, of the general meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of
the Board of Managers and of the general meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept for
that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Managers, if any, when required. He shall
have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks
so delegated.

The Secretary shall have the power and authority, which shall be provided only by the Board of Managers, to issue

certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties
and to be used as official documents.

Chapter V. - General meetings of shareholder(s)

Art. 11. Annual and extraordinary general meetings of the shareholder(s). An annual general meeting of the shareholder

(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office
as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

Art. 12. Shareholder(s)' voting rights. Each shareholder may participate in general meeting of the shareholder(s) irre-

spective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at any

general meeting of the shareholder(s).

Art. 13. Quorum - Majority. Resolutions of the general meeting of the shareholder(s) are only validly taken in so far

as they are adopted by shareholders owning more than half of the Company's share capital.

However, resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate and to merge the Company may only be carried

out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

As long as the Company has no more than 25 shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed

at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit
draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or telegram
or telex or e-mail transmission).

Chapter VI. - Financial year - Financial statements - Profit sharing

Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on January first and ends on December thirty-first of the

same year.

56117

Art. 15. Financial statements. Each year the books are closed and the Board of Managers prepares the financial state-

ments of the Company (including a balance sheet, a profit and loss accounts and the notes to the annual accounts) in
accordance with the relevant Luxembourg legal provisions.

Art. 16. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above financial statements at the Company's

registered office.

Art. 17. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company

is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to their shareholding in the Company.
The general meeting of the shareholder(s) shall have power to make payable one or more interim dividends.

Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause

the dissolution of the Company. The shareholder(s) must agree, in accordance with paragraph 2 of article 13 of the
Articles, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 19. Liquidation. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several

liquidator(s), whether shareholder(s) or not, appointed by the general meeting of the shareholder(s) who will determine
its/their powers and remuneration.

Chapter VIII. - Audit

Art. 20. Statutory Auditor - External Auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company must appoint

a statutory auditor (commissaire aux comptes) only when it has more than 25 shareholders. An external auditor (réviseur
d'entreprises) must be appointed whenever the exemption provided for by articles 69 and 35 of the law of 19 December
2002 concerning the trade and companies register and the bookkeeping and the annual accounts of the companies does
not apply.

Chapter IX. - Governing law

Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no

specific provision is made in the Articles.

<i>Subscription and payment

The Articles having thus been established, EAGLE JV S.à r.l. (the Sole Shareholder) hereby declares that it subscribes

to all the 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty five Euro) each, representing the total share
capital of the Company of an amount of EUR 12,500, (twelve thousand five hundred Euro).

All these 500 (five hundred) shares have been fully paid up by the Sole Shareholder by means of a payment in cash, so

that the subscription amount of EUR 12,500, (twelve thousand five hundred Euro) is forthwith at the free disposal of the
Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, and the undersigned notary expressly acknowl-
edges such payment.

<i>Transitory provisions

By way of derogation of article 14 of the Articles, the Company's first financial year is to run from the date hereof to

31 December 2007.

<i>Estimate of costs

The  amount  of  expenses,  costs,  remunerations  and  charges  in  any  form  whatsoever,  which  shall  be  born  by  the

Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 1,500 (one thousand five hundred euro).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder has adopted the following resolutions:
1. The Sole Shareholder resolves to set the number of managers of the Company at 2 (two).
2. The Sole Shareholder resolves to appoint the following persons as managers of the Company for an unlimited period

of time:

a) Mark Weeden, born in London (United Kingdom) on 4 December 1954, professionally residing at 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg; and

b) Michel van Krimpen, born in Rotterdam (the Netherlands) on 19 February 1968, professionally residing at 20, rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg.

3. The Sole Shareholder resolves to set the registered office of the Company at 20, rue de la Poste in L-2346 Lux-

embourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

56118

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

EAGLE JV S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social au 20, rue de la Poste in L-2346 Luxembourg et en cours d'immatriculation auprès du Registre
de Commerce et de Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Christophe Balthazard, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé.

La procuration de la partie comparante, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte

de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même
temps que celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, ès-qualité en vertu de laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter les statuts

d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclarent constituer comme suit.

Chapitre I 

er

 . - Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom et durée.  Il existe une société à responsabilité limitée sous le nom de EAGLE 4 S.à r.l. (ci-après la

Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts (ci-après les Statuts).

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet social. La Société peut:
- accomplir toutes transactions liées directement ou indirectement à l'acquisition de participations dans toutes sociétés

ou entreprises sous quelque forme que ce soit, ainsi qu'à l'administration, la gestion, le contrôle et le développement des
ces participations;

- créer, gérer, mettre en valeur et liquider un portefeuille se composant de titres et de droits intellectuels (en ce

compris mais de manière non limitative des brevets et marques) de toute origine; elle peut aussi acquérir des titres et
brevets par voie d'investissement, souscription, prise ferme ou option, et les réaliser par voie de vente, de cession,
d'échange ou autrement; elle peut également accorder à des filiales et/ou à des sociétés appartenant au même groupe
que la Société tous concours, prêt, avance ou garantie;

- prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, en ce compris et de manière non limitative, toutes trans-

actions commerciales, financières, personnelles et immobilières qui sont de nature à favoriser directement ou indirecte-
ment la réalisation de son objet social;

-  emprunter  de  ses  filiales  et/ou  de  sociétés  appartenant  au  même  groupe  que  la  Société  et/ou  de  toutes  autres

personnes ou entités sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations de toute nature.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d'une assemblée générale

extraordinaire de l'associé unique/des associés.

La Société peut avoir des bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois au

Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

Chapitre II. - Capital social

Art. 4. Capital.
4.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500

(cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

4.2 Le capital autorisé de la Société est fixé à EUR 50.000.000 (cinquante millions d'euros).
Le ou les gérants de la Société sont autorisés et mandatés d'émettre 1,999.500 (un million neuf cent quatre vingt dix

neuf mille cinq cents) parts sociales et sont donc autorisés à amener le capital social de son montant actuel à un montant
de EUR 50.000.000 (cinquante millions d'euros), étant la limite du capital autorisé.

Le ou les gérants de la Société sont autorisés et mandatés de réaliser cette augmentation, en tout ou en partie, de

temps à autre, pour de quelconques parts autorisées qui n'ont pas encore été souscrites.

Le ou les gérants décideront d'émettre des parts, avec ou sans prime, à libérer en espèces, par apport en nature, par

conversion de créances ou par tout autre moyen, et accepteront des souscriptions pour ces parts.

56119

Chaque fois que le ou les gérants auront fait constater authentiquement une augmentation de capital, telle qu'autorisé,

l'article 4 des Statuts de la Société sera adapté de manière à refléter le résultat de cette action; le ou les gérants prendront
ou autoriseront une personne pour prendre les mesures nécessaires afin de faire acter et publier cette modification.

Art. 5. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à son propriétaire à une fraction des avoirs et

bénéfices de la Société en proportion directe du nombre de parts sociales existantes.

Art. 6. Transfert de parts sociales. En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-

associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent

trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose

à cette fin de réserves distribuables en suffisance.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra

avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts sont
d'application.

Chapitre III. - Gérance

Art. 8. Gérance - Conseil de Gérance.
8.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s), nommés par l'assemblée générale de l'associé unique/des associés

qui décide de leur rémunération et des modalités de nomination de chaque gérant. En cas de pluralité de gérants, ils
constituent un conseil de gérance (le Conseil de Gérance). Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associé. L'assemblée
générale  de  l'associé  unique/des  associés  peut  à  tout  moment  et  sans  justifier  d'une  raison  (ad  nutum)  révoquer  et
remplacer n'importe quel gérant.

Toute référence au Conseil de Gérance dans les Statuts doit être entendue d'une référence au gérant unique de la

Société aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul gérant.

8.2 Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres (le Président).
Le Président, si un est nommé, présidera toutes les assemblées générales de l'associé unique/des associés et toutes

les réunions du Conseil de Gérance. En cas d'absence du Président, l'assemblée générale de l'associé unique/des associés,
ou le cas échéant le Conseil de Gérance, choisira une autre personne en tant que président pro tempore par vote de la
majorité des membres présents ou représentés à l'assemblée en question.

8.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou par deux autres membres du Conseil

de Gérance.

Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d'urgence qui seront

spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra respecter un délai
d'au moins deux jours avant la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement repré-

sentés.

Les réunions se tiennent au lieu, jour et heure indiqués dans la convocation. Les réunions sont en principe, tenues

dans la ville de Luxembourg.

Il peut être renoncé à la convocation de l'accord de chaque gérant donné par écrit, téléfax, télégramme, télex ou email.

Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps indiqués dans un document
préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

8.4 Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit, téléfax, télégramme, télex

ou email un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.
8.5 Un gérant peut participer à toute réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre

moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre
mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant
demeurant au Luxembourg est équivalente à une participation en personne à une telle réunion, et la réunion tenue de
telle manière est réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.6 Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si la majorité de ses membres

sont présents ou représentés.

8.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les réso-

lutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître
sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par voie de résolution circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

56120

8.8 Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance aura les pouvoirs d'agir au nom de la Société en toutes circonstances et

d'exécuter et d'approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société, sous réserve du respect
des dispositions du présent article 8.

8.9 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les Statuts à l'assemblée générale de l'associé unique/

des associés sont de la compétence du Conseil de Gérance. Si la Société n'a qu'un seul gérant, la Société sera engagée
par la seule signature du gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature unique
de  tout  membre  du  Conseil  de  Gérance.  L'assemblée  générale  de  l'associé  unique/des  associés  peut  élire  parmi  les
membres du Conseil de Gérance un ou plusieurs gérants délégués qui auront le pouvoir d'engager la Société par leur
seule signature, pourvu qu'ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de Gérance.

8.10 Le Conseil de Gérance peut déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs

mandataires ad hoc (membre du Conseil de Gérance ou non) et peut révoquer de telles nominations à tout moment.

Le Conseil de Gérance déterminera la responsabilité du/des mandataires(s) et sa/leur rémunération (s'il en a une), la

durée du mandat ainsi que toute autre modalité appropriée du mandat.

8.11 Les décisions du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans un registre spécial et

signés par le Président (ou selon le cas par le président pro tempore), par le Secrétaire ou par deux membres du Conseil
de Gérance. Toutes procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président (ou selon

le cas par le président pro tempore), par le Secrétaire ou par deux membres du Conseil de Gérance.

8.12 La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront

posés à ou à partir de Luxembourg.

Art. 9. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité

personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement
est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.

Chapitre IV. - Secrétaire

Art. 10. Nomination d'un secrétaire. Le Conseil de Gérance peut nommer un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé

de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance (le Secrétaire).

Le Secrétaire, si un est nommé, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions du Conseil de Gérance et,

dans la mesure du possible, des assemblées générales de l'associé unique/des associés, et de garder les procès-verbaux
et les comptes-rendus du Conseil de Gérance et des assemblées générales de l'associé unique/des associés, et de leurs
transactions dans un registre tenu à cette fin, et il effectuera, si nécessaire, des tâches similaires pour tous les comités du
Conseil de Gérance (s'il en existe). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition
qu'il conserve la responsabilité des tâches qu'il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l'autorité, qui lui sera donnée exclusivement par le Conseil de Gérance, d'émettre

des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice, ou, de manière générale,
à l'égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.

Chapitre V. - Assemblées générales de l'associé unique/des associés

Art. 11. Assemblées générales annuelles et extraordinaires de l'associé unique/des associés. Une assemblée générale

annuelle de l'associé unique/des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la ville de son
siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

D'autres assemblées générales de l'associé unique/des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans

la convocation.

Art. 12. Droit de vote d'associé(s). Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales de l'associé unique/

des associés indépendamment du nombre de parts sociales qu'il détient.

Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts sociales qu'il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un mandataire qui n'a pas besoin d'être associé pour le représenter aux

assemblées générales de l'associé unique/des associés.

Art. 13. Quorum - Majorité. Les résolutions de l'assemblée générale de l'associé unique/des associés ne sont valable-

ment prises que si elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts et celles pour dissoudre, liquider ou fusionner la Société ne

pourront être prises que par une majorité en nombre d'associés détenant au moins trois quarts du capital social de la
Société.

Tant que la Société n'a pas plus de 25 associés, les résolutions de l'associé unique/des associés pourront, au lieu d'être

prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite
de la/des résolution(s) à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes
pourront être produits par lettre, téléfax, télégramme, télex ou email).

56121

Chapitre VI. - Exercice social - Comptes annuels - Répartition

Art. 14. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un

décembre de la même année.

Art. 15. Comptes annuels. Chaque année, les livres sont clos et le Conseil de Gérance prépare les comptes annuels

de la Société (composés d'un bilan, d'un compte de pertes et profits et d'annexes aux comptes annuels), conformément
aux dispositions législatives luxembourgeoises applicables.

Art. 16. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance des comptes annuels susmentionnés

au siège social de la Société.

Art. 17. Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société

est affecté à l'établissement d'une réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital
social nominal de la Société.

Le solde peut être distribué à l'associé unique/ aux associés en proportion des parts sociales qu'il(s) détien(nen)t dans

la Société.

L'assemblée générale de l'associé unique/des associés a le pouvoir de déclarer un ou plusieurs dividendes intérimaires.

Chapitre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution. L'insolvabilité ou la faillite ou n'importe quelle autre procédure similaire d'un ou des associé(s)

n'entraînera pas la dissolution de la Société. L'associé unique/les associés doi(ven)t donner leur accord, conformément
aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2 des Statuts, à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les
modalités y relatives.

Art. 19. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s),

associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée générale de l'associé unique/des associés qui déterminera ses/leurs pouvoirs
et sa/leur rémunération.

Chapitre VIII. - Vérification des comptes

Art. 20. Commissaires aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société doit

nommer un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé
lorsque l'exemption prévue par les articles 256 et 215 de la Loi n'est pas applicable.

Chapitre IX. - Loi applicable

Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus dans les Statuts, le ou les

associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription et libération

Les Statuts ayant été ainsi établis, EAGLE JV S.à r.l. (l'Associé Unique), déclare souscrire toutes les 500 (cinq cents)

parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de
la Société d'un montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros).

Toutes ces 500 (cinq cents) parts sociales ont été libérées entièrement par l'Associé Unique au moyen d'un paiement

en numéraire, de sorte que le montant de souscription de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) est immédiatement
à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, et le notaire instrumentant constate
expressément un tel paiement.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 14 des Statuts, le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte

et se clôturera le 31 décembre 2007.

<i>Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

en raison du présent acte, s'élève à approximativement EUR 1.500 (mille cinq cents euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
1. L'Associé Unique décide de fixer le nombre de gérants de la Société à deux (2).
2. L'Associé Unique décide de nommer les deux (2) personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une

durée indéterminée:

(a) Mark Weeden, né à Londres (Royaume-Uni) le 4 décembre 1954, avec adresse professionnelle au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg; et

(b) Michel van Krimpen, né à Rotterdam (Pays-Bas) le 27 février 1969, avec adresse professionnelle au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg.

3. L'Associé Unique décide de fixer le siège social de la Société au 20, rue de la Poste à L-2346 Luxembourg.

56122

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparantes ci-dessus, le

présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française; à la requête de cette même partie comparante, et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé avec le

notaire l'original du présent acte.

Signé: C. Balthazard, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2007. Relation: LAC/2007/5743— Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007054559/242/449.
(070054818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Ginel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 90.205.

Il résulte de la lettre adressée à la société GINEL S.A. en date du 17 avril 2007 que Monsieur Luca Di Fino, Commissaire

aux comptes de la société, a démissionné de sa fonction avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 avril 2007.

Signature
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2007054047/4507/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2007, réf. LSO-CD06900. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Corporate Sailing S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 106.610.

EXTRAIT

Il résulte de la décision des associés en date du 13 juin 2006 que:
- M. Norbert Becker, né le 7 octobre 1953 à Luxembourg (Luxembourg), ayant son adresse professionnelle au 1B,

Heinhaff, L-1736 Senningerberg (Luxembourg), a démissionné de ses fonctions de Gérant de la Société avec effet au 13
juin 2006.

Depuis le 13 juin 2006, le Conseil de Gérance est composé comme suit:
- M. Eeman Jean-François
- M. Leloup Frederik
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 26 avril 2007.

Pour extrait conforme
ATOZ
Signature

Référence de publication: 2007054040/4170/23.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2007, réf. LSO-CD07132. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

56123

William Blair SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Hoehenhof.

R.C.S. Luxembourg B 98.806.

<i>Extrait des Résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 mars 2007

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 20 mars 2007, que Madame

Michelle Seitz et Messieurs Marco Hanig et Arthur Simon ont été réélus en leur qualité d'administrateur de la Société
pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale de 2008 et que ERNST &amp; YOUNG S.A., a été réélu
en leur qualité de réviseur d'entreprises de la Société pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale
de 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour WILLIAM BLAIR SICAV
THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.
E. Laming / D. Micallef
<i>- / Managing Director

Référence de publication: 2007054052/1163/20.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2007, réf. LSO-CD05226. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070055161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Cartrade-Automobile S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 107.039.

A l'attention du conseil d'Administration
Par la présente, veuillez prendre note de ma démission du poste d'Administrateur de la société CARTRADE-AUTO-

MOBILE S.A.

Bertrange, le 25 avril 2007.

F. Zanen.

Référence de publication: 2007054048/7623/13.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2007, réf. LSO-CD07047. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Transports CITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 77.917.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2006 de la société

Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TRANSPORTS CITAL S.A. les résolutions

suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

1. Sont nommés administrateurs, pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2012:
- Claude Wassenich, avocat, à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, Président et administrateur
- Sylvie Leick, employée privée, à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, administrateur,
- Patricia Sand, employée privée, à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel
2. Est nommée commissaire de surveillance pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2012:
- Thérèse Brasseur, professeur, demeurant à L-5762 Hassel, 3, rue des Champs.

Pour extrait conforme
C. Wassenich
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2007054049/276/21.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2007, réf. LSO-CD05532. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

56124

KEV Germany 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 127.049.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the fifth day of April.
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of

Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain depositary of the
original of the present deed.

There appeared:

1.- The company KENMORE EUROPEAN VENTURES S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», incorporated and

existing under Luxembourg law, established and having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, RCS
Luxembourg: B 111.646;

here represented by:
Mr Brendan Desmond Klapp, employee, with professional address in Belvaux, Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 30 March 2007;
2.- KENMORE EUROPE LIMITED, formerly DALGLEN (NO.1006) LIMITED a private limited company by shares,

incorporated and existing under the laws of Scotland, established and having its registered office at Dalmore House, 310
St Vincent Street, Glasgow, G2 5QR, Scotland, Company number: 291351,

here represented by:
Mr Brendan Desmond Klapp, prenamed,
by virtue of a proxy given in London (United Kingdom), on 29 March 2007;
Said proxies, signed ne varietur by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to

the present deed for registration purposes.

Such appearing proxy holder, acting in the here above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw

up the following articles of a joint stock company which the prenamed parties intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («société anonyme) under the name KEV GER-

MANY 3 S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice to the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders'
meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the Company is the purchase, directly or indirectly, letting, sale and development of investments

in commercial and non-commercial property in Germany or such other country as the managers shall agree as well as
the administration and management of such investments.

The Company may borrow in any kind or form and grant security and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial, financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) divided into three

hundred ten (310) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

56125

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a
general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of directors
may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than
one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, facsimile or e-mail being permitted. In case of emergency, directors may
vote either by letter, or by telegram, facsimile or e-mail.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the members present or represented. For the

avoidance of doubt, in case of an equality of votes, the chairman does not have a casting vote.

The Director(s) shall be obliged to consult with the advisory committee constituted by KENMORE EUROPE LIMITED

from time to time in respect of (1) acquisitions or other commitments in excess of 5% of funds available to the Company
and (2) all borrowings by the Company other than from the parent of the Company or any other group member, and,
without being bound to follow any recommendations made by this committee, shall consider any such recommendations
in the course of managing and administering the affairs of the company.

Any decision in respect of matters set out in (1) and (2) hereabove which has been taken without recommendation

of the advisory committee will require the unanimous consent of all directors from time to time.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the

debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. Subject to Article 8, the board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of admin-

istration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting
by the law, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

Art. 11. According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of

the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other
agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution
of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board
of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the
delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 12. Towards third parties the company will be bound by the joint signatures of any two directors or by the sole

signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by

the general meeting, which determines their number and their renumeration.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

56126

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed
by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the first Monday in the month of October of each year at 10.00 a.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing ten percent (10%) of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in

case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on 1 August of each year and ends on 31 July the following year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such

contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In addition the shareholders shall be entitled to declare the payment of an interim dividend at any time during each

financial year.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers.

General dispositions

Art. 21. The law of 10 August 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these

articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 July 2007.
The first annual general meeting shall be held in 2007.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

<i>Subscription and payment

The three hundred and ten (310) shares have been subscribed to by the shareholders hereafter as follows:

1.- KENMORE EUROPEAN VENTURES S.à r.l., prenamed, three hundred and nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- KENMORE EUROPE LIMITED. prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

The subscribed shares have been entirely paid up in cash so that the company has now at its free disposal the amount

of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) as was certified to the undersigned who expressly states this.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two

thousand euro.

56127

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three (3).
The following persons have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be

called to deliberate on the accounts as of 31 July 2012:

1.- Mr Robert William Brook, director, born in Bedeford (U.K.) on 27 September 1966, residing professionally at 5

Wigmore Street, London W1U 1PB (U.K.);

2.- Mr Victor Joseph Hansen, lawyer, born in Luxembourg, on 16 March 1940, residing professionally at 14A, rue des

Bains, L-1212 Luxembourg;

3.- Mrs Pascale Petoud, lawyer, born in Meaux (France), on 16 November 1972, residing professionally at 14A, rue

des Bains, L-1212 Luxembourg.

<i>Second resolution

The number of statutory auditor is set at one (1).
KPMG AUDIT S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg: B 103.590,

has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate

on the accounts as of 31 July 2012.

<i>Third resolution

The company's registered office is located at 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.
The undersigned notary who has perfect knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing parties the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the
same appearing parties and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be
prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his Surnames, Christian names, civil

status and residences, said person appearing signed together with the notary, the present original deed.

Folgt die Deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, am fünften April.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, Notar im Amtssizte in Remich, Grossherzogtum Luxemburg, in

Vertretung von Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim, Grossherzogtum Luxemburg, in dessen Besitz
und Verwahr gegenwärtige Urkunde verbleibt,

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft KENMORE EUROPEAN VENTURES S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet

nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 1, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, RCS Luxemburg: B 111.646,

hier vertreten durch:
Herrn Brendan Desmond Klapp, Angestellter, mit Berufanschrift in Beles, Luxemburg,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht gegeben zu Luxemburg, am 30. März 2007;
2.- Die Gesellschaft KENMORE EUROPE LIMITED, früher DALGLEN (NO.1006 LIMITED) eine Gesellschaft gegründet

nach schottischem Recht, mit Gesellschaftssitz in Dalmore House, 310 St Vincent Street, Glasgow, G2 5QR, Company
number: 29351;

hier vertreten durch:
Herrn Brendan Desmond Klapp, vorgenannt,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht gegeben zu London (Vereinigtes Königreich), am 29. März 2007.
Besagte Vollmachten, nachdem sie von dem Vollmachtnehmer und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet

wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Vorgenannter Vollmachtnehmer, handelnd wie vorerwähnt, ersuchte den unterzeichneten Notar, die Satzung einer,

von den vorbezeichneten Parteien, zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird hiermit eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung KEV GER-

MANY 3 S.A. gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

56128

Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der
Gesellschaftssitz  kann  durch  Beschluß  der  Generalversammlung  an  jeden  beliebigen  Ort  im  Grossherzogtum  verlegt
werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem

Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland
verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die un-
abhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, die Vermietung und der Verkauf von Anlagen

in gewerblich genützten Liegenschaften in Deutschland oder anderen Ländern, wie vom Verwaltungsrat entschieden,
sowie die Verwaltung, Entwicklung und Leitung solcher Anlagen.

Die Gesellschaft darf in jeder Form Kredit aufnehmen und Sicherheiten gewähren, sowie Anleihen und Schuldscheine

herausgeben.

Generell darf die Gesellschaft jegliche geschäftliche, industrielle oder finanzielle Operation vornehmen, welche sie als

dienlich zur Erfüllung und Entwicklung ihrer Zwecke befindet.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in

dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder

nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Haupt-
versammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem
Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder  darf  sechs  Jahre  nicht  überschreiten;  die  Wiederwahl  ist  zulässig. Sie

können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit  aus,  so  können  die  auf  gleiche  Art  ernannten  verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einen  vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung  des  Gesellschaftszweckes  notwendig  sind  oder  diesen  fördern.  Alles,  was  nicht  durch  das  Gesetz  oder  die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weites-

tgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz

einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, welche schriftlich, per Fax oder E-mail
erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fax oder
E-mail erfolgen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an jeder Sizung des Verwaltungsrats über Videokonferenz oder gleichwertigen

Kommunikationsmittel die seine Identifikation gewährleisten, teilnehmen. Diese Kommunikationsmittel müssen techni-
schen Voraussetzungen genügen, die die effektive Teilnahme an der Beratung, welche ununterbrochen übertragen werden
muss, gewährleisten. Die Beteiligung an einer Sitzung über die vorerwähnten Kommunikationswege ist mit einer persön-

56129

lichen Beteiligung an der Sitzung gleichzusetzen. Eine Sitzung des Verwaltungsrats die über vorerwähnte Wege abgehalten
wird gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit

ist die Stimme des Vorsitzenden nicht ausschlaggebend, dies um Zweifel zu vermeiden.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind verpflichtet den Rat von dem von KENMORE EUROPE LIMITED ernannten Ver-

waltungsbeirat von Zeit zu Zeit anzuhören bezugnehmend auf (1) Anschaffungen oder Verpflichtungen die 5% des der
Gesellschaft zur Verfügung stehenden Kapitals übersteigen und (2) sämtliche Anleihen welche die Gesellschaft aufnimmt
außer wenn der Gläubiger eine Gesellschaft der Gruppe ist. Die Verwaltungsratsmitglieder sind nicht an die Empfehlungen
des Beirates gebunden, müssen sie aber in Betracht nehmen bei der Verwaltung der Gesellschaftsangelegenheiten.

Sämtliche in (1) und (2) erwähnte Entscheidungen welche ohne Empfehlung des Beirates genommen wurden benötigen

die absolute Stimmenmehrheit.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. In Zustimmung mit Artikel 8 hat der Verwaltungsrat die weitgehendsten Befugnisse, um die Gesellschaftsan-

gelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Gemäss Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie

die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäfts-
führer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre
zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschliesst ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Über-
tragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen
Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenen
Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.

Art. 12. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern, oder durch die Einzelunterschrift entsprechend durch den Verwaltungsrat bevollmächtigter Personen verpflich-
tet.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl festlegt und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am ersten Montag des Monats Oktober eines jeden Jahres, um 10.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung ein-

berufen.  Sie  muss  einberufen  werden,  falls  Aktionäre,  die  mindestens  zehn  Prozent  (10%)  des  Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen;

für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung alle Verfügungsrechte,
welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer
ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18.  Das  Geschäftsjahr  beginnt  am  ersten  August  eines  jeden  Jahres  und  endet  am  einunddreißigsten  Juli  des

darauffolgenden Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben:
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

56130

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Zusätzlich sind die Aktionäre jeder Zeit berechtigt zur Auszahlung von Vorschussdividenden während eines jeden

Geschäftsjahres zu schreiten.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Juli 2007.
Die erste Generalversammlung findet im Jahre 2007 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Ge-

sellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

<i>Kapitalzeichnung - Einzahlung

Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden durch die nachstehenden Aktionäre wie folgt gezeichnet:

1.- Die Gesellschaft KENMORE EUROPEAN VENTURES S.à .r.l., vorbezeichnet, dreihundertneun Aktien . . . . 309
2.- Die Gesellschaft KENMORE EUROPE LIMITED, vorbezeichnet, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe in bar eingezahlt.
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung, was dem

unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung entstehen, auf zweitausend Euros.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordentli-

chen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, welche über die Konten zum 31. Juli 2012 befindet, wer-

den ernannt:

1.- Herrn Robert William Brook, Verwaltungsrat, geboren in Bedeford (Vereinigtes Königreich) am 27. September

1966, beruflich wohnhaft 5 Wigmore Street, London W1U 1PB (Vereinigtes Königreich);

2.- Herrn Victor Joseph Hansen, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg, am 16. März 1940, beruflich wohnhaft 14A, rue

des Bains, L-1212 Luxemburg;

3.- Frau Pascale Petoud, Rechtsanwältin, geboren in Meaux (Frankreich), am 16. November 1972, beruflich wohnhaft

14A, rue des Bains, L-1212 Luxemburg.

<i>Zweiter Beschluss

Die Zahl der Wirtschaftsprüfer wird auf einen (1) festgelegt.
Zum Wirtschaftsprüfer bis zur Generalversammlung, welche über die Konten zum 31.Juli 2012 befindet, wird ernannt:
KPMG AUDIT S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, R.C.S.

Luxemburg: B 103.590,

56131

<i>Dritter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 14A, rue des Bains, L-1212 Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig und mächtig, stellt hiermit fest, das auf Ersuchen der Er-

schienenen, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfass ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache.
Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen Text und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: B. D. Klapp, M. Schaeffer.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 10. April 2007. Relation: EAC/2007/3606. - Erhalten 310 Euro.

<i>Der Einnehmer ff.

 (gezeichnet): Oehmen.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und

Vereinigungen.

Beles, den 24. April 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007054492/239/389.
(070054656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Cody Internet Ventures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 76.542.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 avril 2007

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Sébastien Schaack, employé privé, avec adresse

professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX KONZERN S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège
social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes
de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 10 avril 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007054036/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2007, réf. LSO-CD03660. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

East Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 102.105.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2007

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Sébastien Schaack, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX KONZERN S.à r.l., ayant son siège social 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant
son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur
les comptes de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 30 mars 2007.

56132

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007054037/655/22.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2007, réf. LSO-CD03655. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

KEV Germany 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 127.046.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the fifth day of April.
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of

Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain depositary of the
original of the present deed.

There appeared:

1.- The company KENMORE EUROPEAN VENTURES S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», incorporated and

existing under Luxembourg law, established and having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, RCS
Luxembourg: B 111.646;

here represented by:
Mr Brendan Desmond Klapp, employee, with professional address in Belvaux, Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 30 March 2007;
2.- KENMORE EUROPE LIMITED, formerly DALGLEN (NO.1006) LIMITED a private limited company by shares,

incorporated and existing under the laws of Scotland, established and having its registered office at Dalmore House, 310
St Vincent Street, Glasgow, G2 5QR, Scotland, Company number: 291351,

here represented by:
Mr Brendan Desmond Klapp, prenamed,
by virtue of a proxy given in London (United Kingdom), on 29 March 2007.
Said proxies, signed ne varietur by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to

the present deed for registration purposes.

Such appearing proxy holder, acting in the here above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw

up the following articles of a joint stock company which the prenamed parties intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («société anonyme») under the name KEV

GERMANY 4 S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice to the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders'
meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

56133

Art. 4. The object of the Company is the purchase, directly or indirectly, letting, sale and development of investments

in commercial and non-commercial property in Germany or such other country as the managers shall agree as well as
the administration and management of such investments.

The Company may borrow in any kind or form and grant security and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial, financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) divided into three

hundred ten (310) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a
general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of directors
may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than
one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, facsimile or e-mail being permitted. In case of emergency, directors may
vote either by letter, or by telegram, facsimile or e-mail.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the members present or represented. For the

avoidance of doubt, in case of an equality of votes, the chairman does not have a casting vote.

The Director(s) shall be obliged to consult with the advisory committee constituted by KENMORE EUROPE LIMITED

from time to time in respect of (1) acquisitions or other commitments in excess of 5% of funds available to the Company
and (2) all borrowings by the Company other than from the parent of the Company or any other group member, and,
without being bound to follow any recommendations made by this committee, shall consider any such recommendations
in the course of managing and administering the affairs of the company.

Any decision in respect of matters set out in (1) and (2) hereabove which has been taken without recommendation

of the advisory committee will require the unanimous consent of all directors from time to time.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the

debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. Subject to Article 8, the board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of admin-

istration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting
by the law, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

Art. 11. According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of

the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other
agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution
of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board
of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the
delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

56134

Art. 12. Towards third parties the company will be bound by the joint signatures of any two directors or by the sole

signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by

the general meeting, which determines their number and their renumeration.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed
by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the first Monday in the month of October of each year at 11.00 a.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing ten percent (10%) of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in

case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on 1 August of each year and ends on 31 July the following year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such

contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In addition the shareholders shall be entitled to declare the payment of an interim dividend at any time during each

financial year.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers.

General dispositions

Art. 21. The law of 10 August 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these

articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 July 2007.
The first annual general meeting shall be held in 2007.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

<i>Subscription and payment

The three hundred and ten (310) shares have been subscribed to by the shareholders hereafter as follows:

1.- KENMORE EUROPEAN VENTURES S.à r.l., prenamed, three hundred and nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- KENMORE EUROPE LIMITED. prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

The subscribed shares have been entirely paid up in cash so that the company has now at its free disposal the amount

of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) as was certified to the undersigned who expressly states this.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

56135

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two

thousand euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three (3).
The following persons have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be

called to deliberate on the accounts as of 31 July 2012:

1.- Mr Robert William Brook, director, born in Bedeford (U.K.) on 27 September 1966, residing professionally at 5

Wigmore Street, London W1U 1PB (U.K.);

2.- Mr Victor Joseph Hansen, lawyer, born in Luxembourg, on 16 March 1940, residing professionally at 14A, rue des

Bains, L-1212 Luxembourg;

3.- Mrs Pascale Petoud, lawyer, born in Meaux (France), on 16 November 1972, residing professionally at 14A, rue

des Bains, L-1212 Luxembourg.

<i>Second resolution

The number of statutory auditor is set at one (1).
KPMG AUDIT S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg: B 103.590,

has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate

on the accounts as of 31 July 2012.

<i>Third resolution

The company's registered office is located at 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.
The undersigned notary who has perfect knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing parties the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the
same appearing parties and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be
prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his Surnames, Christian names, civil

status and residences, said person appearing signed together with the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, am fünften April.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, Notar im Amtssizte in Remich, Grossherzogtum Luxemburg, in

Vertretung von Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim, Grossherzogtum Luxemburg, in dessen Besitz
und Verwahr gegenwärtige Urkunde verbleibt,

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft KENMORE EUROPEAN VENTURES S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet

nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 1, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, RCS Luxemburg: B 111.646,

hier vertreten durch:
Herrn Brendan Desmond Klapp, Angestellter, mit Berufanschrift in Beles, Luxemburg,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht gegeben zu Luxemburg, am 30. März 2007;
2.- Die Gesellschaft KENMORE EUROPE LIMITED, früher DALGLEN (NO.1006 LIMITED) eine Gesellschaft gegründet

nach schottischem Recht, mit Gesellschaftssitz in Dalmore House, 310 St Vincent Street, Glasgow, G2 5QR, Company
number: 29351;

hier vertreten durch:
Herrn Brendan Desmond Klapp, vorgenannt,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht gegeben zu London (Vereinigtes Königreich), am 29. März 2007.
Besagte Vollmachten, nachdem sie von dem Vollmachtnehmer und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet

wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Vorgenannter Vollmachtnehmer, handelnd wie vorerwähnt, ersuchte den unterzeichneten Notar, die Satzung einer,

von den vorbezeichneten Parteien, zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

56136

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird hiermit eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung KEV GER-

MANY 4 S.A. gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der
Gesellschaftssitz  kann  durch  Beschluß  der  Generalversammlung  an  jeden  beliebigen  Ort  im  Grossherzogtum  verlegt
werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem

Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland
verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die un-
abhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, die Vermietung und der Verkauf von Anlagen

in gewerblich genützten Liegenschaften in Deutschland oder anderen Ländern, wie vom Verwaltungsrat entschieden,
sowie die Verwaltung, Entwicklung und Leitung solcher Anlagen.

Die Gesellschaft darf in jeder Form Kredit aufnehmen und Sicherheiten gewähren, sowie Anleihen und Schuldscheine

herausgeben.

Generell darf die Gesellschaft jegliche geschäftliche, industrielle oder finanzielle Operation vornehmen, welche sie als

dienlich zur Erfüllung und Entwicklung ihrer Zwecke befindet.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in

dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder

nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Haupt-
versammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem
Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Si können

von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit  aus,  so  können  die  auf  gleiche  Art  ernannten  verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einen  vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung  des  Gesellschaftszweckes  notwendig  sind  oder  diesen  fördern.  Alles,  was  nicht  durch  das  Gesetz  oder  die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weites-

tgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz

einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, welche schriftlich, per Fax oder E-mail
erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fax oder
E-mail erfolgen.

56137

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an jeder Sizung des Verwaltungsrats über Videokonferenz oder gleichwertigen

Kommunikationsmittel die seine Identifikation gewährleisten, teilnehmen. Diese Kommunikationsmittel müssen techni-
schen Voraussetzungen genügen, die die effektive Teilnahme an der Beratung, welche ununterbrochen übertragen werden
muss, gewährleisten. Die Beteiligung an einer Sitzung über die vorerwähnten Kommunikationswege ist mit einer persön-
lichen Beteiligung an der Sitzung gleichzusetzen. Eine Sitzung des Verwaltungsrats die über vorerwähnte Wege abgehalten
wird gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit

ist die Stimme des Vorsitzenden nicht ausschlaggebend, dies um Zweifel zu vermeiden.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind verpflichtet den Rat von dem von KENMORE EUROPE LIMITED ernannten Ver-

waltungsbeirat von Zeit zu Zeit anzuhören bezugnehmend auf (1) Anschaffungen oder Verpflichtungen die 5% des der
Gesellschaft zur Verfügung stehenden Kapitals übersteigen und (2) sämtliche Anleihen welche die Gesellschaft aufnimmt
außer wenn der Gläubiger eine Gesellschaft der Gruppe ist. Die Verwaltungsratsmitglieder sind nicht an die Empfehlungen
des Beirates gebunden, müssen sie aber in Betracht nehmen bei der Verwaltung der Gesellschaftsangelegenheiten.

Sämtliche in (1) und (2) erwähnte Entscheidungen welche ohne Empfehlung des Beirates genommen wurden benötigen

die absolute Stimmenmehrheit.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. In Zustimmung mit Artikel 8 hat der Verwaltungsrat die weitgehendsten Befugnisse, um die Gesellschaftsan-

gelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Gemäss Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie

die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäfts-
führer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre
zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschliesst ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Über-
tragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen
Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenen
Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.

Art. 12. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern, oder durch die Einzelunterschrift entsprechend durch den Verwaltungsrat bevollmächtigter Personen verpflich-
tet.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl festlegt und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am ersten Montag des Monats Oktober eines jeden Jahres, um 11.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung ein-

berufen.  Sie  muß  einberufen  werden,  falls  Aktionäre,  die  mindestens  zehn  Prozent  (10%)  des  Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen;

für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung alle Verfügungsrechte,
welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer
ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18.  Das  Geschäftsjahr  beginnt  am  ersten  August  eines  jeden  Jahres  und  endet  am  einunddreißigsten  Juli  des

darauffolgenden Jahres.

56138

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben:
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Zusätzlich sind die Aktionäre jeder Zeit berechtigt zur Auszahlung von Vorschussdividenden während eines jeden

Geschäftsjahres zu schreiten.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Juli 2007.
Die erste Generalversammlung findet im Jahre 2007 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Ge-

sellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

<i>Kapitalzeichnung - Einzahlung

Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden durch die nachstehenden Aktionäre wie folgt gezeichnet:

1.- Die Gesellschaft KENMORE EUROPEAN VENTURES S.à .r.l., vorbezeichnet, dreihundertneun Aktien . . . . 309
2.- Die Gesellschaft KENMORE EUROPE LIMITED, vorbezeichnet, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe in bar eingezahlt.
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung, was dem

unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung entstehen, auf zweitausend Euros.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordentli-

chen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, welche über die Konten zum 31. Juli 2012 befindet, wer-

den ernannt:

1.- Herrn Robert William Brook, Verwaltungsrat, geboren in Bedeford (Vereinigtes Königreich) am 27. September

1966, beruflich wohnhaft 5 Wigmore Street, London W1U 1PB (Vereinigtes Königreich);

2.- Herrn Victor Joseph Hansen, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg, am 16. März 1940, beruflich wohnhaft 14A, rue

des Bains, L-1212 Luxemburg;

3.- Frau Pascale Petoud, Rechtsanwältin, geboren in Meaux (Frankreich), am 16. November 1972, beruflich wohnhaft

14A, rue des Bains, L-1212 Luxemburg.

56139

<i>Zweiter Beschluss

Die Zahl der Wirtschaftsprüfer wird auf einen (1) festgelegt.
Zum Wirtschaftsprüfer bis zur Generalversammlung, welche über die Konten zum 31. Juli 2012 befindet, wird ernannt:
KPMG AUDIT S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, R.C.S.

Luxemburg: B 103.590.

<i>Dritter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 14A, rue des Bains, L-1212 Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig und mächtig, stellt hiermit fest, das auf Ersuchen der Er-

schienenen, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfass ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache.
Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen Text und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: B. D. Klapp, M. Schaeffer.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 10. April 2007. Relation: EAC/2007/3607.- Erhalten 310 Euro.

<i>Der Einnehmer ff.

 (gezeichnet): Oehmen.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und

Vereinigungen.

Beles, den 24. April 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007054494/239/389.
(070054651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Armeos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 55.426.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 avril 2007

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Jean Klimis, administrateur de sociétés, demeurant

54, avenue de la Tenderie, B-1170 Bruxelles, de Monsieur Pierre Klimis, directeur commercial, demeurant 12, Drève des
Pommiers, B-1380 Ohain et de Madame Sophie Peereboom, administrateur de sociétés, demeurant 9, avenue du Chili,
B-1000 Bruxelles, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50,
route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de
l'exercice 2007.

Luxembourg, le 5 avril 2007.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007054038/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2007, réf. LSO-CD03673. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Rosa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 11.297.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 17 avril 2007

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue en date du 17 avril 2007 que:
1) L'Assemblée a décidé d'accepter, avec effet immédiat, la démission de l'administrateur en fonction, la société à

responsabilité limitée CD GEST S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, au 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

2) L'Assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat, Madame Josten Renate, Licenciée en sciences économiques

appliquées, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg au 2, rue Jean-Pierre Brasseur, nouvel administrateur
de la société, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

56140

Le nouvel administrateur termine le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle statutaire de l'an 2008.

Luxembourg, le 18 avril 2007.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2007054135/320/22.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2007, réf. LSO-CD06870. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Stars Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 108.173.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue à Luxembourg au siège social, le mardi 17 avril 2007

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 17 avril 2007 que:
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Monsieur Naveaux Jean à la fonction de Président du

Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 18 avril 2007.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2007054133/320/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2007, réf. LSO-CD06869. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Plasticbase SA, Société Anonyme.

Siège social: L-6620 Wasserbillig, 1, rue de la 87ème Division.

R.C.S. Luxembourg B 118.499.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 13 mars 2007

L'assemblée prend note de et accepte la démission de Monsieur Manfred Duchène du conseil d'administration et du

poste d'administrateur-délégué chargé de la gestion journalière.

Wasserbillig, le 13 mars 2007.

J. B. Weis
<i>Président du conseil d'administration

Référence de publication: 2007054141/7626/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2007, réf. LSO-CD07198. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Proteactive Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 74.643.

<i>Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société

<i>en date du 27 septembre 2005 à 11.00 heures

<i>Décisions

L'assemblée, à l'unanimité, a décidé:
- de remplacer Monsieur Frédéric Deflorenne dans ses fonctions de commissaire aux comptes.
- de nommer en remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes, la société anonyme de droit luxembour-

geois DATA GRAPHIC S.A. dont le siège est établi au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, immatriculée

56141

au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 42.166 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007054150/4286/22.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2007, réf. LSO-CD06236. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Moumont S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 36.855.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue en date du 18 mai 2006 à 15.00 heures

Après avoir délibéré, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité:
1. De procéder au remplacement de Monsieur Frédéric Deflorenne dans son mandat de commissaire aux comptes

par la société DATA GRAPHIC S.A., ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, boulevard de la Pétrusse, 128, R.C.S.
Luxembourg B 42.166, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007054145/4286/18.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2007, réf. LSO-CD06227. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Kadan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 62.020.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société

<i>en date du 14 avril 2006 à 8.00 heures

A l'unanimité, l'Assemblée a décidé:
- de remplacer Monsieur Jean-Marc Faber dans son mandat de commissaire aux comptes par la société DATA GRA-

PHIC S.A., ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg B 42.166, qui
terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007054148/4286/18.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2007, réf. LSO-CD06230. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

GEF Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 11.986.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

27 février 2007, enregistré à Luxembourg A.C., le 28 février 2007, Relation LAC/2007/779, que les opérations de liqui-

56142

dation de la société anonyme GEF HOLDING S.A. (ci-après la «Société») ont été définitivement clôturées et que la Société
a cessé d'exister.

Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation

à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

Luxembourg, le 19 avril 2007.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

Référence de publication: 2007054155/230/18.
(070054986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Elbblick (November) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 127.075.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the nineteenth of April.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SELENO (LUXEMBOURG) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 120.644,
having its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Mrs. Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Lux-

embourg, on 18th of April 2007.

Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the
articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding
of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, pro-
motion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations

of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as
the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which
form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem

useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of ELBBLICK (NOVEMBER) S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The

registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several man-
agers, by the board of managers.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case

of several managers, by the board of managers.

56143

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quarters

of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three-quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of two managers.

Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram,
telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent
more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

56144

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The  partners  may  not  change  the  nationality  of  the  Company  otherwise  than  by  unanimous  consent.  Any  other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual Accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on January 1st, and ends on December 31st of the same year.

Art. 21. Each year on December 31st, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by SELENO (LUXEMBOURG) S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.

56145

<i>Resolutions of the Sole Partner

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Bart Zech, born on 5 September 1969, residing at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg;

- Mr. Frank Helmut Walenta, born on 2 February 1972, in Genève, residing at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Michael David Evans, born on 19 November 1952, in Buckland, residing at Chobham Park Lane 1, Chobham,

GU24HQ Surrey, U.K.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by her name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SELENO (LUXEMBOURG) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
120.644, ayant son siège social au 12, rue Léon Thyms, L-2636 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous

seing privé donnée à Luxembourg, le 18 avril 2007.

La procuration, signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un  objet  supplémentaire  de  la  Société  est  l'acquisition  et  la  vente  de  biens  immobiliers  soit  au  Grand-Duché  de

Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de parti-
cipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans
l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle

estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de ELBBLICK (NOVEMBER) S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré

dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y aurait plusieurs gérants, par décision du conseil de
gérance.

56146

Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y aurait plusieurs gérants, par le conseil de gérance,

des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, éco-

nomique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq cents

(500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la

signature conjointe de deux gérants.

Art. 12. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a
pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le  conseil  de  gérance  se  réunira  sur  convocation  du  président  ou  de  deux  gérants  au  lieu  indiqué  dans  l'avis  de

convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation
n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil

de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

56147

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents

ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et Libération

SELENO (LUXEMBOURG) S.à r.l., prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros.

56148

<i>Résolutions de l'associé unique

Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une

assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 12, rue Léon Thyms, L-2636 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Bart Zech, né le 5 septembre 1969, demeurant au 12, rue Léon Thyms, L-2636 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg;

- Monsieur Frank Helmut Walenta, né le 2 février 1972, à Genève, demeurant au 12, rue Léon Thyms, L-2636 Lu-

xembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Monsieur Michael David Evans, né le 19 novembre 1952, à Bouclant, demeurant au Cohen Park Lame 1, Cohen,

GU24HQ Suret, Royaume-Uni.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2007. Relation: EAC/2007/4119. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 25 avril 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007054506/239/339.
(070054999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Rosa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 11.297.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg au siège social, le mardi 17 avril 2007

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 17 avril 2007 que:
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Maître Felten Bernard à la fonction de Président du

Conseil d'Administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 avril 2007.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2007054136/320/18.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2007, réf. LSO-CD06893. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Piani Developments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 39.167.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2007

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Pieter van Nugteren, employé privé, avec adresse

professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l.,
ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX KONZERN S.à r.l., ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.

Luxembourg, le 30 mars 2007.

56149

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007054044/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01193. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Luxair Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 112.996.

<i>Extraits du Procès-verbal de l'assemblée générale du 10 avril 2007

- L'Assemblée prend acte des démissions de M. Jean Louis Kremer et de M. Jean Pierre Walesch de leur mandat

d'administrateur avec effet au 24 juillet 2006.

- En remplacement, l'assemblée ratifie la cooptation de M. Michel Folmer et M. Laurent Jossart, demeurant tous deux

professionnellement à l'aéroport de Luxembourg à L-2987 Luxembourg, en tant qu'administrateurs de la société.

- L'Assemblée reconduit les mandats d'administrateur de M. Adrien Ney, M. Michel Folmer et de M. Laurent Jossart

demeurant tous trois professionnellement à l'aéroport de Luxembourg à L-2987 Luxembourg, jusqu'à l'issue de l'As-
semblée Générale Ordinaire d'avril 2008.

- L'Assemblée reconduit le mandat du Réviseur d'entreprises de PricewaterhouseCoopers jusqu'à l'issue de l'Assem-

blée Générale Ordinaire d'avril 2008.

Luxembourg, le 11 avril 2007.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2007054051/5649/22.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2007, réf. LSO-CD06268. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Eurocom Beratungs- und Treuhand GmbH, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

R.C.S. Luxembourg B 58.715.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte d'un jugement rendu le 1 

er

 février 2007 par le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, que les opérations de liquidation de la société EUROCOM BERATUNGS- UND TREUHAND
GmbH, ayant eu son siège social à L-2167 Luxembourg, 26A, rue des Muguets, ont été déclarées closes pour absence
d'actifs et que les frais ont été mis à charge du Trésor.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

O. Huth
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2007054166/7628/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2007, réf. LSO-CD07294. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

T.S.M. Holding AG, Société Anonyme (en liquidation).

R.C.S. Luxembourg B 24.471.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte d'un jugement rendu le 1 

er

 février par le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, que les opérations de liquidation de la société T.S.M. HOLDING AG, ayant eu son siège social à L-1118
Luxembourg, 14, rue Aldringen, ont été déclarées closes pour absence d'actifs et que les frais ont été mis à charge du
Trésor.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

56150

O. Huth
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2007054169/7628/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2007, réf. LSO-CD07293. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Evli Bank Plc, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 82.970.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de EVLI BANK PLC tenue en date du 16 février

2007, que le régime des signatures autorisées de EVLI BANK PLC, LUXEMBOURG BRANCH, a été modifié comme suit:

<i>Groupe 1:

- Existant: M. Tom Wiik, Directeur, C/O EVLI BANK PLC, LUXEMBOURG BRANCH, 60, Grand-Rue, L-1660 Lu-

xembourg

- Existant: M. Kari Laine, employé de banque, C/O EVLI BANK PLC, LUXEMBOURG BRANCH, 60, Grand-Rue, L-1660

Luxembourg

<i>Groupe 2:

- Existant: Mme Madeleine Abinet, employée de banque, C/O EVLI BANK PLC, LUXEMBOURG BRANCH, 60, Grand-

Rue, L-1660 Luxembourg

- Retrait: M. Jérôme Philippe Goettmann, Directeur, Responsable Ventes Institutionnelles, C/O EVLI BANK PLC, 60,

Grand-Rue, L-1660 Luxembourg

Ces modifications prennent effet immédiatement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 27 avril 2007.

Pour enregistrement
EVLI BANK PLC, LUXEMBOURG BRANCH
K. Laine / M. Abinet

Référence de publication: 2007054054/2301/28.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2007, réf. LSO-CD07256. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Materis Management Aluminates, Société Civile.

Capital social: EUR 115.550,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg E 2.939.

DISSOLUTION

<i>Procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale mixte Ordinaire et Extraordinaire du 12 avril 2007

L'Assemblée  est  ouverte  à  12.00  heures  sous  la  présidence  de  Monsieur  John  Seil  qui  désigne  comme  secrétaire

Madame Alexia Uhl et l'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Gentiane Preaux.

Le Président expose que les associés ont été valablement convoqués conformément aux statuts de la société.
Les associés présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre de parts possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les associés présents et par les mandataires de ceux représentés
et qui demeurera annexée aux présentes.

La liste de présence, certifiée sincère et véritable par le président de séance permet de constater que sur 115.550

parts émises, 100.000 parts sociales sont représentées à l'Assemblée.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
Le président de séance déclare ensuite que l'ensemble des documents prévus par les textes légaux ont été remis ou

tenus à la disposition des associés dans les délais et les conditions prévus par la loi et les statuts.

56151

Le président expose alors l'ordre du jour de la présente Assemblée Générale:
* Partie Ordinaire:
1. Audition du rapport du gérant pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2006.
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2006 et affectation des résultats.
3. Décharge accordée au gérant pour l'exercice de ses fonctions pour l'année 2006.
* Partie Extraordinaire:
4. Approbation d'une situation intermédiaire au 28 février 2007.
5. Décision de dissoudre la société aux droits des parties.
6. Décharge à accorder au gérant jusqu'à ce jour.
7. Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5

années.

Après avoir examiné les comptes annuels au 31 décembre 2006, l'Assemblée entend le rapport de gestion du gérant

et, après en avoir délibéré, elle prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Partie Ordinaire:

<i>Première résolution

Le rapport de gestion du gérant est accepté.

<i>Deuxième résolution

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 sont approuvés. Il en ressort un résultat bénéficiaire d'un montant de EUR

4.519,07. Il est décidé de reporter à nouveau le solde en bénéfice de EUR 95.631,84.

<i>Troisième résolution

Décharge est donnée au gérant pour l'exercice de son mandat concernant l'exercice 2006.

Partie Extraordinaire:

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide d'approuver la situation comptable intermédiaire au 28 février 2007.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de dissoudre la société et nomme, conformément à l'article 16 des statuts,

le gérant actuel liquidateur de la société.

L'Assemblée Générale prend ensuite acte de la déclaration du liquidateur que tous les passifs ont été payés à l'exception

des frais de liquidation qui s'élève à EUR 5.057,00 que le liquidateur paiera en date de ce jour et que suite à ce paiement,
la répartition des actifs sera faite aux droits des parties, et que, partant, la liquidation de la société est à considérer comme
faite et clôturée. Le montant remboursable aux actionnaires s'élève à EUR 218.191,85.

Les associés déclarent, par rapport à d'éventuels passifs actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure

actuelle, assumer irrévocablement et solidairement avec la société l'obligation de payer tout ce passif éventuel actuelle-
ment inconnu.

<i>Sixième résolution

Décharge est donnée au gérant Monsieur Christian Sacchetti.

<i>Septième résolution

Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO COMPAGNIE

FIDUCIAIRE.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 12.45 heures.

J. Seil / G. Preaux / A. Uhl
<i>Président / <i>Scrutateur / <i>Secrétaire

Référence de publication: 2007054186/534/65.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2007, réf. LSO-CD04054. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Winfina S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 66.898.

Par un courrier recommandé en date du 18 avril 2007 aux actionnaires de la société WINFINA SA, avec siège social

à L-2017 Luxembourg, BO 742, 11, boulevard Royal, Monsieur Jean Bernard Zeimet, demeurant professionnellement à

56152

L-2730  Luxembourg,  67,  rue  Michel  Welter,  a  démissionné  avec  effet  immédiat  de  son  mandat  de  commissaire  aux
comptes de la société WINFINA S.A., enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et, à Luxembourg
sous le numéro B 66.898

Signature.

Référence de publication: 2007054652/1137/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2007, réf. LSO-CD05161. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070053790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2007.

S.I. Umbolt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 80.550.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007054655/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2007, réf. LSO-CD06379. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070054610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Finance Agricole S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 114.763.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007054657/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2007, réf. LSO-CD06369. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

ECG Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 73.490.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>ECG Participations S.A.
LOUV Sà.r.l. / FIDIS Sà.r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
Signature / Signature

Référence de publication: 2007054663/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2007, réf. LSO-CD06256. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Turf Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 102.265.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

56153

<i>Pour TURF CAPITAL S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007054662/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2007, réf. LSO-CD06257. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Bomba Grill S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 127.067.

STATUTS

L'an deux mille sept, le six mars.
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1 ) Madame Maria de Lurdes Ramos Da silva Pinto, gérante, née à Pampilhosa/Mealhada (P), le 26 juin 1970, demeurant

à L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.

2) Monsieur Nicodemo Ceravolo, gérant, né à Grotteria (I), le 15 avril 1954, demeurant à L-4660 Differdange, 39, rue

Michel Rodange.

3) Madame Maria Carmela Sita, née à Differdange, le 22 octobre 1970, demeurant à L-4438 Soleuvre, 243, rue de

Differdange.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de BOMBA GRILL S.àr.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la Commune de Differdange. Il pourra être transféré en toute autre

localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

Art. 3. La société a pour objet une rôtisserie et un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.
Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher direc-

tement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes

entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe.

Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou caution-

nements à des personnes privées, aux associés, ainsi que à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou
indirect

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L'année sociale coïncide avec l'année civile, sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- €), divisé en 100 parts

sociales de 125,- € chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) Madame Maria de Lurdes Ramos Da Silva Pinto, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 parts

2) Monsieur Nicodemo Ceravolo, préqualifé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 parts

2) Madame Maria Carmela Sita, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

La somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- €), se trouve à la disposition de la société, ce que les associés

reconnaissent mutuellement.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l'égard de la société.

56154

La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l'accord unanime de tous les associés.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition des

scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

Art. 10. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille cinquante euros (1.050,- €).

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:
1. Sont nommés gérants:
- gérante technique: Madame Zélia Maria Dias Luis, née à Coimbra/Se Nova (P), le 29 août 1972, demeurant à L-4660

Differdange, 35, rue Michel Rodange

- gérante administrative: Madame Maria de Lurdes Ramos Da Silva Pinto, préqualifée
2. La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérantes.
3. Le siège social de la société est fixé à L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: M. Ramos Da Silva Pinto, N. Ceravolo, C. Sita, G. d'Huart.
Enregistré à Esch/Alzette, le 8 mars 2007. Relation: EAC/2007/1967. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 21 mars 2007.

G. d'Huart.

Référence de publication: 2007054620/207/69.
(070054990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Société de Développement Agricole - ZEVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 83.674.

Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007054660/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2007, réf. LSO-CD05223. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070053482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2007.

SGG, Services Généraux de Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 65.906.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / C. Schlesser
<i>Sous-directeur / Directeur Général

Référence de publication: 2007054661/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2007, réf. LSO-CD06254. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

56155

Global Garden Products C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.803.900,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 96.507.

Le bilan au 31 août 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2007.

B. Zech.

Référence de publication: 2007054582/724/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD02997. - Reçu 40 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070054698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Breba - Cars S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5364 Schrassig, 8, Schlassgewan.

R.C.S. Luxembourg B 59.056.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007054677/1420/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2007, réf. LSO-CD00363. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070053520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2007.

Sunderland Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.

R.C.S. Luxembourg B 70.740.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2007054687/1324/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2007, réf. LSO-CD05193. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070053907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2007.

Litoprint S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 41.107.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>LITOPRINT S.A.
LOUV S.à rl / FIDIS Sà r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
Signature / Signature

Référence de publication: 2007054666/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2007, réf. LSO-CD05991. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

56156

VMTO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 86.064.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2007.

TCG GESTION SA
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2007054580/710/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2007, réf. LSO-CD06085. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070054694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2007.

Porto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 89.994.

Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007055221/1031/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2007, réf. LSO-CD04324. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2007.

Porto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 89.994.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007055224/1031/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2007, réf. LSO-CD04337. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2007.

Club Torreense d'Esch asbl, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 9, rue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg F 2.719.

Modification au Art. 1 

er

 des Statuts transfert de siège

L'Assemblée Générale du 3 avril 2007 a prise comme décision de changer le siège du club.
L'Assemblée du 3 avril 2007 par décision majoritaire de tous les membres présents ont modifiés l'art. 1 

er

 des Statuts.

Nouveau siège du Club, 9, X Septembre, L-4320 Esch-Sur-Alzette, Luxembourg

Luxembourg, le 26 avril 2007.

M. Rodrigues Alzira
<i>Président

Référence de publication: 2007055226/7622/16.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2007, réf. LSO-CD06978. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2007.

56157

Shildon S.A., Société Anonyme,

(anc. Customer : View S.A.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 82.239.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 2 avril 2007 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2007.

F. Kesseler
<i>Notaire

Référence de publication: 2007055004/219/14.
(070055828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2007.

'Roma Société Civile Immobilière', Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 193, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg E 2.464.

Suite à la décision des gérants, le siège est transféré de 2A, Beim Kinnebesch - L-8615 Platen au 193, avenue de la

Faïencerie - L-1511 Luxembourg avec effet au 1 

er

 mai 2007.

Pour extrait sincère et conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2007.

ROMA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
R. Zimmer
<i>Associé-gérant

Référence de publication: 2007055228/664/16.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2007, réf. LSO-CD04813. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2007.

Porto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 89.994.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007055222/1031/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2007, réf. LSO-CD04330. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2007.

Autopolis Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 85.902.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007055234/1682/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2007, réf. LSO-CD05772. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2007.

56158

Radio Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 16.364.

Le bilan de la société au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007055361/655/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2007, réf. LSO-CD06314. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070056106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2007.

Lend Lease Europe Real Estate Advisors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 80.200.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale tenue le 19 avril 2007

Il résulte dudit procès-verbal que:
1. La démission de M. Matthew Banks de sa fonction d'administrateur avec effet du 2 octobre 2001 a été accepté.
2. Les mandats des administrateurs existants Susan Desprez, James Quille et Alexander Daniel Jeffrey ont été révoqués

avec effet au 19 avril 2007.

3. M. Craig Matheson, gérant, né le 18 juin 1967 à Dunedin, Nouvelle-Zélande avec adresse professionnelle à 10

Maltravers Street, Londres WC2R 3NG, Royaume Uni, M. Robin Caven, gérant, né le 28 février 1961 à Liverpool, Roy-
aume Uni avec adresse professionnelle à 10 Maltravers Street, Londres WC2R 3NG, Royaume Uni et M. David Kirkby
gérant, né le 11 octobre 1963 à Sydney, Australie avec adresse professionnelle à 10 Maltravers Street, Londres WC2R
3NG, Royaume Uni ont été nommés en tant que nouveaux administrateurs avec effet au 19 avril 2007 pour une période
de six ans.

4. Il résulte des décisions prises le 19 avril 2007 que les personnes suivantes sont actuellement administrateurs de la

Société:

- M. Craig Matheson
- M. David Kirkby
- M. Robin Caven

Luxembourg, le 19 avril 2007.

Pour extrait conforme
S. Hinz
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007055231/275/29.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2007, réf. LSO-CD05357. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2007.

Autopolis Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 85.902.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007055232/1682/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2007, réf. LSO-CD05767. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070054033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2007.

56159

Revedaflo, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 51.340.

Le bilan au 31 décembre 2006, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007054987/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2007, réf. LSO-CD06463. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070055721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2007.

F.L. Lux Entreprise S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 99.986.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2007.

C. Doerner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007055216/209/12.
(070054575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2007.

Interportfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 43.902.

Le bilan au 2 février 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007054983/3085/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2007, réf. LSO-CD06764. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2007.

Boortmalt Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 58.672.

Le bilan au 30 juin 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

Référence de publication: 2007054973/636/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2007, réf. LSO-CD00592. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070055765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

56160


Document Outline

Armeos S.A.

Autopolis Services S.A.

Autopolis Services S.A.

Bomba Grill S.àr.l.

Boortmalt Finance S.A.

Breba - Cars S.à r.l.

Cartrade-Automobile S.A.

Club Torreense d'Esch asbl

Cody Internet Ventures S.A.

Corporate Sailing S.à.r.l.

Customer : View S.A.

Eagle 4 S.à r.l.

East Europe S.A.

ECG Participations S.A.

Elbblick (November) S.à r.l.

Eurocom Beratungs- und Treuhand GmbH

Evli Bank Plc, Luxembourg Branch

Finance Agricole S.A.

F.L. Lux Entreprise S.à r.l.

GEF Holding S.A.

Ginel S.A.

Global Garden Products C S.à r.l.

Interportfolio

Isaver S.A.

Kadan S.A.

KEV Germany 3 S.A.

KEV Germany 4 S.A.

Lend Lease Europe Real Estate Advisors S.A.

Litoprint S.A.

Luxair Re S.A.

Materis Management Aluminates

Moumont S.A.

Piani Developments S.A.

Plasticbase SA

Porto S.A.

Porto S.A.

Porto S.A.

Proteactive Europe S.A.

Radio Finance S.A.

Rainforest Holding S.A.

Revedaflo

'Roma Société Civile Immobilière'

Rosa S.A.

Rosa S.A.

Salon Fashion

Services Généraux de Gestion S.A.

Shildon S.A.

S.I. Umbolt S.A.

Société de Développement Agricole - ZEVA S.A.

Stars Investissement S.A.

Sunderland Immo S.à r.l.

Transports CITAL S.A.

T.S.M. Holding AG

Turf Capital S.A.

VMTO S.à r.l.

William Blair SICAV

Winfina S.A.