logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1077

6 juin 2007

SOMMAIRE

Aberdeen Property Investors Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51653

ACE S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51651

Attuale Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51695

Axelup S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51668

Barba Family Foundation Company Limi-

ted SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51690

Blumenthal Jardinage et Hydroculture

s.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51662

Blumenthal Jardinage et Hydroculture

s.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51662

BR.E.F.I.-Brasil European Finance Invest-

ment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51696

British and Continental Union Limited  . . .

51695

Buderus Giesserei Holding S.àr.l.  . . . . . . . .

51653

CEREP II Investment Ten S.à r.l.  . . . . . . . .

51685

CEREP II Investment Twelve S.à r.l.  . . . . .

51673

Ceres S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51690

C.S.O. Luxembourg s.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

51695

CVI Global Value Fund Luxembourg Secu-

ritisation II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51694

Cyanea S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51662

Ding Feng Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51665

Dofleini S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51664

Europe Trade S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51652

Expo-Performance SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51650

Financière de Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51691

Financière Forêt S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

51663

Finanzimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51696

Fincas Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51670

F.Int. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51667

F.Int. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51667

F.Int. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51668

F.Int. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51668

Fire Door Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

51670

GGP Investissement S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

51664

Global Sport Management S.A. . . . . . . . . . .

51669

Grainger European Healthcare Holdings

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51654

Gravograph Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .

51665

Grossglockner S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51664

Haydn S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51665

House Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51666

Immobilière Vanessa SCI  . . . . . . . . . . . . . . .

51691

Immo-Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51673

Jesmond Benelux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51652

Kapellen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51667

Les Gimbrettes S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51653

Les Thermes du Beauregard S.A. . . . . . . . .

51653

Lipizzaner S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51668

Macropus S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51666

Metatron Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51670

Mohawk International (Europe) S.à r.l.  . . .

51651

Mohawk International Holdings S.à r.l.  . . .

51651

NT Human Services Investments S.A.  . . .

51669

Oeko-Bureau, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51652

Orchestra Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

51696

Palca Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51693

Phoenix Recoveries (UK) Limited S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51694

PLD Germany VII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

51650

Pluton Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51666

ProLogis European Finance III S.àr.l. . . . . .

51650

PWR Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51678

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.  . .

51669

Rodemack Participations S.à r.l.  . . . . . . . . .

51685

Scala Advisory S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51663

Self-Service Kohn S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

51652

Sinabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51669

Tulip S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51678

VCM Golding Investments II S.A.  . . . . . . . .

51664

51649

ProLogis European Finance III S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 80.004.

Le bilan des résultats au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2007.

ProLogis DIRECTORSHIP Sàrl
<i>Gérant
Représenté par P. Cassells
<i>Gérant

Référence de publication: 2007050105/1127/16.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2007, réf. LSO-CD02933. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070049496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

PLD Germany VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 76.588.

Le bilan des résultats au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2007.

ProLogis DIRECTORSHIP Sàrl
<i>Gérant
Représenté par P. Cassells
<i>Gérant

Référence de publication: 2007050107/1127/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2007, réf. LSO-CD02426. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Expo-Performance SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 58, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 82.182.

<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social, en date du 28 mars 2007

<i>Première résolution

Monsieur Carlos Alberto Da Costa, né le 27 mars 1959 à Luanda/Portugal, demeurant à 2, rue de la Tour, L-3575

Dudelange, préqualifié comme administrateur est remplacé par Monsieur David Surreira Tavares, né le 22 août 1982 à
Coimbra/Portugal, demeurant à 58, rue de la Libération, L-3511 Dudelange, et ce avec effet au 28 mars 2007.

<i>Deuxième résolution

La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., avec siège social à 2, rue Hannelanst, L-9544 Wiltz, préqualifiée

comme commissaire aux comptes est remplacée par la société HMS FIDUCIAIRE s.à r.l., avec siège social à 270, route
d'Arlon, L-8010 Strassen, et ce avec effet au 28 mars 2007.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'Assemblée.

Fait à Dudelange, le 28 mars 2007.

J. Mousel / S. Siffert / N. Noyer
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2007050294/3220/22.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2007, réf. LSO-CD00599. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

51650

Mohawk International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 110.608.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007050213/631/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2007, réf. LSO-CD01557. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070049448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Mohawk International (Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 110.609.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007050214/631/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2007, réf. LSO-CD01560. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

ACE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 114.346.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique prises en date du 19 mars 2007

1. Les démissions de Monsieur Enzo Guastaferri et Monsieur Jeffrey Pulsford ont été acceptées avec effet au 15 janvier

2007 et 19 mars 2007 respectivement.

2. Monsieur Philippe van Der Beken, gérant, né le 1 

er

 octobre 1975 à Aalst en Belgique, avec adresse professionnelle

au 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg, a été nommé gérant «Class B» de la Société en remplacement de Monsieur Enzo
Guastaferri avec effet au 15 janvier 2007, pour une durée indéterminée et Monsieur Daniel Peeters, gérant, né le 16 avril
1968 à Schoten en Belgique, avec adresse professionnelle au Boechoutlaan 55, B-1853 Strombeek-Bever, Belgique a été
nommé gérant «Class A» en remplacement de Monsieur Jeffrey Pulsford avec effet au 19 mars 2007 pour une durée
indéterminée.

Le conseil de gérance est dorénavant composé comme suit:
a. Philippe Van der Beken (Class B)
b. Daniel Peeters (Class A)
3. Le transfert du siège social de la Société du 46a, boulevard John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 8, rue Heine,

L-1720 Luxembourg avec effet au 15 janvier 2007 a été approuvé.

Fait le 19 mars 2007.

<i>Pour ACE S. à r. l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007050473/6981/28.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2007, réf. LSO-CC07357. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

51651

Oeko-Bureau, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3714 Rumelange, 3, rue de la Bruyère.

R.C.S. Luxembourg B 24.988.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2007.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

Référence de publication: 2007050215/596/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02258. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070049540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Jesmond Benelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 36.850.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007050217/631/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, réf. LSO-CC06976. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Europe Trade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Luxembourg, 13, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 23.470.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2007.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

Référence de publication: 2007050218/596/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02265. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Self-Service Kohn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 4, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 29.457.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2007.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

Référence de publication: 2007050221/596/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02252. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

51652

Les Gimbrettes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 26.738.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007050252/587/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2007, réf. LSO-CD01469. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070049537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Les Thermes du Beauregard S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.

R.C.S. Luxembourg B 38.891.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2007.

<i>Pour LES THERMES DU BEAUREGARD S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007050254/503/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2007, réf. LSO-CD02127. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Buderus Giesserei Holding S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 44, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 111.078.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007050256/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2007, réf. LSO-CD01767. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Aberdeen Property Investors Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 106.133.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007050257/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2007, réf. LSO-CD01768. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

51653

Grainger European Healthcare Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 126.092.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth day of March.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

GRAINGER EUROPE (NO.2) LIMITED, a company limited by shares formed under the laws of the United Kingdom,

having its registered office at First Floor Citygate, ST James' Boulevard, Newcastle Upon Tyne, NEI 4JE, United Kingdom,
registered with the United Kingdom Trade Register under the number 5520409,

Here represented by Mr. Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address at 15, Côte d'Eich at L-1450 Lux-

embourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said power of attorney, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by

the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on
commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in its articles 7, 10, 11 and 14 the specific rules applying to one-member companies (sociétés
à responsabilité limitée unipersonnelles).

Art. 2. The purpose of the Company is the granting of loans or borrowing in any form with or without security and

raising of funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt instru-
ments or debt securities, convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise, to any company, subsidiary, or
fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the company, subsidiary or fellow
subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest.

The Company may hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, control,

manage, as well as develop these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or in any manner

participate in the establishment, development and control of any company or undertaking or render any assistance to
any company or enterprise (whether or not the Company has any participation in such company or undertaking).

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public and in particular

carry on any property and real estate related activity. In general, it may take any controlling and supervisory measures
and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of it purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name GRAINGER EUROPEAN HEALTHCARE HOLDINGS S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Münsbach (Municipality of Schuttrange), Grand Duchy

of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the board of managers.
The board of managers or the sole manager as the case may be, may decide to open offices and branches, both in

Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the

shareholders general meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits out of the total number

of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

51654

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a resolution

of shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company.

However, if the redemption price exceeds the par value of the shares to be redeemed, the redemption may only be

decided to the extent that sufficient distributable amounts are available with regard to the excess purchase price. Such
redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Art. 12. The Company shall not be wound up by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Art. 13. The Company is managed by one or more managers, appointed by a resolution of the general meeting of

shareholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder,
either in the constitutive instrument or in a subsequent instrument, for a limited or an undetermined period. The Com-
pany's manager(s) may but are not required to be shareholders, and may receive a remuneration or not.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of category

A and of manager(s) of category B.

The managers may be dismissed ad nutum by resolutions taken by the general meeting of shareholders taken by simple

majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve any acts and operations necessary or useful, consistent with the purpose of the Company
and provided the terms of the Articles as they may be amended from time to time shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

In case of a sole manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its

sole manager.

In case of plurality of managers, the Company will be validly committed towards third parties by the joint signature of

two managers, including the signature of one A and one B manager.

The manager or in case of plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate all or part of his/its powers

to one or several ad hoc agents.

The manager or in case of plurality of managers, the board of managers, will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least one day (1) in advance of the

time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.

Notice can be given to each manager verbally or in writing by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any

other suitable communication means.

Any such notice shall specify the time, place and agenda of the meeting.
The notice may be waived by the consent, in writing by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other

suitable communication means, of each manager.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers.

The meeting will be held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of A managers and a majority of B managers present in person, by proxy or by representative, constitute

a quorum.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing, in writing of by fax, cable, telegram, telex, electronic

means another manager as his proxy.

Any manager may participate in a meeting of the board of managers by phone, video conference, or any other suitable

telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers present

or duly represented.

A manager may represent one or several managers.
Except as otherwise required by these articles, decisions of the board of managers are adopted by a majority of the

managers present or duly represented, including a majority of A managers and a majority of B managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meetings.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same

content.

51655

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed jointly by one

A manager and one B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed jointly by one A manager
and one B manager.

Art. 14. Each manager undertakes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him in the name of the Company. As a representative of the Company, he is responsible for the execution of
his mandate.

Art. 15. The shareholders' resolutions shall be adopted at general meetings. The sole shareholder assumes all powers

conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken

insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

In such a case, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolutions, and the whole text of the

resolutions to be taken shall be sent to all shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, telefax or
e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolutions.

Shareholders' meetings may always be convened by the Company's manager(s), or by shareholders holding more than

half of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

be sent to each shareholder at least eight days (8) before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least twenty-one days (21) prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of

the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing by fax, cable, telegram, telex, electronic means

or by any other suitable telecommunication means another person who need not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as shareholders representing more than fifty

percent (50%) of the share capital of the Company are present or represented and as they are adopted by shareholders
representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,

at a majority in number of shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share Company's capital.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of the

Law.

As a consequence thereof, the sole shareholder takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.
Except  in  case  of  current  operations  concluded  under  normal  conditions,  contracts  concluded  between  the  sole

shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Art. 16. The Company's accounting year starts on the first of October and ends on the thirtieth of September of the

following year.

Art. 17. As of the end of each accounting year, the Company's balance sheet and the profit and loss account are

established and the manager or the board of managers prepares an inventory including an indication of all debts owed to
and by the Company, with an annex summarising all its commitments, and the debts of the managers, statutory auditors
and shareholders towards the Company.

The Company's manager(s) prepares the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depre-

ciation charges must be made.

Each shareholder either personally or through a proxyholder, may inspect the above inventory and the balance sheet,

at the Company's registered office.

The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted to the shareholders for approval who shall vote

specifically as to whether discharge is to be given to the manager(s).

Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation, expenses, charges and provision, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit
of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share
capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 19. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends

before the end of the current financial year, including during the first financial year, under the following conditions.

51656

The manager or the board of managers has to establish an interim balance sheet showing that sufficient funds are

available for distribution, such interim balance sheet being evidenced by the report of an independent auditor.

The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, if existing, increased

by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be
established according to the Law or the Articles.

Art. 20. The wind up and the liquidation of the Company shall be decided by an extraordinary shareholders meeting

before a Luxembourg notary.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder, as the case may be, shall appoint one or more liquidators

that will carry out the liquidation, shall specify the powers of such liquidator(s) and determine his/their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company, if any, shall be attributed

to the shareholders proportionally to the shares they hold.

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirtieth

of September 2007.

<i>Subscription - Payment

The five hundred (500) shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each have been subscribed by GRAINGER EUROPE

(NO.2) LIMITED, aforementioned, and have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred
Euros (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at 2,500.- Euro.

<i>Resolutions of the Sole Shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Appoint the followings managers:

<i>Category A manager:

Mr. Andrew Cunningham, Deputy Chief Executive and Finance Director, born on July 22nd, 1956 in Fife (United

Kingdom), residing at 4, Thorp Avenue, Morpeth, Northumberland NE61 1JT (United Kingdom).

<i>Category B managers:

- Mr. Marcel Stéphany, Auditor, born on September 4th, 1951 in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), residing

at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange (Grand Duchy of Luxembourg).

- Mr. Paul Worth, chartered accountant, born on December 13th, 1952 in Wokingham (United Kingdom), residing at

38, rue de Bourglinster, L-6112 Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).

The duration of the managers' mandate is unlimited.
2. Fix the address of the Company at 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung der Urkunde:

Im Jahre zweitausendsieben, am sechsundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Joseph Elvinger, mit Amtsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

GRAINGER EUROPE (NO.2) LIMITED, eine «limited company», gegründet und bestehend nach den Gesetzen des

Vereinigten Königreich von Grossbritannien, mit Gesellschaftssitz in First Floor Citygate, St. James' Boulevard, Newcastle
Upon Tyne, NEI 4JE, Vereinigtes Königreich von Grossbritannien, eingetragen im United Kingdom Trade Register unter
der Nummer 5520409,

Hier vertreten durch Herrn Régis Galiotto, Notariatsgehilfen, geschäftsansässig in 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.

51657

Vorgenannte Vollmacht bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar,

vorliegender Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Dieser Komparent, namens wie er handelt, ersuchte den instrumentierenden Notar nachstehenden Gesellschaftsver-

trag wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die den jeweiligen Gesetzesbestimmungen

unterliegt (hiernach die «Gesellschaft»), und im besonderen dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über Han-
delsgesellschaften (das «Gesetz»), sowie der gegenwärtigen Satzung (die «Satzung»), die in den Artikeln 7, 10, 11 und 14
Ausnahmeregeln über Einpersonengesellschaften beinhalten.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Gewähren von Darlehen, die Aufnahme von Darlehen aller Art mit oder ohne

Sicherheiten  sowie  die  Beschaffung  von  Geldmittel  durch,  aber  nicht  ausschliesslich,  die  Ausgabe  von  Obligationen,
Wechseln, Schuldscheinen, sowie anderen Schuldtitel oder Schuldensicherheiten, umwandelbar oder nicht umwandelbar.
Des weiteren kann die Gesellschaft Finanzderivate an Gesellschaften, Filialen jeglicher Art, oder an jede andere Gesell-
schaft, die der Gesellschaft verbunden ist sowie an Gesellschaften, Filialen an denen die Gesellschaft direkt oder indirekt
beteiligt ist, ausgeben.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen in jeglicher Form in anderen luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften

haben, sowie diese Beteiligungen kontrollieren, verwalten und fördern.

Sie kann Wertpapiere odere andere Rechte erwerben mittels Beteiligungen, Zeichnung oder Negoziierung; deswei-

teren  kann  sie  sich  beteiligen  an  der  Gründung,  Entwicklung  und  Kontrolle  jedweder  Gesellschaft  oder  jedwedes
Unternehmens. Sie kann Gesellschaften und Unternehmen (an denen sie beteiligt ist oder nicht) jede Art von Unterstüt-
zung gewähren.

Die Gesellschaft kann Geschäfte im Industriebereich tätigen, sie kann ein gewerbliches Unternehmen betreiben, das

der Öffentlichkeit zugänglich ist und sie kann insbesondere jede Aktivität im Immobilienbereich ausüben. Generell kann
sie alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Ge-
sellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 4. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung GRAINGER EUROPEAN HEALTHCARE HOLDINGS S.à r.l.

an.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Münsbach (Gemeinde Schuttrange), Großherzogtum Luxemburg.
Er kann durch einen Außerordentlichen Gesellschafterbeschluß, der die Regeln zur Satzungsänderung anwendet, an

jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann innerhalb der Gemeinde durch einen Beschluß des Geschäftsführerrates,

verlegt werden.

Der Geschäftsführerrat, beziehungsweise, der alleinige Geschäftsführer, kann beschließen, Geschäftsräume und Zweig-

niederlassungen, in Luxemburg und im Ausland, zu errichten.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euros (EUR 12.500,-), eingeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nominalwert von fünfundzwanzig Euros (EUR 25,-) pro Anteil.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters, oder im Falle von

mehreren Gesellschaftern durch eine Gesellschafterbeschluss, in Übereinstimmung mit Artikel 14 der vorliegenden Sat-
zung abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen

sowie am Gewinn.

Art. 9. Gegenüber der Gesellschaft, sind die Gesellschaftsanteile unteilbar, da nur ein Eigner pro Anteil zugelassen ist.

Gemeinschaftsbesitzer müssen eine Person, die sie vertritt, ernennen.

Art. 10. Im Falle eines einzigen Gesellschafters, sind die Anteile frei übertragbar.
Im Falle von mehreren Gesellschaftern müssen die von jedem Gesellschafter gehaltenen Anteile gemäß Artikel 189

und 190 des Gesetzes über Handelsgesellschaften übertragen werden.

Art. 11. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Anteile zurückzukaufen. Dieser Rückkauf wird durch einen Beschluß der

Gesellschafter gefasst, die wenigstens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Aktienkapitals der Gesellschaft vertreten.

Sollte der Rückkaufpreis der eigenen Anteile den Nominalwert dieser Anteile übersteigen, dann kann der Rückkauf

nur entschieden werden, wenn genügend verfügbare Mittel vorhanden sind bezüglich des erhöhten Kaufpreises. Die so
zurückgekauften Anteile werden durch eine Kapitalherabsetzung annulliert.

Art. 12. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit

des alleinigen Gesellschafters oder eines Gesellschafters.

51658

Art. 13. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet, der/die durch einen Beschluß

der Gesellschafterversammlung ernannt wird/werden. Der Beschluss wird durch einfache Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst. Im Falle eines alleinigen Gesellschafters, wird/werden der/die Geschäftsführer durch Beschluss des al-
leinigen Gesellschafters in der Gründungsakte oder in einer späteren Akte ernannt. Der/Die Geschäftsführer wird/werden
auf bestimmte oder unbestimmte Dauer ernannt.

Der/die Geschäftsführer kann/können, muss/müssen aber nicht, Gesellschafter der Gesellschaft sein. Er/sie kann/kön-

nen entlohnt werden.

Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat, der aus Geschäftsführern der

Kategorie A und Geschäftsführern der Kategorie B besteht.

Der/Die Geschäftsführer können ad nutum abberufen werden. Im Falle mehrerer Gesellschafter wird der Beschluss

durch eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Im Falle eines alleinigen Gesellschafters wird die Abbe-
rufung durch den alleinigen Gesellschafters beschlossen.

Gegenüber Drittpersonen haben der/die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesell-

schaft zu handeln und alle Handlungen und Operationen zu erledigen und gut zu heissen, die im Sinne und Zweck der
Gesellschaft und dieser Satzung sind.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung

vorbehalten sind, fallen unter die Befugnisse des Geschäftsführerrates.

Im Falle eines alleinigen Geschäftsführers wird die Gesellschaft gegenüber Drittpersonen durch die Einzelunterschrift

dieses alleinigen Geschäftsführers rechtlich verpflichtet. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft
gegenüber Drittpersonen durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer, davon obligatorisch eine Unter-
schrift eines Geschäftsführern der Kategorie A und eine Unterschrift eines Geschäftsführern der Kategorie B, rechtlich
verpflichtet.

Der alleinige Geschäftsführer oder im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, kann seine Be-

fugnisse für bestimmte Aufgaben an einen oder mehrere «ad hoc» Vertreter abtreten.

Der alleinige Geschäftsführer oder im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, wird die Zustän-

digkeiten,  die  Vergütung  (falls  erforderlich)  und  die  Dauer  des  Amtes  des  Vertreters,  sowie  alle  anderen  wichtigen
Konditionen seines Amtes festlegen.

Die Geschäftsführer müssen wenigstens einen (1) Tag vor Abhalten einer Versammlung von der Uhrzeit in Kenntnis

gesetzt werden, ausser im Falle einer dringlichen Angelegenheit, die dann jedoch in der Protokollniederschrift der Ver-
sammlung festgehalten wird.

Die Geschäftsführer können mündlich, oder schriftlich durch Fax, Telegraf, Telex, durch elektronische Mittel oder

jedes andere angepasste Kommunikationsmittel von der Versammlung in Kenntnis gesetzt werden.

Die Benachrichtigung soll Uhrzeit, Ort und Agenda der Versammlung beinhalten.
Die Geschäftsführer können mündlich, oder schriftlich durch Fax, Telegraf, Telex, durch elektronische Mittel oder

jedes andere angepasste Kommunikationsmittel auf die Benachrichtigung verzichten.

Für Versammlungen, deren Uhrzeit und Ort im Vorfeld durch einen Beschluss des Geschäftsführerrates beschlossen

wurden, wird von einer separaten Benachrichtigung abgesehen.

Wenn alle Geschäftsführer präsent oder vertreten sind, wird die Versammlung ohne vorherige Benachrichtigung ein-

berufen.

Eine Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Kategorie A Geschäftsführer und eine Mehrheit der anwesenden

oder vertretenen Kategorie B Geschäftsführer, stellt ein beschlussfähiges Quorum dar.

Jeder Geschäftsführer kann sich durch einen anderen Geschäftsführer bei der Versammlung vertreten lassen. Die

Vertretungsbefugnis wird schriftlich durch Fax, Telegraf, Telex, durch elektronische Mittel oder jedes andere angepasste
Kommunikationsmittel erteilt. Jeder Geschäftsführer kann mittels Telefon- oder Videokonferenz, oder mittels jedes an-
deren gleichartigen Kommunikationsmittel, die es den teilnehmenden Mitgliedern erlauben einander zu hören und zu
verstehen an Geschäftsführerratsitzungen teilnehmen.

Die Teilnahme an einer solchen Sitzung mittels dieser Kommunikationsmittel entspricht der persönlichen Teilnahme

an einer solchen Sitzung.

Falls nicht anders durch vorliegende Satzung vorgesehen, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates durch die

Mehrheit der anwesenden und vertretenen Geschäftsführer gefasst, mit einer obligatorischen Mehrheit in jeder Kategorie
von Geschäftsführern.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Mitgliedern des Geschäftsführerrates gefasst und unterschrieben wurden, haben

die selbe Gültigkeit wie die während einer Geschäftsführerratssitzung gefassten Beschlüsse.

Schriftlich gefasste Beschlüsse können durch ein einziges oder durch mehrere mit gleichem Inhalt schriftlich belegt

werden.

Sitzungen der Geschäftsführer werden in einer Protokollniederschrift festgehalten, die gemeinsam durch einen Ge-

schäftsführer der Kategorie A und einen Geschäftsführer der Kategorie B unterschrieben wird.

51659

Jede Abschrift und jeder Auszug dieser Protokollniederschrift wird gemeinsam durch einen Geschäftsführer der Ka-

tegorie A und einen Geschäftsführer der Kategorie B unterschrieben.

Art. 14. Jeder Geschäftsführer geht durch die Ausübung seines Mandats im Namen der Gesellschaft keine persönliche

Haftung ein. Als ein Beauftragter der Gesellschaft ist er verantwortlich für die Durchführung seines Mandats.

Art. 15. Beschlüsse der Gesellschafter werden bei Gesellschafterversammlungen getroffen.
Im Falle mehrerer Gesellschafter kann jeder Gesellschafter an den Abstimmungen unabhängig von der Anzahl seiner

Anteile teilnehmen.

Die Stimmrechte eines jeden Gesellschafter entsprechen der Anzahl seiner Anteile.
Kollektive Beschlüsse sind nur dann rechtskräftig, wenn sie von den Gesellschaftern, die wenigstens fünfzig Prozent

des Gesellschaftskapital halten, angenommen wurden.

In einem solchen Fall können die Beschlüsse der Gesellschafter getroffen werden indem der ganze Wortlaut aller

Beschlüsse per Rundschreiben an alle Gesellschafter geschickt wird. Das Rundschreiben kann in Original oder per Tele-
gramm, Telex, Fax oder via e-mail gesandt werden. Die Stimmabgabe erfolgt durch Unterschrift der per Rundschreiben
gefassten Beschlüsse.

Gesellschafterversammlungen können immer durch einen oder mehrere Geschäftsführer einberufen werden oder

durch Gesellschafter, die wenigsten die Hälfte des Gesellschaftskapital besitzen.

Schriftliche Einberufungen zu Gesellschafterversammlungen, die die Agenda festsetzen, werden gemäss den Vorschrif-

ten des Gesetzes gemacht und wenigstens acht (8) Tage vor Abhalten der Gesellschafterversammlung an die jeweiligen
Gesellschafter gesandt. Im Falle der jährlichen Generalversammlung der Gesellschafter werden die schriftlichen Einbe-
rufungen wenigstens einundzwanzig (21) Tage vor Abhalten der Gesellschafterversammlung an die jeweiligen Gesell-
schafter gesandt.

Jede schriftliche Einberufung vermerkt Uhrzeit und Ort der Generalversammlung.
Jeder  Gesellschafter  kann  sich  bei  jeder  Gesellschafterversammlung  durch  eine  Person  vertreten  lassen,  die  nicht

unbedingt Gesellschafter sein muss.

Vertretungsbefugnis wird schriftlich durch Fax, Telegraf, Telex, durch elektronische Mittel oder jedes andere ange-

passte Kommunikationsmittel erteilt.

Jeder Gesellschafter kann an Gesellschafterversammlungen teilnehmen.
Die während der Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse gelten als rechtskräftig, wenn mehr als fünfzig Pro-

zent (50%) der Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und wenn die durch Beschlüsse durch Gesellschafter, die
mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals besitzen, angenommen werden.

Beschlüsse, die die Satzung der Gesellschaft abändern, müssen jedoch durch eine zahlungsmässige Mehrheit der Ge-

sellschafter, die mehr als fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals besitzen, angenommen werden.

Ein alleiniger Gesellschafter übernimmt per Gesetz alle Befugnisse, die der Gesellschafterversammlung erteilt wurden.
Als  Folge  trifft  der  alleinige  Gesellschafter  alle  Entscheidungen,  die  die  Befugnisse  des  Geschäftsführerrates  über-

schreiten.

Abgesehen vom täglichen Geschäften, die unter normalen Bedingungen, getätigt werden, werden alle Verträge, die

zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft abgeschlossen werden, in einer Protokollniederschrift oder
schriftlich festgehalten.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober eines jeden Jahres und endet am 30. September des folgenden Jahres.

Art. 17. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, wird vom Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsfüh-

rern, vom Geschäftsführerrat die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar, einschließlich einer
Angabe aller an und von der Gesellschaft geschuldeten Schulden, mit einem Anhang, der eine Zusammenfassung aller
Gesellschaftsverpflichtungen, Verpflichtungen der Geschäftsführer, der statutorischen Kommissare und der Gesellschaf-
ter gegenüber der Gesellschaft auflistet.

Die Geschäftsführer erstellen die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, in denen die Abschreibungen mit in

Betracht gezogen wurden.

Jeder Gesellschafter kann entweder persönlich oder durch einen Vertreter oben erwähntes Inventar sowie die Bilanz

und die Gewinn- und Verlustrechnung werden am Gesellschaftssitz einsehen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wird den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Die Gesell-

schafter werden gesondert über die Entlastung der Geschäftsführer abstimmen.

Art. 18. Der Gesamtgewinn der Gesellschaft, so wie er aus dem jährlichen Gesellschafterbeschluss hervorgeht, stellt

nach Abzug der allgemeinen Ausgaben, Abschreibungen und Kosten den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage

zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Nettogewinn kann an den/die Gesellschafter im Verhältnis zu seinem/ihrem Anteilbesitz in der Gesellschaft verteilt

werden.

51660

Art. 19. Der Geschäftsführer, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Geschäftsführerrat, kann - unter folgenden

Bedingungen - die Auszahlung einer Vorschussdividende vor dem Ende des laufenden Geschäftsjahres, einschließlich wäh-
rend des ersten Geschäftsjahres, beschließen.

Der Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat erstellen eine Zwischenbilanz der Gesellschaft, aus der hervorgeht,

dass genügend finanzielle Mittel zur Auschüttung vorhanden sind. Diese Zwischenbilanz wird durch den Bericht eines
unabhängigen Wirtschaftsprüfer bestätigt.

Der auszuschüttende Betrag darf die seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres erzielten Gewinne die durch vorge-

tragenen Gewinne und freie Reserven erhöht und durch vorgetragene Verluste sowie Beträge die einer - durch das Gesetz
oder dieser Satzung vorgesehene - Reserve zugeschrieben werden, vermindert werden, nicht überschreiten.

Art. 20. Die Auflösung und die Liquidation der Gesellschaft wird von einer ausserordentliche Generalversammlung

vor einem Luxemburgischen Notar beschlossen.

Die Gesellschafterversammlung, beziehungsweise, der Gesellschafter, wird einen oder mehreren Liquidatoren, die

Liquidation ausführen werden ernennen und ihre Befugnisse und ihre Vergütung festlegen werden.

Wenn die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen ist, werden die Liquidationserträge den Gesellschaftern im Ver-

hältnis zu ihren Anteilen zugeführt.

Art. 21. Alles was nicht durch die gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterliegt der bestehenden Gesetzgebung.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. September 2007.

<i>Zeichnung - Einzahlung

Die fünfhundert (500) Anteile sind durch GRAINGER EUROPE (NO.2) LIMITED vorgenannt, gezeichnet und wurden

in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euros (EUR 12.500,-) der Gesellschaft zur Verfügung
steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde, was dieser ausdrücklich bestätigt.

<i>Kostenabschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer

Errichtung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise 2.500,- Euro.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Der Gesellschafter hat die folgende Beschlüsse gefasst:
1) Als Geschäftsführer werden ernannt:

<i>Kategorie A Geschäftsführer:

- Herr Andrew Cunningham, Deputy Chief Executive und Finance Director, geboren am 22. Juli 1956 in Fife (United

Kingdom), wohnhaft in 4, Thorp Avenue, Morpeth, Northumberland NE61 1JT (Vereinigte Königsreich).

<i>Kategorie B Geschäftsführer:

- Herr Marcel Stéphany, Wirtschaftsprüfer, geboren am 4. September 1951 in Luxemburg (Großherzogtum Luxem-

burg), wohnhaft in 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange (Großherzogtum Luxemburg).

- Herr Paul Worth, geprüfter Buchhalter, geboren am 13. Dezember, 1952 in Wokingham (Vereinigtes Königreich von

Grossbritannien), wohnhaft in 38, rue de Bourglinster, L-6112 Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).

Das Mandat der Geschäftsführer gilt auf unbestimmte Zeit.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 5, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

<i>Erklärung

Der Unterzeichnete Notar der die deutsche und englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass, auf Antrag des

Komparenten, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Antrag desselben Komparenten und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und deutschen Fassung,

ist der englische Text maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar

die gegenwärtige Urkunde.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2007, Relation: LAC/2007/3629. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sand.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

51661

Luxembourg, le 12 avril 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007051321/211/438.
(070050845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2007.

Blumenthal Jardinage et Hydroculture s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8369 Hivange, 31, rue de Garnich.

R.C.S. Luxembourg B 47.858.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2007.

<i>Pour BLUMENTHAL JARDINAGE ET HYDROCULTURE S.à.r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007050258/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2007, réf. LSO-CD02129. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070049435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Blumenthal Jardinage et Hydroculture s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8369 Hivange, 31, rue de Garnich.

R.C.S. Luxembourg B 47.858.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2007.

<i>Pour BLUMENTHAL JARDINAGE ET HYDROCULTURE S.à.r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007050259/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2007, réf. LSO-CD02133. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Cyanea S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 122.818.

Changement suivant le contrat de cession de parts sociales du 27 février 2007:
- Ancienne situation:

Parts sociales

LB UK RE HOLDINGS LIMITED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

- Nouvelle situation:

Parts sociales

LB UK RE HOLDINGS LIMITED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

M&amp;W IMMOBILIEN-UND UNTERNEHMENSBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH, enregistrée auprès du

«Lower Court of Potsdam» sous le numéro HRB 19859, Am Anger 9, D-14476 Gross Glienicke: . . . . . . . . . .

25

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2007.

51662

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour CYANEA S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007050299/29/24.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2007, réf. LSO-CD02194. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Financière Forêt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 111.888.

Le bilan pour la période du 28 septembre 2005 (date de constitution) au 31 décembre 2005 a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007050260/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2007, réf. LSO-CD01769. - Reçu 36 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Scala Advisory S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 51.697.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 4 avril 2007 à 15.00 heures au siège social.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de renouveler les mandats de Monsieur Marco Bus en tant que Président et de Messieurs Claude

Defendi et Francesco Molaro en tant qu'Administrateurs.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de ERNST &amp; YOUNG S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.

<i>Conseil d'Administration:

Marco Bus, Président, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Claude Defendi, Administrateur, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg

Francesco Molaro, Administrateur, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Lu-

xembourg.

<i>Commissaire aux comptes:

ERNST &amp; YOUNG S.A., 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Les mandats ci-dessus prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>SCALA ADVISORY S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque Domiciliataire
C. Unsen

Référence de publication: 2007050488/24/29.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2007, réf. LSO-CD02755. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

51663

GGP Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 102.894.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007050261/587/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01066. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070049493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

VCM Golding Investments II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 110.492.

Die Bilanz zum 31. März 2006 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. März 2006 abgelaufene Geschäfts-

jahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Luxemburg, den 4. April 2007.

<i>Für die VCM GOLDING INVESTMENTS S.A.
HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
<i>Die Zentralverwaltungsstelle
M. Dietrich / D. Wolf

Référence de publication: 2007050263/1346/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD03122. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Grossglockner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.722.

EXTRAIT

En date du 2 avril 2007, l'Associé unique a pris la résolution suivante:
- Le siège social de la société est transféré du «rue Léon Thyes, 12, L-2636 Luxembourg» à «avenue de la Gare, 65,

L-1611 Luxembourg» avec effet immédiat.

Luxembourg, le 2 avril 2007.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2007050264/724/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD03141. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Dofleini S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 122.821.

Changement suivant le contrat de cession de parts sociales du 27 février 2007:
- Ancienne situation:
LB UK RE HOLDINGS LIMITED: 250 parts sociales
- Nouvelle situation:
LB UK RE HOLDINGS LIMITED: 225 parts sociales;

51664

M&amp;W IMMOBILIEN- UND UNTERNEHMENSBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH, enregistrée auprès du «Lower

Court of Potsdam» sous le numéro HRB 19859, Am Anger 9, D-14476 Gross Glienicke: 25 parts sociales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2007.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour DOFLEINI S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007050321/29/22.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2007, réf. LSO-CD02176. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070049763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Gravograph Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 76.130.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007050266/5499/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD02976. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Haydn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.745.

EXTRAIT

En date du 2 avril 2007, l'Associé unique a pris la résolution suivante:
- Le siège social de la société est transféré du «rue Léon Thyes, 12, L-2636 Luxembourg» à «avenue de la Gare, 65,

L-1611 Luxembourg» avec effet immédiat.

Luxembourg, le 2 avril 2007.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2007050267/724/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD03173. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Ding Feng Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5710 Aspelt, 13, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 125.863.

<i>Extrait du procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2007

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2007, concernant la société DING FENG Sàrl avec siège

social à L-5710 Aspelt, 13, rue Pierre d'Aspelt, que:

1) Les associés révoquent Zhi Yong Zhan, restaurateur, demeurant à Aspelt de ses fonctions de gérant technique et

lui en donnent décharge.

2) Les associés révoquent Yinyan Zhang, serveuse, demeurant à Aspelt de ses fonctions de gérant administratif et lui

en donnent décharge.

3) Ils nomment Zhi Yong Zhan, susdit, gérant, responsable pour le restaurant et le commerce, pour une durée indé-

terminée.

51665

4) Ils nomment Yinyan Zhang, susdite, gérante, responsable pour le débit de boissons alcooliques et non alcooliques,

pour une durée indéterminée.

5) La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 12 avril 2007.

R. Arrensdorff
<i>Notaire

Référence de publication: 2007050352/218/25.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2007, réf. LSO-CC06446. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

House Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 114.191.

EXTRAIT

En date du 2 avril 2007, l'Associé unique a pris la résolution suivante
- Le siège social de la société est transféré du «rue Léon Thyes, 12, L-2636 Luxembourg» à «avenue de la Gare, 65,

L-1611 Luxembourg» avec effet immédiat.

Luxembourg, le 2 avril 2007.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2007050268/724/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD03174. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Pluton Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 105.292.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007050269/4191/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, réf. LSO-CA04969. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070049468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Macropus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 122.819.

Changement suivant le contrat de cession de parts sociales du 27 février 2007:
- Ancienne situation:

Parts

sociales

LB UK RE HOLDINGS LIMITED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

- Nouvelle situation:

Parts

sociales

LB UK RE HOLDINGS LIMITED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

M&amp;W IMMOBILIEN- UND UNTERNEHMENSBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH, enregistrée auprès du

«Lower Court of Potsdam» sous le numéro HRB 19859, Am Anger 9, D-14476 Gross Glienicke: . . . . . . . . . .

25

51666

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2007.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MACROPUS S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007050320/29/26.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2007, réf. LSO-CD02178. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

F.Int. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 85.244.

Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007050270/5878/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD03204. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Kapellen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.500.000,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 112.433.

EXTRAIT

En date du 2 avril 2007, l'Associé unique a pris la résolution suivante:
- Le siège social de la société est transféré du «rue Léon Thyes, 12, L-2636 Luxembourg» à «avenue de la Gare, 65,

L-1611 Luxembourg» avec effet immédiat

Luxembourg, le 2 avril 2007.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2007050271/724/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD03177. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

F.Int. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 85.244.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007050272/5878/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD03206. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

51667

Axelup S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 81.920.

Conformément à l'article 79 (§1) de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2005 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007050277/1383/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD02974. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070049487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Lipizzaner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.777.

EXTRAIT

En date du 2 avril 2007, l'Associé unique a pris la résolution suivante:
- Le siège social de la société est transféré du «rue Léon Thyes, 12, L-2636 Luxembourg» à «avenue de la Gare, 65,

L-1611 Luxembourg» avec effet immédiat.

Luxembourg, le 2 avril 2007.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2007050273/724/17.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD03182. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

F.Int. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 85.244.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007050274/5878/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD03212. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

F.Int. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 85.244.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007050275/5878/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD03215. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

51668

Global Sport Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 94.863.

Conformément à l'article 79 (§1) de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2005 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007050278/1383/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD02975. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070049490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.

R.C.S. Luxembourg B 47.192.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2007.

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES S.A.
G. Kohr / C. Wirtz-Peitz
<i>Company Secretary / Senior Manager

Référence de publication: 2007050280/1126/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD02980. - Reçu 84 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

NT Human Services Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 98.030.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2007.

<i>Pour NT HUMAN SERVICES INVESTMENTS S.A.
P. Toussaint
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007050281/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2007, réf. LSO-CD02915. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Sinabe, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 44.063.

Le bilan au 31 décembre 2006, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

51669

Signature.

Référence de publication: 2007050282/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2007, réf. LSO-CD02818. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Fire Door Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 71.950.

Les statuts coordonnés suivant n 

o

 46371 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007050467/211/10.
(070049338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Metatron Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 70.135.

Les membres du Conseil d'Administration de la société METATRON HOLDING S.A., à savoir:
- John B. Mills, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas
- SOLON (MANAGEMENT) LIMITED, Midocean Chambers, PO Box 805, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Et le Commissaire aux comptes à savoir:
- Dirk Oppelaar, 12, rue de l'Arquebuse, CH-1211 Genève
déclarent avoir démissionné de leur poste d'administrateur et commissaire aux comptes respectivement de la société

METATRON HOLDING S.A. avec effet immédiat en date du 21 mars 2007.

Luxembourg, le 21 mars 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007050291/631/20.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01287. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Fincas Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 125.973.

STATUTS

L'an deux mille sept, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société MANGIACANE S. à r.l., ayant son siège à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey,
ici représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler,
en vertu d'une procuration lui délivrée le 18 novembre 2006.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant restera annexée

pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle

va constituer:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de FINCAS GROUP S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège

51670

social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en cent (100) actions de trois cent vingt

euros (EUR 320,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société pour-

ront le cas échéant être nommées par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité

d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par l'Administrateur unique, ou en cas
de pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration.

51671

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de mai à 10.00 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2008.

<i>Souscription et libération

Les actions de la Société ont été souscrites comme suit:
La société MANGIACANE S. à r.l., prédésignée, cent actions (100).
Les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que

la somme de huit mille euros (EUR 8.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille six cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

qué, s'est réuni en assemblée générale. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions d'administrateur:
Monsieur Alexander Claessens, économiste, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Mon-

terey.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
MONTEREY AUDIT SARL, ayant son siège à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

51672

<i>Cinquième résolution

L'assemblée faisant usage de la prérogative lui reconnue par l'article 10 des statuts, nomme pour un terme prenant fin

à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2008, Monsieur Alexander Claessens, prénommé, pour engager la société
en toutes circonstances par sa seule signature pour les matières de gestion journalière.

<i>Sixième résolution

Le siège social est fixé au 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Mersch, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: S. Wolter-Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, vol. 157S, fol. 66, case 8. — Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 13 février 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007051356/242/142.
(070050597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2007.

Immo-Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 35.958.

Les membres du Conseil d'Administration de la société IMMO-CAPITAL S.A., à savoir:
- John B. Mills, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas
Et le Commissaire aux comptes à savoir:
- Dirk Oppelaar, 12, rue de l'Arquebuse, CH-1211 Genève
déclarent avoir démissionné de leur poste d'administrateur et commissaire aux comptes respectivement de la société

IMMO-CAPITAL S.A. avec effet immédiat en date du 21 mars 2007.

Luxembourg, le 21 mars 2007.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007050292/631/19.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01277. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

CEREP II Investment Twelve S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 126.022.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the fifteenth day of March.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

CEREP II S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office in 30, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, registered under R.C.S. Luxembourg n 

o

 B 107.559, incorporated by deed enacted on 13 April 2005 and whose

articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 888
dated 13 September 2005 (page 42588);

here represented by Regis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated

14 March 2007.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

51673

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the section XII of the law of August 10th, 1915 on commercial
companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of

real estate and/or of participations in any enterprises in any form whatsoever, and the administration, management, control
and development of those investments participations.

In particular, the Company may use its funds to invest in real estate and real estate holding companies, to establish,

manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its
portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to
acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to
realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights
and to grant to companies in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any
assistance including financial assistance, loans, advances or guarantee.

The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or

immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its
purposes.

Art. 3. The Company is established for an undetermined period.

Art. 4. The Company will have the name CEREP II INVESTMENT TWELVE S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a unitholders'

meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager(s).

Capital - Units

Art. 6. The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by two hundred fifty

(250) units of fifty euro (EUR 50.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder or by a decision of the unitholders'

meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each unit entitles to a part of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of units in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In the case of a single unitholder, the Company's units held by the single unitholder are freely transferable.
In case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single unitholder or of one of the unitholders.

Management

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be unitholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of unitholder(s) holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided that the terms
of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the meeting of unitholders fall within the com-

petence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

51674

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

The use of video-conferencing equipment and conference calls shall be allowed provided that each participating Man-

ager being able to hear and to be heard by all other participating Managers using this technology shall be deemed to be
present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Art. 13. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Unitholders decisions

Art. 14. The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders' meeting.
In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least

three-quarter of the Company's unit capital, subject to the provisions of the Law.

Financial year - Balance sheet

Art. 15. The Company's financial year starts on the first of July and ends on the thirtieth of June of each year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager(s) prepare(s) an

inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each unitholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's unit capital. The
balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to its/their unitholding in the Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 18. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

unitholders or not, appointed by the unitholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

A single unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally all of

its liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Subscription - Payment

All the two hundred fifty (250) units representing the capital have been entirely subscribed by CEREP II S.à r.l., pre-

named, and fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is as now
at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at approximately one thousand three hundred
euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the appearing party, representing the entirety of the unit capital

and exercising the powers devolved to the unitholders' meeting, passed the following resolutions:

(1) The first financial year shall begin on the incorporation date of the Company and shall terminate on the thirtieth

of June 2007.

(2) Is appointed as manager for an undetermined duration:
CEREP II S.à r.l., prenamed.
(3) In accordance with article 12 of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of its single manager.
(4) The Company shall have its registered office at L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

51675

The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quinze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CEREP II S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 107.559, constituée par acte du 13 avril 2005 et dont les statuts ont été
publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 888 en date du 13 septembre 2005 (page
42588);

ici représentée par Regis Galiotto, juriste, résidant à Luxembourg, en vertu de la procuration donnée sous seing privé

en date du 14 mars 2007.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier par la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle
que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient
en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société a pour objet d'effectuer toutes transactions impliquant, directement ou indirectement, l'acquisition

d'actifs immobiliers et/ou la prise de participations dans toutes entreprises généralement quelconques, ainsi que l'admi-
nistration, la gestion, le contrôle et le développement de ces investissements participations.

La Société peut, notamment, investir dans l'immobilier, en ce compris les sociétés d'investissements immobiliers, éta-

blir, gérer, développer et disposer de ses actifs, sans avoir égard à leurs compositions, ceux-ci s'entendent notamment
mais pas exclusivement, de son portefeuille-titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise généralement quelconque, acquérir, par voie d'investissement, souscription, garantie, exercice d'option, titres
et autres droits intellectuels, la réalisation de ceux-ci, le transfert, l'échange ou de toute autre manière, recevoir ou
accorder des licences relatives à des droits intellectuels et accorder aux sociétés, dans lesquelles la Société a une parti-
cipation directe ou indirecte, et aux sociétés affiliées, toute forme soutien, incluant l'aide financière, les prêts, les avances
ainsi que les garanties.

D'une façon générale, elle peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-

cières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination CEREP II INVESTMENT TWELVE S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du/des gérant(s).

Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'assemblée générale des associés ou par une

décision de l'associé unique, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

51676

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite d'un des associés ou de l'associé unique.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société se trouve engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle d'un quelconque membre du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des

premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

L'utilisation d'équipement de vidéo-conférence et de conférence téléphonique est autorisée, dans la mesure où chaque

gérant participant est capable d'entendre et d'être entendu par tous les autres participants utilisant cette technologie ; ils
sont alors considérés présents et sont autorisés à voter par vidéo ou par téléphone.

Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le(s) gérant(s) prépare(nt)

un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à

sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les deux cent cinquante (250) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par

CEREP II S.à r.l., prénommée, et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille cinq cents euros.

51677

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

(1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente juin 2007.
(2) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
CEREP II S.à r.l., prénommée.
(3) Conformément à l'article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son gérant unique.
(4) Le siège social de la Société est établi à L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2007. Relation: LAC/2007/2489. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007051371/211/251.
(070050717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2007.

PWR Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 76.648.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 mars 2007 que:
- Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, né le 20 avril 1963 à Caserta (Italie), demeurant professionnellement à

L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur
José-Marc Vincentelli, Administrateur et Président démissionnaire.

- Monsieur Marco Cameroni, employé privé, né le 20 septembre 1963 à Novara (Italie), demeurant professionnellement

à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a été appelé aux fonctions de Président du Conseil d'Administration.

Tous les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2007050307/58/20.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01338. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Tulip S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 125.995.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und sieben, am zweiundzwanzigsten März.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine Schaeffer, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1) Herr René Faltz, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare, hier vertreten

durch Herrn Lennart Stenke, Direktor, oder Herrn Nico Kruchten, Direktor, beide beruflich wohnhaft in L-1720 Lu-

51678

xemburg, 6, rue Heine, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Luxemburg am 5. März
2007.

2) Herr Lennart Stenke, vorbenannt, hier vertreten durch Herrn Nico Kruchten, vorbenannt, auf Grund einer Voll-

macht unter Privatschrift, gegeben am 5. März 2007.

Welche Vollmachten, nachdem sie ne varietur von den Komparenten und dem amtierenden Notar unterschrieben

wurde, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu

gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung TULIP S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen,

Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Un-

ternehmen,  der  Erwerb  durch  Ankauf,  Unterzeichnung  oder  auf  andere  Art  und  Weise,  sowie  die  Abtretung  durch
Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen
Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen. Außerdem
kann die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,

handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle Geschäfte betreffend unbewegliche Güter tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Benützung, Erneuerung oder Verwaltung
von Immobilien. Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in

Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur

Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiunddreißigtausend Euro (32.000,- EUR), eingeteilt in eintausend

(1.000) Aktien ohne Nennwert, die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Das  genehmigte  Aktienkapital  wird  auf  dreihundertzwanzigtausend  Euro  (320.000,-  EUR)  festgesetzt,  eingeteilt  in

zehntausend (10.000) Aktien ohne Nennwert.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch

Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung
vorgesehen ist.

Des  Weiteren  ist  der  Verwaltungsrat  ermächtigt,  während  der  Dauer  von  fünf  Jahren,  beginnend  am  Datum  der

Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals
zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit
oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im besonderen er-
mächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat
kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person be-
auftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise
Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft können in Namens-respektiv Inhaberform ausgegeben werden, oder können teil-

weise unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, je nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung
der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die

Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt bis eine
Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5. Jede ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre

der Gesellschaft. Sie hat alle Befugnisse um die Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, zu tätigen oder durchzuführen.

Art. 6.  Die  jährliche  Hauptversammlung  findet  statt  am  Geschäftssitz  oder  an  einem  anderen,  in  der  Einberufung

angegebenen Ort, am vierten Donnerstag des Monats Juni um 12.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2008.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen
feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies erfordern.

51679

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu

der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die

vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.

Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich, oder durch
Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen Ge-

neralversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalver-

sammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie

erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionär zu sein brauchen.

Die  Verwaltungsratsmitglieder  werden  von  den  Aktionären  während  der  jährlichen  Generalversammlung  für  eine

Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 8.  Der  Verwaltungsrat  muss  unter  seinen  Mitgliedern  einen  Vorsitzenden  und  «kann»  einen  Vizepräsidenten

wählen. Sollte im Verwaltungsrat Stimmengleichheit herrschen, hat der Verwaltungsratvorsitzende Entscheidungsrecht.

Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der

verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitglie-

dern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem

anderen Mitglied schriftlich, oder durch Telekopie Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-
glieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzu-

nehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich
des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsrats-
mitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson,
welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt
werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates

zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergü-
tungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrats-

mitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten
des Verwaltungsrats.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär

zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl und die Amtszeit, die sechs Jahre

nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, außer dem ersten

Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 2007 enden wird.

51680

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung wird aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3 festge-
setzten gezeichneten Aktienkapitals beträgt, oder gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, so wie in Artikel
3 vorgesehen ist.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns be-

schließen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung ausbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter

durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), der oder die durch die Generalversammlung die die
Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt wird oder werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915.

<i>Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

Aktionär

Gezeichnetes

Eingezahltes

Aktien

Kapital

Kapital

Zahl

EUR

EUR

1) Herr René Faltz, vorgenannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.968,-

31.968,-

999

2) Herr Lennart Stenke, vorgenannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32,-

32,-

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.000,-

32.000,-

1.000

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von zweiunddreißigtausend Euro (32.000,- EUR) zur Verfügung, was

dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder

sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf eintausendfünfhundert Euro (1.500,- EUR) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen Generalver-

sammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig

folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
- Herr René Faltz, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg, am 17. August 1953, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg,

41, avenue de la Gare, Vorsitzender.

- Herr Lennart Stenke, Direktor, geboren in Sundbyberg (Schweden), am 22. September 1951, beruflich wohnhaft in

L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine.

- Herr Nico Kruchten, Direktor, geboren in Luxemburg, am 28. August 1957, beruflich wohnhaft in L-1720 Luxemburg,

6, rue Heine.

3. Zum Kommissar wird ernannt:
SERVER GROUP EUROPE S.A., mit Sitz in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, eingetragen im Handelsregister von

Luxemburg unter der Nummer B 68.574.

4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine.
5. Die Mandate des Vorsitzenden, der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festge-

setzt und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre 2013.

6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäß Artikel 9 der Ge-

sellschaftsordnung zu delegieren.

Der Unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und auch schreibt, fügt hiermit an, dass die erschienen

Personen eine englische Fassung der Satzungen der Deutschen hierunter folgen lassen möchten.

Bei etwaigen Nichtübereinstimmungen der in die englische Sprache übersetzten Satzungen hat die deutsche Fassung

Vorrang.

51681

Worüber Urkunde, aufgenommen und beschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Es folgt die englische Übersetzung des Textes:

In the year two thousand and seven, on the twenty-second of March.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. Mr René Faltz, lawyer, residing professionally at L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, represented by Mr

Lennart Stenke, Direktor, or Mr Nico Kruchten, Director, both residing professionally in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine,
by virtue of a proxy given under private seal at Luxembourg on the March, 5th, 2007.

2. Mr Lennart Stenke, prenamed, here represented by Mr Nico Kruchten, prenamed, by virtue of a proxy given under

private seal at Luxembourg on the March, 5th, 2007.

The said proxies, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to

this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of a corporation which they form between themselves:

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of TULIP S.A.

The corporation is established for an undetermined period.
The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be estab-

lished either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of
any kind, as well as the management, control and development of such participations. Furthermore the Company may
act as business consultant.

The Company may carry out all business of mouvables or real estate, financial or industrial, commercial or civil kind,

which are directly or indirectly in relation with the Company's object. It may also conduct all real estate transactions,
such as buying, selling, using, development, renovation and management of real estate. The Company may invest in prop-
erty.

The Company may accomplish its object directly or indirectly, in its own name or for third persons, by itself or in

association with others, for all business matters which conduct to the fulfillment of the corporate object or the objects
of the companies which it interests it represents.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) consisting of one thousand (1,000)

shares without a nominal value, entirely paid in.

The authorized capital is fixed at three hundred twenty thousand Euro (320,000.- EUR) to consist of ten thousand

(10,000) shares without a nominal value.

The authorized and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article
6 hereof.

Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these

articles of incorporation, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital.
Such increased amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may
from time to time determine. The board of directors is specially authorized to proceed to such issues without reserving
to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the corporation, or to any other

duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

The corporation will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the

corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the corporation.

51682

Art. 5. Any regularly convened meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of share-

holders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations
of the corporation.

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corpo-

ration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the fourth Thursday of June
at 12 a.m. and for the first time in 2008.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circum-
stances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need not

be shareholders of the corporation.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which

may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until
their successors have been appointed. Their re-election is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 8. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose a vice-chairman. If

there is a tie of the votes among the members, the vote of the chairman will prevail.

It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the

meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated

in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telefax another director

as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at  a  meeting  of  the  board  of  directors.  Decisions  shall  be  taken  by  a  majority  of  votes  of  the  directors  present  or
represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

directors' meetings.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the corporation's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and

the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be share-
holders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine.

It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all

officers and employees and fix their emoluments.

Art. 10. The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons

to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not.

51683

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their number, remuner-

ation and term of office which may not exceed six years.

Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December

31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation
and shall terminate on December 31st, 2007.

Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such dissolution
and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Subscribers

Subscribed

Paid-in

Number

capital

capital

of shares

1) Herr René Faltz, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,968.-

31,968.-

999

2) Herr Lennart Stenke, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.-

32.-

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32,000.-

32,000.-

1,000

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-two thousand Euro

(32,000.- EUR) is as of now available to the corporation

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10th, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company

as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of the statutory auditors at one (1).
2. Are appointed as directors:
- Mr René Faltz, lawyer, born in Luxembourg, on August 17th 1953, with professional address in L-1611 Luxembourg,

41, avenue de la Gare, Chairman.

- Mr Lennart Stenke, director, born in Sundbyberg (Sweden) on September 22nd, 1951, with professional address in

L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

- Mr Nico Kruchten, director, born in Luxembourg, on August 28th, 1957, with professional address in L-1720 Lux-

embourg, 6, rue Heine.

3. Has been appointed statutory auditor:
SERVER GROUP EUROPE S.A., having its registered office at L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, and registered at the

District Court of Luxembourg under the number B 68.574.

4. The address of the Corporation is set at L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual

general meeting of shareholders enacting the accounts and the balance sheet of the year 2013.

6. The board of directors is allowed to delegate the daily management's powers in accordance to article 9 of the by-

laws.

51684

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in German followed by a English translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the German and the English text, the German version will be
prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Signé: N. Kruchten, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 26 mars 2007, REM/2007/635. — Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 4 avril 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007051357/5770/358.
(070050653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2007.

Rodemack Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 78.303.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 29 mars 2007 que, sur base du contrat de vente de parts

sociales signé en date du 28 mars 2007, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les parts sociales de la société
de EUR 50,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Designation de l'Associe Unique

Nombre de parts

sociales

HUNTSILLE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205

R. P. Pels.

Référence de publication: 2007050325/724/20.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007, réf. LSO-CD00135. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

CEREP II Investment Ten S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 126.036.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the fifteenth day of March.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

CEREP II S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office in 30, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, registered under R.C.S. Luxembourg n 

o

 B 107.559, incorporated by deed enacted on 13 April 2005 and whose

articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 888
dated 13 September 2005 (page 42588);

here represented by Regis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated

14 March 2007.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

51685

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the section XII of the law of August 10th, 1915 on commercial
companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of

real estate and/or of participations in any enterprises in any form whatsoever, and the administration, management, control
and development of those investments participations.

In particular, the Company may use its funds to invest in real estate and real estate holding companies, to establish,

manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its
portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to
acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to
realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights
and to grant to companies in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any
assistance including financial assistance, loans, advances or guarantee.

The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or

immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its
purposes.

Art. 3. The Company is established for an undetermined period.

Art. 4. The Company will have the name CEREP II INVESTMENT TEN S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a unitholders'

meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager(s).

Capital - Units

Art. 6. The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by two hundred fifty

(250) units of fifty euro (EUR 50.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder or by a decision of the unitholders'

meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each unit entitles to a part of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of units in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In the case of a single unitholder, the Company's units held by the single unitholder are freely transferable.
In case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single unitholder or of one of the unitholders.

Management

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be unitholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of unitholder(s) holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided that the terms
of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the meeting of unitholders fall within the com-

petence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

51686

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

The use of video-conferencing equipment and conference calls shall be allowed provided that each participating Man-

ager being able to hear and to be heard by all other participating Managers using this technology shall be deemed to be
present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Art. 13. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Unitholders decisions

Art. 14. The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders' meeting.
In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least

three-quarter of the Company's unit capital, subject to the provisions of the Law.

Financial year - Balance sheet

Art. 15. The Company's financial year starts on the first of July and ends on the thirtieth of June of each year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager(s) prepare(s) an

inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each unitholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's unit capital. The
balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to its/their unitholding in the Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 18. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

unitholders or not, appointed by the unitholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

A single unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally all of

its liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Subscription - Payment

All the two hundred fifty (250) units representing the capital have been entirely subscribed by CEREP II S.à r.l., pre-

named, and fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is as now
at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at approximately two thousand five hundred euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the appearing party, representing the entirety of the unit capital

and exercising the powers devolved to the unitholders' meeting, passed the following resolutions:

(1) The first financial year shall begin on the incorporation date of the Company and shall terminate on the thirtieth

of June 2007.

(2) Is appointed as manager for an undetermined duration:
CEREP II S.à r.l., prenamed.
(3) In accordance with article 12 of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of its single manager.
(4) The Company shall have its registered office at L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

51687

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quinze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CEREP II S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 107.559, constituée par acte du 13 avril 2005 et dont les statuts ont été
publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 888 en date du 13 septembre 2005 (page
42588);

ici représentée par Regis Galiotto, juriste, résidant à Luxembourg, en vertu de la procuration donnée sous seing privé

en date du 14 mars 2007.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier par la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle
que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient
en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société a pour objet d'effectuer toutes transactions impliquant, directement ou indirectement, l'acquisition

d'actifs immobiliers et/ou la prise de participations dans toutes entreprises généralement quelconques, ainsi que l'admi-
nistration, la gestion, le contrôle et le développement de ces investissements participations.

La Société peut, notamment, investir dans l'immobilier, en ce compris les sociétés d'investissements immobiliers, éta-

blir, gérer, développer et disposer de ses actifs, sans avoir égard à leurs compositions, ceux-ci s'entendent notamment
mais pas exclusivement, de son portefeuille-titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise généralement quelconque, acquérir, par voie d'investissement, souscription, garantie, exercice d'option, titres
et autres droits intellectuels, la réalisation de ceux-ci, le transfert, l'échange ou de toute autre manière, recevoir ou
accorder des licences relatives à des droits intellectuels et accorder aux sociétés, dans lesquelles la Société a une parti-
cipation directe ou indirecte, et aux sociétés affiliées, toute forme soutien, incluant l'aide financière, les prêts, les avances
ainsi que les garanties.

D'une façon générale, elle peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-

cières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination CEREP II INVESTMENT TEN S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du/des gérant(s).

Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'assemblée générale des associés ou par une

décision de l'associé unique, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite d'un des associés ou de l'associé unique.

51688

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société se trouve engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle d'un quelconque membre du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des

premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

L'utilisation d'équipement de vidéo-conférence et de conférence téléphonique est autorisée, dans la mesure où chaque

gérant participant est capable d'entendre et d'être entendu par tous les autres participants utilisant cette technologie; ils
sont alors considérés présents et sont autorisés à voter par vidéo ou par téléphone.

Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le(s) gérant(s) prépare(nt)

un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à

sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les deux cent cinquante (250) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par

CEREP II S.à r.l., prénommée, et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille cinq cents euros.

51689

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

(1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente juin 2007.
(2) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
CEREP II S.à r.l., prénommée.
(3) Conformément à l'article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son gérant unique.
(4) Le siège social de la Société est établi à L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2007. Relation: LAC/2007/2500. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007051376/211/250.
(070050735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2007.

Barba Family Foundation Company Limited SA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 46.029.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue en date du 28 février 2007 à 8.00 heures

Après avoir délibéré, l'Assemblée les résolutions suivantes à l'unanimité:
- de procéder au remplacement de Monsieur Frédéric Deflorenne dans son mandat de commissaire comptes par la

société DATA GRAPHIC S.A., ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, R.C. Luxem-
bourg nr B 42.166. Le mandat du commissaire aux comptes nouvellement nommé prendra fin en date du 27 février 2013.

- de reconduire Madame Helen F. Green, Monsieur Kelvin M. Hudson et Monsieur Jean-Pierre Higuet dans leur mandat

respectif d'administrateur de la société, jusqu'au 27 février 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007050342/4286/21.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2007, réf. LSO-CC04604. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Ceres S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 76.083.

EXTRAIT

Aus einem privatrechtlichen Abtretungsabkommen über Gesellschaftsanteile vom 21. Dezember 2006 geht hervor,

dass Herr Jean-Paul Frisch, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in L-4974 Dippach, 12 rue des Romains,

von insgesamt 67 Anteilen welche er in der Gesellschaft CERES S.à r.l. besitzt,
67 Anteile an Herrn Michael Neylon, Informatiker, wohnhaft in L-6834 Biwer, 8 an der Hiel, abtritt.

51690

Folglich, setzt sich das Gesellschaftskapital ab dem 21. Dezember 2006 wie folgt zusammen:

Anteile

Herr Michael Neylon, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Münsbach, den 21. Dezember 2006.

Für gleichlautende Ausfertigung
M. Neylon

Référence de publication: 2007050344/820/21.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2007, réf. LSO-CA04622. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(070049733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Financière de Diekirch, Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 18.904.

Le bilan au 31 décembre 2005 et annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007050359/317/12.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2007, réf. LSO-CD02328. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Immobilière Vanessa SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5685 Dalheim, 25, Om Widdem.

R.C.S. Luxembourg E 3.348.

STATUTS

L'an deux mille sept, le deux avril.
Entre les soussignés:
1.- Monsieur Joseph Aloyse Mangerich, conseil en informatique financière, né à Luxembourg, le 18 juillet 1956, époux

de Madame Marie-Thérèse Reisdorffer, demeurant à L-5685 Dalheim, 25, Om Widdem, et

2.- La société anonyme BIMACO LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-5685 Dalheim, 25, Om Widdem, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 34.428,

ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Joseph Aloyse Mangerich, préqualifié,
est constituée une société civile immobilière avec les statuts suivants:

Titre I 

er

 - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination de IMMOBILIERE

VANESSA SCI.

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur et la gestion de tous immeubles au Grand-Duché de

Luxembourg ou à l'étranger, de droits immobiliers dans des immeubles ou parties d'immeubles, ainsi que toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter la réalisation, à l'exclusion de
toute activité commerciale.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Dalheim.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l'assemblée générale.

Titre II - Capital social, Parts d'intérêts

Art. 5. Le capital social est fixé à mille euros (1.000,- EUR), représenté par cent (100) parts d'intérêts de dix euros

(10,- EUR) chacune.

51691

En raison de leurs apports, il est attribué:

à 1.- Monsieur Joseph Aloyse Mangerich, conseil en informatique financière, demeurant à L-5685 Dalheim, 25,

om Widdem, une part d'intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

à 2.- La société anonyme BIMACO LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-5685 Dalheim, 25, Om Widdem,

quatre-vingt-dix-neuf parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Total: cent parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L'intégralité de l'apport devra être libérée

sur demande du gérant ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l'appel des fonds ou apports.

Art. 6. Les parts d'intérêts sont librement cessibles entre associés.
Les parts d'intérêts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée

générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts d'intérêts ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des

propriétaires de parts d'intérêts représentant les trois quarts des droits appartenant aux associés restants.

Art. 7. Les cessions de parts d'intérêts doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans

un acte notarié conformément à l'article 1690 du code civil.

Art. 8. Chaque part d'intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre de parts

d'intérêts existantes, dans le bénéfice de la société et dans tout l'actif social.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements de

la société, chacun dans la proportion du nombre de parts d'intérêts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l'article 1863 du code civil.

Art. 10. Chaque part d'intérêt est indivisible à l'égard de la société.
Les copropriétaires indivis d'une ou de plusieurs parts d'intérêts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire

représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
Jusqu'à cette désignation, la société peut suspendre l'exercice des droits afférents aux parts d'intérêts appartenant par
indivis à différents copropriétaires.

Art. 11.  Les  droits  et  obligations  attachés  à  chaque  part  d'intérêts  la  suivent  dans  quelque  main  qu'elle  passe.  La

propriété d'une part d'intérêts emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l'assemblée générale
des associés.

Les héritiers et légataires de parts d'intérêts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant

la durée de la société et jusqu'à la clôture de sa liquidation, requérir l'apposition de scellés sur les biens, documents et
valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni d'immiscer en aucune manière
dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et
aux décisions des assemblées générales.

Art. 12. La société ne sera pas dissoute par le décès, liquidation ou faillite d'un ou de plusieurs des associés, mais

continuera entre le ou les survivants et les héritiers et représentants de l'associé ou des associés décédés.

De même, l'interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d'un ou de plusieurs des associés ne mettront

point  fin  à  la  société;  celle-ci  continuera  entre  les  autres  associés,  à  l'exclusion  de  l'associé  ou  des  associés  en  état
d'interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu'au paiement de la
valeur de leurs parts d'intérêts par les autres associés ou par un tiers acheteur présenté par le gérant.

Titre III - Administration de la société

Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou

autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un gérant.
Le ou les gérants peuvent conférer des mandats spéciaux aux associés et/ou à de tierces personnes.

Art. 14. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Titre IV - Exercice social

Art. 15. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Titre V - Réunion des associés

Art. 16. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l'endroit qui seront indiqués dans l'avis de

convocation.

51692

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenable, mais ils

doivent être convoqués dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés, représentant un
cinquième au moins de toutes les parts d'intérêts existantes. Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires
ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins cinq jours francs à l'avance et qui doivent
indiquer sommairement l'objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou

représentés.

Art. 17. Dans toute réunion d'associés, chaque part d'intérêts donne droit à une voix. En cas de division de la propriété

des parts d'intérêts entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l'usufruitier.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions

contraires des statuts.

Art. 18. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature et l'importance.

Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du
capital social

Titre VI - Dissolution, Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants

ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société, civile ou com-

merciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société
ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts d'intérêts possédées par chacun d'eux.

Titre VII - Dispositions générales

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-

dinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Monsieur Joseph Aloyse Mangerich, conseil en informatique financière, né à Luxembourg, le 18 juillet 1956, de-

meurant à L-5685 Dalheim, 25, om Widdem, est nommé aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée.

2.- Le siège social est établi à L-5685 Dalheim, 25, om Widdem.

Fait en autant d'exemplaires que de parties à Dalheim, date qu'en tête des présentes.

BIMACO LUXEMBOURG S.A. / J. Mangerich
J. Mangerich / -
<i>Administrateur Délégué / -

Référence de publication: 2007050995/231/124.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD03263. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070050328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2007.

Palca Investments, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 44.058.

Le bilan au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

51693

Signature.

Référence de publication: 2007050283/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2007, réf. LSO-CD02813. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Phoenix Recoveries (UK) Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation,

(anc. CVI Global Value Fund Luxembourg Securitisation II S.à r.l.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.426.

In the year two thousand and seven, on the seventh of March.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal,
here represented by Lucinda Clifton-Bryant, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole current partner of CVI GLOBAL VALUE FUND LUXEMBOURG SECURITISATION II S.à r.l., a

société à responsabilité limitée limitée de tritisation, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard
Royal, incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, on December 27, 2006, not yet
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

- That the sole partner has taken the following resolution:

<i>Sole resolution

The sole partner decides to amend the company's name into PHOENIX RECOVERIES (UK) LIMITED S.à r.l. and

decides the subsequent amendment of article 4 of the articles of association, which will henceforth have the following
wording:

« Art. 4. The Company will have the name PHOENIX RECOVERIES (UK) LIMITED S.à r.l.»
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Follows the French version:

L'an deux mille sept, le sept mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

CVI GVF (LUX) MASTER S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal,
Ici représentée par Lucinda Clifton-Bryant, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire ins-

trumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est le seul associé actuel de la société CVI GLOBAL VALUE FUND LUXEMBOURG SECURITISATION II

S.à r.l., société à responsabilité limitée de tritisation, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal,
constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 27 décembre 2006,
non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

51694

- Qu'elle a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale en PHOENIX RECOVERIES (UK) LIMITED S.à r.l. et de

modifier en conséquence l'article 4 des statuts comme suit:

« Art. 4. La société aura la dénomination PHOENIX RECOVERIES (UK) LIMITED S.à r.l.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Clifton-Bryant, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007. Relation: LAC/2007/1907. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007050977/242/64.
(070050252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2007.

C.S.O. Luxembourg s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 41.021.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2007.

<i>Pour C.S.O. LUXEMBOURG s.à.r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007050396/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2007, réf. LSO-CD02124. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

British and Continental Union Limited, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 2.642.

Le bilan au 20 novembre 2006, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007050284/833/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2007, réf. LSO-CD02823. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Attuale Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 32.385.

Le bilan au 31 décembre 2005 et les documents y annexés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

51695

Luxembourg, le 13 avril 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007050358/317/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, réf. LSO-CC06997. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Orchestra Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.P. Beicht.

R.C.S. Luxembourg B 85.447.

Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 10 avril 2007:
- L'Assemblée a accepté la démission de l'Administrateur Monsieur Stefano Giuffra
- L'Assemblée a décidé de pourvoir au remplacement de l'Administrateur démissionnaire en appelant la société DEL-

PHEA S.à r.l., ayant son siège social 22, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg, aux fonctions d'Administrateur jusqu'à
l'Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007050288/1921/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD03180. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Finanzimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 96.671.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007050356/6839/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2007, réf. LSO-CD03115. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

BR.E.F.I.-Brasil European Finance Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 114.998.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu, le 22 mars 2007 à 18.00 heures au siège social

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Sarah Bravetti de sa fonction d'administrateur, décide

d'accepter cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 22 mars 2007, Monsieur Armand De Biase, né

le 15 juin 1975 à Metz en France, résidant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg,
son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>BR.E.F.I.-BRASIL EUROPEAN FINANCE INVESTMENT S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007050286/24/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2007, réf. LSO-CD02763. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070049587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

51696


Document Outline

Aberdeen Property Investors Luxembourg S.A.

ACE S.à r.l.

Attuale Holding S.A.

Axelup S.A.

Barba Family Foundation Company Limited SA

Blumenthal Jardinage et Hydroculture s.à.r.l.

Blumenthal Jardinage et Hydroculture s.à.r.l.

BR.E.F.I.-Brasil European Finance Investment S.A.

British and Continental Union Limited

Buderus Giesserei Holding S.àr.l.

CEREP II Investment Ten S.à r.l.

CEREP II Investment Twelve S.à r.l.

Ceres S.à r.l.

C.S.O. Luxembourg s.à.r.l.

CVI Global Value Fund Luxembourg Securitisation II S.à r.l.

Cyanea S.à r.l.

Ding Feng Sàrl

Dofleini S.à r.l.

Europe Trade S.A.

Expo-Performance SA

Financière de Diekirch

Financière Forêt S.à r.l.

Finanzimmo S.A.

Fincas Group S.A.

F.Int. S.A.

F.Int. S.A.

F.Int. S.A.

F.Int. S.A.

Fire Door Investment S.à r.l.

GGP Investissement S.à r.l.

Global Sport Management S.A.

Grainger European Healthcare Holdings S.à r.l.

Gravograph Luxembourg S.à r.l.

Grossglockner S.à r.l.

Haydn S.à r.l.

House Lux S.à r.l.

Immobilière Vanessa SCI

Immo-Capital S.A.

Jesmond Benelux S.A.

Kapellen S.à r.l.

Les Gimbrettes S.A.

Les Thermes du Beauregard S.A.

Lipizzaner S.à r.l.

Macropus S.à r.l.

Metatron Holding S.A.

Mohawk International (Europe) S.à r.l.

Mohawk International Holdings S.à r.l.

NT Human Services Investments S.A.

Oeko-Bureau, S.à r.l.

Orchestra Holding S.A.

Palca Investments

Phoenix Recoveries (UK) Limited S.à r.l.

PLD Germany VII S.à r.l.

Pluton Capital S.à r.l.

ProLogis European Finance III S.àr.l.

PWR Investment S.A.

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

Rodemack Participations S.à r.l.

Scala Advisory S.A.

Self-Service Kohn S.à r.l.

Sinabe

Tulip S.A.

VCM Golding Investments II S.A.