This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 993
29 mai 2007
SOMMAIRE
Aeromeccanica S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47644
Charterhouse CP1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
47649
D.B. Zwirn Rinol Holdings Offshore S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47618
European Retail Investment Holding S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47656
Formedia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47662
Galatea Lux Two S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
47657
Gax Technologies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47657
Gesellchen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47661
Gesellchen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47660
Grund und Boden G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . .
47663
Grund und Boden G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . .
47662
Helicopters Services Europe . . . . . . . . . . . .
47660
Helicopters Services Europe . . . . . . . . . . . .
47660
ING Lion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47647
Logon Solution Integrator Luxembourg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47660
Logosworld Technology Research
G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47651
Mettle Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
47657
Norsk Vekst Secondary S.à r.l. . . . . . . . . . .
47658
Polskilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47659
Polskilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47659
RCR Industrial Flooring S.à r.l. . . . . . . . . . .
47618
Realilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47647
SPL WorldGroup B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47663
Taris Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47646
Telespazio Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
47644
Visualsound S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47657
Wintergames S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47661
WPP Luxembourg Gamma Four S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47642
WPP Luxembourg Gamma Three S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47654
WPP Luxembourg Holdings Three S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47652
47617
RCR Industrial Flooring S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. D.B. Zwirn Rinol Holdings Offshore S.à r.l.).
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 102.358.
In the year two thousand and seven, on the twelfth day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of D.B. ZWIRN RINOL HOLDINGS OFFSHORE S.à r.l.,
a société à responsabilité limitée de titrisation, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 102358, incorporated pursuant to
a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 21 July 2004, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations of 22 October 2004, number 1062 (the «Company»). The articles of incorporation of the
Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxem-
bourg, on 5 January 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting was opened at 11 a.m. with Mr. Gildas Le Pannérer, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Ms. Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms. Andrea Hoffmann, private employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Increase of the Company's share capital from its current amount of one million eight hundred seventy-five thousand
euro (EUR 1,875,000.-) up to an amount of two million five hundred thousand euro (EUR 2,500,000.-) through the issuance
of twenty-five thousand (25,000) shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
2) Change of the name of the Company into RCR INDUSTRIAL FLOORING S.à r.l.
3) Full restatement of the articles of incorporation of Company.
4) Approval of certain executives as new shareholders of the Company.
5) Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented by proxy, the proxyholders of the represented shareholders and the
number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders
of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at
the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
III. That the whole of the corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and were fully aware of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. That the present meeting, representing the whole of the corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, unanimously passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of one million
eight hundred seventy-five thousand euro (EUR 1,875,000.-) up to an amount of two million five hundred thousand euro
(EUR 2,500,000.-) through the issuance of twenty-five thousand (25,000) shares having a par value of twenty-five euro
(EUR 25.-) each.
The twenty-five thousand (25,000) newly issued shares have been subscribed by OCINSA, OBRAS Y CONSTRUC-
CIONES, S.A., a company duly incorporated and existing under the laws of Spain, with registered address at Plaza Antonio
Beltran Martinez, n
o
1, Edificio Trovador, planta 9, oficinas F-G., 50.002 - Zaragoza, Spain, registered with the Registro
Mercantil de Zaragoza, Tomo 1.269, Folio 1, Hoja Z-6.544 («OCINSA»), here represented by Ms Andrea Hoffmann,
prenamed, by virtue of a proxy hereto attached, for a subscription price of five million five hundred thousand euro (EUR
5,500,000.-), to be allocated as follows:
- six hundred twenty-five thousand euro (EUR 625,000.-) shall be allocated to the Company's share capital;
- four million eight hundred seventy-five thousand euro (EUR 4,875,000.-) shall be allocated to the Company's share
premium.
The shares so subscribed have been fully paid up in cash, so that the amount of five million five hundred thousand euro
(EUR 5,500,000.-) is as of now at the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.
47618
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to change the name of the Company into RCR INDUSTRIAL FLOORING S.à r.l.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to fully restate the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:
« Art. 1. Name - Applicable Laws.
1.1 There is hereby established among the subscribers and all those who may become Shareholders in future a société
à responsabilité limitée under the name of RCR INDUSTRIAL FLOORING S.à r.l. (hereinafter the «Company»).
1.2 The Company shall have the status of a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the
law of 22 March 2004 on securitisation (the «Securitisation Law») and shall be governed by the Securitisation Law and
the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the «Companies Law»), as well as by the present
articles of incorporation.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is to enter into one or more securitisation transactions within the meaning of the
Securitisation Law and the Company may, in this context, assume risks, existing or future, relating to the holding of assets,
whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the obligations assumed by third
parties or relating to all or part of the activities of third parties, in one or more transactions or on a continuous basis.
The Company may assume those risks by acquiring the assets, guaranteeing the obligations or by committing itself in any
other way. It may also transfer, to the extent permitted by law and these articles of incorporation, dispose of the claims
and other assets it holds, whether existing or future, in one or more transactions or on a continuous basis.
2.2 The Company may, in this same context, acquire, dispose and invest in loans, stocks, bonds, debentures, obligations,
notes, advances, shares, warrants and other securities. The Company may grant pledges, other guarantees or security of
any kind to Luxembourg or foreign entities and enter into securities lending activity on an ancillary basis.
2.3 The Company may perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general,
all transactions which are necessary or useful to fulfil and develop its purpose, as well as, all operations connected directly
or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.
Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
4.2 The registered office may be transferred within the same municipality by a resolution of the board of Managers as
the case may be. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the
board of Managers.
4.3 In the event that the board of Managers determines that extraordinary political or military events have occurred
or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
Art. 5. Share Capital. The Company's share capital is set at two million five hundred thousand euro (EUR 2,500,000.-)
represented by one hundred thousand (100,000) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Art. 6. Shares.
6.1 The shares thus issued may be expressed as being exclusively related to one or more specific compartments of
the Company.
6.2 Each share is entitled to one vote at Shareholders' Meeting.
6.3 The share capital may be increased or reduced at any time by approval of a majority of Shareholders representing
three quarters of the share capital at least.
6.4 The Company will recognize only one holder per share.
Art. 7. Transfer Restrictions.
7.1 Transfers to Permitted Transferees
(a) No Shareholder shall transfer any of its Shares other than as permitted in this Art. 7.1. Any purported transfer of
Shares in violation of this Article shall be void and ineffectual and the Company shall not record or permit to be recorded
such Transfer on its Shareholders' register.
(b) Any Shareholder may Transfer all or any part of its Shares to a Permitted Transferee without having to comply
with the provisions of Art. 7.2, 7.3 and 7.4.
Upon occurrence of the foregoing Transfer, such Permitted Transferee shall, as to the Shares so acquired, be substi-
tuted fully for and shall enjoy the same rights and be subject to the same obligations as the Shareholder from whom it
acquired such Shares.
47619
(c) The provisions of Art. 7.2, 7.3 and 7.4 shall not apply to the Transfer of any Snares held by DBZ TO HEMLOCK
(LUX) S.a.r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, and any Transfer of Shares pursuant
to the Option Agreement.
7.2 Right of First Refusal
(a) If any Shareholder wishes to transfer (any such Shareholder, a «Selling Shareholder»), directly or indirectly, any of
its Shares in the Company, to any person or persons (other than a Permitted Transferee) (the «Proposed Purchaser»),
then such Selling Shareholder shall first deliver to the other Shareholders (the «Offeree Shareholders»), a written notice
(a «ROFR Notice») which shall specify (i) the number of Shares proposed to be transferred (the «ROFR Shares»), (ii)
the name of the Proposed Purchaser and the terms on which such ROFR Shares shall be sold to such Proposed Purchaser,
and (iii)the aggregate purchase price (which shall be payable in cash in Euros or marketable securities) which the Proposed
Purchaser has agreed to pay for the ROFR Shares (the «ROFR Purchase Price»). The ROFR Notice shall constitute an
irrevocable offer by the Selling Shareholder (an «ROFR Offer»), for a period of thirty (30) days after delivery thereof to
the Offeree Shareholders (the «ROFR Election Period»), to sell all, but not less than all, of the ROFR Shares to the Offeree
Shareholders at the ROFR Purchase Price.
(b) During the ROFR Election Period, each Offeree Shareholder may elect to purchase up to their pro rata share
(based on the total number of Shares held by such Offeree Shareholder as a percentage of Shares held by all Offeree
Shareholders) of the ROFR Shares at the ROFR Purchase Price by delivering written notice to such effect (a «ROFR
Acceptance Notice»), prior to the expiration of the ROFR Election Period, to the Selling Shareholder. Failure by an
Offeree Shareholder to so notify the Selling Shareholder of its election to accept the ROFR Offer during the applicable
time period shall be deemed a waiver of its purchase rights in connection with such ROFR Offer, but shall not impair or
prejudice any rights of such Offeree Shareholders under this Art. 7.2 in the event that the provisions hereof again become
applicable to a transfer by the Selling Shareholder of any of the Shares referred to in the ROFR Notice.
(c) In the event that not all of the Offeree Shareholders elect to purchase their pro rata share of the ROFR Shares,
the Offeree Shareholders electing to purchase their pro rata share (based on the number of Shares owned by each such
Offeree Shareholder as a percentage of the Shares held by all Offeree Shareholders) of the ROFR Shares shall have the
right to purchase their pro rata share (based on the number of Shares owned by each such Offeree Shareholder as a
percentage of the Shares held by all Offeree Shareholders) of the ROFR Shares shall have the right to purchase their pro
rata share (based on the number of Shares owned directly or indirectly by such exercising Offeree Shareholders as a
percentage of the Shares held by all Offeree Shareholders electing to so purchase under this Art. 7.2.c) of any ROFR
Shares not agreed to be purchased by the other Offeree Shareholders, during an additional fifteen (15) day period (the
«Accretion Period»), beginning following notice to the Offeree Shareholders from the Selling Shareholder that not all of
the ROFR Shares were agreed to be purchased during the ROFR Election Period.
(d) If any of the Offeree Shareholders timely accepts the ROFR Offer and all of ROFR Shares are agreed to be purchased
by such exercising Offeree Shareholders, such exercising Offeree Shareholders and the Selling Shareholder shall, within
thirty (30) days following the delivery of the ROFR Acceptance Notice to the Selling Shareholder, enter into a binding
agreement (a «Sale Agreement») for the sale of the ROFR Shares at the ROFR Purchase Price to such exercising Offeree
Shareholder. The Sale Agreement shall contain such terms as are customary between significant shareholders of an issuer;
provided, that the Selling Shareholder shall not be required to make any representations or warranties or provide any
indemnities regarding the business of the Company.
(e) The closing of the sale of the ROFR Shares under a Sale Agreement shall take place at the offices of the Company
(or at such other place as may be mutually acceptable to the parties thereto) not later than the thirtieth (30th) day after
the Sale Agreement was executed and delivered to the Selling Shareholder by the Offeree Shareholder (subject to ex-
tension under the circumstances and within the time periods provided in this 7.2. At such closing, the Selling Shareholder
shall deliver the certificates representing the ROFR Shares, with any required documentary or transfer taxes or stamp
taxes affixed, to the Offeree Shareholders, against payment therefor as provided in the Sale Agreement, free and clear
of any Encumbrance (other than this Agreement) or other encumbrances of whatsoever nature and with an appropriate
transfer letter addressed to the Company.
(f) If (i) the Offeree Shareholders have not exercised the ROFR Option within the applicable ROFR Election Period
and any Accretion Period for all of the ROFR Shares, or (ii)the Sale Agreement has not been executed by the Offeree
Shareholders and tendered to the Selling Shareholder for execution within the period specified in the first sentence of
Art. 7.2 (d), or (iii) the closing of the purchase and sale of all the ROFR Shares has not occurred by the date scheduled
for closing for any reason other than a breach by the Selling Shareholder of any of its or their covenants, representations
or warranties with respect to such sharing (the date of such closing being hereinafter referred to as the «Free to Sell
Date»), then, in any such event, the Selling Shareholder shall have the right (within the period specified in Art. 7.2 (g) to
sell all, but not less than all, of the ROFR Shares to the Proposed Purchaser specified in the ROFR Notice for the ROFR
Purchase Price and the same terms as are set forth in the ROFR Notice, subject to compliance by the Proposed Purchaser
with the requirements of Art. 7.2 (g) and 7.3.
(g) The Selling Shareholder's right to sell the ROFR Shares to the Proposed Purchaser pursuant to 7.2 (f) shall expire
and all of the provisions of this Art. 7.2 shall be reinstated in the event that the Proposed Purchaser has not purchased
47620
the ROFR Shares and complied with the requirements of Art. 7.2 in full within thirty (30) Business Days following the
Free to Sell Date.
(h) If any Offeree Shareholder accepts an ROFR Offer and then willfully fails to consummate the purchase of the ROFR
Shares in accordance with the provisions of this Art. 7.2 (a «Defaulting Shareholder»), then, in addition to any remedies
at law that the Selling Shareholder may have in respect of such failure, the Defaulting Shareholder shall thereafter cease
to have any right to receive ROFR Offers or to enjoy the benefits of this Art. 7.2 in respect thereof.
(i) If any Offeree Shareholder accepts an ROFR Offer, then during the period from the date of delivery of the ROFR
Acceptance Notice until the date the ROFR Shares are transferred, the Selling Shareholder shall at all times cooperate
with the remaining Shareholders in causing the Company at all times to operate its business in the ordinary course,
consistent with past practices.
7.3 Tag along Right
(a) If any Shareholder wishes to Transfer Shares owned directly or indirectly by it in one or a series of related trans-
actions to any purchaser, after such Shareholder has complied with the obligations under Art. 7.2 and is entitled to sell
the ROFR Shares to the Proposed Purchaser named in the ROFR Notice (the «Buyer») then, for a period of fifteen (15)
Business Days after the date (the «Execution Date») the Selling Shareholder and the Buyer enter into a binding agreement
(a «Tag Along Sale Agreement») for the purchase and sale of the ROFR Shares (the «Tag Along Election Period»), each
Offeree Shareholder (the «Tag Along Shareholder») shall have the right (the «Tag Along Right»), but not the obligation,
to sell to the Buyer up to all of its Shares determined in accordance with the following two sentences. In the event that
the Buyer is willing to purchase all of the Shares that such Tag Along Shareholder elects to sell pursuant to the Tag-Along
Right, all such Shares shall be sold to the Buyer. If the Buyer is not willing to purchase all of the Shares that such Tag
Along Shareholder elects to sell pursuant to the Tag-Along Right, then the Tag Along Shareholder and the Selling Share-
holder, shall have the right to sell to such Buyer a number of Shares (the «Tag-Along Share Number») equal to the number
of Shares that the Buyer wishes to purchase, multiplied by a fraction, the numerator of which is the number of Shares
held by the Selling Shareholder or the Tag Along Shareholder (as applicable) and the denominator of which is the total
number of Shares held by the Selling Shareholder and the Tag Along Shareholder (in each case as of the date of the Tag
Right Notice referred to below); provided, that if the Buyer is willing to increase the number of Shares it is willing to
purchase from that number specified in the ROFR Notice (but is not willing to purchase all of the Shares the Tag Along
Shareholder and the Selling Shareholder wish to sell), such Shareholders shall have the right to include in such Tag-Along
Sale a pro rata amount of their respective Shares to account for such increase. The Selling Shareholder shall notify the
Tag Along Shareholder, in writing (a «Tag Right Notice»), of the Execution Date not less than two (2) Business Days
prior to such date. The Tag Right Notice shall also specify the following: (i)the identity and mailing address of the Buyer,
(ii)the per share purchase price and form of consideration to be paid by the Buyer for the ROFR Shares, (iii) the Tag
Along Share Number (showing the calculation thereof in reasonable detail), (iv) any other material terms and conditions
of the sale of the ROFR Shares (including any indemnification or other post closing obligations to the Selling Shareholder)
and (v) that the Buyer has provided the undertaking referred to in the next following sentence. Any Tag Along Sale
Agreement shall include an irrevocable undertaking by the Buyer to purchase Shares from the Tag Along Shareholders
(x) in an amount equal to the Tag Along Share Number and (y) on the same terms and conditions as those on which the
Buyer has agreed to purchase the ROFR Shares of the Selling Shareholder, and the Tag Along Shareholders shall be named
as express beneficiary of that undertaking in the Tag Along Sale Agreement.
(b) During the Tag Along Election Period, the Tag Along Shareholders may elect to sell a number of Shares owned
directly or indirectly by it which is equal to or less than the Tag Along Share Number to the Buyer by delivering to the
Selling Shareholder and the Buyer written notice to such effect (a «Tag Right Acceptance Notice») prior to the expiration
of the Tag Along Election Period. Failure by a Tag Along Shareholder to so notify the Selling Shareholder and the Buyer
within the Tag Along Election Period shall be deemed a waiver by such Tag Along Shareholder of the Tag Along Right in
connection with the sale by the Selling Shareholder of the ROFR Shares to the Buyer pursuant to the Tag Along Sale
Agreement signed by them on the Execution Date, but shall not impair or prejudice any rights of such Tag Along Share-
holder under this Art. 7.2 in the event that the provisions hereof again become applicable to a transfer by the Selling
Shareholder of any of the Shares referred to in the Tag Right Notice.
(c) If the Tag Along Right is timely exercised, the Selling Shareholder shall cause the Buyer to, within fifteen (15)
Business Days after the Execution Date, enter into a binding agreement (a «Participating Tag Along Sale Agreement»)
with the participating Tag Along Shareholders (the «Participating Tag Along Shareholders») for the purchase from such
Shareholders of Shares owned by them in a total amount equal to or less than (at the election of the Participating Tag
Along Shareholders) the Tag Along Share Number, at the same price per share and on substantially the same terms and
conditions as those offered by the Buyer to the Selling Shareholder (including the form of consideration to be paid to the
Selling Shareholder by the Buyer). Each Participating Tag Along Shareholder shall enter into the Participating Tag Along
Sale Agreement within said fifteen (15) Business Day period with the Buyer and, upon compliance with the terms and
conditions hereof and thereof, each Participating Tag Along Shareholder shall sell to such Buyer the number of Shares it
has agreed to sell to the Buyer as set forth in the Participating Tag Along Sale Agreement, free and clear of all Encumbrances
(other than this Agreement and the Option Agreement), at the price and on the terms determined in accordance with
the immediately preceding sentence. The closings of the purchase by the Buyer of the ROFR Shares and of the Shares to
be sold by the Participating Tag Along Shareholders shall occur simultaneously and shall be conditioned upon each other.
47621
7.4 Drag Along Rights
If one or more Shareholders owning in excess of 50% of the Company's total Shares elect to Transfer all of their Shares
to one or more Persons (other than Permitted Transferees) (the «Prospective Buyers»), such Shareholders (the «Drag
Along Shareholder») shall promptly notify each other Shareholder (the «Dragged Along Shareholders»), specifying the
purchase price and other material terms and conditions of the proposed Transfer and the intended closing date of the
sale, and the Drag Along Shareholder may require the Dragged Along Shareholders to Transfer (and if so required, the
Dragged Along Shareholders shall Transfer) all of their Shares to the Prospective Buyers at the same time, same price
(which shall be in cash), and on the same terms and conditions, as the Drag Along Shareholder will receive for its Shares;
provided, however, that in no event shall any Dragged Along Shareholder be required in connection with such sale to
enter into a non-compete or similar agreement or provide indemnities or representations and warranties concerning the
Company, other than indemnities, representations and warranties with respect to its ownership of Shares, its right, power
and authority to transfer such Shares and similar matters.
7.5 Statutory Transfer Restrictions
Notwithstanding anything in this Art. 7 to the contrary, in accordance with art. 189 of the Companies Law, any Transfer
of Shares to non-Shareholders will be subject to the prior approval of such Transfer given by the Shareholders in a
Shareholders' Meeting, at a majority of three quarters of the share capital.
Art. 8. Compartments.
8.1 The Board of Managers of the Company may create one or more compartments within the Company (each a
«Compartment»). Each Compartment shall, unless otherwise provided for in the resolution of the Board of Managers
creating such compartment, correspond to a distinct part of its assets and liabilities. The resolution of the Board of
Managers creating one or more Compartments within the Company, as well as any subsequent amendments thereto,
shall be binding as of the date of such resolutions against any third party.
8.2 As between Shareholders and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity.
Rights of Shareholders and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as relating
to a Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Compartment
are, except if otherwise provided for in the resolution of the Board of Managers having created the relevant Compartment,
strictly limited to the assets of that Compartment and which shall be exclusively available to satisfy such Shareholders
and creditors. Creditors and Shareholders of the Company whose rights are not related to a specific Compartment of
the Company shall have no rights to the assets of any such Compartment.
8.3 Unless otherwise provided for in the resolution of the Board of Managers of the Company having created such
Compartment, no resolution of the Board of Managers of the Company may be taken to amend the resolution having
created such Compartment or to take any other decision directly affecting the rights of the Shareholders or creditors
whose rights relate to such Compartment without the prior approval of all Shareholders or creditors whose rights relate
to this Compartment. Any decision of the Board of Managers taken in breach of this provision shall be void.
8.4 The Company may issue securities whose value or yield is linked to specific compartments, assets or risks, or
whose repayment is subject to the repayment of other instruments, certain claims or certain categories of shares.
Art. 9. Management.
9.1 Board of Managers
The Company is managed by the Board of Managers, which members do not need to be Shareholders.
9.2 Appointment - Removal
(a) The Managers are appointed and removed by the Shareholders' Meeting, which sets the term of office, pursuant
to the procedure described hereafter.
(b) Each of DBZ, MS and OCINSA shall cast their votes in order to elect the Managers as follows: (i) one from among
the candidates proposed for appointment to the Shareholders' Meeting solely by DBZ, for so long as DBZ has at least
the Minimum Shareholder Amount, (ii) one from among the candidates proposed for appointment to the Shareholders'
Meeting solely by MS, for so long as MS has at least the Minimum Shareholder Amount, (iii)two from among the candidates
proposed for appointment to the Shareholders' Meeting solely by OCINSA, for so long as OCINSA has at least the
Minimum Shareholder Amount, and (iv) one from among the candidates proposed for appointment to the Shareholders'
Meeting jointly by DBZ and MS; provided, that if Management holds in the aggregate at least the Minimum Shareholder
Amount and has designated a Management Representative, the Manager referred to in (iv) shall be elected from the
members of Management. After the date of adoption of the present articles of incorporation, each of DBZ, MS and for
so long as in the aggregate Management holds the Minimum Shareholders Amount and has designated a Management
Representative, Management (deciding by simple majority based on the aggregate number of Shares held by Management
as of the date of determination), shall be entitled to designate to the other Shareholders (a «Manager Designation»), not
less than ten (10) days prior to any Shareholders' Meeting of the Company at which Managers are to be elected, the
number of nominees contemplated in the prior sentence for each Shareholder (or Shareholders acting jointly). If a timely
Manager Designation is not received from a Shareholder in advance of such a Shareholders' Meeting, then such Share-
holder shall be deemed to have re-designated its incumbent Managers as nominees. Each Shareholder agrees to vote its
Shares in favour of the election to the Board of Managers of each Manager nominee of the other Shareholders designated
47622
in accordance with this Art. 9.2. If a «Withdrawing Manager» designated in the manner set forth in this Art. 9.2 is unable
to serve, or once having commenced to serve, is removed from the Board of Managers in the manner set forth in Art.
14.2. or withdraws from the Board of Managers, that Withdrawing Manager's replacement (the «Substitute Manager»)
on the Board of Managers (and, if applicable, any committee thereof) will be designated by the same Shareholder, that
designated the Withdrawing Manager in the manner set forth in this Art. 9.2. The Shareholders agree to take all action
within their power, including, but not limited to, the voting of their Shares (either by written consent or at a meeting),
to cause the election of the Substitute Manager as soon as practicable following the designation of the Substitute Manager.
(c) Each Shareholder shall have the right to propose for removal and replacement, at any time and for any reason (with
or without cause), any of its nominees as Manager, and the other Shareholders shall cast their votes in support of such
removal. In the event of any proposed removal and replacement by a Shareholder of, or upon the death or resignation
of, a Manager, the other Shareholders shall cooperate with the Shareholder who proposed the Manager whose removal,
death or replacement created the vacancy in taking the necessary actions and measures to remove such Manager and,
subject to Art. 9.2(b), to elect such replacement as promptly as practicable. No Shareholder shall seek the removal or
replacement of any Manager proposed by the other Shareholder except in compliance with the preceding sentence.
9.3 Authority and Duties
(a) In dealing with third parties, the Board of Managers has extensive powers to act in the name of the Company in
all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose.
(b) The duties and responsibilities of the Board of Managers shall include all Board Matters, as well as any other matter
falling within the competence of the Board of Managers in accordance with applicable law.
(c) The Board of Managers shall act by majority of Managers attending the meeting at which at least a majority of the
members of the Board of Managers are present, except as otherwise provided by law; provided that with regard to the
Veto Matters, for so long as a Shareholder shall hold the Minimum Shareholder Amount, action by the Board of Managers
approving any such matter shall require the affirmative vote of at least one Manager the appointment of which has been
proposed by such Shareholder.
9.4 Procedure at meetings of the Board of Managers
(a) The Board of Managers shall choose from among its members a chairman (the «Chairman»), and may choose from
among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a Manager, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.
(b) The Board of Managers will meet on a quarterly basis and special meetings shall be held whenever requested in
writing by a Manager to the Chairman of the Board of Managers. All meetings of the Board of Managers will be conducted
in accordance with these articles of incorporation and Luxembourg law. Each of MS and DBZ shall be entitled to have
one non-voting observer (the «Observer») present at each Board meeting, to be designated as such to the Chairman of
the Board of Managers at least one (1) day prior to the meeting.
(c) Notice of regular and special meetings of the Board of Managers shall be given in writing to each Manager specifying
the time and place of the meeting and the agenda therefore, at least seven Business Days in advance of each such meeting.
The Chairman of the Board of Managers shall send such notice to each Manager, or, if the Chairman of the Board of
Managers fails to send such notice within seven days after receiving a written request for a meeting by a Manager, then
the Manager having requested the meeting shall be authorized to send such written notice to each Manager and such
notice, if delivered at least seven Business Days prior to the date of such meeting, shall constitute valid notice of any such
meeting. This notice may be omitted in case of assent of each Manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile,
or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a meeting of the Board of
Managers to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board of Managers.
(d) Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by cable, telegram, email,
telex or facsimile another manager as his proxy. A Manager may represent more than one of his colleagues.
(e) Meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg except as otherwise agreed by the Managers.
Meetings of the Board of Managers may be held through the use of a videoconference, telephone conference or similar
telecommunications device allowing persons participating in the meeting to hear each other at the same time and to speak
to each other. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. Minutes of
all meetings of the Board of Managers shall be drawn and distributed promptly to al Managers.
(f) The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the Chairman or the secretary or, in his
absence, by the vice-chairman, or by two Managers. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial
proceedings or otherwise, shall be signed by the Chairman or the secretary or by two Managers.
(g) The Board of Managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
(h) The Company shall reimburse the members of the Board of Managers and the Observers for any expenses incurred
with in connection with the duties as a Manager or the participation by the Observers in any meeting of the Board of
Managers.
9.5 Representation Towards Third Parties
47623
(a) The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of all Managers or the signature of any
person to whom such signatory power shall be delegated by the Board of Managers.
(b) The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
9.6 Liability
The Managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly
made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for
the execution of their mandate.
9.7 Chief Executive Officer
(a) The Company shall have one chief executive officer (the «CEO»). The CEO shall have the authority and duties,
and the rights and obligations herein. The CEO shall report to the Board of Managers.
(b) The CEO may be removed as CEO by the Board of Managers at any time and for any reason (with or without
cause). The CEO shall be a member of the Board of Managers. The Board of Managers shall also fix the terms and
conditions of the mandate of the CEO. In the event a Person ceases to be CEO for any reason whatsoever (whether or
not for cause) it will be required to promptly resign from the Board of Managers. In the event that such Person fails to
resign, all Shareholders shall vote their Shares and take such other action as may be required to remove such Person
from the Board of Managers.
(c) Sixty (60) days prior to the end of each fiscal year of the Company, the CEO shall cause to be prepared, and present
to the Board of Managers for its review and consideration, an annual budget proposed for the immediately succeeding
fiscal year of the Company and its Subsidiaries. If the CEO deems it appropriate at any time to amend or otherwise modify
an existing annual budget, the CEO may at any time recommend such amendment to the Board of Managers for its
consideration. Any such proposed annual budget or amendment to an existing annual budget shall not become effective
unless and until it has been approved by the Board of Managers.
Art. 10. Shareholders' Meetings.
10.1 Each Shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each Shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
10.2 Shareholders' Meetings of the Company shall take place at least once every year or whenever convened by the
Chairman of the Board upon written request by a Shareholder, in which case a Shareholders' Meeting shall be held within
fourteen days from the receipt of such request by the Shareholder.
10.3 Shareholders' Meetings may be attended either in person or by proxy. Minutes of all Shareholders' Meetings shall
be drawn and kept at the offices of the Company and made available for inspection during business hours by any Share-
holder.
10.4 Each Shareholder shall be entitled to cast one vote for each Share that is held by such Shareholder in the Company
with respect to each matter voted on by the Shareholders.
10.5 Save in the case of Supermajority Matters or as otherwise provided by law, collective decisions are only validly
taken in so far they are adopted by Shareholders owning more than half of the share capital.
10.6 Resolutions of the Shareholders' Meeting with respect to the Supermajority Matters shall be adopted by the
affirmative vote of a majority of the Shareholders representing at least seventy-five per cent. (75%) of the share capital
of the Company.
10.7 The holders of Shares relating to a specific Compartment of the Company may, at any time, hold Shareholders'
Meetings to decide on any matters which relate exclusively to such Compartment. The holders of Shares relating to the
other Compartments of the Company or the holders of Shares relating to the Company shall not attend such shareholders'
meetings.
Art. 11. Financial Year - Annual Accounts.
11.1 The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
11.2 Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the Board of Managers prepares an
inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each Shareholder may inspect the
above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
11.3 On separate accounts (in addition of the accounts held by the Company in accordance with the Companies Law
and normal accounting practice), the Company shall determine at the end of each financial year, a result for each Com-
partment which will be determined as follows:
(a) The result of each Compartment will consist in the balance of all income, profits or other receipts paid or due in
any other manner in relation to the relevant Compartment (including capital gains, liquidation surplus, dividends distri-
bution) and the amount of the expenses, losses taxes and other transfers of funds incurred by the Company during this
exercise and which can regularly and reasonably be attributed to the management, operation of such Compartment
(including fees, costs, corporate income tax on capital gain, expenses relating to dividend distribution).
(b) All income and expenses not attributed to any specific Compartment shall be allocated to all of the Company's
Compartments on a pro rata basis of the shares issued in each Compartment.
47624
11.4 The Shareholders will approve such separate accounts simultaneously with the accounts held by the Company in
accordance with the Companies Law and normal practice. The eventual excess of the total of the credits on the total of
the debits on each of these accounts shall be the available amount, subject to as indicated, of a decision of the Shareholders,
for the payment of dividends to the shares of the corresponding compartment.
Art. 12. Allocation of Profits.
12.1 Five per cent (5 %) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10 %) of the share capital. The balance may be freely used by the Shareholders. Interim dividends
may be distributed upon decision of the Board of Managers.
12.2 The Shareholders' Meeting of Shareholders will determine upon recommendation of the Board of Managers, how
the remainder of the annual net profits will be disposed of. Payments of distributions shall be made to the Shareholders
at their addresses in the register of Shareholders. Distributions may be paid in such currency and at such time and place
that the Board of Managers shall determine from time to time.
12.3 Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by the Companies
Law. The Board of Managers may decide to pay interim dividends to the Shares of a specific Compartment on the basis
of a statement of accounts prepared by the Board of Managers showing that sufficient funds are available for distribution
in this Compartment, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits deriving
from the associated Compartment since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distrib-
utable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by the
Companies Law or by these articles of incorporation.
12.4 The Shareholders' Meeting of Shareholders may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon
such terms and conditions as prescribed by the relevant Shareholders' Meeting.
Art. 13. Dissolution - Liquidation.
13.1 Without prejudice to the provisions contained in article 8, and subject to the authorisation of the Shareholders
in a Shareholders' Meeting which may be required when the articles of incorporation of the Company are modified, each
Compartment may be put into liquidation and its Shares redeemed by a decision of the Board of Managers of the Company
without affecting any other existing Compartment or the Shareholders thereof.
13.2 In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which
do not need to be Shareholders, and which are appointed by the Shareholders' Meeting which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.
13.3 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the Shareholders proportionally to the Shares of each Compartment of the Company held by them.
Art. 14. Miscellaneous.
14.1 The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.
14.2 The bankruptcy or insolvency of one of the Shareholders will not cause the dissolution of the Company.
14.3 Neither creditors, nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
14.4 All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Securi-
tisation Law and the Companies Law and amendments thereto.
Art. 15. Definitions. In these articles of incorporation, the following words and expressions shall have the meanings
set out below:
«Accretion Period» has the meaning set forth in Art. 7.2(c).
«Affiliate» shall mean, with reference to a specific Person, any Person that at the time of determination of Affiliate
status directly or indirectly, whether through one or more intermediaries, is the Controlling Person of, a Controlled
Person of or is under common Control with, such specific Person; provided, that no Shareholder shall be deemed an
Affiliate of any of the other Shareholders solely by reason of any investment in the Company; and provided, further, that
neither the Company nor any Subsidiary shall be deemed an Affiliate of any Shareholder.
«Board Matters» shall mean:
(i) approval of the consolidated annual budget of the Company and the Subsidiaries and any amendments or modifi-
cations thereto proposed by the CEO, which shall be submitted to the Board of Managers by the CEO in accordance
with Art. 9.6, no later than sixty (60) days prior to the end of each fiscal year for the following fiscal year;
(ii) approval of, with respect to the Company and each of the Subsidiaries, the execution, amendment or termination
of contracts or other arrangements committing the Company and/or each of the Subsidiaries, in any given year, to
payments in excess of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) (or its equivalent in other currencies) or transfers of
assets having a Fair Market Value in excess of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) (or its equivalent in other
currencies);
(iii) approval of transactions with Affiliates;
47625
(iv) approval of the hiring, firing and compensation of executive officers other than Key Employees of the Company
and/or each of the Subsidiaries;
(v) decisions regarding any compensation increase for the payroll of the Company and/or each of the Subsidiaries,
except for standard yearly inflation cost of living linked increases;
(vi) decisions regarding pricing policies, general commercial strategies, adoption of new lines of business, and discon-
tinuation of significant lines of business, in each case of the Company and/or each of the Subsidiaries;
(vii) approval of all powers-of-attorney to represent the Company and/or any of the Subsidiaries in transactions in-
volving payments in excess of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) (or its equivalent in other currencies) or
transfers of assets having a Fair Market Value in excess of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) (or its equivalent
in other currencies);
(viii) any matter brought before it by a Manager, and
(ix) any other matter required by law.
and «Board Matter» means any one of them.
«Board of Managers» shall mean the board of Managers (conseil de gérance) of the Company.
«Business Day» means a day that is not a Saturday or a Sunday or any other day on which banking institutions in
London, Luxembourg or Madrid are permitted or obligated to close by law.
«Buyer» has the meaning set forth in Art. 7.3(a).
«Capital Expenditures» means, with respect to any Person for any period, the sum of all expenditures made directly
or indirectly for equipment, fixed assets, real property or improvement thereto or substitutions thereof that have been
reflected as additions to property, plant or equipment on a consolidated balance sheet in accordance with applicable
generally accepted accounting principles.
«Capital Stock» of any Person means any and all shares, interests, rights to purchase, warrants, equity-linked securities,
convertible debentures, options, participations, rights in or other equivalents (however designated) of such Person's
capital stock or other equity participations, including partnership interests, whether general or limited, in such Person,
including any Preferred Stock, and any rights, warrants or options exchangeable for or convertible into such capital stock,
whether outstanding on the date of the Indenture or issued thereafter.
«Chairman» has the meaning set forth in Art. 9.3(a).
«CEO» has the meaning set forth in Art. 9.6.
«Compartment» has the meaning set forth in Art. 8.1.
«Control» means, with reference to a specific Person (other than an individual or a natural person), the possession,
directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of such Person,
whether through the ownership of voting securities, quotas or equity, by contract or otherwise.
«Controlled Person» shall mean, with reference to a specific Person (other than an individual or a natural person),
any Person that at the time of determination of Controlled Person status directly or indirectly, whether through one or
more intermediaries, is under Control of such specific Person.
«Controlling Person» shall mean, with reference to a specific Person, any Person that at the time of determination of
Controlling Person status directly or indirectly, whether through one or more intermediaries, exercises, is entitled to
exercise, or has the ability to exercise Control over such specific Person.
«DBZ» shall mean D.B. ZWIRN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND LTD., a company duly incorporated and in exis-
tence pursuant to the laws of the Cayman Islands, M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O. Box 309GT, Ugland
House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.
«Defaulting Shareholder» has the meaning set forth in Art. 7.2(h).
«Drag Along Shareholder» has the meaning set forth in Art. 7.4.
«Dragged Along Shareholders» has the meaning set forth in Art. 7.4.
«Execution Date» has the meaning set forth in Art. 7.3(a).
«Encumbrance» means any mortgage, pledge, security interest, lien, claim, levy, option, assignment by way of guarantee,
easement, privilege, restriction (including any shareholders agreement or voting agreement), attachment or any other
charge whatsoever, in each case for the purpose of securing financial indebtedness or financial obligations, or for any
other purpose whatsoever.
«Encumber» or «Encumbered» means creating or suffering to exist any such Encumbrance.
«Fair Market Value» means, as to the Company, any Shares or any other assets or properties (including securities),
the cash price at which a willing seller would sell and a willing buyer would buy in an arm's length transaction, neither
party being under time constraints or under any compulsion to buy or sell, in each case as determined by an Independent
Appraiser selected by the Board of Managers. Whenever the Fair Market Value of the Company is to be determined,
such Fair Market Value shall be determined based on a sale of the Company as a going concern in a transaction structured
as a sale of 100% of the Shares of the Company.
47626
«Finance Lease» means a contract treated as a finance or capital lease in accordance with International Financial
Reporting Standards.
«Free to Sell Date» has the meaning set forth in Art. 7.2(f).
«Independent Appraiser» means an investment banking, accounting firm or valuation consulting firm of established
reputation that is, in the reasonable judgment of the Person engaging such firm, qualified to perform the task for which
is being engaged and which has not received remuneration from such Person or an Affiliate in excess of one hundred
thousand euro (EUR 100,000.-) during the 24 month period preceding such engagement.
«Indebtedness» means any indebtedness for or in respect of:
(i) moneys borrowed;
(ii) any amount raised by acceptance under any acceptance credit facility;
(iii) any amount raised pursuant to any note purchase facility or the issue of bonds, notes, debentures, loan stock or
any similar instrument;
(iv) any amount raised pursuant to any issue of shares which are expressed to be redeemable and all obligations to
purchase, retire, defease or otherwise acquire for value any share capital of any person or any warrants, rights or options
to acquire such share capital in respect of transactions which, in each such case, have the commercial effect of a borrowing
or which finance a member of the group or the group's operations or capital requirements;
(v) the amount of any liability in respect of any Finance Lease;
(vi) the amount of any liability in respect of any advance or deferred purchase agreement incurred outside the ordinary
course of trading if such transaction has the commercial effect of a borrowing;
(vii) receivables sold or discounted (other than on a non-recourse basis);
(viii) any agreement or option to re-acquire an asset if one of the primary reasons for entering into such agreement
or option is to raise finance;
(ix) any amount raised under any other transaction (including any forward sale or purchase agreement) having the
commercial effect of a borrowing; and
(x) the amount of any liability in respect of any guarantee or indemnity for any of the items referred to in paragraphs
(i) to (ix) above, but avoiding double counting.
«Key Employee» means, with respect to any Person, each of the CEO, the chief financial officer and the chief operating
officer.
«Management» shall mean all Officers collectively.
«Management Incentive Programme Agreement» means that certain Management Incentive Programme Agreement
among among DBZ, MS and OCINSA dated as of January 15, 2007, as amended from time to time.
«Management Representative» means the Person designated in writing by each Officer to act on their behalf for
purposes of Art. 9.
«Manager» shall mean any Manager (gérant) of the Company.
«Manager Designation» has the meaning set forth in Art. 9.2(b).
«Minimum Shareholder Amount» means with respect to each of (i) DBZ and its Permitted Transferees taken as a
whole 15%, (ii) MS and its Permitted Transferees taken as a whole 15%, (iii) OCINSA and its Permitted Transferees taken
as a whole 15%, and (iv) Management, the direct or indirect ownership of a number of Shares greater than 15% of the
aggregate number of Shares outstanding (excluding any Shares held by the Company and its Subsidiaries) at the date of
determination.
«MS» shall mean MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS INC., a company duly incorporated and in existence
as under the law of the state of New York, with corporate domicile at 1585 Broadway, New York, N.Y. 10036, USA.
«Observer» has the meaning set forth in Art. 9.3(b).
«OCINSA» shall mean OCINSA, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A., a company duly incorporated and existing
under the laws of Spain, with registered address at Plaza Antonio Beltran Martinez, n
o
1, Edificio Trovador, planta 9,
oficinas F-G., 50.002 -Zaragoza, Spain, registered with the Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 1.269, Folio 1, Hoja
Z-6.544.
«Offeree Shareholders» has the meaning set forth in Art. 7.2(a).
«Officer» shall mean the members of the management of the Company and the Subsidiaries benefiting from the option
plan referred to in the Management Incentive Programme Agreement.
«Option Agreement» means the Put/Call Option Agreement among DBZ, MS and OCINSA dated as of January 15,
2007, as amended from time to time.
«Participating Tag Along Sale Agreement» has the meaning set forth in Art. 7.3(c).
«Participating Tag Along Shareholders» has the meaning set forth in Art. 7.3(c).
«Permitted Transferee» shall mean, with respect to any Shareholder, an Affiliate of such Shareholder and any Officer
acquiring Shares pursuant to the Management Incentive Programme Agreement.
47627
«Person» means any individual, estate, corporation, limited or unlimited liability company, partnership, proprietorship,
joint venture, association, joint-stock company, investment fund, trust, union or unincorporated organization or other
group, entity or organization, including a governmental entity.
«Preferred Stock» means, with respect to any Person, any and all shares, interests, participations or other equivalents
(however designated) of such Person's preferred or preference stock, whether outstanding on the date of the Indenture
or issued thereafter, and includes, without limitation, all classes and series of such preferred or preference stock of such
Person.
«Proposed Purchaser» has the meaning set forth in Art. 7.2(a).
«Prospective Buyers» has the meaning set forth in Art. 7.4.
«ROFR Acceptance Notice» has the meaning set forth in Art. 7.2(b).
«ROFR Election Period» has the meaning set forth in Art. 7.2(a).
«ROFR Notice» has the meaning set forth in Art. 7.2(a).
«ROFR Offer» has the meaning set forth in Art. 7.2(a).
«ROFR Purchase Price» has the meaning set forth in Art. 7.2(a).
«ROFR Shares» has the meaning set forth in Art. 7.2(a).
«Sale Agreement» has the meaning set forth in Art. 7.2(d).
«Selling Shareholder» has the meaning set forth in Art. 7.2(a).
«Shareholder» shall mean any shareholder of the Company.
«Shareholders' Meeting» shall mean any general meeting of Shareholders of the Company, whether ordinary or ex-
traordinary.
«Shares» shall mean any shares of the Company with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
«Subsidiary» shall mean, with reference to a Person, any other Person that at the time of determination of Subsidiary
states directly or indirectly, whether through one or more intermediaries, has the power to appoint more than 50% of
the members of the Board of Managers or equivalent body or holds more than 50% of the capital stock of such specified
Person.
«Substitute Manager» has the meaning set forth in Art. 9.2(b).
«Supermajority Matters» shall mean:
(i) approval of any amendment, modification, supplement or replacement of these articles of incorporation;
(ii) the merger or consolidation of the Company in one transaction or in a series of related transactions, or the
acquisition by the Company using Capital Stock of the Company as consideration therefor, of assets (including equity or
other securities);
(iii) the issuance, grant, offer, or sale by the Company of shares of any class or series of its equity or other equity
securities, or any securities convertible into or exercisable or exchangeable for, or options, warrants, or rights of any
kind to subscribe to or acquire, any shares of any class or series of its equity or other equity securities, or any split up,
subdivision, recapitalization, combination or reclassification of the equity of the Company or the entering into of any
contract, agreement, commitment or arrangement with respect to any of the foregoing;
(iv) in relation to the Company, the authorization or payment of any dividends or the redemption, purchase or ac-
quisition of any Capital Stock;
(v) the adoption of any management incentive plan of the Company or any of the Subsidiaries (other than the Man-
agement Incentive Programme Agreement), that would provide for the issuance of any Capital Stock of the Company or
any Subsidiary at less than Fair Market Value or that, upon issuance or exercise, would represent more than five (5) per
cent, of the Company's or such Subsidiary's equity; and
(vi) any voluntary liquidation or dissolution of the Company or any of the Subsidiaries; and
(vii) the reclassification of debt or equity securities, corporate restructuring or reorganization measures.
«Tag Along Sale Agreement» has the meaning set forth in Art. 7.3(a).
«Tag Along Election Period» has the meaning set forth in Art. 7.3(a).
«Tag Along Right» has the meaning set forth in Art. 7.3(a).
«Tag Along Share Number» has the meaning set forth in Art. 7.3(a).
«Tag Along Shareholder» has the meaning set forth in Art. 7.3(a).
«Tag Right Acceptance Notice» has the meaning set forth in Art. 7.3(b).
«Tag Right Notice» has the meaning set forth in Art. 7.3(a).
«Transfer» shall mean any sale, assignment, alienation, gift, exchange, conveyance, transfer, option, issuance, short sale,
swap, derivative transaction or other disposition whatsoever, or an agreement to do any of the foregoing, whether for
value or not, whether voluntary or involuntary, direct or indirect, of Shares of the company or any interest therein.
«Transferred» shall mean the occurrence of a Transfer.
47628
«Veto Matters» shall mean:
(i) approval of any amendment, modification, supplement or replacement of the articles of association, bylaws, incor-
poration documents or any other organizational documents of any of the Subsidiaries;
(ii) any material change in the conduct of the business conducted by the Company or any of the Subsidiaries;
(iii) the hiring of any Key Employee of the Company or any of the Subsidiaries; provided that the renewal of the
employment arrangements for any of the individuals currently serving in these positions shall not be subject to this
provision;
(iv) any change in the Company's or in any of the Subsidiaries' independent auditors or tax advisors;
(v) the creation of any committee of the Board of Managers of the Company or of any of the Subsidiaries or the
expansion or reduction of the powers of any existing committee of the Board of Managers of the Company or of any of
the Subsidiaries;
(vi) the merger or consolidation of any of the Subsidiaries in one transaction or in a series of related transactions, or
the acquisition by any of the Subsidiaries using Capital Stock of any of the Subsidiaries as consideration therefore, of assets
(including equity or other securities);
(vii) any acquisition by the Company or any of the Subsidiaries in one transaction or in a series of transactions of assets
(including equity or other securities) unless such acquisition (x) would not result in a situation, immediately following
such acquisition, wherein the Company would not be able to incur at least one million euro (EUR 1,000,000.-) of additional
indebtedness without exceeding three million euro (EUR 3,000,000.-), or (y) involves aggregate payments or assets having
a Fair Market Value not in excess of one million euro (EUR 1,000,000.-);
(viii) any disposition by the Company or any of the Subsidiaries in a transaction where the Fair Market Value of the
assets disposed of exceeds one million euro (EUR 1,000,000.-), except in the case of any disposition required by the
mandate of a competent governmental authority;
(ix) the issuance, grant, offer, or sale by any of the Subsidiaries of shares of any class or series of its equity or other
equity securities, or any securities convertible into or exercisable or exchangeable for, or options, warrants, or rights of
any kind to subscribe to or acquire, any shares of any class or series of its equity or other equity securities, or any split
up, subdivision, recapitalization, combination or reclassification of the equity of any of the Subsidiaries or the entering
into of any contract, agreement, commitment or arrangement with respect to any of the foregoing;
(x) in relation to any of the Subsidiaries, the authorization or payment of any dividends or the redemption, purchase
or acquisition of any Capital Stock;
(xi) the adoption of any management incentive plan of the Company or any of the Subsidiaries (other than the Man-
agement Incentive Programme Agreement), that would provide for the issuance of any Capital Stock of the Company or
any Subsidiary at less than Fair Market Value or that, upon issuance or exercise, would represent more than five (5) per
cent of the Company's or such Subsidiary's equity;
(xii) the filing by the Company or any of the Subsidiaries for insolvency under the bankruptcy laws of any competent
insolvency court, or the admission in writing of the bankruptcy, insolvency or general inability of the Company or any of
the Subsidiaries to pay its debts as they become due;
(xiii) any voluntary liquidation or dissolution of any of the Subsidiaries;
(xiv) the incurrence of Indebtedness for borrowed money by the Company or any Subsidiary, other than Indebtedness
that, when added to all other outstanding Indebtedness of the Company and its Subsidiaries (net of any cash escrows
dedicated solely to repay Indebtedness) does not exceed at any time three million euro (EUR 3,000,000.-);
(xv) the creation or imposition of any Encumbrance on any assets of the Company or any of the Subsidiaries repre-
senting more than ten percent (10%) of the consolidated assets of the Company, other than statutory Encumbrances;
(xvi) the making of any loan or advance to any person or the guaranteeing of the obligations of any person, other than
(x) any such loan or advance (A) that is in the ordinary course of business of the Company or of the Subsidiaries, (B) the
amount of which does not exceed ten (10) per cent of the Company's consolidated gross revenues during the most recent
four fiscal quarters for which Company financial statements are available and (C) made out of cash resources available at
the Company, or (y) any guaranty of indebtedness of a Subsidiary of less than three million euro (EUR 3,000,000.-);
(xvii) the approval of Capital Expenditures exceeding in the aggregate in any given fiscal year an amount equal to two
and one half (2.5) per cent of the Company's consolidated gross revenues for the prior fiscal year; and
(xviii) the reclassification of debt or equity securities, corporate restructuring or reorganization measures.
«Withdrawing Manager» has the meaning set forth in Art. 9.2(b).»
<i>Fourth resolutioni>
Upon the assignment of certain shares held by the current shareholders of the Company to certain executives of the
group, the general meeting resolves to approve such executives as new shareholders of the Company.
<i>Estimation of Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall
be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 3,000.-.
47629
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing persons,
this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, who are known to the notary by their first and surname, civil
status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le douze janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est réunie:
Une assemblée générale extraordinaire des associés de D.B. ZWIRN RINOL HOLDINGS OFFSHORE S.à r.l., une
société à responsabilité limitée de titrisation, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, rue Schiller, L-1717 Lu-
xembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 102358, constituée par un acte de Maître
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations du 22 octobre 2004, numéro 1062 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la
dernière fois par un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné en date du 5
janvier 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'assemblée s'est ouvert à 11 heures, sous la présidence de M. Gildas Le Pannérer, maître en droit, demeurant à
Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Mlle Nicole Schmidt-Troje, avocat, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Mlle Andrea Hoffmann, Rechtsanwältin, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel d'un million huit cent soixante-quinze mille euros
(EUR 1.875.000,-) à un montant de deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) par l'émission de vingt-cinq mille
(25.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
2) Changement de nom de la Société en RCR INDUSTRIAL FLOORING S.à r.l.
3) Refonte complète des statuts de la Société.
4) Approbation de certains cadres comme nouveaux associés de la Société.
5) Divers.
II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexes aux présentes, les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.
III. Que conformément à liste de présence, la totalité du capital social est présente ou représentée à la présente
assemblée et tous les associés déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée qui leur a été communiqué
au préalable, il a pu être fait abstraction des convocation d'usage.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibérer, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel d'un million huit cent
soixante-quinze mille euros (EUR 1.875.000,-) à un montant de deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) par
l'émission de vingt-cinq mille (25.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Les vingt-cinq mille (25.000) nouvelles parts sociales ont été souscrites par OCINSA, OBRAS Y CONSTRUCCIONES,
S.A., une société constituée et régie selon les loi de l'Espagne avec siège social à Plaza Antonio Beltran Martinez, n
o
1,
Edificio Trovador, planta 9, oficinas F-G., 50.002 - Zaragoza, Espagne, inscrite au Registre Mercantil de Zaragoza, Tomo
1.269, Folio 1, Hoja Z-6.544 («OCINSA»), ici représentée par Melle Andrea Hoffman, prénomée, en vertu d'une procu-
ration sous seing privé ci-annexée, pour un prix de souscription de cinq millions cinq cent mille euros (EUR 5.500.000,-),
qui sera affecté comme suit:
- six cent vingt-cinq mille euros (EUR 625.000,-) seront affectés au capital social de la Société;
47630
- quatre millions huit cent soixante-quinze mille euros (EUR 4.875.000,-) seront affectés à la prime d'émission de la
Société.
Les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de sorte que le montant de
cinq millions cinq cent mille euros (EUR 5.500.000,-) est désormais à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de changer le nom de la Société en RCR INDUSTRIAL FLOORING S.à r.l.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide la refonte complète des statuts de la Société qui auront la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Nom - Droit applicable.
1.1 II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir Associés par la suite une société à respon-
sabilité limitée sous la dénomination de RCR INDUSTRIAL FLOORING S.à r.l. (ci-après la «Société»).
1.2 La Société aura le statut d'une société de titrisation conformément à la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation (la
«Loi sur la Titrisation») et sera régie par la Loi sur la Titrisation, la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»), ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet de conclure une ou plusieurs opérations de titrisations conformément à la Loi sur la
Titrisation et la Société pourra, dans ce contexte, assumer les risques, existants ou futurs, liés à la possession de biens
meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, de même que les risques résultants d'engagements assumés par des tiers
ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers, dans une ou plusieurs opérations ou de façons régulière.
La Société pourra assumer ces risques par l'acquisition de biens, l'octroi de garanties ou en s'engageant par tout autre
moyen. Elle pourra aussi transférer, dans la mesure prévue par la loi et les présents statuts, ou disposer des titres et
autres biens qu'elle détient, qu'ils soient présents ou futurs, dans une ou plusieurs opérations ou de façon régulière.
2.2 La Société pourra, dans ce même contexte, acquérir, disposer et investir dans des prêts, valeurs mobilières, titres,
actifs, obligations, billets à ordre, avances, actions, bons de souscriptions et autres sûretés. La Société pourra accessoi-
rement octroyer des gages, d'autres garanties et des sûretés, de quelque nature que ce soit, à toute entité luxembour-
geoise ou étrangère et conduire, de manière accessoire, des opérations de prêt de titres.
2.3 La Société pourra exercer tout investissements ou opérations de nature légale, commerciale, technique ou finan-
cière, et en général, toutes transactions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet, ainsi que toutes opérations
liées directement ou indirectement à la facilitation de l'accomplissement de son objet dans tous les domaines décrits ci-
dessus.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
4.2 II peut être transféré dans la même commune par décision du Conseil de Gérance. La Société peut ouvrir des
agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays par décision du Conseil de Gérance.
4.3 Au cas où le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de deux millions cinq cent mille euros (EUR
2.500.000,-) représenté par cent mille (100.000) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Art. 6. Parts Sociales.
6.1 Les parts sociales ainsi émises pourront être exclusivement rattachées à un ou plusieurs compartiments déterminés
de la Société.
6.2 Chaque part sociale donne droit à une voix dans les Assemblées des Associés.
6.3 Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit moyennant l'accord de la majorité des Associés
représentant au moins les trois quarts du capital social.
6.4 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune des parts sociales.
Art. 7. Restrictions de Transfert.
7.1 Transfert à des Cessionnaires Autorisés
(a) Les Associés ne transféreront leurs Parts Sociales que conformément à cet Article 7.1. Tout transfert de Parts
Sociales effectué en violation de cet Article sera nul et caduc et la Société n'enregistrera pas ou n'autorisera pas d'enre-
gistrer un tel Transfert dans son registre des Associés.
47631
(b) Tout Associé peut Transférer toutes ou une partie de ses Parts Sociales à un Cessionnaire Autorisé sans devoir
respecter les dispositions des Articles 7.2, 7.3 et 7.4. Dans ce cas, le Cessionnaire Autorisé remplacera et aura, pour les
Parts Sociales ainsi acquises, les mêmes droits et sera soumis aux mêmes obligations que l'Associé duquel il a acquis ces
Parts Sociales.
(c) Les dispositions des Articles 7.2, 7.3 et 7.4 ne s'appliquent pas à un Transfert de Parts Sociales détenues par DBZ
à HEMLOCK (LUX) S.à r.l., une société constituée et régie selon les lois de Luxembourg, ni à un Transfert de Parts
Sociales qui s'effectuerait conformément au Droit d'Option.
7.2 Droit de Premier Refus
(a) Si un Associé décide de Transférer (un tel Associé sera dénommé ci-après un «Associé Cédant») directement ou
indirectement, des Parts Sociales qu'il détient dans la Société à une personne ou à des personnes (autre qu'un Cessionnaire
Autorisé) (I'«Acquéreur Proposé»), cet Associé Cédant enverra d'abord aux autres Associés (les «Associés Destinatai-
res») une notification écrite (une «Notification DPR») qui précisera (i) le nombre de Parts Sociales à transférer (les «Parts
Sociales DPR»), (ii) le nom de l'Acquéreur Proposé et les termes selon lesquels les Parts Sociales DPR seront cédées à
cet Acquéreur Proposé, et (iii) le prix d'acquisition total (qui devra être payé en espèces en euros ou en titres négociables)
que l'Acquéreur Proposé a consenti de payer pour les Parts Sociales DPR (le «Prix d'Acquisition DPR»). La Notification
DPR constitue une offre irrévocable de la part de l'Associé Cédant (une «Offre DPR») pour une période de trente (30)
jours suivant la remise de la notification aux Associés Destinataires (la «Période d'Option DPR») de céder pas moins de
la totalité des Parts Sociales DPR aux Associés Destinataires au Prix d'Acquisition DPR.
(b) Pendant la Période d'Option DPR, chaque Associé Destinataire peut choisir d'acquérir un nombre de Parts Sociales
DPR à hauteur de sa quote-part de parts sociales détenues (sur la base du nombre total des Parts Sociales détenues par
cet Associé Destinataire comme un pourcentage de Parts Sociales détenues par toutes les Associés Destinataires) au
Prix d'Acquisition DPR en envoyant avant l'expiration de la Période d'Option DPR une notification écrite (une «Notifi-
cation d'Acceptation DPR») à l'Associé Cédant. Le manquement à l'obligation de notification par un Associé Destinataire
à un Associé Cédant de son acceptation de l'Offre DPR pendant la période applicable sera considéré comme une re-
nonciation à une Offre DPR; les droits de cet Associé Destinataire sous cet Article 7.2 ne seront pourtant pas affectés
au cas où les dispositions de cet Article deviendront à nouveau applicables à un transfert par l'Associé Cédant de toutes
Parts Sociales mentionnées dans la Notification DPR.
(c) Dans le cas où une partie seulement des Associés Destinataires décide d'acquérir des Parts Sociales DPR, les
Associés Destinataires choisissant d'acquérir un nombre de Parts sociales proportionnel (sur la base du nombre de Parts
Sociales détenues par chaque Associé Destinataire représentant un pourcentage du nombre de Parts Sociales détenues
par tous les Associés Destinataires) aux Parts Sociales DPR auront le droit d'acquérir leurs parts proportionnellement
(sur la base du nombre de Parts Sociales détenues directement ou indirectement par cet Associé Destinataire exerçant
son droit comme un pourcentage des Parts Sociales détenues par tous les Associés Destinataires choisissant d'acquérir
leur part proportionnelle conformément à cet Article 7.2.c) à toutes les Parts Sociales DPR qui ne seront pas acquises
par les autres Associés Destinataires dans un délai additionnel de quinze (15) jours (le «Délai Additionnel») à partir de
la notification aux Associés Destinataires par laquelle l'Associé Cédant informe les Associés Destinataires que toutes les
Parts Sociales DPR seront acquises pendant la Période d'Option DPR.
(d) Si tous les Associés Destinataires acceptent l'Offre DPR dans les délais et si toutes les Parts Sociales DPR sont
acquises par ces Associés Destinataires exerçant leur droit, ces Associés Destinataires et l'Associé Cédant concluront
dans les trente (30) jours suivant la remise de la Notification d'Acceptation DPR à l'Associé Cédant un contrat (le «Contrat
de Cession») pour la cession des Parts Sociales DPR au Prix d'Acquisition à cet Associé Destinataire exerçant ses droits.
Le Contrat de Cession doit contenir les termes habituels entre des associés importants d'un émetteur, à condition que
l'Associé Cédant ne soit pas obligé de faire des déclarations, d'apporter des garanties ou de payer des indemnités con-
cernant les activités de la Société.
(e) La réalisation de la cession des Parts Sociales DPR dans le cadre d'un Contrat de Cession aura lieu dans les bureaux
de la Société (ou dans tout autre lieu déterminé par les deux parties) pas plus tard que le trentième (30e) jour suivant la
signature et la remise du Contrat de Cession à l'Associé Cédant par l'Associé Destinataire (sous réserve d'une prolon-
gation dans les circonstances et les délais prévus par cet Article 7.2.). Au moment de cette réalisation l'Associé Cédant
remettra les certificats représentant les Parts Sociales DPR, ainsi que tous les documents requis, droits d'enregistrement
ou droits de timbres, aux Associés Destinataires, en échange du paiement prévu dans le Contrat de Cession, libre et
quitte de toute Charge (autres que celles mentionnées dans le Contrat) ou autres charges de quelque sorte que ce soit
et avec une lettre de transfert appropriée adressée à la Société.
(f) Si (i) les Associés Destinataires n'ont pas exercé leur Option DPR dans la Période d'Option DPR et tout Délai
Additionnel pour toutes les Parts Sociales DPR ou (ii) le Contrat de Cession n'a pas été signé par les Associés Destinataires
et soumis à l'Associé Cédant pour signature dans le délai spécifié dans la première phrase de l'Article 7.2 (d) ou (iii) la
réalisation de l'acquisition et de la cession de toutes les Parts Sociales DPR n'a pas eu lieu le jour prévu pour la réalisation
pour une raison quelconque autre que la violation par l'Associé Cédant de tous ses ou leurs engagements, déclarations
ou garanties par rapport à cette participation (la date de cette réalisation sera dénommée ci-après la «Date de Libre
Cession»), alors, dans ce cas, l'Associé Cédant aura le droit (dans le délai spécifié à l'Article 7.2 (g)) de céder pas moins
de la totalité des Parts Sociales DPR à l'Acquéreur Proposé spécifié dans la Notification DPR au Prix d'Acquisition DPR
47632
et selon les termes tels que décrits dans la Notification DPR, sous réserve de l'application des dispositions de l'Article
7.2 et 7.3 par l'Acquéreur Proposé.
(g) Dans le cas où l'Acquéreur Proposé n'aurait pas acquis les Parts Sociales et respecté les conditions de l'Article 7.2
en entier dans les trente (30) Jours Ouvrables suivant la Date de Libre Cession, le droit de l'Acquéreur Cédant de céder
les Parts Sociales DPR à l'Acquéreur Proposé conformément à l'Article 7.2 (f) s'éteint et toutes les dispositions de cet
Article 7.2 seront à nouveau applicables.
(h) Si un Associé Destinataire accepte une Offre DPR et manque délibérément à son obligation d'acquérir des Parts
Sociales DPR conformément aux dispositions de cet Article 7.2 (un «Actionnaire Défaillant»), alors, en plus de tout
recours légal que l'Associé Cédant peut avoir par rapport à ce manquement, l'Associé Défaillant n'aura plus le droit de
recevoir des Offres DPR ou de bénéficier de cet Article 7.2 à cet égard.
(i) Si un Associé Destinataire accepte une Offre DPR, alors pendant la période à partir de la remise de la Notification
d'Acceptation DPR jusqu'à la date du transfert des Parts Sociales DPR, l'Associé Cédant coopérera à tout moment avec
les autres Associés en autorisant la Société à tout moment à gérer ses affaires courantes.
7.3 Droit de Sortie Conjointe
(a) Si un Associé souhaite Transférer des Parts Sociales détenues directement ou indirectement suite à la réalisation
d'une ou plusieurs transactions, après avoir respecté les obligations de l'Article 7.2 et s'il est autorisé à vendre les Parts
Sociales DPR à l'Acquéreur Proposé nommé dans la Notification DPR (I'«Acquéreur»), alors, dans un délai de quinze (15)
Jours Ouvrables suivant la date (la «Date d'Exécution») à laquelle l'Associé Cédant et l'Acquéreur ont conclu a contrat
(un «Contrat de Sortie Conjointe») pour l'acquisition et la vente de Parts Sociales DPR (la «Période d'Option de Sortie
Conjointe»), chaque Associé Destinataire (I'«Associé de Sortie Conjointe») aura le droit (le «Droit de Sortie Conjointe»),
mais pas l'obligation, de céder à l'Acquéreur une partie ou la totalité de ses Parts Sociales déterminées conformément
avec les deux phrases suivantes. Dans le cas où l'Acquéreur veut acquérir toutes les Parts Sociales, que cet Associé de
Sortie Conjoint veut vendre conformément au Droit de Sortie Conjointe, toutes ces Parts Sociales seront cédées à
l'Acquéreur. Si l'Acquéreur ne veut pas acquérir toutes les Parts Sociales que cet Associé de Sortie Conjointe veut céder
conformément au Droit de Sortie Conjointe, alors l'Associé de Sortie Conjointe et l'Associé Cédant ont le droit de céder
à cet Acquéreur un nombre de Parts Sociales (le «Nombre de Parts Sociales de Sortie Conjointe») égal au nombre de
Parts Sociales que l'Acquéreur désire acquérir multiplié par une fraction dont le numérateur est le nombre de Parts
Sociales détenues par l'Associé Cédant ou l'Associé de Sortie Conjointe (le cas échéant) et le dénominateur est le nombre
total de Parts Sociales détenues par l'Associé Cédant et l'Associé de Sortie Conjointe (dans tous les cas à partir de la
date de la Notification de Sortie Conjointe mentionnée ci-dessous); à condition que si l'Acquéreur veut augmenter le
nombre de Parts Sociales il veut acquérir le nombre spécifié dans la Notification DPR (mais il ne veut pas acquérir toutes
les Parts Sociales que l'Associé de Sortie Conjointe et l'Associé Cédant souhaitent céder), ces Associés auront le droit
d'inclure dans cette Vente de Sortie Conjointe une quote-part de leurs Parts Sociales respectives afin de rendre compte
de cette augmentation. L'Associé Cédant notifiera à l'Associé de Sortie Conjointe par écrit (une «Notification de Droit
de Sortie Conjointe») la Date d'Exécution au moins deux (2) Jours Ouvrables avant cette date. La Notification de Droit
de Sortie Conjointe indiquera aussi ce qui suit: (i) l'identité et l'adresse postale de l'Acquéreur, (ii) le prix d'acquisition
par Part Sociale et le mode de paiement par l'Acquéreur pour les Parts Sociales DPR, (iii) le Nombre de Parts Sociales
de Sortie Conjointe (incluant les calculs détaillés de manière raisonnable), (iv) tous autres termes et conditions matérielles
de la cession des Parts Sociales DPR (y compris toute indemnisation ou autre obligation postérieure à la signature à
l'Associé Cédant) et (v) que l'Acquéreur s'engage à ce qui suit. Tout Contrat de Sortie Conjointe comprendra un enga-
gement irrévocable pris par l'Acquéreur d'acquérir des Parts Sociales des Associés de Sortie Conjointe (x) pour un
montant égal au Nombre de Parts Sociales de Sortie Conjointe et (y) selon les mêmes termes et conditions que ceux
pour lesquels l'Acquéreur acquerra les Parts Sociales DPR de l'Associé Cédant, et les Associés de Sortie Conjointe seront
nommés les bénéficiaires réels de cet engagement dans le Contrat de Sortie Conjointe.
(b) Pendant la Période d'Option de Sortie Conjointe les Associés de Sortie Conjointe peuvent choisir de céder un
nombre de Parts Sociales directement ou indirectement détenues par eux équivalent à ou inférieur au Nombre de Parts
Sociales de Sortie Conjointe à l'Acquéreur en envoyant à l'Associé Cédant et à l'Acquéreur une notification écrite (une
«Notification d'Acceptation du Droit de Sortie Conjointe») avant l'expiration de la Période d'Option de Sortie Conjointe.
Le manquement par un Associé de Sortie Conjointe de notifier à l'Associé Cédant et l'Acquéreur pendant la Période
d'Option de Sortie Conjointe sera considéré comme un renoncement par cet Associé de Sortie Conjointe au Droit de
Sortie Conjointe par rapport à la cession par l'Associé Cédant des Parts Sociales DPR à l'Acquéreur conformément au
Contrat de Sortie Conjointe signé par eux à la Date d'Exécution, mais n'affectera pas les droits de cet Associé de Sortie
Conjointe sous cet Article 7.2 dans le cas où les dispositions de cet Article deviennent à nouveau applicables à un transfert
par l'Associé Cédant de toutes Parts Sociales mentionnées dans la Notification de Droit de Sortie Conjointe.
(c) Si le Droit de Sortie Conjointe est exercé dans les délais, l'Associé Cédant doit amener l'Acquéreur à conclure
dans les quinze (15) Jours Ouvrables suivant la Date d'Exécution un contrat (un «Contrat de Participation à la Sortie
Conjointe») avec les Associés de Sortie Conjointe participant (les «Associés de Sortie Conjointe Participant») à l'acqui-
sition par ces Associés de Parts Sociales détenues par eux pour un montant total égal ou inférieur (au moment de la
décision des Associés de Sortie Conjointe Participant de participer) au Nombre de Parts Sociales de Sortie Conjointe,
au même prix par Part Sociale et notamment selon les mêmes termes et conditions que ceux offerts par l'Acquéreur à
l'Associé Cédant (y compris le moyen de paiement par l'Acquéreur à l'Associé Cédant). Chaque Associé de Sortie Con-
47633
jointe Participant conclura au cours de ladite période de quinze (15) Jours Ouvrables un Contrat de Sortie Conjointe
avec l'Acquéreur et selon les termes et conditions de ce contrat chaque Associé de Sortie Conjointe Participant cédera
à cet Acquéreur le nombre de Parts Sociales qu'il s'était engagé à céder à l'Acquéreur tel que stipulé dans le Contrat de
Sortie Conjointe, exempt et libre de toute Charge (autre que ce Contrat et le Contrat d'Option), au prix et selon les
termes et conditions déterminés ci-dessus. La réalisation de l'acquisition par l'Acquéreur des Parts Sociales DPR et celle
de la cession des Parts Sociales par les autres Associés de Sortie Conjointe Participant auront lieu simultanément et
dépendront l'une de l'autre.
7.4. Droits de Cession Forcée
Si un ou plusieurs Associés détenant plus de 50% de la totalité des Parts Sociales de la Société décide(nt) de transférer
toutes ses/leurs Parts Sociales à une ou plusieurs Personnes (autres que des Cessionnaires Autorisés) (les «Acquéreur
Potentiels»), ces Associés (les «Associés Majoritaires») en informeront immédiatement tout autre Associé (les «Associés
Minoritaires») en spécifiant le prix d'acquisition, les autres termes et conditions matérielles du Transfert prévu et la date
prévue pour la réalisation de la cession, et l'Associé Majoritaire pourra demander aux Associés Minoritaires de Transférer
(et s'il le demande les Associés Minoritaires Transféreront) toutes leurs Parts Sociales aux Acquéreurs Potentiels au
même moment, au même prix (qui sera en espèces) et selon les mêmes termes et conditions que l'Associé Majoritaire
recevra pour ses Parts Sociales; à condition qu'à aucun moment il ne soit demandé, lors de cette cession, à un Associé
Minoritaire d'accepter une clause de non-concurrence ou une obligation semblable, de payer des indemnités ou de faire
des déclarations ou d'apporter des garanties relatives à la propriété de ses Parts Sociales, à son droit, mandat et pouvoir
de transférer ces Parts Sociales ou d'autres matières semblables.
7.5 Restriction de Transfert Statutaires
Sauf disposition contraire de l'Article 7, tout Transfert de Parts Sociales à des non-Associés sera, conformément à
l'article 189 de la Loi sur les Sociétés Commerciales, soumise à l'accord préalable des Associés donné par l'Assemblée
Générale à la majorité de trois quarts du capital social.
Art. 8. Compartiments.
8.1 Le Conseil de Gérance de la Société pourra créer un ou plusieurs compartiments au sein de la Société (chacun un
«Compartiment»). Sauf disposition contraire dans la résolution du Conseil de Gérance créant un tel compartiment,
chaque Compartiment devra correspondre à une partie distincte de l'actif et du passif de la Société. La résolution du
Conseil de Gérance créant un ou plusieurs Compartiments au sein de la Société, ainsi que toute modification subséquente,
engagera ce dernier vis-à-vis des tiers, à compter de la date des résolutions.
8.2 Entre les Associés et les créanciers, chaque Compartiment de la Société devra être traité comme une entité séparée.
Les droits des Associés et créanciers de la Société (i) qui dès leur création, ont été rattachés à un Compartiment ou (ii)
qui sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation d'un Compartiment sont, sauf disposition
contraire dans les résolutions du Conseil de Gérance créant un tel Compartiment, strictement limitées aux biens de ce
Compartiment et seront exclusivement disponibles pour satisfaire ces Associés et créanciers. Les créanciers et Associés
de la Société dont les droits ne sont pas spécifiquement rattachés à un Compartiment déterminé de la Société n'auront
aucun droit aux biens d'un tel Compartiment.
8.3 Sauf disposition contraire dans les résolutions du Conseil de Gérance de la Société créant un tel Compartiment,
aucune résolution du gérant unique ou du conseil de gérance de la Société ne pourra être prise afin de modifier les
résolutions ayant créé un tel Compartiment ou afin de prendre toute décision affectant directement les droits des Associés
ou créanciers dont les droits sont rattachés à un tel Compartiment sans le consentement préalable de l'ensemble des
Associés ou créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment. Toute décision prise par le Conseil de Gérance
en violation de cette disposition sera nulle et non avenue.
8.4 La Société pourra émettre des sûretés dont la valeur ou l'intérêt est lié à des Compartiments spécifiques, biens
ou autres engagements, ou dont le remboursement dépend du remboursement d'autres instruments, de certains droits
ou de certaines catégories de parts sociales.
Art. 9. Gérance.
9.1. Conseil de Gérance
La Société est gérée par un Conseil de Gérance dont les membres n'ont pas besoin d'être des Associés.
9.2 Nomination - Révocation
(a) Les Gérants sont nommés et révoqués par l'Assemblée des Associés qui fixera le terme de leur mandat confor-
mément à la procédure décrite ci-après.
(b) DBZ, MS et OCINSA votent tous pour nommer les Gérants comme suit: (i) un gérant choisi parmi les candidats
proposés pour la nomination à l'Assemblée des Associés par DBZ à condition que DBZ détienne au moins le Montant
Minimum de Parts Sociales, (ii) un gérant choisi parmi les candidats proposés pour la nomination à l'Assemblée des
Associés par MS à condition que MS détient au moins le Montant Minimum de Parts Sociales, (iii) deux gérants choisis
parmi les candidats proposés pour la nomination à l'Assemblée des Associés par OCINSA à condition que OCINSA
détienne au moins un Montant Minimum de Parts Sociales, et (iv) un gérant choisi parmi les candidats proposés pour la
nomination à l'Assemblée des Associés par DBZ et MS conjointement; à condition que, la Gérance détienne au moins un
Montant Minimum de Parts Sociales et désigne un Représentant de la Gérance, le Gérant mentionné (iv) sera nommé
47634
parmi les membres de la Gérance. Après la date d'adoption de ces statuts, DBZ, MS et, à condition que la Gérance
détienne au total le Montant Minimum de Parts Sociales et désigne un Représentant de la Gérance, ce dernier (prenant
des décisions avec une majorité simple sur la base du nombre de Parts Sociales détenues par la Gérance au jour de la
détermination), auront chacun le droit de signaler aux autres Associés (une «Nomination de Gérant») pas moins de quinze
(15) jours avant toute Assemblée des Associés de la Société lors de laquelle des Gérants seront nommés, le nombre de
candidats envisagé dans la phrase précédente pour chaque Associé (ou Associés agissant conjointement). Si un Associé
n'a pas envoyé une convocation à la Nomination de Gérant dans les délais requis, on considère que cet Associé a renommé
les Gérants en fonction comme candidats. Chaque Associé exerce son droit de vote aux fins de nommer au Conseil de
Gérance un candidat proposé par les autres Associés conformément à cet Article 9.2. Si du fait «départ d'un gérant» dans
les conditions décrites à I' Article 9.2 ce dernier n'est pas en mesure d'exécuter son mandat ou est révoqué après avoir
commencé son mandat de la manière décrite à l'Article 14.2 ou se retire du Conseil de Gérance, le remplaçant de ce
Gérant Résignant (le «Gérant Remplaçant») dans le Conseil de Gérance (et, le cas échéant, tout comité de ce conseil)
sera désigné par le même Associé qui avait désigné le Gérant Résignant de la manière décrite à l'Article 9.2. Les Associés
décident d'un commun accord de prendre toutes mesures dans le cadre de leur pouvoir, notamment d'exprimer leur
vote (soit par un accord écrit ou lors d'une réunion), pour nommer le Gérant Remplaçant aussitôt que possible après la
désignation du Gérant Remplaçant.
(c) Chaque Associé aura le droit de proposer pour la révocation ou le remplacement, à tout moment et pour toute
raison (avec ou sans cause) un de ses candidats comme Gérant, et les autres Associés voteront au profit de cette révo-
cation. Dans le cas d'une révocation ou d'un remplacement d'un Gérant proposé par un Associé ou en cas de décès ou
de résignation d'un Gérant, les autres Associés coopérons avec l'Associé qui a proposé le Gérant dont la révocation, le
décès ou le remplacement créera un poste vacant en prenant toutes les mesures nécessaires pour la révocation de ce
Gérant et, conformément à l'Article 9.2 (b), la nomination d'un remplaçant aussitôt que possible. Aucun Associé ne
demandera la révocation ou le remplacement d'un Gérant proposé par un autre Associé, sauf en conformité avec la phrase
précédente.
9.3 Autorités et Devoirs
(a) Vis-à-vis de tiers, le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
(b) Les devoirs et responsabilités du Conseil de Gérance comprennent toutes les Décisions du Conseil, ainsi que tout
autre matière de la compétence du Conseil de Gérance conformément à la loi applicable.
(c) Le Conseil de Gérance agira avec la majorité des Gérants participant à la réunion lors de laquelle au moins une
majorité des membres du Conseil de Gérance est présente, sauf dispositions légales contraires. Les Décisions de Veto,
seront prises par un Associé qui doit détenir le Montant Minimum de Parts Sociales, et l'approbation par le Conseil de
Gérance d'une telle décision nécessite le vote affirmatif d'au moins un Gérant dont la nomination a été proposée par cet
Associé.
9.4 Procédures lors des réunions du Conseil de Gérance
(a) Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le «Président») et pourra choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.
(b) Le Conseil de Gérance se réunira tous les trois mois et des réunions extraordinaires auront lieu sur la demande
écrite d'un Gérant adressée au Président du Conseil de Gérance. Toute réunion du Conseil de Gérance sera menée
conformément à ces statuts et la loi luxembourgeoise. DBZ et MS auront chacun le droit d'avoir un observateur sans
droit de vote (I'«Observateur») qui participera aux réunions du Conseil de Gérance, à indiquer en tant que tel au Président
du Conseil de Gérance au moins un (1) jour avant la réunion.
(c) Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance régulière ou extraordinaire, spécifiant l'heure et le lieu de la
réunion ainsi que son agenda, sera donné à tous les Gérants au moins sept (7) Jours Ouvrables avant la réunion. Le
Président du Conseil de Gérance enverra l'avis de convocation à chaque Gérant, ou si le Président du Conseil de Gérance
manque d'envoyer cet avis écrit à chaque Gérant dans les sept (7) jours suivant la réception d'une demande écrite d'une
réunion par un Gérant, alors le Gérant ayant demandé la réunion aura le droit d'envoyer un tel avis écrit à chaque Gérant
et cet avis, si envoyé au moins sept (7) Jours Ouvrables avant la date de la réunion, sera considéré comme une convocation
valable à cette réunion. Il pourra être passé à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque Gérant par écrit ou
par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne
sera pas requise pour une réunion du Conseil de Gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.
(d) Tout Gérant pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit ou par
câble, télégramme, courrier électronique, télex ou télécopie un autre Gérant comme son mandataire. Un Gérant peut
présenter plusieurs de ses collègues.
(e) Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu à Luxembourg, sauf si les Gérants ont convenu autre chose. Toute
réunion du Conseil de Gérance peut être tenue par vidéoconférence, conférence téléphonique ou par d'autres moyens
de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres.
47635
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Des procès-
verbaux de toutes les réunions du Conseil de Gérance seront établis et distribués aussitôt à tous les Gérants.
(f) Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président ou le secrétaire
ou, en son absence, par le vice-président ou par deux Gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir
en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou le secrétaire ou par deux Gérants.
(g) Le Conseil de Gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer
par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
(h) La Société remboursera les membres du Conseil de Gérance et les Observateurs pour toutes les dépenses en-
courues en rapport avec les devoirs en tant que Gérant ou la participation des Observateurs aux réunions du Conseil
de Gérance.
9.5 Représentation vis-à-vis de Tiers
(a) La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de tous les Gérants ou la signature de
toute personne à laquelle un pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil de Gérance.
(b) Le Conseil de Gérance peut conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou des procurations sous
seing privé.
9.6 Responsabilité
Les Gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur
mandat.
9.7 Chief Executive Officer
(a) La Société aura un chief executive officer (le «CEO»). Le CEO aura les pouvoirs et les devoirs, les droits et les
obligations définis dans ces statuts. Le CEO remet ses observations au Conseil de Gérance.
(b) LE CEO peut être révoqué de son poste de CEO par le Conseil de Gérance à tout moment ou pour toute raison
(avec ou sans cause). Le CEO sera un membre du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance fixera les termes et
conditions du mandat du CEO. Dans le cas où une Personne cesse d'être CEO pour une raison quelle qu'elle soit (avec
ou sans cause) elle sera demandé de démissionner immédiatement du Conseil de Gérance. Dans le cas où cette Personne
manque de démissionner, tous les Associés votent et prennent toutes les mesures nécessaires pour révoquer cette
Personne du Conseil de Gérance.
(c) Soixante (60) jours avant la fin de chaque exercice social de la Société, le CEO sera amené à préparer et présenter
au Conseil de Gérance pour contrôle et commentaires un budget annuel proposé pour l'année fiscale suivante de la
Société et de ses Filiales. Si le CEO le considère approprié à un moment ou autre d'amender ou de modifier un budget
annuel existant, le CEO peut à tout moment recommander une telle modification au Conseil de Gérance pour ce faire.
Tout budget annuel proposé ou toute modification d'un budget annuel existant n'est effectif qu'à moins que et à partir
du moment où cela a été approuvé par le Conseil de Gérance.
Art. 10. Assemblées des Associés.
10.1 Chaque Associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque Associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède ou représente.
10.2 Les Assemblées des Associés de la Société auront lieu au moins une fois par an ou si convoquées par le Président
du Conseil de Gérance sur demande écrite d'un Associé, et dans ce dernier cas une Assemblée des Associés aura lieu
dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la demande de l'Associé.
10.3 Les Associés peuvent participer aux Assemblées des Associés personnellement ou par un mandataire. Des procès-
verbaux de toutes les Assemblées des Associés seront rédigés et tenus au siège social de la Société et pourront être
consultés partout Associé pendant les heures de bureau.
10.4 Tout Associé aura droit à une voix par Part Sociale détenue dans le capital de la Société et cela pour tous les
sujets votés par les Associés.
10.5 Sauf dispositions légales contraires ou Décisions exigeant la Majorité Qualifiée, les décisions de l'assemblée gé-
nérale ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des Associés représentant plus de la
moitié du capital social.
10.6 Des résolutions des Assemblées des Associés par rapport à des Décisions à prendre à la Majorité Qualifiée seront
adoptées par le vote affirmatif d'une majorité des Associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du
capital social de la Société.
10.7 Les détenteurs de Parts Sociales relatives à un Compartiment spécifique de la Société peuvent, à tout moment,
tenir des Assemblées des Associés afin de délibérer sur des sujets qui ne concernent que ce Compartiment.
Les détenteurs de Parts Sociales relatives aux autres Compartiments de la Société ou les détenteurs de Parts Sociales
relatives à la Société ne participeront pas à ces assemblées des associés.
47636
Art. 11. Année Sociale - Comptes Annuels.
11.1 L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
11.2 Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le Conseil de Gérance dresse un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout Associé peut prendre communication au siège
social de l'inventaire et du bilan.
11.3 Sur des comptes séparés (en plus des comptes tenus par la Société conformément à la Loi sur les Sociétés
Commerciales et la pratique comptable courante), la Société déterminera à la fin de chaque année sociale un résultat
pour chaque Compartiment comme suit:
(a) Le résultat de chaque Compartiment sera le solde entre tous revenus, profits ou autres produits payés ou dus en
quelque forme que ce soit relatifs à ce Compartiment (y compris des plus-values, des bonis de liquidation, des distributions
de dividendes) et le montant des dépenses, pertes, impôts ou autres transferts de fonds encourus par la Société pendant
cet exercice et qui peuvent être régulièrement et raisonnablement attribués à la gestion et fonctionnement de ce Com-
partiment (y compris honoraires, coûts, impôts sur plus-values, dépenses relatives à la distribution de dividendes).
(b) Tous produits et dépenses non attribués à un Compartiment en particulier seront alloués entre les différents
Compartiments proportionnellement aux parts sociales émises dans chaque Compartiment.
11.4 Les Associés approuveront ces comptes séparés simultanément avec les comptes tenus par la Société confor-
mément à la Loi sur les sociétés commerciales et la pratique courante. Par une décision des Associés l'éventuel surplus
résultant du total du solde créditeur sur le solde débiteur sur chacun des comptes sera distribué comme dividendes aux
parts sociales du Compartiment correspondant.
Art. 12. Répartition des Profits.
12.1 Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition des Associés. Des acomptes sur
dividendes pourront être versés sur décision du Conseil de Gérance.
12.2 L'Assemblée des Associés décidera, sur recommandation du Conseil de Gérance, comment le surplus des profits
annuels sera distribué. Le paiement de distributions se fera aux Associés à leurs adresses figurant sur le registre des
actionnaires. Les distributions seront payées en la devise et au moment et lieu que le Conseil de Gérance déterminera
périodiquement.
12.3 Des acomptes sur dividendes pourront être versés conformément aux conditions prévues à la Loi sur les Sociétés
Commerciales.
Le Conseil de Gérance pourra décider de la distribution d'acomptes sur dividendes aux actions d'un Compartiment
déterminé, sur base d'un bilan préparé par le Conseil de Gérance et faisant ressortir que des fonds suffisants sont dis-
ponibles pour la distribution dans ce Compartiment, étant entendu que le montant à distribuer ne pourra excéder les
profits réalisés découlant de ce Compartiment correspondant depuis la fin de la dernière année fiscale, augmenté des
profits reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des montants à attribuer à une réserve
qui sera constituée par la Loi sur les Sociétés Commerciales ou par les présents statuts.
12.4 L'Assemblée des Associés pourra décider de distribuer des dividendes en parts sociales au lieu de dividendes en
espèces selon les conditions requises par une telle Assemblée des Associés.
Art. 13. Dissolution - Liquidation.
13.1 Sans préjudice aucun aux dispositions de l'article 8, et sous réserve de l'autorisation des Associés accordée lors
d'une Assemblée des Associés statuant comme en matière de modification des statuts de la Société, chaque compartiment
de la Société pourra être mis en liquidation et ses Parts Sociales pourront être rachetées par une décision du Conseil de
Gérance de la Société sans avoir aucun effet sur les Compartiments existants ou les Associés de ces Compartiments.
13.2 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), Associé(s) ou non,
nommé(s) par l'Assemblée des Associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf disposition contraire, le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
13.3 L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les Associés en proportion des Parts Sociales de chaque
Compartiment de la Société détenues par eux.
Art. 14. Divers.
14.1 Le décès ou la résignation d'un gérant, pour quelque motif que ce soit, ne mettra pas fin à la Société.
14.2 La faillite ou insolvabilité d'un des Associés ne mettra pas fin à la Société.
14.3 Les créanciers, ayants-droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et
documents de la Société.
14.4 Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les Associés s'en réfèrent aux dispositions de la Loi de
Titrisation et la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Art. 15. Définitions. Dans ces statuts, les termes et expressions suivants auront les significations suivantes:
«Délai Additionnel» a la signification décrite à l'Art. 7.2 (c).
47637
«Affilié» signifie, par rapport à toute Personne spécifique, toute Personne qui au moment de la détermination du statut
d'Affilié est directement ou indirectement, par un ou plusieurs intermédiaires, la Personne Contrôlant ou une Personne
Contrôlée de ou sous le Contrôle commun avec cette Personne spécifique; à condition qu'aucun Associé ne soit considéré
comme Affilié d'un des autres Associés pour la seule raison que cet Associé aura effectué un investissement dans la
Société; et à condition que ni la Société ni une Filiale ne soit considérée comme un Affilié d'un Associé.
«Décisions du Conseil» signifie:
(i) approbation du budget annuel consolidé de la Société et les Filiales et tout amendement ou toute modification y
relatif proposé par le CEO, qui sera soumis au Conseil de Gérance par le CEO conformément à l'Art. 9.6, pas plus tard
que soixante (60) jours avant la fin de chaque année sociale pour l'année fiscale suivante;
(ii) approbation de, par rapport à la Société et chacune des Filiales, l'exécution, la modification ou résiliation de contrats
ou autres arrangements qui engagent la Société et/ou chacune des Filiales, au cours d'une année donnée, à des paiements
supérieurs à cent mille euros (EUR 100.000,-) (ou son équivalent dans une autre devise) ou des transferts d'actifs ayant
une juste valeur du marché supérieure à cent mille euros (EUR 100.000,-) (ou son équivalent dans une autre devise);
(iii) approbation de transactions avec des Affiliés;
(iv) approbation de l'embauche, le licenciement et de la rémunération de cadres autres que les Employées Clefs de la
Société et / ou de chacune des Filiales;
(v) décisions concernant toute augmentation de la rémunération du personnel de la Société et/ou de chacune des
Filiales, sauf augmentation du coût de la vie liée à l'inflation standard annuelle;
(vi) décisions concernant la politique des prix, les stratégies commerciales générales, l'adoption de nouveaux secteurs
d'activité et dissolution de secteurs d'activités importants, dans tous les cas de la Société et/ou de chacune des Filiales;
(vii) approbation de toutes les procurations pour représenter la Société et/ou toute Filiale dans des transactions
impliquant des paiements supérieurs à cent mille euros (EUR 100.000,-) (ou son équivalent dans une autre devise) ou des
transferts d'actifs ayant une juste valeur du marché supérieure à cent mille euros (EUR 100.000,-) (ou son équivalent dans
une autre devise);
(viii) tout sujet présenté au Conseil par un Gérant, et
(ix) tout autre sujet requis par la loi,
et «Décision du Conseil» se rapporte à toute décision mentionnée ci-dessus.
«Conseil de Gérance» désigne le conseil de gérance de la Société.
«Jour Ouvrable» désigne tout autre jour qu'un samedi ou un dimanche, ou un jour lors duquel les banques à Londres,
Luxembourg ou Madrid sont fermées ou obligées de fermer du fait de l'application de la loi.
«Acquéreur» a la signification décrite à l'Art. 7.3 (a).
«Dépenses de capital» signifie le total de toutes les dépenses encourues, quelque que soit les personnes qui les ont
engagées ou la période lors de laquelle ces dépenses ont été engagées, directement ou indirectement pour l'acquisition
d'équipement, d'actifs immobilisés, de biens immobiliers, des biens acquis dans le but d'aménager ces derniers ou de les
remplacer qui viennent s'ajouter aux immobilisations et dotations figurant sur un bilan consolidé établi conformément
aux principes comptables généralement acceptés.
«Capital Social» de toute Personne signifie toutes/tous parts sociales, intérêts, droits d'achat, garanties, titres conver-
tibles, obligations convertibles, options, participations, droits dans ou autres équivalents (cependant désignés) du capital
social de cette Personne ou autres participations au capital, y compris des actions d'une société en commandite, que ce
soient des actions de commandité ou de commanditaire, de cette Personne, y compris toutes actions à droits préférentiels
et tous droits, garanties ou options échangeables pour ou convertibles en capital social, qu'il soit impayé à la date du
Contrat ou émis après.
«Président» a la signification décrite à l'Art. 9.3 (a).
«CEO» a la signification décrite à l'Art. 9.6.
«Compartiment» a la signification décrite à l'Article 8.1.
«Contrôle» fait référence à une Personne spécifique (autre qu'une personne physique), qui détient directement ou
indirectement le pouvoir de diriger ou d'influencer la gérance et les principes de cette Personne, que ce soit par la
détention de titres avec droit de vote, part sociales, par contrat ou tout autre moyen.
«Personne Contrôlée» fait référence à une Personne spécifique, toute Personne qui au moment de la détermination
du statut de la Personne Contrôlée est directement ou indirectement, par un ou plusieurs intermédiaires, soumis au
Contrôle de cette Personne spécifique.
«Personne Contrôlant» fait référence à toute Personne spécifique, toute Personne qui au moment de la détermination
du statut de Personne Contrôlant, directement ou indirectement, par un ou plusieurs intermédiaires, exerce ou a le droit
d'exercer ou est en mesure d'exercer Contrôle sur cette Personne spécifique.
«DBZ» désigne D.B. ZWIRN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND LTD., une société dûment constituée et existant
selon les lois des Iles Caïman, ayant son siège social à M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O. Box 309GT, Ugland
House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, lles Caïman.
«Associé Défaillant» a la signification décrite à l'Art. 7.2 (h).
47638
«Associé Majoritaire» a la signification décrite à l'Art. 7.4.
«Associé Minoritaire» a la signification décrite à l'Art. 7.4.
«Date d'Exécution» a la signification décrite à l'Art. 7.3 (a).
«Charge» désigne toute hypothèque, tout gage, tout privilège, toute créance, toute taxe, toute option, toute cession
par garantie, servitude, privilège, restriction (y compris tout pacte d'associés ou contrat de vote), saisie ou autre charge
de quelque sorte que ce soit, visant à se prémunir contre tout endettement ou toutes obligations financières, ou à toutes
autres fins.
«Charger» ou «Chargé» désigne le fait de créer ou de supporter une telle Charge.
«Juste Valeur du Marché» désigne, en rapport avec la Société, toutes Parts Sociales, les autres actifs ou biens (y compris
les titres), le prix en espèces pour lequel un cédant cédera et un acquéreur acquerra lors une transaction selon les
conditions normales du marché, sans qu'aucune partie n'y ait été contrainte du fait d'un délai court qui lui aurait été
imparti pour prendre sa décision ou du fait d'une compulsion, dont les conditions seront appréciées par un expert
indépendant nommé par le Conseil de Gérance. La Juste Valeur du Marché sera déterminée sur la base de la cession de
la Société comme celle intervenant lors d'une transaction dans laquelle 100% des Parts Sociales de la Société seraient
cédées.
«Leasing Financier» désigne un contrat traité en tant qu'un leasing financier ou leasing de capital conformément aux
International Financial Reporting Standards (normes comptables internationales).
«Date de Libre Cession» a la signification décrite à l'Art.7.2 (f).
«Expert Indépendant» désigne une banque, un cabinet comptable ou un cabinet de consulting spécialisé dans l'évaluation
et réputé pour ses compétences en la matière, l'appréciation d'un Professionnel engageant le cabinet ou l'établissement,
engagé pour accomplir cette tâche et pour laquelle il n'a pas reçu de rémunération par ce même Professionnel ou Par-
tenaire excédant cent mille euro (EUR 100.000,-) pendant les 24 mois qui ont précédés cet engagement.
«Endettement» désigne tout endettement par rapport à:
(i) des sommes d'argent empruntées;
(ii) tout emprunt supplémentaire consenti dans le cadre d'une opération de financement
(iii) tout emprunt supplémentaire consenti dans le cadre du d'un plan de financement pour l'achat d'obligations ou
l'émission d'obligations, de titres d'emprunt ou autre instruments similaires;
(iv) toute augmentation de la dette résultant de l'émission de parts sociales dites rachetables et toutes obligations à
acheter, retirer, annuler ou autrement acquérir à titre onéreux tout capital social de toute personne ou autres garanties,
droit ou options pour acquérir ce capital social en rapport avec des transactions, qui, dans de telles cas, ont l'effet
commercial d'emprunt ou qui l'objet de financer un membre du groupe, des opérations du groupe ou des exigences en
termes de fond;
(v) le montant de toute responsabilité par rapport à tout Leasing Financier;
(vi) le montant de toute dette par rapport à toute avance ou contrat d'achat différé résultant des usages commerciaux
si cette transaction à l'effet commercial d'un emprunt;
(vii) créances vendues ou rendues au rabais (autre que sur une base non-échue);
(viii) tout contrat ou toute option de racheter un actif si un des motifs principaux pour la conclusion d'un tel contrat
ou d'une telle option est de lever des fonds;
(ix) toutes sommes engagées dans le cadre d'une transaction (tel qu'un contrat de vente ou d'acquisition à terme)
ayant l'effet commercial d'un emprunt; et
(x) le montant de toute responsabilité par rapport à toute garantie ou indemnité de tous les points mentionnés dans
les paragraphes (i) à (ix) ci-dessus, mais évitant le double compte.
«Employés Clefs» désigne, par rapport à toute Personne, chacun des CEO, chief financial officer et chief operating
officer.
«Gérance» désigne l'ensemble des Membres de la Gérance.
«Contrat de Participation des Gérants» désigne le Mangement Incentive Programme Agreement entre DBZ, MS et
OCINSA en date du 15 janvier 2007, y compris toutes modifications qui y sont apportées de temps à autre.
«Représentant de la Gérance» désigne les Personnes désignées par écrit par chacun des Membres de la Gérance pour
agir en leur nom pour les besoins de l'Art. 9.
«Gérant» désigne tout gérant de la Société.
«Nomination de Gérant» a la signification décrite à l'Art. 9.2 (b).
«Montant Minimum de Parts Sociales» désigne par rapport à (i) DBZ et ses Cessionnaires Autorisés considérés comme
une seule entité 15%, (ii) MS et ses Cessionnaires Autorisés considérés comme une seule entité 15%, (iii) OCINSA et ses
Cessionnaires considérés comme une seule entité 15%, et (iv) la Gérance, la propriété directe ou indirecte d'un nombre
de Parts Sociales supérieur à 15%du nombre total de Parts Sociales impayées (à l'exclusion de toutes Parts Sociales
détenues par la Société et ses Filiales) à la date de détermination.
47639
«MS» désigne MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS INC., une société dûment constituée et existant selon les
lois de New York, avec siège social à 1585 Broadway, New York, N.Y. 1036, USA
«Observateur» a la signification décrite à l'Art. 9.3 (b).
«OCINSA» désigne OCINSA, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A., une société dûment constituée et existant selon
les lois de l'Espagne avec siège social à Plaza Antonio Beltran Martinez, n
o
1, Edificio Trovador, planta 9, oficinas F-G.,
50.002 -Zaragoza, Espagne, inscrite au Registre Mercantil de Zaragoza, Tomo 1.269, Folio 1, Hoja Z-6.544.
«Associé Destinataire» a la signification décrite à l'Article 7.2 (a).
«Membre de la Gérance» désigne les membres de la gérance de la Société et des Filiales profitant d'un plan de parti-
cipation mentionné dans le Contrat de Participation des Gérants.
«Contrat d'Options» désigne le Contrat d'Option de Vente/d'Achat entre DBZ, MS et OCINSA en date du 15 janvier
2007, y compris toutes modifications y apportées de temps à autre.
«Contrat de Participation à la Sortie Conjointe» a la signification décrite à l'Article 7.3 (c).
«Associés de Sortie Conjointe Participant» a la signification décrite à l'Article 7.3 (c).
«Cessionnaire Autorisé» désigne, par rapport à tout Associé, un Affilié de cet Associé et tout Cadre acquérant des
Parts Sociales conformément au Contrat de Participation des Gérants.
«Personne» désigne tout individu, bien, personne morale, société à responsabilité limitée ou illimitée, association,
propriété, joint-venture, société anonyme, fond d'investissement, fidéicommis, union ou organisation non incorporée ou
autre groupe, entité ou organisation, y compris toute entité gouvernementale.
«Titres Préférentiels» désigne, par rapport avec toute Personne, toutes parts sociales, intérêts, participations ou autre
équivalents (cependant désignés) du capital préférentiel ou non-préférentiel, impayés à la date du Contrat ou émises
après, et comprend entre autres toutes classes et séries de ces tires préférentiels ou de préférence de cette Personne.
«Acquéreurs Proposés» a la signification décrite à l'Article 7.2 (a).
«Acquéreurs Potentiels» a la signification décrite à l'Article 7.4.
«Notification d'Acceptation DPR» a la signification décrite à l'Article 7.2 (b).
«Période d'Option DPR» a la signification décrite à l'Article 7.2 (a).
«Notification DPR» a la signification décrite à l'Article 7.2 (a).
«Offre DPR» a la signification décrite à l'Article 7.2 (a).
«Prix d'Acquisition DPR» a la signification décrite à l'Article 7.2 (a).
«Parts Sociales DPR» a la signification décrite à l'Article 7.2 (a).
«Contrat de Cession» a la signification décrite à l'Article 7.2 (d).
«Associé Cédant» a la signification décrite à l'Article 7.2 (a).
«Associé» désigne tout associé de la Société.
«Assemblée des Associés» désigne tout assemblée générale des Associés de la Société, qu'elle soit ordinaire ou ex-
traordinaire.
«Parts Sociales» désigne les parts sociales de la Société d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
«Filiale» désigne, par rapport à une Personne, toute autre Personne qui au moment de la détermination du statut de
Filiale a directement ou indirectement, par un ou plusieurs intermédiaires, le pouvoir de nommer plus de 50% des mem-
bres du Conseil de Gérance ou d'un organe équivalent ou détient plus de 50% du capital social de cette Personne.
«Gérant Remplaçant» a la signification décrite à l'Article 9.2 (b).
«Décisions exigeant la Majorité Qualifiée» désigne:
(i) approbation de tout amendement, toute modification, tout avenant à ou substitut de ces statuts;
(ii) la fusion ou consolidation de la Société résultant d'une transaction ou d'un ensemble de transactions, ou de l'ac-
quisition de la Société, utilisant le Capital Social de la Société comme prix, d'actifs (y compris capital et autres titres);
(iii) l'émission, l'accord, l'offre ou la cession par la Société de parts sociales de toute classe ou série de ses capitaux
propres ou autres titres, ou tous titres convertibles en ou susceptibles d'être exercés ou échangeables en, ou options,
garanties ou droits de toute sorte pour souscrire ou acquérir, toutes parts sociales de toute classe ou série des capitaux
propres ou autres titres, ou toute division, subdivision, recapitalisation, combinaison ou reclassification des capitaux
propres de la Société ou la conclusion de tout contrat, toute convention, tout engagement ou tout autre arrangement
par rapport à ce qui précède;
(iv) par rapport à la Société, l'autorisation ou le paiement de tout dividende ou rachat, achat ou acquisition de tout
Capital Social;
(v) l'adoption de tout plan de participation des gérants de la Société ou de toute Filiale (autre que le Contrat de
Participation des Gérants) qui prévoit l'émission de tout Capital Social de la Société ou de toute Filiale à moins de la Juste
Valeur du Marché ou qui, après émission ou exercice, représentera plus de cinq (5) pour cent du capital de la Société ou
des Filiales;
(vi) une liquidation ou dissolution volontaire de la Société ou de toute Filiale; et
47640
(vii) la reclassification d'obligations ou de titres, la restructuration sociale ou des mesures de réorganisation.
«Contrat de Sortie Conjointe» a la signification décrite à l'Article 7.3 (a).
«Période d'Option de Sortie Conjointe» a la signification décrite à l'Article 7.3 (a).
«Droit de Sortie Conjointe» a la signification décrite à l'Article 7.3 (a).
«Associé de Sortie Conjointe» a la signification décrite à l'Article 7.3 (a).
«Notification d'Acceptation de Sortie Conjointe» a la signification décrite à l'Article 7.3 (b).
«Notification de Droit de Sortie Conjointe» a la signification décrite à l'Article 7.3 (a).
«Transfert» désigne toute vente, cession, aliénation, tout don, échange, transfert, toute option, émission, vente nue,
transaction dérivée ou autre disposition de toute sorte, ou tout contrat conclu à cet effet, que ce soit à titre onéreux ou
non, volontairement ou involontairement, directement ou indirectement, de Parts Sociales de la Société ou de tout intérêt
dans cette Société.
«Transférer» signifie qu'un Transfert a eu lieu.
«Décisions de Veto» désigne:
(i) approbation de tout amendement, toute modification, tout avenant à ou substitut des statuts, documents de con-
stitution ou autres documents organisationnels de toute Filiale;
(ii) tout changement matériel dans la conduite des affaires par la Société ou toute Filiale;
(iii) l'embauche de tout Employée Clef de la Société ou de toute Filiale; à condition que le renouvellement des contrats
de travail pour un des individus actuellement travaillant dans ces fonctions ne soit pas soumis à cette disposition;
(iv) tout changement des auditeurs ou conseillers fiscaux de la Société ou de toute Filiale;
(v) la création de tout comité du Conseil de Gérance de la Société ou de toute Filiale ou l'extension ou la réduction
des pouvoirs de tout comité existant du Conseil de Gérance de la Société ou de toute Filiale;
(vi) la fusion ou consolidation de toute Filiale résultant d'une transaction ou d'un ensemble de transactions, ou de
l'acquisition de toute Filiale, utilisant le Capital Social de toute Filiale comme prix, d'actifs (y compris capital et autres
titres);
(vii) toute acquisition par la Société ou de ses Filiale, par une transaction ou une plusieurs transactions liées, d'actifs
(incluant des capitaux propres ou autres titres) à moins que cette acquisition (x) n'aboutisse pas, immédiatement après
cette acquisition, à une situation dans laquelle la Société ne sera pas capable de supporter un endettement d' un million
euros (EUR 1.000.000,-) d'endettement supplémentaire sans dépasser trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-) ou (y)
implique des paiements ou actifs totaux d'une Juste Valeur du Marché ne dépassant pas un million d'euros (EUR
1.000.000,-);
(viii) toute cession par la Société ou par toute Filiale dans le cadre d'une transaction pour laquelle la Juste Valeur du
Marché des actifs cédés dépasse un million d'euros (EUR 1.000.000,-), sauf dans le cas d'une cession exigée par décision
d'une autorité gouvernementale compétente;
(ix) l'émission, l'accord, l'offre ou la cession par toute Filiale de parts sociales de toute classe ou série de ses capitaux
propres ou autres titres, ou tous titres convertibles en ou susceptibles d'être exercés ou échangeables en, ou options,
garanties ou droits de toute sorte pour souscrire ou acquérir, toutes parts sociales de toute classe ou série des capitaux
propres ou autre titres, ou toute division, subdivision, recapitalisation, combinaison ou reclassification des capitaux pro-
pres de toute Filiale ou la conclusion de tout contrat, toute convention, tout engagement ou tout autre arrangement par
rapport à ce qui précède;
(x) par rapport à toute Filiale, l'autorisation ou le paiement de tout dividende ou rachat, achat ou acquisition de tout
Capital Social;
(xi) l'adoption de tout plan de participation des gérants de la Société ou de toute Filiale (autre que le Contrat de
Participation des Gérants) qui prévoit l'émission de tout Capital Social de la Société ou de toute Filiale à moins de la Juste
Valeur du Marché ou qui, après émission ou exercice, représentera plus de cinq (5) pour cent des capitaux propres de
la Société ou des Filiales;
(xii) l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la Société ou de l'une des Filiales conformément à la loi et
devant le tribunal compétent, la déclaration du dépôt de bilan, de sursis de paiement, ou l'incapacité de la société ou d'une
des Filiales de payer ses dettes exigibles;
(xiii) toute liquidation ou dissolution volontaire de toute Filiale;
(xiv) naissance de tout Endettement pour des sommes d'argent empruntées par la Société ou par ses Filiales, autre
qu'un Endettement qui, s'il s' ajouté à tout autre Endettement de la Société ou de ses Filiales (net de toute trésorerie
réservée uniquement au remboursement la dette) ne dépasse à aucun moment trois million d'euros (EUR 3.000.000,-);
(xv) la constitution ou mise en œuvre de toute Charge sur des actifs de la Société ou de toute Filiale représentant plus
de 10 pour cent (10%) des actifs consolidés de la Société, autre que des Charges statutaires;
(xvi) l'accord de tout prêt ou de toute avance à toute personne ou la garantie de toutes obligations de toute personne,
autre que (x) tout prêt ou toute avance (A) qui fait partie de la pratique courante des affaires de la Société ou des Filiales,
(B) dont le montant ne dépasse pas dix (10) pour cent des revenus bruts consolidés de la Société pendant les quatre
47641
derniers trimestres fiscaux pour lesquels des états financiers de la Société sont disponibles et (C) fait(e) à partir de
ressources disponibles en espèces de la Société, ou (y) toute garantie contre l'endettement d'une Filiale inférieur à trois
millions d'euros (EUR 3.000.000,-);
(xvii) l'approbation de Dépenses de Capital dépassant en total pour un exercice fiscal donné un montant égal à deux
virgule cinq (2,5) pour cent des revenus bruts consolidés de la Société pour l'année fiscale précédente; et
(xviii) la reclassification d'obligations et de titres, la restructuration sociale ou des mesures de réorganisation.
«Gérant Résignant» a la signification décrite à l'Art. 9.2 (b).»
<i>Quatrième résolutioni>
Au moment de la cession de certaines parts sociales détenues par les associés actuels de la Société à certains cadres
du groupe, l'assemblée générale décide de reconnaître ces cadres comme nouveaux associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ EUR 3.000,-.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Le Pannérer, N. Schmidt-Troje, A. Hoffmann, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 janvier 2007, vol. 316S, fol. 66, case 7. — Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 janvier 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007046311/242/1400.
(070044651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
WPP Luxembourg Gamma Four S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R.C.S. Luxembourg B 108.491.
In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth of February.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of WPP LUXEMBOURG GAMMA FOUR
S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue
Heine, in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
108.491 (the Company), incorporated on 26 May 2005 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Association C, N
o
1085 of 24 October 2005. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended
several times and for the last time on 30 October 2006 pursuant to a deed of the undersigned notary, which deed has
been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N
o
2368 of 19 December 2006.
There appeared:
WPP LUXEMBOURG GAMMA S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée)
with registered office at 6, rue Heine, in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B 79.018 (the Sole Shareholder), hereby represented by Olivier Wuidar, Avocat à la Cour,
professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The proxy from the Sole Shareholder, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the
Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the 250 shares of USD 100.- each in the share capital of the Company amounting
to USD 25,000.-.
47642
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Setting of the date of closing of the financial year of the Company that had started on 1st March 2006 on 28 February
2007, decision that the date of the closing of the Company's financial year shall be the last day of February each year and
amendment of article 14 of the articles of association of the Company to reflect these changes; and
3. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder
waives the convening notices, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and
declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that (i) the financial year of the Company that had started on 1st March 2006 shall close
on 28 February 2007 and that (ii) the date of the closing of the Company's financial year shall be the last day of February
each year.
As a consequence, the Sole Shareholder resolves to amend article 14 of the Articles which will henceforth have the
following wording:
« Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on 1st March each year and ends on the last day of
February of the following year.»
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the
Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 700.- (seven hundred Euros).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-six février.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé de WPP LUXEMBOURG GAMMA FOUR
S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.491 (la Société), constituée
le 26 mai 2005 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N
o
1085 du 24 octobre 2005. Les
statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 30 octobre 2006 suivant un
acte du notaire instrumentant, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N
o
2368 du
19 décembre 2006.
A comparu:
WPP LUXEMBOURG GAMMA S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social
au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 79.018 (l'Associé Unique), ici représentée par Maître Olivier Wuidar, Avocat à la Cour, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
La procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de
l'Associé Unique et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps
avec celui-ci.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que l'Associé Unique détient toutes les 250 parts sociales de USD 100,- chacune dans le capital social de la Société
s'élevant à USD 25.000,-;
II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
47643
2. Détermination de la date de clôture de l'exercice social de la Société ayant débuté le 1
er
mars 2006 au 28 février
2007, décision que la date de clôture de l'exercice social de la Société soit le dernier jour de février de chaque année et
modification de l'article 14 des statuts de la Société afin d'y refléter ces modifications; et
3. Divers.
III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Associé Unique renonce aux
formalités de convocation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqué et dé-
clarant avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.
<i>Seconde résolutioni>
L'Associé Unique décide que (i) l'exercice social de la Société ayant débuté le 1
er
mars 2006 sera clôturé le 28 février
2007 et que (ii) la date de clôture de l'exercice social de la Société sera le dernier jour de février de chaque année.
Par conséquent, l'Associé Unique décide de modifier l'article 14 des Statuts de telle sorte qu'il aura désormais la teneur
suivante:
« Art. 14. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
mars de chaque année et se termine dernier
jour de février de l'année suivante.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par
la Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à EUR 700,- (sept cents euros).
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la requête de la même partie comparante, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: O. Wuidar, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 2 mars 2007. REM 2007/425. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 22 mars 2007.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007046160/5770/112.
(070044604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
Aeromeccanica S.A., Société Anonyme,
(anc. Telespazio Luxembourg S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 70.876.
L'an deux mille sept, le six mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son confrère empêché,
Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier reste dépositaire du présent acte.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-
nommée TELESPAZIO LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri, inscrite
au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 70.876,
constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner en date du 13 juillet 1999, publié au Mémorial C de
1999, page 36473, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Jacques Delvaux en date du 23
octobre 2006, publié au Mémorial C de 2007, page 1472.
L'assemblée des actionnaires est présidée par M. Andrew G.D. Simms, Directeur, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire M. Pascal Verdin-Pol, employé, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur M. Dominique Audia, employé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.
47644
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'entièreté du capital social souscrit sont présents ou
dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant
à l'ordre du jour, sans convocation préalable.
II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de la dénomination sociale de la société en AEROMECCANICA S.A. et modification subséquente de
l'article 1
er
des statuts (version anglaise et traduction française) pour lui donner la teneur suivante:
Art. 1. Form, name of the company. There is hereby formed a company in Luxembourg law in the form of a société
anonyme [public limited company].
It shall exist under the corporate name of AEROMECCANICA S.A.
Art. 1
er
. Form, dénomination. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société
anonyme.
Elle existera sous la dénomination de AEROMECCANICA S.A.
2) Changement de la date de l'assemblée générale annuelle pour la porter au dernier mardi du mois de mars de chaque
année à 11.00 heures, et modification subséquente de l'article 15 des statuts (version anglaise et traduction française)
pour lui donner la teneur suivante:
Art. 15. Annual General meeting. The General Meeting shall meet ipso jure in the commune where the registered
office is located on the last Tuesday of the month of March each year at 11 a.m.. If this day is a bank holiday, the Meeting
shall take place on the first banking day thereafter at the same hour.
Art. 15. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social,
le dernier mardi du mois de mars de chaque année à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier
jour ouvrable bancaire suivant, à la même heure.
3) Dispositions transitoires:
A titre de dispositions transitoires, l'assemblée générale des actionnaires appelée à approuver les comptes annuels de
l'exercice social clos au 31 décembre 2006, se tiendra le dernier mardi du mois de mars 2007 à 11.00 heures.
4) Divers
L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé
l'ordre du jour.
Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée des actionnaires décide de changer la dénomination sociale de la société en AEROMECCANICA S.A.
et modifie en conséquence l'article 1
er
des statuts (version anglaise et traduction française) pour lui donner la teneur
suivante:
Art. 1. Form, name of the company. There is hereby formed a company in Luxembourg law in the form of a société
anonyme [public limited company].
It shall exist under the corporate name of AEROMECCANICA S.A.
Art. 1
er
. Form, dénomination. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société
anonyme.
Elle existera sous la dénomination de AEROMECCANICA S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée des actionnaires décide de changer la date de A l'assemblée générale annuelle pour la porter au dernier
mardi du mois de mars de chaque année à 11.00 heures, et modifie en conséquence l'article 15 des statuts (version anglaise
et traduction française) pour lui donner la teneur suivante:
Art. 15. Annual General meeting. The General Meeting shall meet ipso jure in the commune where the registered
office is located on the last Tuesday of the month of March each year at 11 a.m. If this day is a bank holiday, the Meeting
shall take place on the first banking day thereafter at the same hour.
Art. 15. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social,
le dernier mardi du mois de mars de chaque année à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier
jour ouvrable bancaire suivant, à la même heure.
47645
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée des actionnaires décide, à titre de dispositions transitoires, que l'assemblée générale des actionnaires
appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice social clos au 31 décembre 2006, se tiendra le dernier mardi du
mois de mars 2007 à 11.00 heures
<i>Clôturei>
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. G. D. Simms, P. Verdin-Pol, D. Audia, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, 13 mars 2007. Relation: LAC/2007/1.985. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 20 mars 2007.
J. Delvaux.
Référence de publication: 2007045762/208/88.
(070044084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2007.
Taris Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 81.088.
L'an deux mille sept, le six février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding dénommée TARIS
HOLDING S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce
à Luxembourg sous la section B et le numéro 81088,
constituée par acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 26 février 2001, publié
au Mémorial C de 2001, page 42394.
L'assemblée des actionnaires est présidée par M. Dominique Audia, employé, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mme Fabienne Perusini, employée, Luxembourg.
L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Mme Gabrielle Mingarelli, employée, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Suivant la prédite liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'entièreté du capital social, sont présents
ou dûment représentés à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer et décider sur tous les différents points figurant à l'ordre du jour.
II.- Que la société n'a pas d'emprunts obligataires.
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Abandon du statut de société holding et modification subséquente de l'article 3 des statuts, relatifs à l'objet social,
pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers.
47646
La société a également pour objet le financement direct ou indirect des activités de sa société mère et des sociétés
filiales ou affiliées de la Société, de sa société mère (le groupe) ou des autres sociétés qui la contrôlent, le tout dans les
limites légales».
2. Fixation de la date de prise d'effet sur le plan comptable.
3. Divers.
L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé
l'ordre du jour.
Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale, après avoir constaté que la société n'a pas émise d'obligations, décide d'abandonner le régime
fiscal des sociétés holding régies par la loi du 31 juillet 1929, afin d'adopter un nouvel objet social et modifie en conséquence
l'article 3 des statuts comme suit:
« Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a également pour objet le financement direct ou indirect des activités de sa société mère et des sociétés
filiales ou affiliées de la Société, de sa société mère (le groupe) ou des autres sociétés qui la contrôlent, le tout dans les
limites légales».
Suite à la présente résolution, l'assemblée décide également d'omettre le mot «holding» à l'article 1
er
des statuts.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée, réunissant tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social, décide que sur le plan comp-
table, la décision qui précède prendra effet à partir du 12 février 2007.
<i>Clôture de l'assembléei>
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: D. Audia, F. Perusini, G. Mingarelli, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, vol. 32CS, fol. 13, case 1. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2007.
J. Delvaux.
Référence de publication: 2007045763/208/80.
(070044095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2007.
Realilux S.A., Société Anonyme,
(anc. ING Lion S.A.).
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 82.504.
L'an deux mille sept, le neuf février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ING LION S.A., ayant son
siège social à L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon, R.C.S. Luxembourg section B numéro 82.504, constituée suivant acte
reçu le 8 juillet 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 478 du 23 novembre
1994.
47647
L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert, juriste, demeurant à
Luxembourg
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 1.000 (mille) actions, représentant l'intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1- Changement de la dénomination de ING LION S.A. en REALILUX S.A.
2- Démissions des administrateurs, à savoir Messieurs Gusbin et Senepart et de l'administrateur et administrateur-
délégué Monsieur Coucke, et du commissaire aux comptes, Monsieur Ikhtiar et décharge jusqu'au 8 décembre 2006;
3- Création de deux catégories d'Administrateurs A et B et modification conséquente des pouvoirs de signatures
engageant la société
4- Nominations de Messieurs Luc et Marc Liegeois en tant qu'Administrateurs de catégorie A et de Messieurs Jean-
Marc Faber et Christophe Mouton en tant qu'Administrateurs de catégorie B
5- Nomination de la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER & CIE S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, au poste de Commissaire aux Comptes de la société
6- Transfert du siège social au 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en REALILUX S.A. et de modifier en conséquence l'article
1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination actuelle REALILUX S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de prendre acte des démissions des administrateurs et administrateurs-délégués en place savoir
Messieurs Gusbin, Senepart et Coucke, ainsi que de la démission du commissaire aux comptes Monsieur Ikhtiar, et leur
consent décharge pour leurs activités dans le cadre de leur missions respectives jusqu'au 8 décembre 2006.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide que le conseil d'administration sera composé de deux catégories d'administrateurs dénommés
administrateurs de catégorie A et administrateurs de catégorie B.
L'assemblée décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non divisé en
administrateurs de catégorie A et administrateurs de catégorie B, pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.»
La société décide en outre de modifier les pouvoirs de signature pouvant engager la société en modifiant le deuxième
alinéa de l'article 6 comme suit:
« Art. 6. al. 2. La société se trouve engagée par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un
administrateur de catégorie B.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans à compter des présentes:
<i>Administrateurs de catégorie A:i>
Monsieur Luc Liégeois, né à Kinshasa, le 24 mai 1971, demeurant au 12, Bosweidelaan B-1640 Sint-Genesius-Rode
Monsieur Marc Liégeois, né à Kinshasa, le 22 mai 1968, demeurant au 41, avenue Eugène Demolder B-1030 Schaerbeek
<i>Administrateurs de catégorie B:i>
Monsieur Jean-Marc Faber, né à Luxembourg, le 7 avril 1966 demeurant à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
Monsieur Christophe Mouton, né à Saint-Mard (Belgique), le 20 novembre 1971, demeurant à L-2146 Luxembourg,
63-65, rue de Merl.
47648
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans à compter des
présentes:
FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER & CIE S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
L'assemblée décide en conséquence de modifier le deuxième alinéa de l'article 1
er
comme suit:
«Le siège social est établi à Luxembourg».
<i>Fraisi>
Les fiais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cent Euro.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Galiotto, F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2007, vol. 157S, fol. 91, case 4. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007045765/211/84.
(070044105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2007.
Charterhouse CP1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 537.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 114.478.
In the year two thousand and seven, on the thirteenth of March.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appear:
CCP VII LP N
o
1.1, an English Limited Partnership having its registered office at Warwick Court, Paternoster Square,
London EC4M 7DX, United Kingdom, registered with the Companies House under number LP008194; acting through
its general partner, CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED, a Private Limited Company incorporated
under British law, having its registered office at Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M 7DX, United King-
dom, registered with the Companies House under number 2197301,
CCP VII LP N
o
1.2, an English Limited Partnership having its registered office at Warwick Court, Paternoster Square,
London EC4M 7DX, United Kingdom, registered with the Companies House under number LP008195, acting through
its general partner, CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED, prenamed,
CCP VII LP N
o
2.1, an English Limited Partnership having its registered office at Warwick Court, Paternoster Square,
London EC4M 7DX, United Kingdom, registered with the Companies House under number LP008196, acting through
its general partner, CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED, prenamed,
CCP VII LP N
o
2.2, an English Limited Partnership having its registered office at Warwick Court, Paternoster Square,
London EC4M 7DX, United Kingdom, registered with the Companies House under number LP008197, acting through
its general partner, CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED, prenamed,
CCP VII CO-INVESTMENT LP A, B, C, D, E, F and G, English Limited Partnerships having their registered office at
Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M 7DX, United Kingdom, registered with the Companies House, re-
spectively under numbers LP00248, LP008250, LP008251, LP008252, LP010460, LP010459, acting through their general
partner, CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED, prenamed,
CCP VII GmbH & CO. KG, a German Limited Partnership, having its registered office at Mainzer Landstrasse 46, 60325
Frankfurt-am-Main, Germany, registered with the Frankfurt am Main Commercial Court under number HRA 30617,
Here represented by Mr Grégoire Fraisse, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
by virtue of six proxies established on March 9, 2007
The said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
47649
Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité limitée»)
existing in Luxembourg under the name of CHARTERHOUSE CP1 S.à r.l. (the «Company»), with registered office at 1
B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B, under
number 114.478, incorporated by a deed of the undersigned notary of February 13, 2006, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (hereafter the «Mémorial C») n
o
984 of May 19, 2006 and whose articles have been
last amended pursuant to a deed of the undersigned notary of June 16, 2006, published in the Mémorial C n
o
1942 of
October 17, 2006;
II. The Company's share capital is fixed at five hundred thirty-seven thousand five hundred Euro (€ 537,500.-) divided
into twenty-one thousand five hundred (21,500) shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.
III. The shareholders resolve to transfer the registered office of the Company from 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
to 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
IV. Pursuant to the above transfer of registered office, the first paragraph of article 5 of the Company's articles of
association is amended and shall henceforth read as follows:
« Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le treize mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
CCP VII LP N
o
1.1, Limited Partnership de droit britannique ayant son siège social à Warwick Court, Paternoster
Square, London EC4M 7DX, United Kingdom, immatriculée à la Companies House sous le numéro LP008194, représentée
par son associé commanditaire, CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED, Private Limited Company de
droit britannique, ayant son siège social à Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M 7DX, United Kingdom,
immatriculée à la Companies House sous le numéro 2197301,
CCP VII LP N
o
1.2, Limited Partnership de droit britannique ayant son siège social à Warwick Court, Paternoster
Square, London EC4M 7DX, United Kingdom, immatriculée à la Companies House sous le numéro LP008195, représentée
par son associé commanditaire, CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED, précitée,
CCP VII LP N
o
2.1, Limited Partnership de droit britannique ayant son siège social à Warwick Court, Paternoster
Square, London EC4M 7DX, United Kingdom, immatriculée à la Companies House sous le numéro LP008196, représentée
par son associé commanditaire, CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED, précitée,
CCP VII LP N
o
2.2, Limited Partnership de droit britannique ayant son siège social à Warwick Court, Paternoster
Square, London EC4M 7DX, United Kingdom, immatriculée à la Companies House sous le numéro, représentée par son
associé commanditaire, CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED, précitée,
CCP VII CO-INVESTMENT LP A, B, C, D, E, F et G, Limited Partnerships de droit britannique ayant leur siège social
à Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M 7DX, United Kingdom, immatriculées à la Companies House sous
les numéros respectifs LP00248, LP008250, LP008251, LP008252, LP010460, LP010459, représentées par leur associé
commanditaire, CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED, précitée
CCP VII GmbH & CO. KG, société en commandite simple de droit allemand ayant son siège social à Mainzer Lands-
trasse 46, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne, immatriculée au Tribunal de Commerce de Francfort sous le numéro
HRA 30617,
ici représentées par M. Grégoire Fraisse, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Sennin-
gerberg,
en vertu de six procurations données le 9 mars 2007.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
47650
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparantes sont les associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
CHARTERHOUSE CP1 S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1 B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 114.478, constituée suivant acte du
notaire soussigné reçu en date du 13 février 2006 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après
le «Mémorial C») n
o
984 du 19 mai 2006 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 16 juin 2006 publié au Mémorial C n
o
1942 du 17 octobre 2006.
II. Le capital social de la Société est fixé à cinq cent trente-sept mille cinq cents Euro (€ 537.500,-) divisé en vingt-et-
un mille cinq cents (21.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.
III. Les associés décident de transférer le siège social de la Société du 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
IV. Suite au transfert du siège social ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié
pour avoir désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état
et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: G. Fraisse, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2007, Relation: LAC/2007/2354. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007045773/211/117.
(070044276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2007.
Logosworld Technology Research G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4305 Esch-sur-Alzette, 16, rue Marcel Reuland.
R.C.S. Luxembourg B 125.526.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsieben, den dreißigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Herr Axel Angeli, Informatiker, geboren in Mannheim, (Bundesrepublik Deutschland), am 23. Mai 1961, wohnhaft in
D-68782 Brühl, Scheffelstrasse 23, (Bundesrepublik Deutschland).
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche
er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie
den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die IT-Beratung.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist LOGOSWORLD TECHNOLOGY RESEARCH G.m.b.H..
47651
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Esch an der Alzette.
Er kann an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesell-
schafter.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in hundert (100) An-
teile von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter Herrn
Axel Angeli, Informatiker, wohnhaft in D-68782 Brühl, Scheffelstrasse 23, (Bundesrepublik Deutschland), gezeichnet wur-
den.
Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-
schaftsrechts festgelegt ist.
Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen
sowie am Gewinn.
Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter,
bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.
Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden muss.
Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäß Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des
Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit
eines Gesellschafters.
Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente
pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könn-
ten.
Art. 11. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein
müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.
Art. 12. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.
Art. 13. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten
vertreten lassen.
Art. 14. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten,
akzeptiert werden.
Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche
mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.
Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder
Satzung der
Référence de publication: 2007046016/231/61.
(070044161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2007.
WPP Luxembourg Holdings Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.194.774.000,00.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R.C.S. Luxembourg B 106.206.
In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth of February.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of WPP LUXEMBOURG HOLDINGS
THREE S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at
6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number
B 106.206 (the Company), incorporated on 14 February 2005 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary
residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Association C - N° 598 of 21 June 2005. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended
several times and for the last time on 12 December 2006 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, which
deed has not been published yet in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association.
47652
There appeared:
WPP LUXEMBOURG HOLDINGS TWO S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée) with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under the number B 99.124 (the Sole Shareholder), hereby represented by Olivier Wuidar, Avocat
à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The proxy from the Sole Shareholder, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the
Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the 11,947,740, shares of USD 100.- each in the share capital of the Company
amounting to USD 1,194,774,000.-.
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Setting of the date of closing of the financial year of the Company that had started on 1 March 2006 on 28 February
2007, decision that the date of the closing of the Company's financial year shall be the last day of February each year and
amendment of article 14 of the articles of association of the Company to reflect these changes; and
3. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder
waives the convening notices, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and
declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that (i) the financial year of the Company that had started on 1st March 2006 shall close
on 28 February 2007 and that (ii) the date of the closing of the Company's financial year shall be the last day of February
each year.
As a consequence, the Sole Shareholder resolves to amend article 14 of the Articles which will henceforth have the
following wording:
« Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on 1st March each year and ends on the last day of
February of the following year.»
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the
Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 700.- (seven hundred Euro).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-six février.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé de WPP LUXEMBOURG HOLDINGS
THREE S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.206 (la
Société), constituée le 14 février 2005 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence alors à Mersch,
Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 598 du
21 juin 2005. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 12 décembre
2006 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, susmentionné, lequel acte n'a pas encore été publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
A comparu:
WPP LUXEMBOURG HOLDINGS TWO S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec
siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 99.124 (l'Associé Unique), ici représentée par Maître Olivier Wuidar, Avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
47653
La procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de
l'Associé Unique et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps
avec celui-ci.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que l'Associé Unique détient toutes les 11.947.740 parts sociales de USD 100,- chacune dans le capital social de la
Société s'élevant à USD 1.194.774.000,-;
II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Détermination de la date de clôture de l'exercice social de la Société ayant débuté le 1
er
mars 2006 au 28 février
2007, décision que la date de clôture de l'exercice social de la Société soit le dernier jour de février de chaque année et
modification de l'article 14 des statuts de la Société afin d'y refléter ces modifications; et
3. Divers.
III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Associé Unique renonce aux
formalités de convocation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqué et dé-
clarant avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.
<i>Seconde résolutioni>
L'Associé Unique décide que (i) l'exercice social de la Société ayant débuté le 1
er
mars 2006 sera clôturé le 28 février
2007 et que (ii) la date de clôture de l'exercice social de la Société sera le dernier jour de février de chaque année.
Par conséquent, l'Associé Unique décide de modifier l'article 14 des Statuts de telle sorte qu'il aura désormais la teneur
suivante:
« Art. 14. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
mars de chaque année et se termine dernier
jour de février de l'année suivante.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par
la Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à EUR 700,- (sept cents euros).
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la requête de la même partie comparante, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: O. Wuidar, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 2 mars 2007. REM/2007/418. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 27 mars 2007.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007046141/5770/112.
(070044586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
WPP Luxembourg Gamma Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R.C.S. Luxembourg B 108.492.
In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth of February.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of WPP LUXEMBOURG GAMMA THREE
S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue
Heine, in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
108.492 (the Company), incorporated on 26 May 2005 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
47654
Association C, N
o
1086 of 24 October 2005. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended
several times and for the last time on 30 October 2006 pursuant to a deed of the undersigned notary, which deed has
been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N
o
2405 of 27 December 2006.
There appeared:
WPP LUXEMBOURG GAMMA S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée)
with registered office at 6, rue Heine, in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B 79.018 (the Sole Shareholder), hereby represented by Olivier Wuidar, Avocat à la Cour,
professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The proxy from the Sole Shareholder, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the
Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the 250 shares of USD 100.- each in the share capital of the Company amounting
to USD 25,000.-.
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Setting of the date of closing of the financial year of the Company that had started on 1st March 2006 on 28 February
2007, decision that the date of the closing of the Company's financial year shall be the last day of February each year and
amendment of article 14 of the articles of association of the Company to reflect these changes; and
3. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder
waives the convening notices, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and
declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that (i) the financial year of the Company that had started on 1st March 2006 shall close
on 28 February 2007 and that (ii) the date of the closing of the Company's financial year shall be the last day of February
each year.
As a consequence, the Sole Shareholder resolves to amend article 14 of the Articles which will henceforth have the
following wording:
« Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on 1st March each year and ends on the last day of
February of the following year.»
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the
Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 700.- (seven hundred Euros).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-six février.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé de WPP LUXEMBOURG GAMMA THREE
S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.492 (la Société), constituée
le 26 mai 2005 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N
o
1086 du 24 octobre 2005. Les
statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 30 octobre 2006 suivant du,
notaire instrumentant, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N
o
2405 du 27
décembre 2006.
47655
A comparu:
WPP LUXEMBOURG GAMMA S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social
au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 79.018 (l'Associé Unique), ici représentée par Maître Olivier Wuidar, Avocat à la Cour, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
La procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de
l'Associé Unique et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps
avec celui-ci.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que l'Associé Unique détient toutes les 250 parts sociales de USD 100,- chacune dans le capital social de la Société
s'élevant à GBP 25.000,-;
II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Détermination de la date de clôture de l'exercice social de la Société ayant débuté le 1
er
mars 2006 au 28 février
2007, décision que la date de clôture de l'exercice social de la Société soit le dernier jour de février de chaque année et
modification de l'article 14 des statuts de la Société afin d'y refléter ces modifications; et
3. Divers.
III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Associé Unique renonce aux
formalités de convocation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqué et dé-
clarant avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.
<i>Seconde résolutioni>
L'Associé Unique décide que (i) l'exercice social de la Société ayant débuté le 1
er
mars 2006 sera clôturé le 28 février
2007 et que (ii) la date de clôture de l'exercice social de la Société sera le dernier jour de février de chaque année.
Par conséquent, l'Associé Unique décide de modifier l'article 14 des Statuts de telle sorte qu'il aura désormais la teneur
suivante:
« Art. 14. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
mars de chaque année et se termine dernier
jour de février de l'année suivante.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par
la Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à EUR 700,- (sept cents euros).
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la requête de la même partie comparante, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: O. Wuidar, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 2 mars 2007. REM 2007/424. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 22 mars 2007.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007046163/5770/112.
(070044620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
European Retail Investment Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 247.000,00.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 110.901.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
47656
Luxembourg, le 27 mars 2007.
G. Lecuit
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007046229/220/13.
(070044848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
Visualsound S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 89.382.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2007.
G. Lecuit
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007046230/220/12.
(070044839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
Galatea Lux Two S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.602.850,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 111.542.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
41798 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007046234/211/12.
(070044922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
Mettle Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: ZAR 649.260,00.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 83.303.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45859 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007046233/211/12.
(070044917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
Gax Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 90, rue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 115.849.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2007.
G. Lecuit
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007046231/220/12.
(070044832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
47657
Norsk Vekst Secondary S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 111.684.
DISSOLUTION
In the year two thousand seven, on the eighth day of March.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Jorrit Crompvoets, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of NORSK VEKST SECONDARY AS, a private company organised under the laws
of Norway, registered with the Companies Register under number 988 521 388, having its registered office at Roald
Amundsens gate, 6, NO-0110 Oslo, Norway,
by virtue of a proxy given on March 6, 2007.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation NORSK VEKST SECONDARY, S.à r.l., having its principal office in L-2636 Luxembourg, 12, rue
Léon Thyes, has been incorporated pursuant to a notarial deed dated on October 19, 2005, published in the Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations number 309 of February 11, 2006;
- that the capital of the corporation NORSK VEKST SECONDARY, S.à r.l. is fixed at twelve thousand and five hundred
Euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euros
(EUR 25.-) each, fully paid;
- that NORSK VEKST SECONDARY AS has become owner of the shares and has decided to dissolve the company
NORSK VEKST SECONDARY, S.à r.l. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;
- that NORSK VEKST SECONDARY AS, being sole owner of the shares and liquidator of NORSK VEKST SECON-
DARY S.à r.l., declares:
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume
the obligation to pay for such liabilities;
- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
with the result that the liquidation of NORSK VEKST SECONDARY S.à r.l., is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2636 Luxembourg,
12, rue Léon Thyes.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le huit mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Jorrit Crompvoets, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de NORSK VEKST SECONDARY AS, une société de droit norvégien,
inscrite au Registre des Sociétés sous le numéro 988.521.388, ayant son siège social à Roald Amundsens gate, 6, NO-0110
Oslo, Norvège,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 6 mars 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
47658
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société NORSK VEKST SECONDARY S.à r.l., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes,
a été constituée suivant acte notarié, en date du 19 octobre 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
numéro 309 du 11 février 2006;
- que le capital social de la société NORSK VEKST SECONDARY S.à r.l. s'élève actuellement à douze mille cinq cents
Euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de
vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées;
- que NORSK VEKST SECONDARY AS, étant devenue seule propriétaire des parts sociales dont s'agit, a décidé de
dissoudre et de liquider la société à responsabilité limitée NORSK VEKST SECONDARY S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute
activité;
- que NORSK VEKST SECONDARY AS, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société NORSK VEKST SE-
CONDARY S.à r.l., qu'en tant qu'associé unique, déclare:
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-
vocablement l'obligation de les payer,
- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associé unique;
de sorte que la liquidation de la société NORSK VEKST SECONDARY S.à r.l. est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants, pour l'exercice de leurs mandats;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2636 Luxembourg,
12, rue Léon Thyes;
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: J. Crompvoets, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007. LAC/2007/1741. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007046207/220/85.
(070044882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
Polskilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 60.307.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2007.
<i>Pour POLSKILUX S.A.
i>P. Toussaint / E. Magrini
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007047593/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, réf. LSO-CC07157. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070044787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
Polskilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 60.307.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
47659
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2007.
<i>Pour POLSKILUX S.A.
i>P. Toussaint / E. Magrini
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007047595/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, réf. LSO-CC07155. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070044786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
Logon S.I. Luxembourg, Logon Solution Integrator Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.
R.C.S. Luxembourg B 70.719.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 mars 2007.
<i>Pour la société
i>M
e
M. Decker
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007047610/241/13.
(070044773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
H.S.E. S.à r.l., Helicopters Services Europe, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 66.311.
Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007047611/6312/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, réf. LSO-CC07109. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070044823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
H.S.E. S.à r.l., Helicopters Services Europe, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 66.311.
Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007047613/6312/13.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007, réf. LSO-CC07112. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070044821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
Gesellchen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6790 Grevenmacher, 7, rue des Tanneurs.
R.C.S. Luxembourg B 94.517.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
47660
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007047631/3342/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2007, réf. LSO-CD00661. - Reçu 93 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070044980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
Gesellchen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6790 Grevenmacher, 7, rue des Tanneurs.
R.C.S. Luxembourg B 94.517.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007047633/3342/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2007, réf. LSO-CD00667. - Reçu 93 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070044977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
Wintergames S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 120.095.
RECTIFICATIF
In the year two thousand six, on the twenty-ninth day of the month of December,
There appeared M
e
Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 2 November
2006 granted by the shareholder of WINTERGAMES S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of
Luxembourg, with its registered office at 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B, number 120.095, incorporated by
deed of the undersigned notary on 14th September 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations («Mémorial») of 18th November 2006, Number 2158.
The appearing party requested the notary to record as follows: the present deed is passed in order to rectify form
errors (erreurs matérielles) which occurred in the deed n
o
44723 recording the minutes of the extraordinary general
meeting of the sole shareholder of 2 November 2006 of WINTERGAMES S.à r.l., recorded at Luxembourg A.C. on
November 6th, 2006, Vol. 155S Fol. 95 Case 12.
In such Deed,
- in paragraph 3 on page 1 the reference to the deed incorporating the Company must be read as follows: «incorporated
by deed of the undersigned notary, on 14th September 2006»; and
- in the agenda, item 1), in the first resolution as well as in the restated article 11 in the first resolution the reference
to the first accounting year must be read as follows: «the first accounting year which has started on 14th September
2006».
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at thousand euros.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that this deed is drafted in English
followed by a French translation; in case of divergences between the English and French version, the English version will
be prevailing.
Done in Luxembourg on the day beforementioned.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-neuf décembre.
A comparu M
e
Toinon Hoss, maître en droit, residant à Luxembourg, selon une procuration datée du 2 novembre
2006 donnée par l'associé de WINTERGAMES S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social à 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg, enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés du Luxembourg Section B sous le numéro B 120.095, constituée suivant acte reçu du notaire
47661
soussigné en date du 14 septembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»)
numéro 2158 du 18 novembre 2006.
La personne comparante a requis le notaire d'acter ce qui suit: le présent acte a été fait afin de rectifier des erreurs
matérielles s'étant produites se rapportant à l'acte n
o
44723 en date du 2 novembre 2006 transcrivant le procès-verbal
de l'assemblée générale extraordinaire de l' unique associé de WINTERGAMES S.à r.l., enregistré à Luxembourg A.C., le
6 novembre 2006, Vol. 155S Fol. 95 Case 12.
Dans l'acte passé,
- au troisième paragraphe de la première page la référence à l'acte de constitution de la Société doit se lire comme
suit: «constituée le 14 septembre 2006 par acte du notaire soussigné»; et
- à l'ordre du jour, point 1), à la première résolution et au nouvel article 11 tel qu'énoncé dans la première résolution
la référence à l'année comptable doit se lire comme suit: «la première année sociale qui a commencé le 14 septembre
2006».
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, ou changements sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à
sa charge, en raison des présentes sont évalués à mille euros.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une
version française; en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite par le notaire instrumentant, la comparante a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: T. Hoss, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 47 Case 10.— Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, 15 février 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007046257/211/63.
(070044940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
Formedia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 40, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 63.052.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007047620/3342/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2007, réf. LSO-CD00741. - Reçu 95 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070044937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
Grund und Boden G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6650 Wasserbillig, 34, rue des Vignes.
R.C.S. Luxembourg B 95.335.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007047619/3342/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2007, réf. LSO-CD00757. - Reçu 93 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070044965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
47662
Grund und Boden G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6650 Wasserbillig, 34, rue des Vignes.
R.C.S. Luxembourg B 95.335.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007047616/3342/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2007, réf. LSO-CD00758. - Reçu 93 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070044960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
SPL WorldGroup B.V., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 110.313.
In the year two thousand and seven, on the thirteenth day of March.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Mr Marc Elvinger, maître en droit, lawyer of ARENDT&MEDERNACH, LUXEMBOURG, residing in Luxembourg, duly
appointed as attorney of SPL WorldGroup B.V. (the «Company»), a société à responsabilité limitée, having its principal
place of business at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies'
register under section B number 110.313, pursuant to a notarial shareholders resolution dated 6 March 2007 in order
to reiterate and formalize the resolutions taken by the shareholders in Amsterdam, pursuant to a notarial deed of the
notary Johannes Cornelis Christiaan Paans on 27 February 2007 resolving on the dissolution and liquidation of the Com-
pany and the appointment of AIM SERVICES S.à r.l., as liquidator,
The notarial shareholders resolutions, as of 27 February 2007 and 6 March 2007 passed in front of the notary Johannes
Cornelis Christiaan Paans in Amsterdam shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.
The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state his declarations as follows:
1) The Company has been incorporated in the Netherlands pursuant to a deed of the notary Hendrik van Wilsum,
Esq, residing in Amsterdam, dated 28 March 1994, which principal establishment has been transferred to Luxembourg in
accordance with a deed of the notary, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on 1
August 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 20 December 2005, number 1416.
2) The general meeting of shareholders of the Company decided to dissolve the Company on 27 February 2007, before
a civil-law notary in Amsterdam.
3) As a consequence of the above taken resolution, the shareholders decided to appoint AIM SERVICES S.à r.l., a
société à responsabilité limitée, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered
with the Luxembourg trade and companies' register under number B 74.676, as liquidator of the Company and to grant
the liquidator the following powers:
The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the Luxembourg law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended.
The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 without requesting the authorization of the
general meeting in the cases in which it is requested.
The liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all
in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of
all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such
part of its powers it determines and for the period it will fix.
The liquidator may distribute the Company's assets to the partners in cash or in kind to his willingness in the proportion
of their participation in the capital.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing known to the notary by name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
47663
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le treize mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
A comparu:
M. Marc Elvinger, maître en droit, avocat d'ARENDT&MEDERNACH, LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg,
dûment nommée mandataire de: SPL WorldGroup B.V. une société à responsabilité limitée ayant principal établissement
au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous la section B numéro 110.313, à la suite d'une décision notariée des associés à Amsterdam datant du 6 mars 2007, à
la suite d'un acte notarié datant du 27 février 2007 décidant de la dissolution et de la liquidation et de la nomination de
AIM SERVICES S.à r.l. comme liquidateur.
La décision notariée des associés en date du 27 février 2007 et du 6 mars 2007 passées devant le notaire Johannes
Cornelis Christiaan in Amsterdam resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l'enregistrement.
Le comparant, agissant en ladite qualité a pris les résolutions suivantes:
1) La société a été constituée aux Pays-Bas suivant acte reçu par le notaire Hendrik van Wilsum, Esq, alors de résidence
à Amsterdam en date du 28 Mars 1994, dont le l'établissement principal a été transféré au Luxembourg conformément
à un acte reçu par le notaire Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 1
er
août
2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 20 décembre 2005, sous le numéro 1416.
2) L'assemblée générale des associés a décidé de dissoudre la Société le 27 février 2007 devant un notaire à Amsterdam.
3) En conséquence de la résolution ci-dessus, les associés ont décidé de nommer AIM SERVICES S.à r.l, une société à
responsabilité limitée, ayant son siège social au 8, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.676, en tant que liquidateur de la Société et de lui conférer
les pouvoirs suivants:
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus tel que prévu aux articles 144 à 148 bis de la loi luxembourgeoise du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 sans demander l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où cette autorisation serait requise.
Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les
droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes
les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres charges.
Le liquidateur n'a pas à faire l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs
mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.
Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté
en fonction de leur participation au capital.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Elvinger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2007, Relation: LAC/2007/2346. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Joseph.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007046196/211/94.
(070044920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
47664
Aeromeccanica S.A.
Charterhouse CP1 S.à r.l.
D.B. Zwirn Rinol Holdings Offshore S.à r.l.
European Retail Investment Holding S.à r.l.
Formedia S.à r.l.
Galatea Lux Two S.àr.l.
Gax Technologies S.A.
Gesellchen S.à r.l.
Gesellchen S.à r.l.
Grund und Boden G.m.b.H.
Grund und Boden G.m.b.H.
Helicopters Services Europe
Helicopters Services Europe
ING Lion S.A.
Logon Solution Integrator Luxembourg
Logosworld Technology Research G.m.b.H.
Mettle Luxembourg S.à r.l.
Norsk Vekst Secondary S.à r.l.
Polskilux S.A.
Polskilux S.A.
RCR Industrial Flooring S.à r.l.
Realilux S.A.
SPL WorldGroup B.V.
Taris Holding SA
Telespazio Luxembourg S.A.
Visualsound S.A.
Wintergames S.à r.l.
WPP Luxembourg Gamma Four S.à r.l.
WPP Luxembourg Gamma Three S.à r.l.
WPP Luxembourg Holdings Three S.à r.l.