logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 861

11 mai 2007

SOMMAIRE

3 Ccom LUXEMBOURG S.A.  . . . . . . . . . . .

41309

3 H S.A. Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41321

Americourt S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41308

Balder S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41328

BCG Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41321

Creditanstalt Derivatives Trust . . . . . . . . . .

41307

D.B. Zwirn Asia Pacific LP (Lux) S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41299

Fidulor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41320

Fifof 2 S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41290

Financière Européenne S.A. . . . . . . . . . . . . .

41319

Fornebulux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41319

Gemplus International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

41309

Glas Moske Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . .

41318

Hal Finance Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .

41317

Hal Finance Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .

41321

HAL Investments Luxembourg S.A.  . . . . .

41318

HAL Investments Luxembourg S.A.  . . . . .

41319

International Hotel Licensing Company S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41285

Investing Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

41319

Luxfly S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41308

Mousel et Klein S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41327

NewTel S.A. et Cie S.E.C.S.  . . . . . . . . . . . . .

41318

NewTel S.A. et Cie S.E.C.S.  . . . . . . . . . . . . .

41328

NH Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41320

Omega Investment Corporation S.A.  . . . .

41317

Palais des Parfums S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

41326

Parfumerie Gisèle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41287

Parmeria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41320

Partelcom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41288

PATRIZIA Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

41282

Resources Services Holdings S.à r.l. . . . . . .

41328

Sagittarius Investissements S.A.  . . . . . . . . .

41320

Skuld Re II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41327

Société luxembourgeoise de Leasing BIL-

LEASE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41318

Technologies Industrielles Européennes

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41328

Tipi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41308

Union & Power S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41284

Windpark Op Der Hei AG  . . . . . . . . . . . . . .

41321

Zirkon S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41289

41281

PATRIZIA Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 122.906.

Im Jahr zweitausend und sieben, am zweiundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

PATRIZIA PROJEKT 170 GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in Fuggerstrasse

26, D-86150 Augsburg, eingetragen im Handelsregister B von Augsburg unter Blattnummer 21603, hier rechtmäßig ver-
treten  durch  Andreas  Heinzmann,  Rechtsanwalt,  mit  Wohnsitz  in  Luxemburg,  im  Wege  einer  am  21.  Februar  2007
privatschriftlich erteilten Vollmacht.

Die von dem alleinigen Anteilsinhaber ausgestellte Vollmacht, welche von der anwesenden Partei und dem Notar ne

varietur paraphiert wurde, bleibt der Urkunde beigeheftet, um zusammen mit dieser registriert zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben beschrieben, erklärt dann wie folgt:
I. Dass sie der alleinige Anteilsinhaber von PATRIZIA LUXEMBOURG S.àr.l. ist, einer «société à responsabilité limitée»

mit Sitz in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der
Nummer B 122906 (die «Gesellschaft») gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am
27. November 2006, die noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht worden ist; die
Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 21.
Dezember 2006, die noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht worden ist.

II.  Dass  das  Gesellschaftskapital  der  Gesellschaft  vierundfünfzig  millionen  einhundertzwanzigtausend  Euro  (€

54.120.000,-) beträgt, eingeteilt in zwei M;illionen einhundertvierundsechzigtausend achthundert (2.164.800) Anteile von
je fünfundzwanzig EURO (€ 25.-).

III. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Abänderung von Artikel 13 der Satzung bezüglich der Erteilung von Einzelvertretungsbefugnis für jeden bestellten

Geschäftsführer auch für den Fall, dass mehrere Geschäftsführer bestellt sind.

2. Bestellung als neue Geschäftsführer von Herrn Dr. Bernhard Engelbrecht, Diplom-Kaufmann, geboren in München,

am 21. Dezember 1967 mit beruflicher Anschrift in 4, Grand Rue, L-1660 Luxemburg sowie von Herrn Dr. Georg Erd-
mann, Diplom-Kaufmann, geboren in Opladen am 12. Juli 1970 mit beruflicher Anschrift in Fuggerstrasse 26, D-86150
Augsburg.

3. Abberufung des bisherigen alleinigen Geschäftsführers Herrn Alexander Keller, privater Angestellter, geboren in

Rostoch, am 4. August 1977 mit beruflicher Anschrift in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg.

4. Die koordinierte Satzung der Gesellschaft in Zukunft mit der deutschen Version zu beginnen.
Der oben benannte alleinige Anteilsinhaber der Gesellschaft hat nun den Notar gebeten, folgende Beschlüsse aufzu-

nehmen und zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Anteilsinhaber beschließt, Artikel 13 der Satzung abzuändern um diesem folgenden Wortlaut zu geben:
« Art. 13. Die Gesellschaft wird rechtlich in jeder Hinsicht durch die Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden.

Dies gilt auch für den Fall, dass mehrere Geschäftsführer bestellt sind, es sei denn, dass eine gesonderte Entscheidung
getroffen wurde, durch welche die Zeichnungs- oder Vertretungsbefugnis nach Artikel 10 dieser Satzung durch Entschei-
dung des Geschäftsführers an andere Personen delegiert wurde.»

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Anteilsinhaber beschließt die Bestellung als neue Geschäftsführer von Herrn Dr. Bernhard Engelbrecht,

Diplom-Kaufmann, geboren in München, am 21. Dezember 1967 mit beruflicher Anschrift in 4, Grand Rue, L-1660 Lu-
xemburg sowie von Herrn Dr. Georg Erdmann, Diplom-Kaufmann, geboren in Opladen am 12. Juli 1970 mit beruflicher
Anschrift in Fuggerstrasse 26, D-86150 Augsburg.

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Anteilsinhaber beschließt die Abberufung des bisherigen alleinigen Geschäftsführers Herrn Alexander

Keller, privater Angestellter, geboren in Rostoch, am 4. August 1977 mit beruflicher Anschrift in 73, Côte d'Eich, L-1450
Luxemburg.

<i>Vierter Beschluss

Der alleinige Anteilsinhaber beschließt die koordinierte Satzung der Gesellschaft in Zukunft mit der deutschen Version

zu beginnen.

41282

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache verstehen und sprechen kann, erklärt, dass die vorstehende

Urkunde auf Verlangen der Partei auch in die englische Sprache übersetzt worden ist. Die Parteien legen fest, dass im
Falle von Widersprüchen zwischen beiden Versionen, die deutsche Version Vorrang hat.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem diese Urkunde der erschienenen Person, welche dem Notar durch Vorname, Name, Stand und Wohnort

bekannt ist, vorgelesen wurde, hat diese Person zusammen mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.

Follows the English version:

In the year two thousand and seven, on the twenty second day of February.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PATRIZIA PROJEKT 170 GmbH, a company organised under the laws of Germany with registered office at Fugger-

strasse 26, D-86150 Augsburg, registered with the trade and companies register of Augsburg under number 21603, here
represented by Andreas Heinzmann, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated February 21,
2007 given under private seal.

Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary and shall be attached to

the present deed for the purpose of registration.

The above named party, represented as mentioned above, declares:
I. That it is the sole shareholder of PATRIZIA LUXEMBOURG S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» with regis-

tered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under registration number B 122906 (the «Company»), incorporated by deed of the undersigned notary on November
27, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations; the articles of association have been
amended by deed of the undersigned notary on December 21, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

II. That the Company's share capital is set at fifty four million one hundred twenty thousand euro (€ 54,120,000.-)

represented by two million one hundred sixty four thousand eight hundred (2.164.800) shares of twenty five euro (€
25.-) each.

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Amendment of Article 13 of the Articles of Incorporation to reflect that even in case of several managers of the

Company it shall be bound by the signature of one manager.

2. Appointment as manager of the Company of both Mr Dr. Bernhard Engelbrecht, Diplom-Kaufmann, born in Munich,

on 21st December 1967, residing professionally at 4, Grand Rue, L-1660 Luxembourg and of Mr Dr. Georg Erdmann,
Diplom-Kaufmann, born in Opladen, on 12th July 1970, residing professionally at Fuggerstrasse 26, D-86150 Augsburg.

3. Removal from office of Mr Alexander Keller, private employee, born in Rostoch, on 4th August 1977, residing

professionally at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

4. To commence the coordinated articles of the Company with their German version.
After this had been set forth, the above named shareholder of the Company, representing the entire capital of the

Company, now requests the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First Resolution

Decision of the sole shareholder to amend Article 13 of the Articles of Incorporation which now reads as follows:
« Art. 13. The company will be bound in any circumstances by the signature of one manager even in case that several

managers have been appointed unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of
delegation of powers or proxies given by the manager(s) pursuant to article 10 of the present articles of association.»

<i>Second Resolution

Decision of the sole shareholder to appoint as managers of the Company both Mr Dr. Bernhard Engelbrecht, Diplom-

Kaufmann, born in Munich, on 21st December 1967, residing professionally at 4, Grand Rue, L-1660 Luxembourg and Mr
Dr. Georg Erdmann, Diplom-Kaufmann, born in Opladen, on 12th July 1970, residing professionally at Fuggerstrasse 26,
D-86150 Augsburg.

<i>Third Resolution

Decision of the sole shareholder to remove from office Mr Alexander Keller, private employee, born in Rostoch, on

4th August 1977, residing professionally at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

<i>Fourth Resolution

Decision of the sole shareholder to commence the coordinated articles of the Company with their German version.

41283

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,

this deed is worded in German followed by an English version. On request of the same appearing person and in case of
discrepancies between the German and the English text, the German version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the representative of the appearing person, whom is known to the notary by first and

surname, civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

Gezeichnet: A. Heinzmann, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, vol. 32CS, fol. 16, case 2. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

Luxemburg, 8. März 2007.

P. Frieders.

Référence de publication: 2007039601/212/122.
(070036291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

Union &amp; Power S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 65.249.

L'an deux mille six, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNION &amp; POWER S.A., ayant

son siège social à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 65.249, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 24 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 682 du 23
septembre 1998, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire André Schwachtgen en date du
18 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 217 du 30 mars 1999,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 décembre 1999, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 183 du 2 mars 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Cédric Hulpiau, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Stéphanie Stacchini,

employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont  été  portés  sur une  liste  de présence, signée  par  les  actionnaires  présents  et  par  les mandataires  de  ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l'article 6 des statuts de la Société.
2.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société et plus précisément le troisième alinéa pour lui

donner la teneur suivante:

« Art. 6. (troisième alinéa). Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et décider sur les matières

suivantes que moyennant le consentement unanime de tous les administrateurs:

41284

a) pour hypothéquer, gager, ou de quelque manière soumettre la propriété ou les avoirs de la société à un privilège;
b) emprunter de l'argent ou contracter un engagement ou une dette pour la société;
c) vendre des avoirs ou propriétés de la société.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Hulpiau, S. Stacchini, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2007, vol. 540, fol. 62, case 12. GRE/2007/170. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 8 mars 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007039589/231/58.
(070036361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

International Hotel Licensing Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 153.340.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 67.136.

In the year two thousand and seven, on the ninth of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

I.H.L.C. INVESTMENT COMPANY S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal,

R.C.S. Luxembourg B 67.138,

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2346 Lux-

embourg, 20, rue de la Poste, itself being represented by Mr Fabrice Geimer, Fondé de pouvoir A and Mr Ton Zwart,
fondé de pouvoir A, both professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder, acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. I.H.L.C. INVESTMENT COMPANY S.à r.l., is the sole partner of INTERNATIONAL HOTEL LICENSING COM-

PANY S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a notarial
deed on October 29, 1998, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 54 of January 30, 1999 (the Company).
The Articles of Incorporation have been amended for the last time by a notarial deed on November 13, 2002, published
in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 36 of January 14, 2003;

II. the Company's share capital is presently set at USD 153,340,000.- (one hundred and fifty-three million three hundred

and forty thousand US dollars) divided into 153,340 (one hundred and fifty-three thousand three hundred and forty)
shares of USD 1,000.- (one thousand U.S. dollars) each;

III. the agenda of the meeting is as follows:
1. Creation of two categories of managers, namely category A and category B.
2. Appointment of a new manager.
3. Amendment of the articles of incorporation.
IV. the sole partner has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner of the Company resolves to create two categories of managers, namely category A and category B.
The existing managers are designated as follows:
- Mr Victor Elvinger, manager of category A.
- Mr Lester Pulse, manager of category B.

41285

<i>Second resolution

The sole partner of the Company resolves to appoint a new manager of category B for and indefinite period, namely:
- Mr Michel Miserez, born in Gent, Belgium, on April 12, 1965, with business address in D-65760 Eschborn/Frankfurt,

Frankfurterstrasse 10-14.

<i>Third resolution

Following the above resolutions, the sole partner resolves to amend article 12 of the articles of incorporation so that

it shall henceforth read as follows:

« Art. 12. The Company is managed by a board of managers composed of one or more A manager(s) and one or more

B manager(s). The managers are appointed and designated as A manager or B manager by a resolution of the partners
which sets the term of their office. The managers need not be partner. The manager(s) may be revoked ad nutum.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not,

by an A manager and a B manager of the Company acting jointly.

The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented,

including at least one A manager and one B manager. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority
of the votes cast provided that at least an A manager and a B manager agreed on those resolutions. The resolutions of
the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of two managers of the Company, one of

whom must be an A manager or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such
signatory power has been validly delegated.

In case the partners would decide to reduce the number of the managers to one, the latest would have the most

extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances and to authorise acts and activities relating to the
company's objectives by its single signature.

If the managers are temporarily unable to act, the Company's affairs can be managed by the sole shareholder, or, in

case the Company has more than one shareholder, by the shareholders acting under their joint signature.»

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version. In case of discrepancies between the English
version and the German version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder, acting on behalf of the appearing party, the proxyholder signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Folgt die Deutsche Uebersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundsieben, den neunten Januar.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

I.H.L.C. INVESTMENT COMPANY S.à r.l, mit Sitz in L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg

B 67.138,

hier vertreten durch LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., mit Sitz in L-2346 Luxemburg, 20, rue de

la Poste, welche hier vertreten ist durch Herrn Fabrice Geimer, Fondé de pouvoir A, und Herrn Ton Zwart, Fondé de
pouvoir A, beide beruflich wohnhaft in Luxembourg, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben erwähnt, hat den unterzeichneten Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:
I.- I.H.L.C. INVESTMENT COMPANY S.à r.l. ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft INTERNATIONAL

HOTEL LICENSING COMPANY S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche gegründet wurde gemäß
notarieller Urkunde vom 29. Oktober 1998, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 54 vom 30. Januar
1999 (die Gesellschaft). Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal abgeändert gemäss notarieller Urkunde vom
13. November 2002, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 36 vom 14. Januar 2003;

II.- Das Kapital der Gesellschaft beträgt USD 153.340.000,- (einhundertdreiundfünfzig millionen dreihundertvierzig-

tausend  U.S.  Dollar)  eingeteilt  in  153.340  (einhundertdreiundfünfzigtausend  dreihundertvierzig)  Anteile  von  je  USD
1.000,- (eintausend U.S. Dollar).

III.- Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Schaffung von zwei Kategorien von Geschäftsführern, nämlich Kategorie A und Kategorie B Geschäftsführer.
2. Ernennung eines neuen Geschäftsführers.
3. Abänderung der Satzung der Gesellschaft.

41286

Der alleinige Gesellschafter fasst folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst zwei Kategorien von Geschäftsführern zu schaffen, nämlich Kategorie A Geschäftsführer

und Kategorie B Geschäftsführer.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst einen neuen Geschäftsführer der Kategorie B für eine unbestimmte Dauer zu ernennen,

nämlich:

Herr Michel Miserez, geboren in Gent, Belgien, am 12. April 1965, mit beruflicher Adresse in D-65760 Eschborn/

Frankfurt, Frankfurterstrasse 10-14.

<i>Dritter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst Artikel 12 der Satzung wie folgt abzuändern:
«Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführerrat bestehend aus einem oder mehreren Geschäftsführern der

Kategorie A und einem oder mehreren Geschäftsführern der Kategorie B verwaltet. Die Geschäftsführer werden als
Geschäftsführer A und Geschäftsführer B durch einen Beschluss der Gesellschafter ernannt, welche die Dauer ihres
Mandates festlegen. Die Geschäftsführer brauchen keine Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer können zu jeder Zeit
abberufen werden.

Spezielle Vollmachten für bestimmte Aufgaben können von einem Geschäftsführer A und einem Geschäftsführer B

gemeinsam handelnd an einzelne Bevollmächtigte gegeben werden, welche Gesellschafter sind oder nicht.

Der Geschäftsführerrat kann rechtsgültig beschliessen und handeln wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist, wovon wenigstens ein A Geschäftsführer und ein B Geschäftsführer anwesend oder vertreten sein
muss. Beschlüsse des Geschäftsführerrats werden rechtsgültig getroffen durch die Mehrzahl der Stimmen, inbegriffen die
Stimmen von mindestens einem Geschäftsführer A und einem Geschäftsführer B. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates
werden in Protokolle niedergeschrieben und von allen anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet.

Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern ver-

pflichtet, wovon jedoch einer ein Geschäftsführer A sein muss, oder durch die Einzel- oder gemeinsame Unterschrift von
jeder Person welche hierzu ermächtigt wurde.

Falls die Gesellschafter beschliessen sollten die Anzahl der Geschäftsführer auf einen zu reduzieren, so kann dieser

durch seine alleinige Unterschrift die Gesellschaft rechtsgültig verpflichten, sowie alle Aktivitäten und Geschäfte geneh-
migen, welche sich auf den Gesellschaftszweck beziehen.

Sollten die Geschäftsführer zeitweise verhindert sein, kann die Gesellschaft durch den alleinigen Anteilseigner geführt

werden. Falls es mehrere Anteilseigner gibt, können diese die Gesellschaft gemeinsam vertreten.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten

ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der
deutschen Fassung die englische Fassung maßgeblich ist.

Worüeber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Geimer, T. Zwart, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, vol. 31cs, fol. 59, case 7. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für Gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Mersch, den 20. Februar 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007039608/242/136.
(070036665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

Parfumerie Gisèle, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6750 Grevenmacher, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 17.215.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le neuf mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

41287

Ont comparu:

1.- Monsieur Peter Matthias dit Pierre Schritz, diplômé en sciences commerciales, né à Nittel (D) le 27 février 1949,

demeurant à L-6715 Grevenmacher, 24, rue Boland.

2.- Madame Giselle Fernande dite Gisèle Fero, commerçante, née à Grevenmacher le 24 janvier 1949, demeurant à

L-6715 Grevenmacher, 24, rue Boland.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société ci-après désignée et ont requis le notaire instru-

mentaire de documenter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée PARFUMERIE GISELE avec siège social à L-6750 Grevenmacher, route de

Luxembourg, constituée sous la dénomination de PARFUMERIE ROYALE aux termes d'un acte reçu par Maître Hyacinthe
Glaesener, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 novembre 1979, publié au Mémorial C numéro 19
du 29 janvier 1980, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 17.215.

- Les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Hyacinthe Glaesener, préqualifiée, en date du 9

janvier 1980, publié au Mémorial C numéro 60 du 22 mars 1980.

- Les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Greven-

macher, en date du 18 juillet 1984, publié au Mémorial C numéro 230 du 28 août 1984.

- Que le capital social de ladite société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500)

parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune entièrement libérées.

- Que les comparants sont détenteurs de l'intégralité des parts sociales et ont décidé de dissoudre et de liquider ladite

société, celle-ci ayant cessé toute activité le 31 décembre 2006.

Un bilan de clôture a été dressé au 31 décembre 2006.
- Que partant, ils prononcent la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Qu'ils déclarent avoir réglé tout le passif de la société et transféré tous les actifs à leur profit.
Qu'ils se trouvent donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle, et régleront également les frais
des présentes.

Qu'en conséquence, la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clôturée

et liquidée.

- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société pour l'exercice de leurs mandats.
- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-6715 Grevenmacher,

24, rue Boland.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Schritz, G. Fero, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-Alzette, le 12 mars 2007. Relation: EAC/2007/2097. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 13 mars 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007039795/272/48.
(070036733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

Partelcom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 71.866.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 14 mars 2007.

<i>Pour PARTELCOM S.A.
J. Reuter

Référence de publication: 2007040496/517/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC02103. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

41288

Zirkon S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 11.730.

Im Jahre zweitausendsechs den siebenundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

anonymen Holdinggesellschaft ZIRKON S.A.H., mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
H.G.R. Luxemburg Sektion B Nummer 11.730.

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den damals in Mersch, jetzt in Luxemburg

residierenden Notar Frank Baden am 18. Januar 1974, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 70 vom 2. April 1974.

Die Satzung wurde abgeändert durch Urkunden aufgenommen durch den vorgenannten Notar Frank Baden, am 25.

November 1975, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 56 vom 22. März 1976, und am 21. Juli 1986, veröffentlicht im
Mémorial C Nummer 288 vom 14. Oktober 1986.

Das Gesellschaftskapital wurde erhöht und umgewandelt in fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR), eingeteilt in zweitau-

send (2.000) Aktien ohne Nennwert, gemäß Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung der Aktieninhaber
der Gesellschaft am 20. Oktober 1999, wovon ein Auszug des Protokolles im Mémorial C Nummer 482 vom 7. Juli 2000
veröffentlicht wurde.

Die Satzung wurde zuletzt abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 19. März 2004,

veröffentlicht im Mémorial C Nummer 532 vom 21. Mai 2004.

Den Vorsitz der Versammlung fuhrt Herr Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Raphaël Rozanski, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1331

Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxem-

burg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet wurde und in der Kanzlei des Letztgenannten aufbewahrt wird.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung

und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben wurden, diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben ein-
registriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1. Aufstockung des Gesellschaftskapitals in Höhe von EUR 600.000,-, um es von seinem jetzigen Betrag von EUR

50.000,- auf EUR 650.000,- zu erhöhen durch die Ausgabe von 24.000 neuen Aktien ohne Nennwert, welche dieselben
Rechte und Pflichten wie die bestehenden Aktien verbriefen.

2. Vollständige Einzahlung der 24.000 neuen Aktien mittels Rücklagen der Gesellschaft und Verteilung der 24.000 neuen

Aktien unter die bestehenden Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung am Kapital.

3. Entsprechende Abänderung des Artikels 3 der Satzung, welcher künftig folgenden Wortlaut haben wird:
« Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt sechshundertfünfzigtausend Euro (EUR 650.000,-), eingeteilt in sechsund-

zwanzigtausend (26.000) Aktien ohne Nennwert.»

4. Abänderung des ersten Absatzes des Artikels 9 der Satzung, welcher künftig folgenden Wortlaut haben wird:
« Art. 9. Erster Absatz. Die ordentliche Generalversammlung tritt alljährlich am zweiten Mai um neun Uhr dreißig in

Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen.»

5. Verschiedenes.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Aufstockung des Gesellschaftskapitals in Höhe von sechshunderttausend Euro

(EUR 600.000,-), um es von seinem jetzigen Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) auf sechshundertfünfzigtausend

41289

Euro (EUR 650.000,-) zu erhöhen durch die Ausgabe von vierundzwanzigtausend (24.000) neuen Aktien ohne Nennwert,
welche dieselben Rechte und Pflichten wie die bestehenden Aktien verbriefen.

<i>Einzahlung

Die vierundzwanzigtausend (24.000) neuen Aktien wurden vollständig eingezahlt mittels Rücklagen der Gesellschaft

und werden unter die bestehenden Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung am Kapital verteilt.

Die Existenz der Rücklagen wurde dem Notar auf Grund einer Bescheinigung der Gesellschaft, unterzeichnet durch

den Verwaltungsrat und den Kommissar, nachgewiesen.

Diese Bescheinigung bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die Mitglieder der Versammlung und den amtie-

renden Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge dieser Kapitalerhöhung beschließt die Generalversammlung die entsprechende Abänderung des Artikels 3 der

Satzung, welcher künftig folgenden Wortlaut haben wird:

« Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt sechshundertfünfzigtausend Euro (EUR 650.000,-), eingeteilt in sechsund-

zwanzigtausend (26.000) Aktien ohne Nennwert.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Abänderung des ersten Absatzes des Artikels 9 der Satzung, welcher künftig

folgenden Wortlaut haben wird:

« Art. 9. Erster Absatz. Die ordentliche Generalversammlung tritt alljährlich am zweiten Mai um neun Uhr dreißig in

Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen.»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf etwa eintausendsiebenhundertfünfzig Euro veranschlagt sind,

sind zu Lasten der Gesellschaft.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit dem
Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, R. Rozanski, D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 janvier 2007, vol. 540, fol. 58, case 7. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 27 février 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007039759/231/88.
(070036543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

Fifof 2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 124.985.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-seventh of December.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

There appeared:

FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., a company incorporated under the laws of the Grand-

Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Company Register of the Luxembourg under number B 63707 with
registered office at 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, acting as management company of FORTIS INVESTMENTS
NON LISTED REAL ESTATE FUND OF FUNDS,

here represented by Mr. Patrick Van Hees, lawyer, with professional address at 21, rue de Colmar-Berg, L-7225 Mersch,

by virtue of a proxy given on December 27th, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the entity appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

41290

Such appearing entity, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the «Company»), which will be governed

by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

The Company is initially composed of one single Shareholder, subscriber of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several Shareholders, but not exceeding forty (40) Shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Object. The primary purpose of the Company is going to achieve high risk adjusted returns from a portfolio

of investments in closed-ended finite life Asian non listed real estate funds and assimilated entities in the form of Lux-
embourg or foreign partnerships, investorships, partnership limited by shares, limited companies or other commonly used
investment structures.

In addition, the Company may acquire ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises

in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular acquire by
subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures,
certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by
any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity

securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its
subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in favor
of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.
The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets. The
Company may also issue warrant instruments.

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The Company will have the name of FIFOF 2 S.à r.l.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-city.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Chapter II. Capital, shares

Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (€ 12,500.-), represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (€ 25.-) each, all of which are fully paid up.

Art. 7. Premium account. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any

premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used
to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised
losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 8. Increase and reduction of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder

or by a decision of the Shareholders' meeting voting with the quorum and majority rules set out by article 18 of these
Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.

Art. 9. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote

at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of the Company
and the resolutions of the single Shareholder or the general meeting of Shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

41291

The single Shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single Shareholder. The

shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of Shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 10. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The Company shall not be dissolved by reason of the

death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Chapter III. Manager(s)

Art. 11. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several Managers. If several Managers

have been appointed, they will constitute a Board of Managers.

The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without legitimate

cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of votes.

Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders' meeting, which will determine their

number and the duration of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of
the single Shareholder or by a resolution of the Shareholders' meeting.

Art. 12. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the Manager or the Board of Managers will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Manager or Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single Manager or, in case of plurality

of Managers, by the joint signature of any two Managers of the Company.

The Manager or Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more

proxyholders, selected from its members or not either Shareholders or not.

Art. 13. Day-to-day management. The Manager or Board of Managers may delegate the day-to-day management of the

Company to one or several Manager(s) or agent(s) and will determine the Manager's / agent's responsibilities and remu-
neration  (if  any), the  duration  of the period of  representation  and  any other  relevant  conditions  of  his  agency.  It is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition,
financing and refinancing have to obtain the prior approval from the Board of Managers.

Art. 14. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers may elect a chairman from among its members.

If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among Managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager may be represented by another member of the Board of Managers.
The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or represented

by proxies. Any decisions made by the Board of Managers shall require a simple majority. In case of ballot, the chairman
of the meeting has a casting vote.

In case of a conflict of interest as defined in article 16 below, the quorum requirement shall apply without taking into

account the affected Manager or Managers.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all members having
participated.

A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board

of Managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all members of the Board of Managers.

Art. 15. Liability, Indemnification. The Board of Managers assumes, by reason of its position, no personal liability in

relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages

or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in

41292

connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did
not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such
Manager or officer may be entitled.

Art. 16. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as
otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's or officer's interest therein shall be reported
to the single Shareholder or to the next general meeting of Shareholders.

Chapter IV. Shareholder(s)

Art. 17. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single Shareholder, the latter exercises

the powers granted by law to the general meeting of Shareholders.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) Shareholders, the decisions of the Shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the Shareholders are under the obligation to, within a delay of
fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may meet in a general meeting of Shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily by Shareholders representing half the
corporate capital. The notice sent to the Shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders' meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a Shareholder.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of

Managers, which is final, circumstances of «force majeure» so require.

Art. 18. Powers of the meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company

represents the entire body of Shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles and subject to the object of

the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is subject

by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of
the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by Shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 20. Financial Year. The Company's accounting year starts on January 1st and ends on December 31st of each year.

Art. 21. Adoption of financial statements. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established

and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single Shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of Shareholders for approval.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Appropriation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,

costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

41293

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the Shareholders. However, the Shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 23. Interim dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the Board of Managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the Manager or the Board of Managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the statutory
reserve.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, shareholders or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and remu-
neration.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 25. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31st of

December 2007.

<i>Subscription - Payment

All the five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (€ 25.-) each, have been subscribed by FORTIS

INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., prenamed.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (€ 12,500.-) is

at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand euros.

<i>Resolution of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Fix the number of Managers at four (4).
2. Appoint the following persons as Managers of the Company:
- Mr. Jean-François Fortemps, Chief Executive Officer, born in Forge Philippe, Belgium, on May 16, 1965, residing at

15 Faubourg Rastenne, F-57330 Hettange Grande, France;

- Mr. Marnix Arickx, Head product management group, born in Ostende, the Netherlands, on December 16, 1966,

residing at Europaplein 8, B-9840 De Pinte, Belgium;

- Mr. William De Vijlder, Chief investment officer global, born in Gent, Belgium, on February 4, 1960, residing at

Loveldstraat 53, B-9070 Destelbregen, Belgium; and

- Mr. Benoît Quisquater, Managing Director, born in Haine-Saint-Paul, Belgium, on January 6, 1965, residing at 4, rue

du Château Fort, L-3472 Dudelange, Grand Duchy of Luxembourg.

The duration of the managers' mandate is unlimited.
3. Fix the address of the Company at 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
4. PricewaterhouseCoopers, with registered office at 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, is appointed as inde-

pendent Auditor.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

41294

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., une société de droit luxembourgeois, inscrite au Re-

gistre  du Commerce et des Sociétés luxembourgeois  sous  le  numéro  B  63707, et  ayant  son  siège  social  au  14, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg, agissant en tant que société de gestion de FORTIS INVESTMENTS NON LISTED REAL
ESTATE FUND OF FUNDS,

Représentée par M. Patrick Van Hees, juriste, avec adresse professionnelle au 21, rue de Colmar-Berg, L-7225 Mersch,

en vertu d'une procuration donnée le 27 décembre.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité

(ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. L'objet premier de la Société est de retirer des profits élevés d'un portefeuille d'investissement composé

de fonds immobiliers asiatiques non côtés, de type fermé, et d'entités assimilées, établies sous la forme de société en
commandite simple, société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée luxembour-
geoises ou étrangères, ou sous toute autre forme couramment utilisée.

De plus, la Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés

ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la
gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à

l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter
des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à
toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de
garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en
outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur toute ou partie de ses avoirs. La Société pourra également émettre des warrants.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de

propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y
rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination FIFOF 2 S.à r.l.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du Gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

41295

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part étant entièrement
libérée.

Art. 7. Prime d'émission. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les

primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut
être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour
compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve
légale.

Art. 8. Augmentation et diminution du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en

une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de
majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 9. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et

dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein
droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 10. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la sus-

pension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Chapitre III. Gérant(s)

Art. 11. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants sont

nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance.

Les Gérants ne doivent pas être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime,

par une décision des associés représentant une majorité des voix.

Chaque Gérant sera nommé par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la

durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou
des associés.

Art. 12. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir

au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément
à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature de son Gérant unique ou, en cas de pluralité de

Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés

parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.

Art. 13. Gestion journalière. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs

gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/ mandataires, la
durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion
journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition, de finance-
ment et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance.

Art. 14. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le

président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le Conseil

de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

41296

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procurations.

Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité simple. En cas de ballottage, le président du conseil

a un vote prépondérant.

En cas de conflit d'intérêt tel que défini à l'article 16 ci-dessous, les exigences de quorum s'appliqueront sans prendre

en compte le ou les gérants concernés.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

Art. 15. Responsabilité, indemnisation. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-

mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société,
de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas droit à être indemnisé(e),
sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action,
procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans

l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour

lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations
telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel Gérant ou
mandataire pourrait prétendre.

Art. 16. Conflit d'intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera

affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront Gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé
de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou
employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires,
ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis
et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l'actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée
générale des associés.

Chapitre IV. Associé(s)

Art. 17. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs

qui sont dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le réviseur d'entreprises, ou à leur
défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité avec
la loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi
qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de

l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un manda-

taire, lequel peut ne pas être associé.

41297

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque

fois  que  se  produiront  des  circonstances  de  force  majeure  qui  seront  appréciées  souverainement  par  le  Conseil  de
Gérance.

Art. 18. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente

l'ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformément

à l'objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations
de la Société.

Art. 19. Procédure - Vote. Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.

Chapitre V. Année sociale, Répartition

Art. 20. Année sociale. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Approbation des comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont

établis et le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la
Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas,

des associés.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 22. Affectation des résultats. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,

charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 23. Dividendes intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve

du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le Conseil de Gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

- Le Gérant ou le Conseil de Gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés et une fois que cinq pourcents (5 %) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou

plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 25. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2007.

<i>Souscription - Libération

Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEM-

BOURG S.A., préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

41298

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros.

<i>Décision de l'associé unique

L'associé unique décide de:
1. Fixer le nombre de gérants à quatre (4).
2. Nommer les personnes suivantes en tant que Gérants de la Société:
- M. Jean-François Fortemps, Directeur Général, né à Forge Philippe, Belgique, le 16 mai 1965, résidant au 15 Faubourg

Rastenne, F-57330 Hettange Grande, France;

- M. Marnix Arickx, Directeur Général, né à Ostende, Pays-Bas, le 16 décembre 1966, résidant à Europaplein 8, B-9840

De Pinte, Belgique;

- M. William De Vijlder, Directeur Général, né à Gent, Belgique, le 4 février 1960, résidant à Loveldstraat 53, B-9070

Destelbregen, Belgique; et

- M. Benoît Quisquater, Directeur Général, né à Haine-Saint-Paul, Belgique, le 6 janvier 1965, résidant au 4, rue du

Château Fort, L-3472 Dudelange, Grand Duché de Luxembourg.

La durée du mandat des gérants est illimitée.
3. Fixer l'adresse du siège social au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
4. PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, est appelé aux fonctions

de Commissaire aux comptes indépendant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 janvier 2007, vol. 440, fol. 68, case 10. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 31 janvier 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007038852/242/490.
(070035262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

D.B. Zwirn Asia Pacific LP (Lux) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 124.953.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the sixteen's day of February.
Before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company D.B. ZWIRN ASIA/PACIFIC SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, L.P., a limited partnership organized

and existing under the Delaware Revised Uniform Limited Partnership Act with registered office at 615 South DuPont
Highway, County of Kent, City of Dover, State of Delaware 19901, registered with the trade register in Delaware under
number 4199181, represented herein by Mr Tomáš Lichý, manager, with professional address at 26, rue Philippe II L-2340
Luxembourg by virtue of a power of attorney given under private seal in New York (U.S.A.), on 15th February 2007,

The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,

shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the following articles of association (hereafter the

«Articles») of a company which they declare to establish as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name D.B.

ZWIRN ASIA PACIFIC LP (LUX) S.àr.l. (hereafter the «Company»), which is governed by the laws of Luxembourg, in

41299

particular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by
the present Articles.

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. The

registered office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
board of managers (as used in these Articles, «board of managers» means the sole manager if the said board consists of
a single manager only) of the Company. The registered office may further be transferred to any other place within the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of partners (as used in these Articles,
«general meeting of partners» means the sole partner if there is no more than one partner) adopted in the manner
required for the amendment of these Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers determines that extraordinary
political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would
interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between
such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company
which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Purpose.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies

or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries and/or affiliated companies. It may also
give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
subsidiaries and/or affiliated companies. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise
hypothecate all or some of its assets.

3.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 4. Duration.
4.1. The duration of the Company is unlimited.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or other similar event affecting one or more of its partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment of the Articles and in accordance with
the Law.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties. If the

Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

41300

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is being made to articles
189 and 190 of the Law.

6.4. A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the general meeting of

partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of
managers. Manager(s) need not be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time without cause (ad nutum).

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by Law or these Articles to the general meeting of partners shall fall within the

competence of the board of managers, which shall be empowered to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more agents, whether partners or

not, by any manager of the Company.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state that they were duly informed and had full knowledge of the agenda of the
meeting. The notice may be waived by a consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of
each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are valid if approved by a majority of the votes cast. Resolutions of the board of
managers shall be recorded in minutes signed by all managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. Participation in a meeting by such means is deemed to constitute participation in person at such meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple counterparts of identical minutes
and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound in all matters by the sole signature of its single manager, and,

in case of plurality of managers, by the joint signature of any two of the members of the board of managers or by the
joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with
article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company provided that such commitment is in compliance
with these Articles and with applicable Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. If the Company is owned by a sole partner, such partner shall have all powers conferred by Law to the general

meeting of partners.

12.2. Each partner shall have voting rights in proportion to the partner's ownership interest in the Company.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

41301

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of partners may be taken without a meeting by

circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the resolution. Signatures of partners may appear on a
single document or on multiple counterparts of an identical resolution and may be evidenced by original or facsimile
signature.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than one half of

the share capital of the Company.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and end on the thirty-

first day of December.

Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts shall be established,

and the board of managers shall prepare a balance sheet setting out the Company's assets and liabilities and the profit
and loss account.

14.2. The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted for approval to the general meeting of

partners who shall vote specifically as to whether discharge is given to the board of managers and, if applicable, the
statutory auditors.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company as stated in its annual accounting, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses, shall constitute the Company's net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits
of the Company shall be annually allocated to the statutory reserve, until the reserve is equal to ten per cent (10%) of
the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) Interim accounts are established by at least one manager;
(ii) These interim accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
(iii) The decision to pay interim dividends is taken by general meeting of the partners;
(iv) The above decision is taken after the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the

Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not be partners, appointed by resolution of the general meeting of partners, which will determine the powers and
remuneration of the liquidators. Unless otherwise provided in the resolution of the partner(s) or by law, the liquidators
shall be invested with the broadest powers available under applicable law for the realisation of assets and payment of the
liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company shall be dis-

tributed to the partners in proportion to their share ownership in the Company.

VII. General provision

17. Reference is made to the provisions of applicable Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2007.

<i>Subscription - Payment

The shares in the Company have been subscribed as follows:

The company D.B. ZWIRN ASIA/PACIFIC SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, L.P., prenamed, five hundred

shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro

(EUR 12,500.-) is as of now at the free disposal of the Company.

41302

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro (EUR 1,700.-).

<i>General meeting of partners

The appearing party, representing the entire subscribed share capital and considering himself as having been duly

convened, immediately proceeded to hold a general meeting of partners of the Company.

Having first verified that it was regularly constituted, he has passed the following resolutions by unanimous vote:
(i) that the number of the members of the board of managers of the Company be set at five (5);
(ii) that there be appointed as members of the board of managers of the Company for an unlimited duration the

following persons:

(a) Mr Edmond Deforest, manager, born in New York (U.S.A.), on 19th February 1963, whose business address is 745,

Fifth Avenue, New York, NY 10151 (U.S.A.);

(b) Mr Iain Macleod, manager, born in Glasgow (United Kingdom) on 8th August 1955, whose business address is 59,

Cité Millewee, L-8064 Bertrange (Luxembourg);

(c) Mr Thijs van Ingen, manager, born in Tiel (the Netherlands) on 5th December 1974, whose business address is 20,

rue de la Poste L-2346 Luxembourg;

(d) Mr Lorenzo Patrassi, manager, born in Padova (Italy), on 22nd April 1972, whose business address is 26, rue Philippe

II, L-2340 Luxembourg;

(e) Mr Tomáš Lichý, manager, born in Ostrava (Czech Republic), on 25th November 1972, whose business address is

26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

(iii) that the address of the registered office of the Company is set at 26, rue Philippe II L-2340 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the above-appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between the
English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said appearing person signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le seize février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette (Grand-Duché du Luxembourg).

A comparu:

La société D.B. ZWIRN ASIA/PACIFIC SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, L.P., un société organisé et constitué sous

les lois du Delaware (États-Unis d'Amérique) et ayant son siège social à 615 South DuPont Highway, County of Kent,
City of Dover, Delaware 19901, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Delaware sous le numéro 4199181,
ici dûment représentée par M. Tomáš Lichý, directeur, demeurant professionnellement au 26, rue Philippe II, L-2340
Luxembourg en vertu d'une procuration lui délivrée à New York (U.S.A.) en date du 15 février 2007.

Laquelle procuration demeurera, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisées avec elles.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts (les

«Statuts») d'une société qu'ils déclarent constituée entre eux comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination D.B. ZWIRN ASIA PACIFIC

LP (LUX) S.à r.l. (la «Société»), qui est régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents Statuts.

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré

dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société (dans ces Statuts, «conseil
de gérance» désigne le gérant si ledit conseil ne se compose que d'un seul gérant). Le siège social peut être transféré en
tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des associés (dans ces Statuts,
«assemblée générale des associés» désigne l'associé unique lorsque la Société n'a qu'un seul associé) délibérant comme
en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Dans les cas où le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires
d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication

41303

aisée entre le siège social et l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provi-
soirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera une
société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, incluant l'acquisition et l'octroi de brevets concernant
de tels droits de propriété intellectuelle, de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder,

par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations,
à ses filiales et/ou sociétés affiliées. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces
personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales et/ou sociétés affiliées. La Société pourra en
outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque crédit, le risque
de change, de fluctuations de taux d'intérêt et tout autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de
son objet social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l'incapacité, de l'insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers. En cas de pluralité

d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil. Pour toutes autres questions, il est
fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé qui le souhaite.

6.5. La société pourra racheter ses parts sociales en conformité avec les dispositions légales applicables.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par résolution de l'assemblée générale des associés

laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s)
gérant(s) ne doivent pas nécessairement être associé(s).

41304

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opé-
rations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,

associés ou non, par tout gérant de la Société.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants

au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
sera mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit (par courrier ou téléfax
ou tous autres moyens électroniques de communication y compris le courrier électronique).

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou

représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, par la simple signature du gérant unique et,

en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance ou par la ou les signature
(s) simple ou conjointes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués con-
formément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. Si la Société est représentée par un associé unique, cet associé exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par

la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit que ce soit par courrier, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique y compris par courrier
électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

sans assemblée par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par
téléfax soit tous autres moyens de communication électronique y compris le courrier électronique. Les associés expri-
meront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou
sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par un original ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant ensemble, au moins les trois quarts du capital social
de la Société.

41305

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le conseil de gérance prépare un

bilan avec l'indication des valeurs actives et passives de la Société auquel est annexé un sommaire de tous ses engagements
et des dettes du/des gérants et associés à l'égard de la Société et un compte des pertes et profits.

14.2. Le bilan et le compte des profits et pertes seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des associés

qui devront spécialement voter pour donner décharge au conseil de gérance, et, le cas échéant, au commissaire.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net de la société. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la
Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de
la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment sous réserve du respect des conditions

suivantes:

(i) Des comptes intérimaires doivent être établis par au moins un gérant;
(ii) Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

(iii) L'assemblée générale des associés est seule compétente pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes;
(iv) La décision susvisée n'est adoptée que dans la mesure où la Société s'est assurée que les droits des créanciers de

la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition
contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les
plus étendus qui leur sont confiés par la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué

aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales

de la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2007.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales de la Société ont été souscrites comme suit:

La société D.B. ZWIRN ASIA/PACIFIC SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, L.P., susmentionnée, cinq cents parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille sept cents euros (EUR
1.700,-).

<i>Assemblée générale des associés

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social souscrit et se considérant comme ayant été dûment convoqué,

a immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale des associés de la Société.

Après avoir vérifié que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
(i) le nombre des membres du conseil de gérance de la Société est fixé à cinq (5);

41306

(ii) sont nommés comme membres du conseil de gérance de la Société pour une période indéterminée les personnes

suivantes:

(a) M. Edmond Deforest, directeur, né à New York (États-Unis d'Amérique ), le 19 février 1963, dont l'adresse pro-

fessionnelle est située à 745, Fifth Avenue, New York, NY 10151 (États-Unis d'Amérique);

(b) M. Iain Macleod, directeur, né à Glasgow (Royaume-Uni), le 8 août 1955, dont l'adresse professionnelle est située

à 59, Cité Millewee, L-8064 Bertrange (Luxembourg);

(c) M. Thijs van Ingen, directeur, né à Tiel (Pays-Bas), le 5 décembre 1974, dont l'adresse professionnelle est située à

20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

(d) M. Lorenzo Patrassi, directeur, né à Padova (Italie) le 22 avril 1972, dont l'adresse professionnelle est située à 26,

rue Philippe II, L-2340 Luxembourg;

(e) M. Tomáš Lichý, directeur, né à Ostrava (République Tchèque) le 25 novembre 1972, dont l'adresse professionnelle

est située à 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,

(iii) le siège social de la société est fixé au 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui parle et lit l'anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le présent acte

en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ledit comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: T. Lichý, F. Kesseler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 février 2007. Relation: EAC/2007/1314. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 6 mars 2007.

F. Kesseler.

Référence de publication: 2007038942/219/430.

(070034751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Creditanstalt Derivatives Trust, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 47.021.

<i>Auszug aus der Beschlußfassung der ordentlichen Generalversammlung vom 5. Februar 2007

Die Herren Johann Kernbauer, Hannes Saleta mit beruflichem Wohnsitz Lassallestrasse 1 A-1020 Wien, Serge D'O-

razio, André Schmit mit beruflichem Wohnsitz 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, werden als Verwaltungsrats-
mitglieder für das neue Geschäftsjahr wiedergewählt.

Der Abschlussprüfer, DELOITTE S.A. wird für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Für beglaubigten Auszug
<i>Für CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007039970/526/18.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02580. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

41307

Americourt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 54.119.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les décisions suivantes ont

été prises:

Renouvellement de mandats:
- Les Mandats d'administrateur de Monsieur Patrick Meunier, demeurant professionnellement au siège de la société,

et de Madame Anna Meunier de Meis ont été renouvelés pour une durée de 5 ans

- Le mandat de Commissaire aux comptes de la société FIGESTA SARL a été renouvelé pour une durée de 5 ans
- Les mandats susvisés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2011.

Pour extrait sincère et conforme
AMERICOURT SA
P. Houbert
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007040037/6102/21.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2007, réf. LSO-CC02090. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

Tipi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 73.930.

Le bilan au 31 mars 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040502/817/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC03098. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

Luxfly S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 75.499.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 5 février 2007, que:
Les mandats d'administrateur de Mme Chantal Keereman, juriste, ayant comme adresse professionnelle 44, rue de la

Vallée à L-2661 Luxembourg, de Mme Corinne Philippe, juriste, ayant comme adresse professionnelle 44, rue de la Vallée
à L-2661 Luxembourg, de M 

e

 Alex Schmitt, avocat-avoué, ayant comme adresse professionnelle 44, rue de la Vallée à

L-2661 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de M. Lex Benoy, expert-comptable, ayant comme
adresse professionnelle 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg ont été renouvelés avec effet rétroactif au 1 

er

 juin

2004 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2009.

Luxembourg le 5 février 2007.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007039995/751/21.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04139. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

41308

3 Ccom LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 39.690.

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale des Actionnaires de 3 Ccom LUXEMBOURG S.A. («la Société») prises

à l'unanimité le 31 janvier 2007 que:

- la démission de M. Michael Balzer en sa qualité d'administrateur est acceptée et que
- M. Michele Ferraris, né le 23 avril 1964 à Alessandira (Italie), de nationalité italienne et demeurant à 40, rue d'Arlon,

B-6700 Arlon est nommé administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel
administrateur prendra fin à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2007.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour 3 Ccom LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007040043/1053/22.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC02953. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

Gemplus International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 73.145.

In the year two thousand and seven, on the eleventh day of January.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Stéphanie Ouadjed, Office Manager Luxembourg, residing in France, of GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. (the

«Company»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg, 46a John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated by deed of notary Gérard Lecuit, as a société à responsabilité limitée on 6th
December, 1999 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n 

o

 120 on 4th February,

2000 and has been transformed into a société anonyme by deed of notary Gérard Lecuit prenamed on 1st February 2000
published in the Mémorial n 

o

 363 on 20th May 2000. The articles of incorporation were amended several times and for

the last time by deed of the notary Jean-Joseph Wagner, with residence at Sanem, in replacement of Maître Joseph Elvinger,
excused, on November 15th 2006, not yet published in the Mémorial.

The appearing party, acting in its capacity as attorney in fact of the chief executive officer of the Company acting

pursuant to resolutions of the board of directors of the Company taken in meetings held in Luxembourg on 2nd February
2000, 1st March, 2000 (extracts of which were registered with the deed of notary Gérard Lecuit, prenamed, of 18th May
2000) and on 13th November 2000, (an extract of which was registered with the deed of notary Joseph Elvinger, pre-
named, on 28th November, 2000) as well as a delegation of power and proxy by the chief executive officer dated 12th
September 2002 (a copy of which was registered with the deed of notary Joseph Elvinger, prenamed, of 15th November
2002), a delegation of power and proxy by the Company's secretary dated 28th October 2002 (a copy of which was
registered with the deed of notary Joseph Elvinger, prenamed, of 15th November 2002),requested the notary to record
its declarations as follows:

(I) Article 5 of the articles of incorporation of the Company provides as follows:
«[...]
5.2. The authorised capital is fixed at four hundred million Euro (Euro 400,000,000.-) consisting of one billion eight

hundred and eighty-nine million four hundred and sixty-six thousand two hundred and twenty-six (1,889,466,226) shares,
of no nominal value.

Out of the authorised share capital the board of directors is authorised to issue further shares up to the total authorised

share capital in whole or in part from time to time with or without reserving any pre-emptive subscription rights for
existing shareholders and as it may in its discretion determine within a period expiring (x) for issues of shares reserved
pursuant to items (i) to (iv) in 5.2.1. below, on the fifth anniversary after the date of publication of the minutes of the
extraordinary general meeting held on 25th April 2006 (y) for issues of shares reserved pursuant to item (v) in 5.2.1.

41309

below as set out therein and (z) for any other issues of shares pursuant to 5.2.2. hereunder on the third anniversary after
the date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting held on 27th April 2004 (each time subject
to extensions) and to determine the conditions of any such subscription (provided that part of the authorised capital is
reserved as described below).

5.2.1. Out of the authorised share capital the following items (i) to (v) shall be reserved with no pre-emption rights

for:

(i) the issue of a maximum of twenty million (20,000,000) shares in exchange at a ratio of fifty (50) new shares in the

Company for one (1) share of classes A, B or C of GEMPLUS S.A., a company incorporated under the laws of the Republic
of France, registered in Marseille, under the number 349711200;

(ii) the issue of a maximum of fifty-six million eight hundred forty-five thousand and seven hundred (56,845,700) shares

either in exchange at a ratio of fifty (50) new shares of the Company for one share of GEMPLUS S.A. to be issued under
any of the GEMPLUS S.A. stock option plans in existence on 1st February 2000 or before or with respect to options to
be issued by the Company to subscribe for shares in the Company upon terms identical to those existing for options
issued under any of the GEMPLUS S.A. stock option plans in existence on 1st February, 2000 or before, against surrender
or exchange of, or renunciation to, such latter stock options in the same amounts on an adjusted basis (subject to the
applicable ratio);

(iii) the issue of a maximum of fifty million (50,000,000) shares with respect to the options granted to the employees

or officers of the GEMPLUS GROUP (including any subsidiaries or affiliates of the Company) in accordance with the stock
option plan as from time to time determined by the board of directors subject to such further conditions as may be
imposed by the general meeting of shareholders;

(iv) the issue of a total number of a maximum of up to sixty million (60,000,000) shares without nominal value to senior

management, board members and/or executives throughout the GEMPLUS GROUP either (a) by way of stock options,
the terms and conditions thereof and/or relating thereto to be determined by the board of directors in its sole discretion,
and/or (b) except in the case of board members, by way of free shares, the Company transferring, upon the issue of such
free shares, an amount equivalent to the accounting par of such shares from its realised profits or distributable reserves
to its share capital;

[...]»
(II) Contribution in cash: By virtue of the authority granted by the board of directors, the following contributions in

cash upon exercise of stock options to the Company has been accepted and shares of the Company have been issued to
the in cash contributors in accordance with article 5 of the articles of incorporation of the Company:

Date of contribution and issue

Payment received by the

Number of

of shares

Company in Euro GEMPULUS INTERNATIONAL

(EUR)

S.A. shares issued

7 November 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

908.82

918

17 November 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

818.73

827

17 November 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,289.79

5,651

20 November 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.199.68

3,232

20 November 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,829.42

2,858

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,594.49

5,651

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,050.29

2,071

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,392.23

8,477

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,331.15

5,385

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,113.55

3,145

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,040.39

2,061

8 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,465.00

3,500

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,366.99

3,401

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,392.23

8,477

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,554.10

3,590

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,930.00

7,000

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

12 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

12 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

41310

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

12 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,776.85

3,815

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,339.37

2,363

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,783.47

16,953

10 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

12 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

10 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,729.53

1,747

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,729.53

1,747

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,729.53

1,747

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,729.53

1,747

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,369.96

3,404

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,221.56

2,244

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

987.03

997

14 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,084.84

3,116

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,554.10

3,590

14 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,965.15

1,985

14 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,161.17

2,183

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,107.01

9,199

14 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,188.98

11,302

14 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,229.48

2,252

14 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,696.66

3,734

12 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62,938.26

63,574

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

827.64

836

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,838.23

3,877

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207.90

210

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,019.89

9,111

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,533.41

2,559

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,729.53

1,747

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,729.53

1,747

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,414.61

2,439

11 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

12 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

12 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,188.98

11,302

12 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,726.53

1,747

12 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,726.53

1,747

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,726.53

1,747

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,965.15

1,985

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,188.98

11,302

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,700.82

1,718

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,729.53

1,747

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,888.91

12,009

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,729.53

1,747

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,221.56

2,244

13 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,594.49

5,651

14 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,729.53

1,747

41311

14 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,770.00

23,000

14 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,921.59

1,941

14 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,509.45

4,555

14 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,553.90

5,610

14 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

14 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

15 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,217.70

1,230

15 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

15 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

15 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,729.53

1,747

15 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

15 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,791.10

9,890

15 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,696.66

3,734

15 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,056.72

7,128

15 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

15 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,336.00

6,400

15 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

15 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,731.41

2,759

15 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,659.14

2,686

17 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27,972.45

28,255

18 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,975.05

1,995

18 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,281.95

2,305

18 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,571.92

3,608

18 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,522.32

4,568

18 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,264.92

4,308

18 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,270.96

3,304

19 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,392.23

8,477

19 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,161.17

2,183

19 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,392.23

8,477

19 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,594.49

5,651

20 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,899.71

2,929

20 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,529.55

1,545

20 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,405.00

9,500

20 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,910.00

9,000

21 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,729.53

1,747

21 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,415.00

8,500

21 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,447.28

2,472

22 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,470.94

3,506

22 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,207.00

9,300

7 December 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94,767.27

73,463

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

626,431.35

608,785

Thus a total of six hundred and twenty six thousand four hundred and thirty one point thirty five Euro (Euro 626,431.35)

has been contributed to the Company on the date set out hereabove and on the same date a total of six hundred and
eight thousand seven hundred and eighty five (608,785) shares with no nominal value in the Company have been issued.

(III) The contributions in cash referred to under (II) above by way of exercise of stock options in the Company amount

to six hundred and twenty six thousand four hundred and thirty one point thirty five Euro (Euro 626,431.35) and the
Company has issued six hundred and eight thousand seven hundred and eighty five (608,785) new shares without nominal
value, thus an amount of one hundred and twenty eight thousand eight hundred and seventy nine point seventy eight Euro
(Euro 128,879.78) has been allocated to the share capital account and an amount of four hundred and ninety seven
thousand five hundred and fifty one point fifty seven Euro (Euro 497,551.57) is allocated to the premium account.

The details of the contributors in cash, their respective contributions and the number of shares subscribed by each of

them have been submitted to the notary.

Evidence of payment to the Company of such contributions in cash was given to the undersigned notary.
(IV) Pursuant to the above, the issued share capital of the Company has been increased by a total amount of one

hundred and twenty eight thousand eight hundred and seventy nine point seventy eight Euro (Euro 128,879.78) and the

41312

share premium by an amount of four hundred and ninety seven thousand five hundred and fifty one point fifty seven Euro
(Euro 497,551.57) by the issue of a total of six hundred and eight thousand seven hundred and eighty five (608,785) shares
in the Company. As a result of the preceding increase of capital, the sub paragraph 5.1 of article 5 of the articles of
incorporation of the Company is amended so as to read as follows:

«5.1. The subscribed capital is set at one hundred and thirty four million three hundred and sixty nine thousand four

hundred and twenty point twenty four Euro (Euro 134,369,420.24) consisting of six hundred and thirty four million six
hundred and thirty thousand three hundred and twenty three shares (634,630,323) in registered form without nominal
value.»

(V) The total contributions in cash are valued at six hundred and twenty six thousand four hundred and thirty one

point thirty five Euro (Euro 626,431.35).

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of capital are estimated at eleven thousand Euro.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le onzième jour du mois de janvier
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Stéphanie Ouadjed, Office Manager Luxembourg, résidant en France, de GEMPLUS INTERNATIONAL S.A.

(la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, au 46A, John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, sous forme d'une société à responsabilité limitée
en date du 6 décembre 1999 publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n 

o

 120 le 4

février 2000 et a été transformée en une société anonyme suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, susmentionné,
le 1 

er

 février 2000, publié au Mémorial n 

o

 363 le 20 mai 2000. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier

lieu par acte du notaire Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Joseph Elvinger,
empêché, le 15 novembre 2006 non encore publié au Mémorial.

La partie comparante, agissant en tant que mandataire de l'administrateur délégué de la Société lui-même agissant en

vertu de résolutions du conseil d'administration de la Société prises lors de réunions qui se sont tenues à Luxembourg
le 2 février 2000, le 1 

er

 mars 2000 (dont des extraits ont été enregistrés avec l'acte du notaire Gérard Lecuit, susmen-

tionné, du 18 mai 2000) et le 13 novembre 2000 (dont un extrait a été enregistré avec l'acte du notaire Joseph Elvinger,
susmentionné, du 28 novembre 2000), ainsi qu'une délégation de pouvoir et procuration par l'administrateur délégué
daté au 12 septembre 2002 (une copie de laquelle a été enregistrée avec l'acte du notaire Joseph Elvinger, susmentionné,
le 15 novembre 2002), une délégation de pouvoir et procuration par le secrétaire de la Société au 28 octobre 2002 (une
copie de laquelle a été enregistrée avec l'acte du notaire Joseph Elvinger, susmentionné, le 15 novembre 2002) a requis
le notaire d'acter ses déclarations de la manière suivante:

(I) L'article 5 des statuts de la Société prévoit ce qui suit:
«[...]
5.2 Le capital autorisé s'élève à quatre cent millions d'euros (euros 400.000.000,-) représenté par un milliard huit cent

quatre-vingt-neuf millions quatre cent soixante-six mille deux cent vingt-six (1.889.466.226) actions sans valeur nominale.

A l'intérieur du capital social autorisé, le conseil d'administration est autorisé à émettre de nouvelles actions dans la

limite du capital social autorisé en une ou plusieurs fois de temps en temps en réservant ou non un droit préférentiel de
souscription aux actionnaires existants tel que déterminé de manière discrétionnaire par le conseil, pendant une période
expirant (x) pour les émissions d'actions réservées conformément aux points (i) à (iv) du 5.2.1 ci-dessous, le 5 

e

 anni-

versaire après la date de publication du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 25 avril 2006 (y)
pour les émissions d'actions réservées conformément au point (v) du 5.2.1 tel que déterminé ci-après et (z) pour toute
autre émission d'actions conformément au 5.2.2 ci-dessous le 3 

e

 anniversaire après la date de publication du procès-

verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 27 avril 2004 (chaque fois sous réserve d'extensions), et de
déterminer les conditions d'une telle souscription (étant entendu qu'une partie du capital autorisé est réservé tel que
décrit ci-dessous).

41313

5.2.1 Dans le cadre du capital social autorisé, les points suivants (i) à (v) seront réservés sans droit préférentiel de

souscription à:

(i) l'émission d'un maximum de vingt millions (20.000.000) d'actions suivant un rapport d'échange de cinquante (50)

nouvelles actions de la Société pour une (1) action des classes A, B ou C de GEMPLUS S.A., une société constituée sous
les lois françaises et enregistrée à Marseille sous le n 

o

 349711200;

(ii) l'émission d'un maximum de cinquante-six millions huit cent quarante-cinq mille sept cents (56.845.700) actions

soit, suivant un rapport d'échange de cinquante (50) nouvelles actions de la Société pour une (1) action de GEMPLUS
S.A. devant être émises conformément à un quelconque plan d'option d'actions de GEMPLUS S.A. existant au 1 

er

 février

2000 ou antérieurement soit sur base d' options devant être émises par la Société pour souscrire des actions de la Société
en termes identiques à ceux existant pour des options émises conformément à tout plan d'option d'actions de GEMPLUS
S.A. existant au 1 

er

 février 2000 ou antérieurement, contre remise ou échange de, ou renonciation à, ces options d'actions

existantes pour les mêmes montants sur une base ajustée (en tenant compte du ratio applicable);

(iii) l'émission d'un nombre total maximum de cinquante millions (50.000.000) d'actions sur base des options offertes

aux employés et agents du groupe GEMPLUS (englobant toute filiale ou société affiliée à la Société) conformément au
plan d'option d'actions déterminé par le conseil d'administration sous réserve d'autres conditions supplémentaires qui
pourront être imposées par l'assemblée générale des actionnaires;

(iv) l'émission d'un maximum de soixante millions (60.000.000) d'actions sans valeur nominale aux cadres supérieurs

(senior management), administrateurs et/ou aux cadres exécutifs (exécutives) du groupe GEMPLUS, soit (a) au moyen
d'options d'actions, les termes et conditions applicables ou connexes, devant être déterminés par le conseil d'adminis-
tration de manière discrétionnaire, et/ou (b) sauf le cas des administrateurs, au moyen d'actions gratuites, la Société
transférant à la suite de l'émission de telles actions gratuites un montant équivalent au pair comptable de ces actions
calculé à partir des profits réalisés ou des réserves disponibles de son capital social;

[...]»
(II) Apports en numéraire: En vertu des pouvoirs donnés par le conseil d'administration, les apports en numéraire

suivants  à  la  Société  ont  été  acceptés  et  des  actions  de  la  Société  ont  été  émises  aux  apporteurs  en  numéraire  en
conformité avec l'article 5 des statuts de la Société:

Date de l'apport et de l'émission

Paiements reçus par la

Nombre d'actions

des actions

Société en euros GEMPULUS INTERNATIONAL

(EUR)

S.A. émises

7 novembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

908,82

918

17 novembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

818,73

827

17 novembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.289,79

5.651

20 novembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.199,68

3.232

20 novembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.829,42

2.858

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.594,49

5.651

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.050,29

2.071

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.392,23

8.477

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.331,15

5.385

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.113,55

3.145

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.040,39

2.061

8 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.465,00

3.500

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.366,99

3.401

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.392,23

8.477

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.554.10

3.590

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.930,00

7.000

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

12 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

12 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

12 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.776,85

3.815

41314

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.339,37

2.363

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.783,47

16.953

10 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

12 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

10 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.729,53

1.747

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.729,53

1.747

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.729,53

1.747

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.729,53

1.747

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.369,96

3.404

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.221,56

2.244

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

987,03

997

14 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.084,84

3.116

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.554,10

3.590

14 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.965,15

1.985

14 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.161,17

2.183

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.107,01

9.199

14 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.188,98

11.302

14 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.229,48

2.252

14 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.696,66

3.734

12 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.938,26

63.574

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

827,64

836

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.838,23

3.877

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207,90

210

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.019,89

9.111

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.533,41

2.559

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.729,53

1.747

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.729,53

1.747

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975.05

1.995

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.414,61

2.439

11 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

12 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

12 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.188,98

11.302

12 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.726,53

1.747

12 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.726,53

1.747

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.726,53

1.747

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.965,15

1.985

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.188,98

11.302

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.700,82

1.718

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.729,53

1.747

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.888,91

12.009

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.729,53

1.747

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.221,56

2.244

13 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.594,49

5.651

14 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.729,53

1.747

14 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.770,00

23.000

14 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.921,59

1.941

14 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.509,45

4.555

41315

14 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.553,90

5.610

14 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

14 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

15 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.217,70

1.230

15 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

15 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

15 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.729,53

1.747

15 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

15 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.791,10

9.890

15 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.696,66

3.734

15 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.056,72

7.128

15 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

15 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.336,00

6.400

15 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

15 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.731,41

2.759

15 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.659,14

2.686

17 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.972,45

28.255

18 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.975,05

1.995

18 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.281,95

2.305

18 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.571,92

3.608

18 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.522,32

4.568

18 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.264,92

4.308

18 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.270,96

3.304

19 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.392,23

8.477

19 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.161,17

2.183

19 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.392,23

8.477

19 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.594,49

5.651

20 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.899,71

2.929

20 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.529,55

1.545

20 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.405,00

9.500

20 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.910,00

9.000

21 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.729,53

1.747

21 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.415,00

8.500

21 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.447,28

2.472

22 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.470,94

3.506

22 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.207,00

9.300

7 décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94.767,27

73.463

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

626.431.35

608.785

En conséquence, un total de six cent vingt six mille quatre cent trente et un virgule trente-cinq euros (euros 626.431,35)

a été apporté à la Société aux dates ci-dessus et aux mêmes dates un total de six cent huit mille sept cent quatre vingt-
cinq (608.785) actions sans valeur nominale ont été émises par la Société.

(III) Les apports en numéraire mentionnés sous (II) par exercice d'options d'actions dans la Société ont une valeur de

six cent vingt six mille quatre cent trente et un virgule trente-cinq euros (euros 626.431,35) et la Société a émis six cent
huit mille sept cent quatre vingt-cinq (608.785) actions nouvelles sans valeur nominale et par conséquent un montant de
cent vingt huit mille huit cent soixante dix-neuf virgule soixante dix-huit euros (euros 128.879,78) a été alloué au compte
capital social et un montant de quatre cent quatre vingt dix-sept mille cinq cent cinquante et un virgule cinquante-sept
euros (euros 497.551,57) est alloué au compte prime d'émission.

Une liste des apporteurs en numéraire, leurs apports respectifs et le nombre d'actions souscrites par chacun d'entre

eux ont été soumis au notaire instrumentant.

Preuve du paiement des apports en numéraire à la Société a été donnée au notaire instrumentant.

(IV) Au vu de ce qui précède, le capital social émis de la Société a été augmenté d'un montant total de cent vingt huit

mille huit cent soixante dix-neuf virgule soixante dix-huit euros (euros 128.879,78) et la prime d'émission d'un montant
total de quatre cent quatre vingt dix-sept mille cinq cent cinquante et un virgule cinquante-sept euros (euros 497.551,57)
par l'émission d'un total de six cent huit mille sept cent quatre vingt-cinq (608.785) actions de la Société. Il résulte de

41316

l'augmentation de capital qui précède que le paragraphe 5.1 de l'article 5 des statuts de la Société a été modifié comme
suit:

«5.1. Le capital souscrit s'élève à cent trente-quatre millions trois cent soixante neuf mille quatre cent vingt virgule

vingt-quatre euros (euros 134.369.420,24) divisé en six cent trente quatre millions six cent trente mille trois cent vingt-
trois (634.630.323) actions nominatives sans valeur nominale.»

(V) Les apports en numéraire ont été évalués au total à six cent vingt six mille quatre cent trente et un virgule trente-

cinq euros (euros 626.431,35).

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société émis à sa charge

en raison de l'augmentation de capital sont évalués à onze mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'entête des présents.
Lecture faite de l'acte, la partie comparante a signé avec Nous, Notaire, le présent acte original.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande de la personne comparant,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la demande de la même partie comparante en cas
de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: S. Ouadjed, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 55, case 4. — Reçu 6.264,31 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007038728/211/443.
(070035069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2007.

Omega Investment Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 48.273.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 1 

er

 mars 2007

que:

- l'assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN

LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu'à la prochaine
assemblée approuvant les comptes 2006;

-  l'assemblée  renomme  VAN  LANSCHOT  TRUST  COMPANY  (LUXEMBOURG)  S.A.,  comme  commissaire  aux

comptes, et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2006;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 1 

er

 mars 2007.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

Référence de publication: 2007040047/695/21.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02279. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

Hal Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 67.040.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

41317

Luxembourg, le 26 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040554/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02810. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

HAL Investments Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 49.506.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040556/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02816. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070036870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

Société luxembourgeoise de Leasing BIL-LEASE, Société Anonyme.

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 38.718.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2007.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LEASING BIL-LEAS
M. Hoferlin / S. Freilinger
<i>Directeur / Responsable Administration

Référence de publication: 2007040506/6/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02811. - Reçu 44 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

Glas Moske Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 40, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 89.870.

Le bilan au 31 décembre 2005 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2007.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Référence de publication: 2007040560/800/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02654. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

NewTel S.A. et Cie S.E.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 53.688.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

41318

Luxembourg, le 27 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040558/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02822. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

HAL Investments Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 49.506.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040557/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02820. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070036871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

Financière Européenne S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 21.264.

Le bilan et compte de résultat au 22 décembre 2006 suite à la dissolution du 22 décembre 2006 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2007.

FIDUPAR
Signature

Référence de publication: 2007040596/1172/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03325. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

Fornebulux S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 29.245.

Le bilan et comptes de résultat au 22 décembre 2006 suite à la dissolution du 22 décembre 2006 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2007.

FIDUPAR
Signature

Référence de publication: 2007040597/1172/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03327. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

Investing Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 37.818.

Le bilan et comptes de résultat au 22 décembre 2006 suite à la dissolution du 22 décembre 2006 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

41319

Luxembourg, le 17 janvier 2007.

FIDUPAR
Signature

Référence de publication: 2007040598/1172/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03329. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

Parmeria, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 5.391.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007040599/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03331. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070037113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

NH Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 104.517.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007040593/677/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02445. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

Fidulor S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 32.397.

Le bilan et compte de résultat au 22 décembre 2006 suite à la dissolution du 22 décembre 2006 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2007.

FIDUPAR
Signature

Référence de publication: 2007040595/1172/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03324. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

Sagittarius Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 69.113.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 7 février 2007 que M. Fernand

Heim avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommé à la
fonction de Président du Conseil d'Administration.

41320

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2007040616/521/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, réf. LSO-CC01660. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

Hal Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 67.040.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040555/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02814. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070036868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

3 H S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 49.077.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040505/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC03139. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

Windpark Op Der Hei AG, Société Anonyme.

Siège social: L-9089 Ettelbrück, 16, rue Michel Weber.

R.C.S. Luxembourg B 91.675.

Le bilan au 31 décembre 2005 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2007.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Référence de publication: 2007040561/800/15.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02723. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

BCG Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 38.676.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 86.337.

In the year two thousand and seven, on the eighteenth of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

41321

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of BCG HOLDING S.à r.l., a «Société à responsabilité

limitée», having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, incorporated by deed enacted on
February  25,  2002,  inscribed  on  March  15,  2002  at  the  Luxembourg  Trade  Register  number  B  86.337,  published  in
Mémorial C number 884, page 42387, on June 11, 2002 and whose Articles of Incorporation have been amended by deed
enacted on December 22nd, 2003, published in Mémorial C number 141, on February 4th, 2004.

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally at Luxembourg
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing profes-

sionally at Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance

list. That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 693,520 (six hundred ninety three thousand five hundred twenty) shares,

representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of
the agenda of which the shareholder has been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 4,000,000.- (four million euro) so as to raise it from its

present amount of EUR 34,676,000.- (thirty-four million six hundred seventy-six thousand euro) to EUR 38,676,000.-
(thirty-eight million six hundred seventy-six thousand) by the issue of 80,000 (eighty thousand) new shares having a par
value of EUR 50.- (fifty euro) each, subject to payment of a share premium amounting globally to EUR 16,000,000.- (sixteen
million euro).

2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by contribution in kind of shares.
3.- Acceptation by the managers of BCG HOLDING S.à r.l.
4.- Amendment of article 8 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder decides what follows:

<i>First resolution

The company THE BOSTON CONSULTING GROUP CIE, a company organized under the laws of France and having

its registered office at 4-14, rue d'Aguesseau, 75008 Paris, France; sole shareholder, exercising the powers devolved to
the general meeting of shareholders, decides to increase the issued share capital by EUR 4,000,000.- (four million euro)
so as to raise it from its present amount of EUR 34,676,000.- (thirty-four million six hundred seventy-six thousand euro)
to EUR 38,676,000.- (thirty-eight million six hundred seventy-six thousand euro) by the issue of 80,000 (eighty thousand)
new shares having a par value of EUR 50.- (fifty euro) each, subject to payment of a share premium amounting globally
to EUR 16,000,000.- (sixteen million euro), the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in
shares of a company having its registered office in a European Union state.

<i>Second resolution

The shareholder accepts the subscription of the new shares by himself, that is to say:
- THE BOSTON CONSULTING GROUP CIE, prenamed, for all the 80,000 (eighty thousand) new shares to be issued.

<i>Contributor's Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the aforenamed company THE BOSTON CONSULTING GROUP CIE, here represented as

stated here-above;

which declares to subscribe to the 80,000 (eighty thousand) new shares and to pay them up as well as the share

premium by a contribution in kind hereafter described:

<i>Description of the contributions

129 shares with a par value of NLG 100.- (one hundred Gulden) of THE BOSTON CONSULTING GROUP B.V., a

company incorporated under the laws of The Netherlands, representing 24.39% of the share capital of this latest company,
divided in 529 shares; this contribution being valued at EUR 20,000,000.- (twenty million euro), remunerated by issue of
80,000 new shares in BCG HOLDING S.à r.l.

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is evaluated at EUR 20,000,000.- (twenty million euro).
The subscriber requests that this total amount of the contribution has to be considered as share capital for a total

amount of EUR 4,000,000.- (four million euro) and as share premium for an amount of EUR 16,000,000.- (sixteen million
euro), to be allocated as follows:

- EUR 14,342,138.- (fourteen million three hundred forty-two thousand one hundred thirty-eight euro) to a distrib-

utable item of the balance sheet;

41322

- EUR 1,657,862.- (one million six hundred fifty-seven thousand eight hundred sixty-two euro) to an undistributable

item of the balance sheet as allocated to the legal reserve.

<i>Evidence of the contribution's existence

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by the Memorandum

of Articles of Association of the concerned companies and by a declaration issued by the managers of BCG HOLDING
S.à r.l. attesting the current number of shares, their ownership, and their true valuation in accordance with current market
trends.

<i>Effective implementation of the contribution

THE BOSTON CONSULTING GROUP CIE, contributor prenamed here represented as stated hereabove, declares:
- all the shares are fully paid up;
- such shares are in registered form;
- there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the shares be transferred to him;

- such shares are legally and conventionally freely transferable;
- they have checked that these shares are owned by THE BOSTON CONSULTING GROUP CIE;
- all formalities shall be carried out in Luxembourg in order to formalise the transfer and to render it effectively

anywhere and toward any third party.

<i>Manager's intervention

Thereupon intervene:
a) Mr Xavier Pauwels, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
b) Mr Florent Callec, with professional address at 4-14, rue d'Aguesseau, 75008 Paris, France
c) Mrs Deborah Simpson, with professional address at 1 Exchange place, Boston, MA02109 USA
here represented by Régis Galiotto, prenamed by virtue of a proxy which will remain here annexed.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, each of them personally and

solidarly legally engaged as managers of the company by reason of the here above described contribution in kind, both
of them expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of
these shares, and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the shareholder

decides to amend the article 8 of the Articles of Incorporation to read as follows:

« Art. 8. The Company's capital is set at EUR 38,676,000.- (thirty-eight million six hundred seventy-six thousand euro)

represented by 773,520.- (seven hundred seventy-three thousand five hundred twenty euro) shares with a par value of
EUR 50.- (fifty euro) each.»

<i>Pro rata contribution tax payment exemption request

THE BOSTON CONSULTING GROUP B.V., registered under number 475.405 at the Netherlands Trade Register

and having its registered office at Baarn, is a financial stock company, considered as such by the Netherlands laws as well
as by Luxembourg laws, covered by the Council Directive 69/335/CEE of July 17, 1969 concerning indirect taxes on the
raising of capital.

Considering that it concerns an increase of the share capital of a Luxembourg company by a contribution in kind

consisting of shares of a financial stock company (société de capitaux) having its registered office in an European Union
State, bringing its participation from 75.61%, already owned, to 100% after the present contribution, the company ex-
pressly requests the pro rata fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29,
1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a
case.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 6,500.- euro.

<i>Retainer

Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the undersigned

notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

41323

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille sept, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée BCG HOLD-

ING S.à r.l., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 86.337, constituée suivant acte reçu le 25 février 2002, publié au Mémorial
C, numéro 884, page 42387 du 11 juin 2002 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 22 décembre 2003,
publié au Mémorial C numéro 141, du 4 février 2004,

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Hubert Janssen, juriste, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 693.520 (six cent quatre-vingt treize mille cinq cent vingt) parts sociales,

représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé a été préalablement
informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 4.000.000,- (quatre millions euros) pour le

porter de son montant actuel de EUR 34.676.000,- (trente-quatre millions six cent soixante-seize mille euros) à EUR
38.676.000,- (trente-huit millions six cent soixante-seize mille euros) par l'émission de 80.000 (quatre-vingt mille) parts
sociales  nouvelles  d'une  valeur  nominale  de  EUR  50,-  (cinquante  euros)  chacune,  moyennant  paiement  d'une  prime
d'émission globale de EUR 16.000.000,- (seize millions euros).

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les parts sociales nouvelles par apport en nature

d'actions.

3.- Acceptation par les gérants de BCG HOLDING S.à r.l.
4.- Modification afférente de l'article 8 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

La société THE BOSTON CONSULTING GROUP CIE, une société régie par le droit français et ayant son siège social

à 4-14, rue d'Aguesseau, 75008 Paris, France; associé unique exerçant les prérogatives dévolues à l'assemblée, décide
d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 4.000.000,- (quatre millions euros) pour le porter de son montant
actuel de EUR 34.676.000,- (trente-quatre millions six cent soixante-seize mille euros) à EUR 38.676.000,- (trente-huit
millions six cent soixante-seize mille euros) par l'émission de 80.000 (quatre-vingt mille) parts sociales nouvelles d'une
valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune, moyennant paiement d'une prime d'émission globale de EUR
16.000.000,- (seize millions euros), le tout intégralement souscrit par l'apport réalisé en nature d'actions d'une société
ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté Européenne.

<i>Deuxième résolution

L'associé accepte la souscription des parts sociales nouvelles par lui-même, à savoir:
- THE BOSTON CONSULTING GROUP CIE, prédésignée, pour l'intégralité des 80.000 nouvelles parts sociales à

émettre.

<i>Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée THE BOSTON CONSULTING GROUP CIE, représentée

comme dit ci-avant;

laquelle a déclaré souscrire les 80.000 (quatre-vingt mille) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement ainsi

que la prime d'émission par un apport en nature ci-après décrit.

<i>Description de l'apport

129 actions d'une valeur nominale de NLG 100,- (cent Florins) chacune, de THE BOSTON CONSULTING GROUP

B.V., une société régie par les lois des Pays-Bas, représentant 24.39% du capital social de cette dernière, divisé en 529

41324

actions; cet apport étant évalué à EUR 20.000.000,- (vingt millions euros), rémunéré par l'émission de 80.000 parts sociales
nouvelles de BCG HOLDING S.à r.l.

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 20.000.000,-.
Le souscripteur déclare que la valeur totale de l'apport fait à BCG HOLDING S.à r.l. doit être considérée comme du

capital pour un montant de EUR 4.000.000,- (quatre millions euros) et comme une prime d'émission pour un montant
total de EUR 16.000.000,- (seize millions euros), à allouer comme suit:

- EUR 14.342.138,- (quatorze millions trois cent quarante-deux mille cent trente-huit euros) à une réserve distribuable

du bilan;

- EUR 1.657.862,- (un million six cent cinquante-sept mille huit cent soixante-deux euros) à une réserve non distribuable

du bilan telle que la réserve légale.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par les statuts des sociétés

concernées et une déclaration émise par les gérants de BCG HOLDING S.à r.l. attestant le nombre actuel d'actions, leur
appartenance et leur valeur réelle conformément aux tendances actuelles du marché.

<i>Réalisation effective de l'apport

THE BOSTON CONSULTING GROUP CIE, prédésigné, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare:
- que les actions de THE BOSTON CONSULTING GROUP B.V. sont entièrement libérées;
- qu'il est le seul plein propriétaire et possédant les pouvoirs de disposer de ces actions conventionnellement et

librement transmissibles, n'existant aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait
avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;

- que toutes formalités seront réalisées au Luxembourg, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout

et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Intervention des gérants

Sont alors intervenus:
a) Monsieur Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
b) Monsieur Florent Callec, avec adresse professionnelle au 4, rue d'Aguesseau, 75008 Paris
c) Madame Deborah Simpson, avec adresse professionnelle au 1 Exchange Place, Boston, MA02109, USA
ici représentés par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée, agissant en qualité

de gérants de la société BCG HOLDING S.à r.l.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement personnellement et solidairement

engagés en leur qualité de gérants de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, tous les deux marquent
expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété
desdites actions, et confirment la validité des souscriptions et libération.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, l'associé

décide de modifier l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 38.676.000,- (trente-huit millions six cent soixante-seize mille euros) divisé en

773.520 (sept cent soixante-treize mille cinq cent vingt) parts sociales de EUR 50,- (cinquante euros) chacune.»

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

THE BOSTON CONSULTING GROUP B.V, enregistrée sous le numéro 475.405 au Registre de Commerce des Pays-

Bas et ayant son siège social à Baarn, est une société de capitaux, considérée comme telle tant par la loi des Pays-Bas que
par la loi luxembourgeoise, entrant dans le champ d'application de la Directive 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969,
concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.

Compte tenu qu'il s'agit de l'augmentation du capital social d'une société luxembourgeoise par apport en nature de

parts sociales non encore apportées, émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l'Union Euro-
péenne, portant sa participation de 75,61%, déjà détenue, à 100% après le présent apport, la société requiert expressément
l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle
que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 6.500,- euros.

41325

<i>Provision

Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d'ores et déjà à la dis-

position du notaire soussigné, l'apport étant réalisé en nature.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Galiotto, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, vol. 157S, fol. 49, case 4. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007040255/211/240.
(070037222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

Palais des Parfums S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 21.274.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le neuf mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

Ont comparu:

1.- Monsieur Peter Matthias dit Pierre Schritz, diplômé en sciences commerciales, né à Nittel (D) le 27 février 1949,

demeurant à L-6715 Grevenmacher, 24, rue Boland.

2.- Madame Giselle Fernande dite Gisèle Fero, commerçante, née à Grevenmacher le 24 janvier 1949, demeurant à

L-6715 Grevenmacher, 24, rue Boland.

Lesquels comparants déclarent être le seuls associés de la société ci-après désignée et ont requis le notaire instru-

mentaire de documenter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée PALAIS DES PARFUMS S.à r.l. avec siège social à L-6686 Mertert, route de

Wasserbillig, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en
date du 3 février 1984, publié au Mémorial C numéro 58 du 25 février 1984, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 21.274.

- Les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Joseph Gloden, préqualifié, en date du 7 décembre

1987, publié au Mémorial C numéro 60 de l'année 1988 à la page 2854.

- Les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Joseph Gloden, préqualifié, en date du 26 avril

1988, publié au Mémorial C numéro 189 de l'année 1988 à la page 9033.

- Que le capital social de ladite société est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-), divisé

en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune entiè-
rement libérées.

- Que les comparants sont détenteur de l'intégralité des parts sociales et ont décidé de dissoudre et de liquider ladite

société, celle-ci ayant cessé toute activité le 31 décembre 2006.

Un bilan de clôture a été dressé au 31 décembre 2006.
- Que partant, ils prononcent la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Qu'ils déclarent avoir réglé tout le passif de la société et transféré tous les actifs à leur profit.
Qu'ils se trouvent donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle, et régleront également les frais
des présentes.

Qu'en conséquence, la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clôturée

et liquidée.

- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société pour l'exercice de son mandat.
- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-6715 Grevenmacher,

24, rue Boland.

41326

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Schritz, G. Fero, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette., le 12 mars 2007. Relation: EAC/2007/2093. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 13 mars 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007039796/272/49.
(070036479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

Mousel et Klein S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4451 Belvaux, 266, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 28.203.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 14 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040590/3220/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00599. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

Skuld Re II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 45.068.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le 18 décembre 2006

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires a pris les résolutions suivantes:
1. L'assemblée accepte la démission de Monsieur Douglas Jacobsohn, Monsieur Svein Sollund et Monsieur Jacobs en

tant qu'Administrateurs prenant effet à la clôture de la présente réunion.

2. L'assemblée décide de nommer comme nouveaux Administrateurs de la société, pour une période allant jusqu'à

l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2007, qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant le 31
décembre 2006, les personnes suivantes:

- Monsieur Jacques Reckinger, Administrateur, né le 14 mars 1965 à Luxembourg, domicilié professionnellement à

L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,

- Monsieur Georges Gudenburg, Avocat, né le 25 novembre 1964 à Luxembourg, domicilié professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,

- Monsieur Pierre Metzler, Avocat, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,

- Monsieur Claude Weber, né le 24 avril 1960 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-2146 Luxembourg,

au 74, rue de Merl.

3. L'associé unique décide de nommer comme réviseur d'entreprises indépendant KPMG AUDIT S.à.r.l en remplace-

ment de ERNST &amp; YOUNG pour une période allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2007, qui
statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007040190/4685/31.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01481. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070036578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.

41327

NewTel S.A. et Cie S.E.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 53.688.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007040559/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02823. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070036877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

Technologies Industrielles Européennes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 34.583.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WILSON ASSOCIATES
Signature

Référence de publication: 2007040609/803/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03295. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

Balder S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 70.121.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2007.

FIDUPAR
Signature

Référence de publication: 2007040602/1172/14.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03337. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

Resources Services Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.793.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2007.

FIDUPAR
Signatures

Référence de publication: 2007040600/1172/14.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03332. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

41328


Document Outline

3 Ccom LUXEMBOURG S.A.

3 H S.A. Holding

Americourt S.A.

Balder S.A.

BCG Holding S.à r.l.

Creditanstalt Derivatives Trust

D.B. Zwirn Asia Pacific LP (Lux) S. à r.l.

Fidulor S.A.

Fifof 2 S. à r.l.

Financière Européenne S.A.

Fornebulux S.A.

Gemplus International S.A.

Glas Moske Luxembourg S.à r.l.

Hal Finance Luxembourg S.A.

Hal Finance Luxembourg S.A.

HAL Investments Luxembourg S.A.

HAL Investments Luxembourg S.A.

International Hotel Licensing Company S.à r.l.

Investing Partners S.A.

Luxfly S.A.

Mousel et Klein S.à r.l.

NewTel S.A. et Cie S.E.C.S.

NewTel S.A. et Cie S.E.C.S.

NH Properties S.A.

Omega Investment Corporation S.A.

Palais des Parfums S.à r.l.

Parfumerie Gisèle

Parmeria

Partelcom S.A.

PATRIZIA Luxembourg S.à r.l.

Resources Services Holdings S.à r.l.

Sagittarius Investissements S.A.

Skuld Re II S.A.

Société luxembourgeoise de Leasing BIL-LEASE

Technologies Industrielles Européennes S.A.

Tipi S.A.

Union &amp; Power S.A.

Windpark Op Der Hei AG

Zirkon S.A.H.