This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 752
2 mai 2007
SOMMAIRE
AKS (Holdings) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36087
Albert Seyler et Compagnie . . . . . . . . . . . .
36091
Alcentra Mezzanine QPAM S.à r.l. . . . . . . .
36089
Ava Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36091
Baticeram, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36096
Behedam (Holdings) S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
36090
Brodequin Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36088
CGM Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36050
Copernicus Finance Buffer S.à r.l. . . . . . . .
36073
Doria S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36096
Dragonera S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36090
Elisabeth Stëftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36092
Epicure Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36082
EPI Oakwood GP 5 S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
36066
European Property Fund (Radans) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36059
Eylau - Raymond Poincaré «Paris 75116»
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36087
Fargo Investment Holdings S.A. . . . . . . . . .
36090
Filiaris S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36086
Fondation Greenpeace Luxembourg, Eta-
blissement d'Utilité Publique . . . . . . . . . . .
36076
Fondation Lydie Schmit . . . . . . . . . . . . . . . .
36082
Geholux Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36095
Glibro Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36086
IAP Immobilière S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36096
Infomail S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36095
Ismat International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
36089
Kateco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36084
L.B.G. S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36087
Leaders Motors Luxembourg S.A. . . . . . . .
36081
Lubow Illsen S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36085
March Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36083
Masco Europe INC Financial S.C.S. . . . . . .
36078
Medest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36085
MobiLease S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36089
Mod'in Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36081
Next Future Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . .
36084
Nordviking Gesellschaft Reederei S.A. . . .
36088
Paunsdorf Centre Luxco . . . . . . . . . . . . . . . .
36083
Rom Top 1 Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36085
SAP Luxembourg Succursale de NV SAP
Belgium SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36089
SAP Luxembourg Succursale de NV SAP
Belgium SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36088
S.D.C.H. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36081
Société Immobilière Pandy S.A. . . . . . . . . .
36085
Tolub Chamszadeh Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
36091
Zwickau Arcaden Luxco . . . . . . . . . . . . . . . .
36084
36049
CGM Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 125.072.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the ninth day of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CGM LUX 1 S.à r.l. having its registered office at 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, incorporated by a
deed of the undersigned notary of this day, represented by Mrs Inga Pawlitschko, lawyer, professionally resident in Wies-
baden, Germany, by virtue of a proxy which, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall
be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing person, acting in his above-mentioned capacity, has requested the undersigned notary to draw up the
articles of incorporation of a société à responsabilité limitée, which is herewith established as follows:
Art. 1. Form. There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the «1915 Law»), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by these articles of incorporation (the
«Articles of Incorporation»).
The Company is to be initially composed of a single shareholder who is therefore the owner of the entire issued share
capital of the Company. The Company may however at any time be composed of several shareholders, as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares, but the number of shareholders shall never exceed thirty (30).
The Company shall not have any natural persons as shareholders.
Art. 2. Name. The Company will exist under the name of CGM LUX 2 S.à r.l.
Art. 3. Object. The purpose of the Company is the acquisition, holding, management, selling, financing (including through
borrowings with third party lenders) and exchange of properties or securities of companies holding properties and more
generally assets constitutive of authorised investments of CG REAL ESTATE MASTER FCP, a mutual investment fund
(fonds commun de placement) organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Fund»).
The Company may provide financial support to CG REAL ESTATE LUXEMBOURG S.à r.l. acting in its capacity as
management company of the Fund and to companies in which the Fund holds directly or indirectly a participation, in
particular by granting loans, facilities, security interests or guaranties in any form and for any term whatsoever and grant
them any advice and assistance in any form whatsoever.
The Company may carry out any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining however
within the limitations set forth by the Fund's constitutional documents and the applicable Luxembourg laws and regula-
tions.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time if a single shareholder, owning the entire issued share capital if the Company
so decides. If there is more than one shareholder, the Company may be dissolved at any time, pursuant to a shareholder
resolution taken at a general meeting.
Art. 5. Registered Office. The registered office is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the board
of directors.
The Company may establish subsidiaries and branches where it considers them to be useful, whether in the Grand
Duchy of Luxembourg or abroad.
Art. 6. Capital. The corporate capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)
represented by one hundred and twenty-five (125) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.
In addition to the capital, there may be set up a premium account into which any premium amount paid on any share
in addition to its nominal value (including any payment made on warrants attached to any shares, bonds, notes or similar
instruments) is transferred.
The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares, which the Company may
redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate
funds to the legal reserve.
Art. 7. Variation of the corporate capital. The corporate capital may at any time be increased or decreased, by decision
of the single shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be.
36050
Art. 8. Authorised corporate capital. The authorised capital of the Company is set at two hundred and fifty million
euros (EUR 250,000,000.-) divided into two million five hundred thousand (2,500,000) shares, each share with a par value
of one hundred euros (EUR 100.-).
The Board of Directors is authorised, during a period ending five (5) years following the date of publication of the
Articles of Incorporation creating the authorised capital in the Mémorial Recueil C, to increase the share capital within
the limits of the authorised capital in one or several times by issuing shares to the existing holders of shares or any persons
that have been approved by the shareholders at the same quorum and majority requirements as provided by article 189
paragraph 1 of the 1915 Law.
Such shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the board of directors may determine.
The board of directors may in particular determine:
- the time and the number of shares to be subscribed and issued;
- whether a share premium will be paid on the shares to be subscribed and issued and the amount of such share
premium if any;
- whether the shares will be paid-in by a contribution in cash or in kind; and
- that shares will be issued following the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the board
of directors under the terms of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instru-
ments), convertible bonds or notes or similar instruments issued from time to time by the Company.
The board of directors may delegate to any director or officer of the Company or to any other duly authorised person,
the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts
of capital.
Upon each increase of the share capital of the Company by the board of directors within the limits of the authorized
capital, the present article 8 shall be amended accordingly.
Art. 9. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets
of the Company and to one vote at shareholder general meetings.
If the Company is composed of a single shareholder, that shareholder exercises all those powers granted to all share-
holders by the 1915 Law and the Articles of Incorporation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of any decision made by a single
shareholder owning the entire issued share capital of the Company or by a group of shareholders in general meeting.
The creditors or successors of the single shareholder or of any of the shareholders may in no event request that a
seal be affixed to the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court. They must,
for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and resolutions.
Art. 10. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented by a common attorney-in-fact, whether or not jointly appointed.
Art. 11. Transfer of shares. Where the Company is composed of a single shareholder, that single shareholder may
freely transfer the shares owned, subject to the restrictions in the Articles of Incorporation.
Where the Company is composed of more than one shareholder, the shares may be freely transferred amongst any
existing shareholders. A transfer to a non-shareholder is subject to the restrictions of the Articles of Incorporation.
Where the Company is composed of more than one shareholder, the shares can be transferred by living persons to
non-shareholders only with the authorisation, granted at a general meeting of shareholders, of the shareholders repre-
senting at least three quarters (3/4) of the corporate capital of the Company.
Art. 12. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
A transfer will not be binding upon the Company and third parties, unless duly notified to, or accepted by the Company,
pursuant to article 1690 of the Civil Code.
The Company will refuse to register any transferee as shareholder if the transferee is a natural person or if, as a
consequence of such transfer, the number of shareholders exceeds thirty (30).
Art. 13. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the
1915 Law.
Art. 14. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting a shareholder will not cause the Company to go into liquidation.
Art. 15. Board of directors. The Company is managed and administered by a board of directors consisting of at least
two (2) directors. A director can be a shareholder or a non-shareholder.
Each director is appointed for a limited or an unlimited duration by the single shareholder owning the entire issued
share capital or by a group of shareholders in general meeting.
36051
Any director may be removed at any time by the single shareholder holding the entire issued share capital, or by a
majority of shareholders in general meeting, who collectively hold at least three quarters (3/4) of the corporate capital
of the Company. Any director may resign at any time.
The single shareholder holding the entire issued share capital, or a group of shareholders in general meeting decides
upon the compensation of each director (if any).
The board of directors shall appoint, from among its members, a chairman. The board of directors shall choose a
secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping board meeting minutes.
The board of directors may also appoint officers of the Company considered necessary for the operation and man-
agement of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the board. Officers need not be directors
or shareholders of the Company. The officers appointed shall have the powers and duties entrusted to them by the board.
Art. 16. Meetings of the board of directors. The board of directors shall meet at the place indicated in the notice of
the meeting.
Written notice of any board meeting shall be given to all directors at least 24 hours in advance of the time set for such
meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the
notice of the meeting. This notice may be waived if each director consents in writing, by cable, telegram, telex or telefax.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing, by cable, telegram, telex or
telefax, another director as his proxy. Directors may also cast their vote in writing, by cable, telegram, telex or telefax.
Meetings of the board of directors may be held by way of conference call, video conference or any other similar means
of communication, in which case the directors participating by such means shall be deemed to be present in Luxembourg.
The board of directors shall act validly only if a majority of directors are present or represented at a meeting of the
board. Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented.
Resolutions may also be passed in the form of a consent resolution, set out in identical terms. This may be signed
jointly or by the use of counterparts by all the directors. The chairman of the board of directors shall have a casting vote.
Art. 17. Powers of representation. In dealing with third parties, any two directors shall have the power to act jointly
in the name of the Company in all circumstances and to carry out and authorise all acts and operations consistent with
the Company's purpose. The Company is bound in all circumstances by the signature of two directors.
Art. 18. Board of Directors' Committees. The board of directors may, by a majority vote, set up one or more com-
mittees to deal with specific matters under its supervision and responsibility, each committee to consist of one or more
directors of the Company. The board may designate one or more directors as alternate members of any committee to
replace any absent or disqualified member at a committee meeting.
Art. 19. Death, incapacity, bankruptcy or insolvency of a director. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency, res-
ignation, removal or any other similar event affecting a director, will not cause the Company to go into liquidation.
Creditors, heirs and successors of a director may in no event have seals affixed to the assets and documents of the
Company.
Art. 20. Liability of a director. A director will not incur any personal liability arising out of the functions performed on
behalf of the Company. He is only liable for the performance of his mandate.
The Company shall indemnify, to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or
is threatened to be made a part to, or is involved in any manner in, any threatened, pending or completed action, suit or
proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative) by reason of the fact that such person (1) is or was a
director or officer of the Company or a subsidiary or (2) is or was serving at the request of the Company or a subsidiary
as a director, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint venture, trust,
committee or other enterprise.
To the extent deemed advisable by the board of directors, the Company may indemnify, to the fullest extent permitted
by applicable law, any person who was or is a party or is threatened to be made a party to, or is involved in any manner
in, any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative)
by reason of the fact that the person is or was an employee or agent (other than a director or officer) of the Company
or a subsidiary.
The Company shall have the power to purchase and maintain insurance on behalf of any person who is or was a
director, officer, employee or agent of the Company or a subsidiary, or is or was serving at the request of the Company
or a subsidiary as a director, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint
venture, trust, committee or other enterprise, against any expense, liability or loss asserted against him and incurred by
him in any such capacity, or arising out of his status as such, whether or not the Company or a subsidiary would have the
power to indemnify him against such expense, liability or loss under the provisions of applicable law.
No repeal, modification or amendment of, or adoption of any provision inconsistent with, this article 20, nor to the
fullest extent permitted by applicable law, any modification of law shall adversely affect any right or protection of any
person granted pursuant hereto existing at, or with respect to events that occurred prior to, the time of such repeal,
amendment, adoption or modification.
36052
The right to indemnification conferred in this article 20 also includes, to the fullest extent permitted by applicable law,
the right to be paid the expenses (including attorney's fees) incurred in connection with any such proceeding in advance
of its final disposition. The payment of any amounts to any director, officer, partner, member, employee or agent pursuant
to this article 20 shall subrogate the Company to any right such director, officer, partner, member, employee or agent
may have against any other person or entity. The rights conferred in this article 20 shall be contractual rights.
Art. 21. General meeting of shareholders. When the Company is composed of one single shareholder, that shareholder
exercises the powers granted by the 1915 Law to shareholders in general meeting.
Articles 194 to 196 and 199 of the 1915 Law are not applicable to that situation.
When the Company is composed of a group of shareholders, shareholder decisions are taken in a general meeting or
by written resolution, the text of which will be sent by the board of directors to the shareholders by registered post.
In this case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and send it by registered post to the
Company within 15 days of receiving the text.
When the Company is composed of a group of shareholders, unless otherwise specified in the Articles of Incorporation,
shareholder decisions are only validly taken if they are adopted by shareholders holding more than half of the corporate
capital. However, resolutions to amend the Articles of Incorporation and to liquidate the Company may only be taken
by a majority of shareholders representing three quarters (3/4) of the Company's corporate capital.
Art. 22. Decisions. The decisions of the single shareholder or of a group of shareholders in general meeting are
documented in writing, recorded in a register and kept at the registered office of the Company. Shareholder votes and
any powers of attorney are attached to the minutes.
Art. 23. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of
the same year.
Art. 24. Statutory auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided
by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.
The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case
may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six (6) years, and they will hold
office until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but
they may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of share-
holders, as the case may be.
Art. 25. Balance-sheet. On 31 December of each year, the accounts are closed and the board of directors will produce
an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the 1915 Law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or to a group of shareholders
in general meeting for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may consult the financial documents at the registered office of the Company
for a period of fifteen days prior to the deadline set for the shareholder general meeting.
Art. 26. Allocation of profits. The balance of the profit and loss account, after the deduction of overheads, depreciation
and provisions is the net profit of the financial year.
Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be
mandatory when the reserve amounts to ten per cent of the capital.
The remaining profit is allocated by the decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of a group of
shareholders in general meeting.
Any amount out of the share premium account may be distributed to the shareholders upon a decision of the single
shareholder or pursuant to a resolution of a group of shareholders in general meeting.
The single shareholder or a group of shareholders in general meeting may also decide to allocate any amount out of
the share premium account to the legal reserve account.
Art. 27. Dissolution, liquidation. In the case of the dissolution of the Company, for any reason and at any time, the
liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not. The liquidator(s) will be appointed by
the single shareholder or by a group of shareholders in general meeting, who will set the powers and compensation of
the liquidator(s).
Art. 28. Matters not provided. All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in ac-
cordance with applicable laws.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company have been drawn up by the appearing party. This party has subscribed
and entirely paid-up in cash the amount of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-) representing one
hundred and twenty-five (125) shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.
36053
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article
183 of the 1915 Law have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind, borne by the Company as a result of its formation, are estimated
at approximately EUR 2,000.-.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2007.
<i>Decisions by the Sole Shareholderi>
The appearing party in its capacity as sole shareholder of the Company has passed the following resolutions:
1 Resolved to set the minimum number of directors at two and further resolved to elect the following in their respective
capacity as a director of the Company for an unlimited period of time:
- Dr. Bodo Zöll, Head of legal at Commerz Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH, born on 12 October 1953 in
Lambrecht, Germany, professionally residing at 65205 Wiesbaden, Kreuzberger Ring 56, Germany;
- Mr. Ralf Schwarzer, Head of tax at Commerz Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH, born on 6 May 1966 in Kusel,
Germany, professionally residing at 65205 Wiesbaden, Kreuzberger Ring 56, Germany;
2 The registered office shall be at 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
3 PricewaterhouseCoopers S.à r.l., a company having its registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg,
is appointed as statutory auditor of the Company for a period of six years.
The present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who is knowledgeable of the English language, states that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English and followed by a French version. At the request of the same person and
in case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, the said person signed together with the notary the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le neuf février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
CGM LUX 1 S.à r.l. ayant son siège social au 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par le notaire soussigné, en date de ce jour, représentée par Mme Inga Pawlitschko, juriste, demeurant profession-
nellement à Wiesbaden en Allemagne, en vertu d'une procuration, qui, après avoir été signée ne varietur par le comparant
et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Le comparant, agissant en sa qualité susmentionnée a requis le notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts
d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée comme suit:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par l'actionnaire unique une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la
législation luxembourgeoise et notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi de 1915»), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).
La Société comportera initialement un associé unique propriétaire de toutes les parts sociales. La Société peut ce-
pendant, à tout moment, comporter plusieurs associés dont le nombre ne peut dépasser 30 associés notamment suite à
la cession de parts sociales ou l'émission de nouvelles parts sociales.
Les associés ne doivent pas être des particuliers.
Art. 2. Nom. La Société prend la dénomination sociale de CGM LUX 2 S.à r.l.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion, la vente, le financement (notamment par
des emprunts souscrits auprès de tiers prêteurs) et l'échange d'immeubles ou de titres de toutes sociétés détenant des
immeubles et plus généralement des avoirs constitutifs d'investissements autorisés par CG REAL ESTATE MASTER FCP,
un fonds commun de placement organisé en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg (le «Fonds»).
La Société pourra fournir un soutien financier à CG REAL ESTATE LUXEMBOURG S.à r.l. agissant en sa capacité de
société de gestion du Fonds et aux sociétés dans lesquelles le Fonds détient directement ou indirectement une partici-
pation, en particulier en octroyant des prêts, facilités, sûretés ou garanties de quelque nature et durée que ce soit et leur
fournir tout conseil et assistance de quelque nature que ce soit.
La Société peut effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement de son objet social, tout en restant
toujours dans les limites fixées par les documents constitutifs du Fonds et par la législation et la réglementation du
Luxembourg.
36054
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique détenant la totalité du capital libéré. S'il
y a plusieurs associés, la Société peut être dissoute à tout moment par résolution adoptée par l'assemblée générale des
associés.
Art. 5. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision du conseil
d'administration.
La Société pourra établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Art. 6. Capital Social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-
cinq (125) parts sociales entièrement libérées d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale (y compris tout paiement effectué sur des warrants attachés aux parts sociales,
obligations, billets ou instruments similaires) seront transférées.
L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales
des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou
pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Modification du Capital social. Le capital social, peut, à tout moment, être augmenté ou diminué, par décision
de l'associé unique ou, le cas échéant, suivant une résolution de l'assemblée générale des associés.
Art. 8. Capital autorisé. Le capital autorisé de la Société est fixé à deux cent cinquante millions d'euros (€ 250.000.000,-)
divisé en deux million cinq cent mille (2.500.000) de parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (€ 100,-)
chacune.
Le conseil d'administration de la Société est autorisé, pendant une période prenant fin cinq (5) années après la date
de publication dans le Mémorial, recueil C, des Statuts créant le capital autorisé, à augmenter le capital social dans les
limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par l'émission de parts sociales au profit des détenteurs de parts
sociales existants ou de toute personne approuvée par les associés aux conditions de quorum et de majorité prévues à
l'article 189, alinéa 1, de la Loi de 1915.
Ces parts sociales peuvent être souscrites et émises selon les termes et conditions déterminés par le conseil d'admi-
nistration de la Société.
Le conseil d'administration peut en particulier déterminer:
- la période et le nombre de parts sociales à souscrire et à émettre;
- si une prime d'émission sera payée sur les parts sociales à souscrire et à émettre, et le montant de cette prime
d'émission, le cas échéant;
- si les parts sociales seront libérées par un apport en espèce ou en nature; et,
- que les parts sociales seront émises après l'exercice du droit de souscription et/ou du droit de conversion octroyé
par le conseil d'administration de la Société selon les termes des warrants (qui peuvent être séparés ou attachés aux parts
sociales, obligations, billets ou instruments similaires), obligations convertibles, billets ou instruments similaires émis par
la Société de temps à autre.
Le conseil d'administration de la Société peut déléguer à tout administrateur de la Société autorisé ou fondé de pouvoir
de la Société ou toute autre personne dûment autorisée, l'obligation d'accepter les souscriptions et de recevoir le paie-
ment de parts sociales représentant une partie ou l'entièreté de telles augmentations de capital.
A chaque augmentation du capital social de la Société par le conseil d'administration dans les limites du capital autorisé,
le présent article 8 sera modifié en conséquence.
Art. 9. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices et avoirs de la Société et une voix aux assemblées générales des associés.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus à tous les associés par la
Loi de 1915 et les Statuts.
La propriété d'une part sociale emporte adhésion implicite aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique,
détenant la totalité du capital libéré de la Société, ou de l'assemblée générale des associés.
Les créanciers ou ayants droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire
des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 10. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis des parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.
36055
Art. 11. Cession des parts sociales. Lorsque la Société comporte un associé unique, cet associé unique pourra librement
céder ses parts sociales.
Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Le transfert
à un non-associé est soumis aux restrictions des Statuts.
Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés
que moyennant l'agrément de l'assemblée générale des associés représentant trois-quarts (3/4) du capital social de la
Société.
Art. 12. Formalités. La cession des parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou
acceptées par elle conformément à l'article 1690 du code civil.
La société refusera de faire entrer dans le registre des associés un cessionnaire qui serait un particulier ou dès lors
que, à la suite du transfert de parts, le nombre des associés excèderait trente (30).
Art. 13. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions
légales de la Loi de 1915.
Art. 14. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement
similaire affectant un associé n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 15. Conseil d'administration. La Société est gérée et administrée par un conseil d'administration comprenant au
moins deux (2) administrateurs, associés ou non.
Chaque administrateur est nommé avec ou sans limitation de durée par l'associé unique détenant la totalité du capital
social libéré ou par l'assemblée générale des associés.
L'associé unique détenant la totalité du capital libéré ou l'assemblée générale des associés en vertu d'une résolution
favorable représentant 75% du capital social de la Société, pourra décider la révocation d'un administrateur à tout moment.
Chaque administrateur peut démissionner de ses fonctions à tout moment.
L'associé unique, détenant la totalité du capital libéré, ou l'assemblée générale des associés décidera, le cas échéant,
de la rémunération de chaque administrateur.
Le conseil d'administration pourra nommer, parmi ses membres, un président. Le conseil d'administration pourra
choisir un secrétaire, qui sera administrateur ou non et qui sera responsable de la conservation des minutes des réunions
du conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra nommer des fondés de pouvoirs de la Société jugés nécessaires pour la conduite
des affaires et la gestion de la Société. Pareilles nominations pourront être révoquées à tout moment par le conseil
d'administration. Les fondés de pouvoirs ne doivent pas être administrateur ou associé de la Société. Les fondés de
pouvoirs auront les pouvoirs et obligations qui leur seront conférés par le conseil d'administration.
Art. 16. Réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunira au lieu indiqué dans l'avis de
convocation.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 heures avant
l'heure prévue pour celle-ci, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être renoncé à cet avis si chaque administrateur y consent par écrit, par câble,
télégramme, télex ou message télécopié.
Tout administrateur pourra se faire représenter lors d'une réunion du conseil d'administration en désignant par écrit,
câble, télégramme, télex ou message télécopié un autre administrateur comme son mandataire. Les administrateurs
peuvent également voter par écrit ou par câble, télégramme, télex ou message télécopié. Les réunions du conseil d'ad-
ministration peuvent être tenues au moyen de conférences téléphoniques ou visioconférences ou tous autres moyens de
communication, auxquels cas les administrateurs participant par le biais de tels moyens de communication seront réputés
être présents à Luxembourg.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs
sont présents ou représentés à une réunion du conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs
présents ou représentés à la réunion.
Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises par des résolutions circulaires identiques en
leurs termes, signées sur un ou plusieurs documents par tous les administrateurs. Le président du conseil d'administration
a un droit de vote décisif.
Art. 17. Pouvoirs de représentation. Vis-à-vis des tiers, deux administrateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour
agir conjointement au nom de la Société en toutes circonstances ainsi que pour accomplir et autoriser tous les actes et
opérations relatifs à l'objet social de la Société. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de deux
administrateurs.
Art. 18. Comités du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, par un vote à la majorité de tout le
conseil, constituer un ou plusieurs comités afin de traiter sous son contrôle et sa responsabilité de sujets particuliers,
36056
chaque comité comprenant un ou plusieurs membres administrateurs de la Société. Le conseil d'administration peut
désigner un ou plusieurs administrateurs comme membre alternatif de l'un des comités en vue du remplacement d'un
membre absent ou disqualifié pour une réunion du comité.
Art. 19. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture d'un administrateur. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture
d'un administrateur ou tout événement similaire affectant un administrateur, de même que sa démission ou révocation,
n'entraînent pas la dissolution de la Société.
Les créanciers, héritiers et ayants droit d'un administrateur ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les
biens et documents de la Société.
Art. 20. Responsabilité d'un administrateur. Un administrateur ne contracte, du fait de ses fonctions, aucune obligation
personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable
que de l'exécution de son mandat.
La Société dédommagera, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne
qui a été ou est partie, ou est menacée d'être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action,
procès ou procédure (en matière civile, pénale, administrative ou à l'occasion d'une procédure d'instruction) du fait que
cette personne (1) a été ou est administrateur ou fondé de pouvoir de la Société ou d'une filiale ou (2) a rendu ou rend
des services à la demande de la Société ou d'une filiale en tant qu'administrateur, fondé de pouvoir, associé, membre,
employé ou agent d'une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou toute autre entreprise.
Dans la mesure où le conseil d'administration l'estime recommandé, la Société peut indemniser, dans toute la mesure
du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne qui a été partie, ou est partie, ou est menacée
d'être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action, procès ou procédure menaçant d'être
entamé, en cours d'instance ou terminé (de nature civile, pénale, administrative ou à l'occasion d'une procédure d'ins-
truction) du fait que cette personne a été ou est un employé ou un agent (autre qu'administrateur ou fondé de pouvoir)
de la Société ou d'une filiale.
La Société aura le pouvoir de souscrire et de maintenir une police d'assurance pour le compte de cette personne qui
est ou a été administrateur, ou fondé de pouvoir, employé ou agent de la Société ou d'une filiale, ou qui a rendu ou rend
des services à la demande de la Société ou d'une filiale comme administrateur, fondé de pouvoir, associé, membre, employé
ou agent d'une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou toute autre entreprise, du fait de toute dépense,
responsabilité ou perte imposée à cette personne et encourue par elle en cette qualité ou en raison de son statut, que
la Société ou une filiale ait ou non le pouvoir de l'indemniser du fait d'une telle dépense, responsabilité ou perte en vertu
des dispositions légales applicables.
Toute abrogation, modification, avenant ou adoption d'une disposition en contradiction avec cet article 20, ainsi que
dans la mesure où cela serait permis en vertu des dispositions légales en vigueur, toute modification du droit n'entravera
les droits ou la protection accordés à toute personne en vertu du présent article 20 tels qu'ils sont ou étaient en vigueur
au moment ou antérieurement à de tels abrogation, avenant, adoption ou modification.
Le droit à l'indemnisation conféré en vertu de cet article 20 comporte également, dans la mesure où cela est permis
par les dispositions légales en vigueur, le droit d'être remboursé des dépenses (comprenant les honoraires d'avocat)
encourues du fait de telles procédures avant même leur issue définitive. Le paiement de tout montant au profit d'un
administrateur, fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent en vertu de cet article 20 subrogera la Société
dans les droits que peuvent avoir de tels administrateurs, fondés de pouvoir, associés, membres, employés ou agents
contre toute autre personne ou entité. Les droits conférés en vertu de cet article 20 seront des droits contractuels.
Art. 21. Assemblées générales des associés. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les
pouvoirs dévolus par la Loi de 1915 à l'assemblée générale des associés.
Dans ce cas, les articles 194 à 196, ainsi que 199 de la Loi de 1915 ne sont pas applicables.
Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le conseil d'administration aux associés par lettre
recommandée.
Dans ce cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote par écrit et de l'envoyer à la Société par lettre recom-
mandée, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les décisions des associés ne sont valablement prises qu'avec l'accord
des associés représentant plus de la moitié du capital social sauf dispositions contraires contenues dans ces statuts.
Cependant, des décisions portant modification des présents statuts et notamment celle de liquider la Société ne peuvent
être valablement prises qu'avec l'accord de la majorité des associés représentant trois-quarts (3/4) du capital social de la
Société.
Art. 22. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit
et consignées dans un registre tenu au siège social de la Société. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les
procurations seront annexées aux procès-verbaux.
Art. 23. Année sociale. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du
mois de décembre de l'année suivante.
36057
Art. 24. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs com-
missaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être dans les cas prévus par la loi.
Le ou les commissaires aux comptes, s'il y en a, seront nommés par décision de l'associé unique ou des associés, selon
le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu'à
ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif
par décision de l'associé unique ou des associés.
Art. 25. Approbation des comptes annuels. Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil
d'administration dresse un inventaire des avoirs et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la Loi de
1915.
Les comptes annuels sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, de l'assemblée générale des
associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut consulter les documents financiers au siège social de la Société, au cours
d'une période de quinze jours précédant la date de l'assemblée générale des associés.
Art. 26. Répartition des bénéfices et dividendes intérimaires. L'excédent du compte de résultats, déduction faite des
frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve a atteint dix pour cent du capital social.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés.
Tout montant non compris dans le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés suivant une décision
de l'associé unique ou une résolution de l'assemblée générale des associés.
L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut aussi décider d'affecter tout montant non compris dans le
compte de prime d'émission à la réserve légale.
Art. 27. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce
soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 28. Disposition générale. Tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, est soumis aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Souscription et paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit et a entièrement libéré en espèces le montant
de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,-) chacune.
La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article
183 de la Loi de 1915 ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ EUR 2.000,-.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
<i>Décision de l'associé uniquei>
Le comparant, en sa qualité d'associé unique de la Société, a pris les résolutions suivantes:
1 L'associé unique décide de fixer à deux (2) le nombre d'administrateurs et de nommer les personnes suivantes en
leur qualité respective d'administrateur de la Société pour une durée indéterminée:
- Dr Bodo Zöll, Directeur du département juridique de Commerz Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH,, né le 12
octobre 1953 à Lambrecht, Allemagne, ayant sa résidence professionnelle au 65205 Wiesbaden, Kreuzberger Ring 56,
Allemagne;
- M. Ralf Schwarzer, Directeur du département fiscal de Commerz Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH, né le 6
mai 1966 à Kusel, Allemagne, et ayant sa résidence professionnelle au 65205 Wiesbaden, Kreuzberger Ring 56, Allemagne;
2 Le siège social est fixé à 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
3 PricewaterhouseCoopers S.à r.l., une société ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg est
nommé commissaire de la Société pour une durée de six ans.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
36058
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent
acte.
Signé: I. Pawlitschko, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, vol. 32cs, fol. 6, case 7. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 28 février 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007040074/242/505.
(070036655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2007.
European Property Fund (Radans) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 124.538.
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-first day of December 2006.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
EUROPEAN PROPERTY FUND LIMITED S.à.r.l., a private limited liability company incorporated and organised under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, in
the process of registration with the Luxembourg trade register,
represented by Mr Patrick Van Hees, jurist in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given on
December 21, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
EUROPEAN PROPERTY FUND (RADANS) S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of
Luxembourg, in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the
Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
36059
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and
undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may acquire, directly or indirectly, manage, enhance, lease and dispose of real estates located in
Luxembourg or abroad.
3.5. The Company may carry out any marketing, advertising, maintenance, commercial, financial or industrial operations
and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its
object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand and six hundred euro (EUR 12,600.-) represented
by one hundred and twenty-six (126) shares in registered form with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each,
all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the general meeting of
partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of
managers. Manager(s) need not be partner(s).
7.2. The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within
the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any two managers of the Company.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
36060
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of
any two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has
been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General Meetings of Partners
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,
the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
36061
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by
law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner
in the Company.
VII. General provision
Art. 17. General provision.
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
The shares in the Company have been subscribed as follows:
EUROPEAN PROPERTY FUND LIMITED S.à.r.l.: one hundred and twenty-six shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of EUR 12,600.- (twelve thousand six
hundred euro) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimated costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately two thousand euro.
<i>Resolutions of the partnersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the partners, representing the entirety of the subscribed share
capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Michael David Evans, born on 19 November 1952 in Buckland, Buckinghamshire, United Kingdom, residing in
Chobham Park House, Chobham Park Lane, Chobham, Surrey GU24 HQ, United Kingdom;
- Mr Bart Zech, company director, born on 5 September 1969 in Putten (The Netherlands), residing in 12, rue Léon
Thyes, L-2636 Luxembourg; and
- Mr Frank Walenta, company director, born on 2 February 1972, professionally residing in 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt et unième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
A comparu:
EUROPEAN PROPERTY FUND LIMITED S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont
le siège social est établi au 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, en cours d'enregistrement au registre de com-
merce de Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Jean-Marc Delcour, avocat, résident à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 21 décembre 2006.
36062
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à res-
ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination EUROPEAN PROPERTY
FUND (RADANS) S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des
succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou
des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou
obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre
société ou personne.
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change,
de taux d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations publicitaire, marketings, de maintenance, commerciales, financières
ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favo-
risent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.
4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-), représenté par cent vingt-six (126) parts
sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entière-
ment libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
5.3. La Société ne peut émettre des instruments financiers, convertibles ou non, qu'exclusivement à ses associés, sous
condition que chaque associé souscrive à un tel instrument et pour le même pourcentage que son intérêt dans le capital
social de la société.
36063
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par résolution de l'assemblée générale des associés
laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s)
gérant(s) ne doivent pas nécessairement être actionnaire(s).
7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le gérant de la Société, ou, en cas de pluralité de gérants, par au moins deux gérants de la Société.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou
représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenu. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers, par la signature du gérant,
et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'au moins deux gérants ou par la ou les signature(s) simple
ou conjointes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à
l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
36064
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.
VIII. Disposition générale
Art. 17. Disposition générale.
17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales de la Société ont été souscrites de la façon suivante:
EUROPEAN PROPERTY FUND LIMITED S.à r.l.: cent vingt-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR
12.600,- (douze mille six cents euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instru-
mentaire, qui le reconnaît expressément.
<i>Estimation des fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille euros.
36065
<i>Décision de l'associé uniquei>
Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Bart Zech, administrateur de sociétés, né le 5 septembre 1969 à Putten, administrateur de sociétés, résident
professionnellement au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
- M. Frank Walenta, administrateur de sociétés, né le 2 février 1972, résident professionnellement au 12, rue Léon
Thyes, L-2636 Luxembourg; et
- M. Michael David Evans, né le 19 novembre 1952 à Buckland, Buckinghamshire, Royaume-Uni, résident à Chobham
Park House, Chobham Park Lane, Chobham, Surrey GU24 HQ, Royaume-Uni.
2. Le siège social de la Société est établi au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en
langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 janvier 2007, vol. 440, fol. 64, case 10. — Reçu 126 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Mersch, le 15 février 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007034481/242/395.
(070029557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.
EPI Oakwood GP 5 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 124.653.
STATUTES
In the year two thousand seven, on the nineteenth day of January
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
EPI OAKWOOD HOLDING S.à.r.l., a limited liability company existing under the laws of Luxembourg, and having its
registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under the
number not yet available;
hereby represented by Mr Yves Barthels, manager, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» (limited
liability partnership company), which it declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed by
the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and more particularly
the law of December 28th, 1992 about unipersonal companies.
At any moment, the sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners
may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercises the powers devolved to the General Meeting of partners.
Art. 2. The Company is incorporated under the name of EPI OAKWOOD GP 5, S.à.r.l.
Art. 3. The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial
or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution,
underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to
36066
manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances
or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without
taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of the Company's purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any partner.
Art. 7. The creditors, representatives, parties entitled or heirs of any partner are neither allowed, under any circum-
stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the
administration of the Company. Such parties must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the
decisions of the meetings.
Capital - Units
Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred euros) represented by 500
(five hundred) units of EUR 25.- (twenty-five euros) each.
Art. 9. Each unit confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The units may only be transferred, as applicable on a valuation day (hereafter referred to as «Valuation Day»
and being, for the purposes of this clause, the last day that banks are open for business in London of each calendar month),
provided that, for the avoidance of doubt, the entering into by the partners of an agreement on a date other than a
Valuation Day providing for such transfer to occur on a Valuation Day shall not be in breach of such restriction and
provided further that (a) such restriction shall not apply where the Company holds less than four real estate assets directly
or indirectly and (b) such restriction shall not apply to any transfer resulting from the enforcement of security by a creditor
of the Company or a creditor of the partner in the Company. The Company shall determine and notify to the partner
of its equity gains (Aktiengewinn) on any Valuation Day.
Only partners that are institutional investors (being investors that are not natural persons) shall be allowed to invest,
hold or be the beneficial owner of a unit in the Company.
Partnerships shall not be allowed to invest, hold or be the beneficial owner of a unit in the Company, unless the
Company confirms in writing that it does not object to such participation of a partnership.
There shall be no more than 30 institutional investors (being investors that are not natural persons) investing, holding
or being the beneficial owner of a unit in the Company at any one time.
Units may not be transferred inter vivos to non-partners unless partners representing at least three-quarter of the
corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The units are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers, appointed by the partners with or without limitation of
their period of office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s)
need not to be partners. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners
holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
36067
All powers not expressly reserved by law or the present articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a proxy-holder he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers. Any manager may act at any meeting of
managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
manager's meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or telecopy, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.
Partners decisions
Art. 14. Partners' decisions are taken by partners' meetings. However the holding of meetings is not compulsory as
long as the partner's number is less than twenty-five.
In such case the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or decisions
to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a second
meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be
represented.
However, decisions concerning an amendment to the articles of association must be taken by a majority vote of
partners representing the three quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of
the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company's financial year begins on April 1st and closes on March 31st.
Art. 17. Each year, as of the 31st of March, the management will draw up the balance sheet which will contain a record
of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all the commitments and debts of the manager(s) to the company.
At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of partners together with the balance sheet.
Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
36068
The balance is at the disposal of the partners, which may be distributed to the partners pro-rata (in accordance with
their respective participations in the share capital of the Company) unless otherwise provided in an agreement among
the partners to be entered into from time to time.
However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction
of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
The partners may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers
showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves,
but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles
of incorporation.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners propor-
tionally to their participation in the corporate capital of the Company.
Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing
laws.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on March 31st, 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 500 (five hundred) units representing the capital have been entirely subscribed by EPI OAKWOOD HOLDING
S.à.r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros)
is as now at the disposal of the Company, EPI OAKWOOD GP 2 S.à.r.l., proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand three hundred euros.
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as managers:
a) Mr Bruno Bagnouls, residing professionally at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
b) Mrs Anita Lyse, residing professionally at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
c) Mr Yves Barthels, residing professionally at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
d) Mr Richard James, residing professionally at One Curzon Street, W1J 5HD London, United Kingdom.
e) Mr Ronald Seacombe, residing professionally at One Curzon Street, W1J 5HD London, United Kingdom.
All acts binding the Company must be signed by two managers or by an officer duly authorized by two managers.
2) The Company shall have its registered office in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person signed with us, the Notary, the present original
deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendsieben, den neunzehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
EPI OAKWOOD HOLDING S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in 5, allée
Scheffer, L-2520 Luxemburg, noch nicht im Handelsregister in Luxemburg eingetragen,
hier vertreten durch Herrn Yves Barthels, Geschäftsführer, mit Amstwohnsitz in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg,
durch eine privatschriftlich ausgestellte Vollmacht.
36069
Diese Vollmacht wird ne viatur vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar paraphiert und bleibt diesem
Akt beigelegt.
Diese Komparentin, erklärte eine Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, welche den folgenden
Satzungen unterliegt.
Name - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der vorliegenden Sat-
zung unterliegt sowie den entsprechenden Gesetzesbestimmungen und besonders die Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaften und vom 18. September 1933 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
wie von Zeit zu Zeit abgeändert, und insbesondere das Gesetz vom 28. Dezember 1992 über Einmann-Gesellschaften.
Der Gesellschafter kann jedoch zu jeder Zeit einen oder mehrere Gesellschaftspartner annehmen. Zukünftige Ge-
sellschafter können die notwendigen Massmahmen ergreifen um den Status einer Einmann-Gesellschaft wiederherzustel-
len. Solange die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat, hat dieser alle Befugnisse die der Hauptversammlung der
Gesellschafter zustehen.
Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet unter der Bezeichnung EPI OAKWOOD GP 5 S.à r.l.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in beliebiger Form durch Kauf, Umtausch oder ähnliche
Transaktionen an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung
dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann außerdem diese Beteiligungen durch Verkauf, Umtausch oder ähnliche Transaktionen abtreten.
Die Gesellschaft kann außerdem jedwede Patente, Warenzeichen oder intellektuelle und unkörperliche Rechte sowie
andere damit verbundene oder komplettierende Rechte erwerben und entwickeln.
Die Gesellschaft kann auf beliebige Weise Fremdkapital aufnehmen, insbesondere durch Ausgabe von Anleihen, u.a.
Wandelanleihen, Bankkredite oder Erhöhung des Eigenkapitals, und sie kann anderen Unternehmen, an denen sie direkt
oder indirekt beteiligt ist oder nicht, Kredite, Darlehen oder Vorschüsse gewähren bzw. Garantien ausstellen.
Außerdem kann die Gesellschaft Wertpapiere, Bareinlagen, Schatzpapiere erwerben oder Investitionen auf andere Art
und Weise tätigen, insbesondere durch den Kauf, die Zeichnung oder auf ander Art und Weise von Aktien, Obligationen,
Optionsrechten oder andere Arten von Wertpapieren um diese zu verkaufen oder zu tauschen.
Sie kann Transaktionen von gewerblichen, kommerziellen und finanziellen Vermögenswerten sowie Sachanlagen und
Immoblilien vornehmen, die ganz oder teilweise direkt oder indirekt seinem Geschäftszweck entsprechen.
Sie kann direkt oder indirekt, auf eigene Rechung oder im Namen Dritter, allein oder in Zusammenarbeit mit anderen
tätig sein und dabei alle Arten von Tätigkeiten im Rahmen des oben genannten Gesellschaftsobjekts bzw. zugunsten des
Gesellschaftsobjekts der Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, ausführen.
Die Gesellschaft kann grundsätzlich alle Kontroll- oder Überwachungsmassnahmen übernehmen und alle Tätigkeiten
durchführen, die sie als zur Erfüllung ihres Gesellschaftsobjekts erforderlich erachtet, und kann das Mandat zur Leitung
eines beliebigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmens mit oder ohne Vergütung übernhemnen.
Die Gesellschaft unterliegt nicht dem spezifischen Steuerstatut laut Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesell-
schaften.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungs-
rates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im
Ausland errichtet werden.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Geschäftsführer im inneren der Stadt Luxemburg geändert
werden.
Die Gesellschaft kann mehrere Geschäftsräume und Zweigstellen im Inland und Ausland eröffnen.
Sollte die Geschäftsführung feststellen, dass politische, ökonomische oder soziale Entwicklungen die normalen Ge-
schäftsaktivitäten der Gesellschaft am Gesellschaftssitz verhindern oder kurzfristig verhindern könnten, oder sollten
Kommunikationsprobleme zwischen dem Personal in den Geschäftsräumen des Gesellschaftssitzes und dem Personal im
Ausland bestehen, kann der Gesellschaftssitz vorläufig ins Ausland übertragen werden bis die außergewöhnliche Umstände
sich wieder eingeordnet haben. Diese vorläufigen Massnahmen haben keinen Einfluss auf die Staatsangehörigkeit der
Gesellschaft, welche, trotz Verlegung des Gesellschaftssitzes, eine Gesellschaft unter Luxemburger Recht bleibt.
Art. 5. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit sowie die ge-
setzliche Untersagung eines Teilhabers.
Art. 7. Gläubiger, Vertreter oder Erben eines Gesellschafters können unter keinen Umständen, die Eigentümer und
Dokumente der Gesellschaft versiegeln lassen, noch können sie sich in keiner Weise in der administrativen Tätigkeit der
Gesellschaft einmischen. Zur Ausführung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bücher der Gesellschaft und die Entschei-
dungen der Hauptversammlung der Gesellschafter beziehen.
36070
Aktienkapital
Art. 8. Das gezeichnete Aktienkapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, eingeteilt in
fünfhundert (500) Anteile mit einem Nominalwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Art. 9. Jeder Anteil gibt Recht auf das gleiche Stimmrecht bei Gesellschafterbeschlüssen.
Art. 10. Die Anteile können nur von den Gesellschaftern an jedem Auswertungsdatum (das «Auswertungsdatum»,
welches zum Zweck dieses Artikels, der letzte Arbeitstag eines jeden Kalendermonats der Londoner Banken bedeutet)
veräußert werden, vorausgesetzt, dass die Abschließung eines solchen Übertragungsvertrages zu einem Datum welcher
nicht dem Auswertungsdatum entspricht, aber an einem Auswertungsdatum in Kraft treten soll nicht als Verletzung dieser
Beschränkung angesehen werden. Weitere Voraussetzungen sind a) solche Beschränkung ist nicht gültig falls die Gesell-
schaft weniger als vier Grundeigentum-Vermögen direkt oder indirekt besitzt und b) solche Beschränkung ist nicht gültig
im Zusammenhang mit einer Anteilübertragung welche durch die Erzwingung einer Sicherheit durch einen Gläubiger der
Gesellschaft oder seines Gesellschafters in Kraft tritt. Die Gesellschaft bestimmt und informiert den Gesellschafter an
jedem Auswertungstag über ihren Aktiengewinn.
Nur Gesellschaftern (Institutionskapitalanleger, welche also keine natürliche Personen sind) ist es erlaubt in die Ge-
sellschaft zu investieren oder einen Anteil der Gesellschaft auf irgendeine Weise zu besitzen.
Teilhaberschaften ist es nicht erlaubt in die Gesellschaft zu investieren oder Anteile der Gesellschaft auf irgendeine
Weise zu besitzen, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft einer solchen Anteilnahme schriftlich zustimmt.
Es sollen zu keiner Zeit mehr als 30 Institutionalkapitalanleger in die Gesellschaft investieren oder Anteile der Gesell-
schaft besitzen.
Anteile sind nicht inter vivos an Nicht-Gesellschafter übertragbar, vorausgesetzt dass die Gesellschafter, die zumindest
drei-viertel des Gesellschaftskapital repräsentieren, einer solchen Übertragung in einer Generalversammlung zustimmen.
Ansonsten sind die Anteilübertragungen Artikeln 189 and 190 des Gesetzes über Handelsgesellschaften unterlegen.
Die Anteile sind unteilbar und somit kann jeder Anteil nur einen Besitzer haben.
Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, welche Gesellschafter oder Nicht-
gesellschafter sein können und welche, mit oder ohne bestimmte Dauer, durch die Gesellschafter ernannt werden.
Geschäftsführer können jederzeit abberufen werden, mit oder ohne Grund, mit einem Mehrheitsbeschluss der Gesell-
schafter.
Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse um die Geschäfte der Gesellschaft hinsichtlich
des Gesellschaftszecks, im Rahmen der Bestimmungen dieses Artikels, durchzuführen und um die Gesellschaft gegenüber
Dritten zu vertreten.
Befugnisse, welche laut Gesetz oder dieser Satzung, nicht ausdrücklich der Hauptversammlung der Gesellschafter
zugestimmt sind, fallen in den Kompetenzbereich der Geschäftsführer, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, der
Geschäftsführung.
Die Gesellschaft ist jederzeit durch die Einzelunterschrift des einzigen Geschäftsführers, oder im Falle mehrerer Ge-
schäftsführer, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei der Geschäftsführer verpflichtet.
Die Geschäftsführer kann, oder im Falle mehreren Geschäftsführer, kann die Geschäftsführung spezifische Aufgaben
seiner Befugnisse an einen oder mehreren ad hoc Agenten subdelegieren.
Die Geschäftsführer, oder im Falle mehreren Geschäftsführern, bestimmt die Geschäftsführung die Verantwortlichkeit
und eventuelle Vergütung solcher Agenten, sowie die Dauer ihres Mandats und alle weiteren Bedingungen ihres Mandats.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer kann eine Versammlung der Geschäftsführung nur mit der Teilnahme von der
Mehrheit der Geschäftsführer gehalten werden. In diesem Fall sind alle Entscheidungen der Geschäftsführung rechtskräftig,
insofern die Mehrheit der Anwesenden diesen zustimmt.
Alle Befugnisse und Vergütungen der Geschäftsführer, welche eventuell an einem späteren Zeitpunkt ernannt werden,
zusätzlich oder in Ersatz der ersten Geschäftsführer werden im Nominierungsakt festgesetzt.
Art. 12. Der oder die Geschäftsführer sind einfache Mandatare der Gesellschaft und sie gehen persönlich keine Ver-
bindlichkeiten ein in Bezug auf die Verbindlichkeiten, welche sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer
Befugnisse eingegangen sind. Sie sind der Gesellschaft gegenüber nur für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 13. Die Entscheidungen der Geschäftsführer werden in den Versammlungen der Geschäftsführung getroffen. Jeder
Geschäftsführer der nicht an einer Versammlung teilnehmen kann, kann schriftlich, per Telefax, Telegramm, Telex oder
sonstigen Kommunikationsmitteln, einen anderen Geschäftsführer als seine Vertretung ernennen.
Eine schriftlich festgelegte Entscheidung, unterschrieben von allen Geschäftsführern, hat dieselbe Gültigkeit als eine
bei einer Versammlung getroffenen Entscheidung. In solchem Fall, sind die getroffenen Entscheidungen schriftlich durch
Rundschreiben, per normalem Postversand, Email oder Fax zu verteilen. Versammlungen können ebenfalls per Telefon-
konferenz oder anderen Kommunikationsmitteln gehalten werden.
36071
Gesellschafterversammlungen
Art. 14. Gesellschafterbeschlüsse werden in Hauptversammlungen getroffen. Jeder Gesellschafter nimmt an den Ge-
sellschaftsbeschlüssen teil mit soviel Stimmen wie er Anteile besitzt. Solange die Anzahl der Gesellschafter unter 25 liegt,
ist die Haltung einer Hauptversammlung nicht obligatorisch.
Die Geschäftsführung kann in solchen Fällen entscheiden den einzelnen Gesellschaftern, die zu treffenden Entschei-
dungspunkte, schriftlich mit normaler Post, per Email oder Faxmitteilung zukommen zu lassen.
Art. 15. Die Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit des Gesellschaftskapitals gefasst.
Falls die beschlussfähige Anzahl während der ersten Hauptversammlung nicht erreicht wird, werden die Gesellschafter
sofort, per Einschreiben, zu einer zweiten Versammlung eingeladen.
Bei dieser zweiten Hauptversammlung werden die Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen getroffen,
ob diese über fünfzig Prozent des Gesellschaftskapitals repräsentieren oder nicht.
Beschlüsse, die im Rahmen von Satzungsabänderungen und besonders im Hinblick auf die Auflösung der Gesellschaft
gefasst werden, bedürfen der Mehrheit von Gesellschaftern, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen.
Alle Hauptversammlungen finden in Luxemburg statt, oder an jedem von den Geschäftsführern angegebenen Orts.
Laut den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, Sektion II, befugt der Einmann-
Gesellschafter allein über alle Rechte die der Hauptversammlung der Gesellschafter zustehen.
Somit unterliegen alle Entscheidung die den Rahmen der Befugnisse der Geschäftsführung überschreiten, dem Einmann-
Gesellschafter.
Geschäftsjahr - Gesellschaftskonten
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März jedes Jahres.
Art. 17. Am 31. März jedes Jahres, erstellt die Geschäftsführung eine Bilanz welche das Inventar der Guthaben und
Schulden der Gesellschaft, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung und eine Anlage mit einer Kurzfassung aller Ver-
pflichtungen und Schulden der Gesellschaft enthält. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dann den
Gesellschaftern vorgelegt.
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Kenntnis des Inventars, der Bilanz sowie der Gewinn- und
Verlustrechnung nehmen.
Art. 19. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese
Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel sechs
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.
Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrates, über Verwendung des Nettogewinnes beschlie-
ßen. Der Nettogewinn, kann unter den Gesellschaftern, hinsichtlich ihrer Anteilnahme in der Gesellschaft, verteilt werden,
vorausgesetzt, dass keine Abkommen zwischen den Gesellschaftern anders über die Gewinnverteilung verfügen.
Im Falle von Anteilen, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung ausbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften und der Vorlegung einer Zwischenbilanz können Vor-
schussdividenden, soweit verfügbar, ausgezahlt werden.
Auflösung - Liquidierung
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter
durchgeführt, (die natürliche oder juristische Personen sein können) und die durch die Generalversammlung die die
Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Bei Abschluss der Liquidierung, werden die restlichen Guthaben der Gesellschaft unter den Gesellschaftern, propor-
tional zu ihrem Anteil im Gesellschaftskapital, verteilt.
Art. 18. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915, so wie auf die späteren Änderungen.
<i>Vorläufige Verfügungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. März 2007.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Der alleinige Gesellschafter EPI OAKWOOD HOLDING S.à r.l., hat sämtliche Anteile voll und ganz in bar eingezahlt,
so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem
amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.
<i>Kosteni>
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten
fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, wird auf EUR 1.300,- geschätzt.
36072
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Geschäftsführer werden ernannt:
a) Herrn Bruno Bagnouls, wohnhaft in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg;
b) Frau Anita Lyse, wohnhaft in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg;
c) Herrn Yves Barthels, wohnhaft in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg;
d) Herrn Richard James, wohnhaft in One Curzon Street, W1J 5HD London, England.
e) Herrn Ronald Seacombe, wohnhaft in One Curzon Street, W1J 5HD London, England.
Die Geschäftsführung ist berechtigt die Gesellschaft durch die Unterschrift von jeweils zwei Mitgliedern, oder eine
dazu bevollmächtigte Person, rechtsgültig zu vertreten.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten
ist, gefolgt von einer deutschen Uebersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der
deutschen Fassung die englische Fassung massgebend ist.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: Y. Barthels, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, vol. 157S, fol. 50, case 9. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007035207/211/375.
(070031014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Copernicus Finance Buffer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 112.550.
In the year two thousand and six, on the twenty-seventh of June.
Before the undersigned Maître Anja Holtz, notary public residing in Wiltz.
Appeared:
- COPERNICUS EQUITY EMP BUFFER Sàrl, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal,
constituted by a deed before notary Gérard Lecuit, in Luxembourg, on December 2, 2005, published on March 6 2006,
number 476 (The Shareholder),
here represented by its manager PRO SERVICES MANAGEMENT Sàrl with registered office at L-2449 Luxembourg,
47, boulevard Royal for these purposes duly represented by Monsieur Matthijs Bogers, companies director, born in
Amsterdam (Netherlands), on November, 24, 1966, residing professionally in L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal
- CALCIUM ALUMINATE TEAM LIMITED, a limited company duly formed, organized and existing under the laws of
the Island of Cyprus, having its registered office at 48 Themistoklis Dervis, Centennial Building, office 701, 1066, Nicosia,
Island of Cyprus, registered under the number HE 177162 at the Department of Registrar of Companies and Official
Receiver, Nicosia, Island of Cyprus,
here represented by Monsieur Matthijs Bogers, companies director, born in Amsterdam (Netherlands), on November,
24, 1966, residing professionally in L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal, by virtue of a proxy given on June 26th,
2006, at Nicosia.
The before said proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party, acting in her capacity as stated her-above stated capacities, has requested the notary to draw up the
following deed:
COPERNICUS FINANCE BUFFER, Sàrl, a société à responsabilité limitée, having its registered office in Luxembourg,
has been constituted by a deed before notary Gérard Lecuit, in Luxembourg, on December 2, 2005, published on March
4, 2006, number 471 and is registered with the register of commerce and companies under number B 112.550 (The
Company);
the company has a subscribed capital of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented by five hundred
(500) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each;
36073
The Shareholder is the sole shareholder of the Company;
The above-mentioned company, COPERNICUS FINANCE BUFFER Sàrl, doesn't own any real estate;
then the above-mentioned appearing party has requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. To increase the subscribed capital of COPERNICUS FINANCE BUFFER Sàrl with an amount of eighty-seven thou-
sand five hundred euro (87,500.- EUR) to increase the subscribed capital from its present amount of twelve thousand
five hundred euro (12,500.- EUR) to hundred thousand euro (100,000.- EUR) through the issuance of three thousand five
hundred (3,500) new shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each.
2. To amend the article 6 of the Articles of the Association.
After the meeting has approved the foregoing, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to increase the subscribed capital by eighty-seven thousand five hundred euro (87,500.-
EUR) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) to hundred thousand euro
(100,000.- EUR) through the issuance of three thousand five hundred (3,500) new shares with a par value of twenty-five
euro (25.- EUR) each.
The amount of eighty-seven thousand five hundred euro (87,500.- EUR) has been fully paid up in cash and is actually
at the disposal of the company; proof of the payment has been given to the undersigned notary.
The subscription is as follows:
Shares
COPERNICUS EQUITY EMP BUFFER SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,300
CALCIUM ALUMINATE TEAM LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to amend the article 8 of the articles of incorporation, which will henceforth have the
following wording:
« Art. 6. The subscribed capital of the corporation is fixed at hundred thousand euro (100,000.- EUR) represented by
four thousand (4,000) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each.»
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its presents, is approximately 2,000.- EUR.
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Wiltz, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
S'est présenté:
- COPERNICUS EQUITY EMP BUFFER Sàrl, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal, con-
stituée aux termes d'un acte reçu le 2 décembre 2005 par le notaire Gérard Lecuit, à Luxembourg, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations du 6 mars 2006, numéro 476,
ici représentée par son gérant ProServices MANAGEMENT Sàrl dont le siège social est à L-2449 Luxembourg, 47,
boulevard Royal, laquelle est elle-même représentée par Monsieur Matthijs Bogers, administrateur de société, demeurant
à L- 2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal
- CALCIUM ALUMINATE TEAM LIMITED, une société de responsabilité limitée de droit de l'Ile de Chypre, avec siège
social à 48 Themistoklis Dervis, Centennial Building, office 701, 1066, Nicosia, Island of Cyprus, enregistrée sous le numéro
HE 177162 au Département d'enregistrement des sociétés à Nicosia, Ile de Chypre,
Représentée ici par Monsieur Matthijs Bogers, administrateur de sociétés avec adresse professionnelle à L-2449 Lu-
xembourg, 47, boulevard Royal
en vertu d'une procuration sous seing privée, dressée le 26 juin à Nicosia, Ile de Chypre,
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le notaire et le comparant restera ci-annexée pour être
enregistrée ensemble avec la présente minute
36074
laquelle comparante, tel que représentée, a exposé au notaire:
- que la société à responsabilité limitée COPERNICUS FINANCE BUFFER Sàrl dont le siège social est à Luxembourg,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit le 2 décembre 2005 publiée au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations le 4 mars 2006 numéro 471 et
- qu'elle est inscrite au registre de commerce sous le numéro B 112.550
- qu'elle a un capital de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales
d'une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune
- que la comparante est la seule et unique associée représentant l'intégralité du capital social
- que la société ne possède pas d'immeuble ni de parts d'immeubles
ensuite, la comparante représentée a requis le notaire instrumentant d'acter que:
L- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmenter le capital social de COPERNICUS FINANCE BUFFER Sàrl d'un montant de 87.500,- euros, portant ainsi
son montant actuel de 12.500,- euros à un montant de 100.000,- euros;
2. Modifier l'article 6 des statuts.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (87.500,- EUR)
pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à cent mille euros (100.000,- EUR)
avec émission de trois mille cinq cents (3.500) parts nouvelles, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.
La somme de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (87.500,- EUR) est intégralement libérée de telle sorte que ladite
somme de cent mille euros (100.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ce qui a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.
La souscription a été faite comme suit:
Parts
COPERNICUS EQUITY EMP BUFFER SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300
CALCIUM ALUMINATE TEAM LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par quatre mille (4.000) parts d'une
valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ 2.000,- EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire,
Signé: M. Bogers, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 28 juin 2006, vol. 320, fol. 27, case 9. — Reçu 875 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Pletschette.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Wiltz, le 21 juillet 2006.
A. Holtz.
Référence de publication: 2007034720/2724/134.
(070030070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.
36075
Fondation Greenpeace Luxembourg, Etablissement d'Utilité Publique.
Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 34, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg G 112.
<i>Annual accounts for the year ended 31 December 2006 (with auditor's report thereon)i>
Report of the «Réviseur d'entreprises»
Following our appointment by the FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, we have audited the accompanying
annual accounts of the FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, which comprise the balance sheet as at 31 De-
cember 2006, and the profit and loss account for the year then ended, and a summary of significant accounting policies
and other explanatory notes.
The board of directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts in accordance
with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual accounts. This responsibility
includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of
annual accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appro-
priate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.
The key figures of the audited annual accounts for the year ended 31 December 2006 are:
EUR
Balance sheet total as at 31 December 2006: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.162,12
Result of the year ending 31 December 2006: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.968,40 (Loss)
Our responsibility is to express an opinion on these annual accounts based on our audit. We conducted our audit in
accordance with International Standards on Auditing as adopted by the Institut des réviseurs d'entreprises. Those stand-
ards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
whether the annual accounts are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual
accounts. The procedures selected depend on the judgement of the «réviseur d'entreprises», including the assessment
of the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error. In making those risk assess-
ments, the «réviseur d'entreprises» considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation
of the financial statements in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimates made by the board of directors, as well as evaluating the overall presentation of
the annual accounts. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for our audit opinion.
In our opinion, the annual accounts give a true and fair view of the financial position of FONDATION GREENPEACE
LUXEMBOURG as of 31 December 2006, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with
Luxembourg legal and regulatory, requirements relating to the preparation of the annual accounts.
Without qualifying our opinion, we draw your attention to note 8 to the annual accounts. FONDATION GREEN-
PEACE LUXEMBOURG faces a legal claim brought against it by ESSO LUXEMBOURG S.A. and a number of other parties
(ESSO). The claim is for financial damages as a result of the demonstrations which took place at 28 ESSO petrol stations
in Luxembourg on 25 October 2002. Two cases have been filed in relation with this claim. On 13 December 2005 and
17 May 2006 the responsibility of FONDATION GREENPEACE LUXEMBOURG, together with GREENPEACE LUX-
EMBOURG A.S.B.L and GREENPEACE INTERNATIONAL B.V. has been confirmed by the Tribunal d'Arrondissement
of Luxembourg and the 2
ième
Chambre de la Cour d'Appel de Luxembourg. An expert has also been appointed to
determine the level of damages to be awarded. Total claims estimated by ESSO amount to EUR 309,272.16 for GREEN-
PEACE as a whole. This amount has not been confirmed by the lawyers in charge. The ultimate outcome of the matter
cannot presently be determined, and a provision of EUR 50,000.00 has been booked in the annual accounts of the Fon-
dation based on an board decision.
The management report, which is the responsibility of the management, is in accordance with the annual accounts.
Luxembourg, February 14th, 2007.
M. Muller
<i>Réviseur d'Entreprisesi>
Compte de profits et pertes allant du 1
er
janvier au 31 decembre 2006 exprime en euros
2006
2005
A. Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691.422,00 619.342,51
Charges Administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.836,74 80.711,67
Charges de Relations Publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.341,62 56.489,17
Frais liés à la collecte de fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.766,79 122.773,56
36076
Frais de Campagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234.636,35 234.348,11
- Changement Climatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.021,42 84.645,88
- Organismes Génétiquement Modifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107.412,15 102.831,91
- Autres Campagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.202,78 46.870,32
Campagnes Internationales
115.840,50 125.020,00
Provision ESSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00
B. Produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691.422,00 619.342,51
Dons, Cotisations, et autres produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609.881,38 588.244,20
Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.572,22
2.818,44
Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.968,40 28.279,87
Bilan au 31 decembre 2006 exprime en euros
<i>Actifi>
31 décembre 2006
31 décembre 2005
C. Actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.004,08
13.771,51
II. Immobilisations corporelles
3. Autres installations, outillage et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.004,08
13.771,51
D. Actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178.809,24
211.791,35
II. Créances
4. Autres créances
a) dont la durée résiduelle est inférieur à 1 an . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.114,94
40.888,00
III. Valeurs mobilières
3. Autres valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.196,90
5.196,90
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques
et encaisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143.497,40
165.706,45
E. Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.348,80
3.820,02
Total actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.162,12
229.382,88
<i>Passifi>
31 décembre 2006
31 décembre 2005
A. Capitaux Propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111.226,48
189.194,88
IV. Réserves
4. Autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189.194,88
217.474,55
VI. Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 77.968,40
- 28.279,67
B. Provisions pour risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54.000,00
4.000,00
C. Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.935,64
36.188,00
9. Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.935,64
36.188,00
a) dont la durée résiduelle est inférieur ou égale à 1 an . . . . . . . . . .
Total passif: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.162,12
229.382,88
Budget de l'exercice allant du 1
er
janvier 2007 au 31 decembre 2007 (exprime en 1.000,00 eur)
<i>Produitsi>
Dons, Cotisations et, autres produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665
Total produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665
<i>Chargesi>
Frais de campagnes
Changement climatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Organismes génétiquement modifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Autres campagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Campagnes internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Total campagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Frais liés à la collecte de fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Media & communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Public information & outreach (Magazine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Actions et volontaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Charges administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Total charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
36077
Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -6
Référence de publication: 2007034805/1353/117.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06678. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06683. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Masco Europe INC Financial S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 326.964.000,00.
Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 114.183.
In the year two thousand six, on the 28th day of December,
before US Maître Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
There appeared:
MASCO EUROPE S.à r.l., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg
with registered office at 22, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Company Register section B under number 68.104.
MASCO EUROPE INC., a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware (United States of America)
with registered office at 21001 Van Board Road, Taylor, Michigan 48180, United States of America, registered with
Secretary of State of the State of Delaware under Delaware Charter Number 2143248,
Both appearing parties, here represented by Régis Galiotto, jurist, with professional address at Luxembourg, by virtue
of two powers of attorney given under private seal on December 27, 2006.
Such powers of attorney, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary
public, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the partners (hereinafter the «Partners») of MASCO EUROPE INC FINANCIAL SCS, a
«société en commandite simple» incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg on December 23,
2005 by M
e
Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in «Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations», N° 429, having its registered office at 22, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand
Duchy of Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 114.183
(hereinafter the «Partnership»).
II. The Partnership's capital is currently set at fifty thousand euros (EUR 50,000.-) represented by fifty (50) partnership
interests with a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each.
III. The Partners have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Partners resolved to increase the Partnership's capital of the Partnership by an amount of three hundred twenty-
six million nine hundred fourteen thousand euros (EUR 326,914,000.-) to raise it from its present amount of fifty thousand
euros (EUR 50,000.-) to three hundred twenty-six million nine hundred sixty-four thousand euros (EUR 326,964,000.-)
by the creation and issue of three hundred twenty-six thousand nine hundred fourteen (326,914) new partnership in-
terests with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each, having the same rights and obligations as the existing
partnership interests, such partnership interests to be fully paid up, together with an aggregate share premium of one
billion eight hundred fifty-two million five hundred eleven thousand four hundred euros and sixty cents (EUR
1,852,511,400.60) to be fully paid up.
<i>Second resolution / Subscription - Paymenti>
MASCO EUROPE S.à r.l., aforementioned, through its proxyholder, declared to subscribe to the three hundred twen-
ty-six thousand nine hundred fourteen (326,914) newly issued partnership interests with a par value of one thousand
euros (EUR 1,000.-) each, and fully pay them up together with a share premium of a total amount of one billion eight
hundred fifty-two million five hundred eleven thousand four hundred euros sixty cents (EUR 1,852,511,400.60) fully paid
up, by contribution in kind consisting in the transfer of 100% of the shares of MASCO INTERNATIONAL SERVICES
BVBA, a company incorporated under the law of Belgium having its registered office at Heulentakstraat 1, 3650 Dilsen-
Stokkem, Belgium and registered with the Belgian Banque-Carrefour des Entreprises et Registre du Commerce under
company number 0466.780.529.
Evidence of the transfer of shares has been given to the undersigned notary by a copy of a contribution agreement
between the Partnership and MASCO EUROPE S.à r.l.
36078
Said contribution agreement, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
Pursuant to the above increase of capital, Article 6 of the Partnership's articles of association is amended and shall
henceforth read as follows:
« Art. 6. The Partnership's capital is set at three hundred twenty-six million nine hundred sixty-four thousand euros
(EUR 326,964,000.-), represented by three hundred twenty-six thousand nine hundred sixty-four (326,964) partnership
interests with a par value of one thousand euros (EUR. 1,000.-) each, fully paid-in.
The General Partner owns one (1) partnership interest of the Partnership.
The Limited Partner owns three hundred twenty-six thousand nine hundred sixty-three (326,963) partnership interests
of the Partnership.
Each partnership interest of general partner or partnership interest of limited partner gives one voting right in general
meetings of partners, either annual or extraordinary.»
<i>Variable rate capital tax exemption requesti>
Considering that it involves a contribution in kind of shares of one EU resident company (i.e. MASCO INTERNA-
TIONAL SERVICES BVBA) to a Luxembourg resident company (i.e. the Partnership) the Partnership expressly requests
the capital duty exemption on basis of Article 4.2. of the Luxembourg law of December 29th, 1971, as amended by the
law of December 3rd, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the presently stated increase of share capital are estimated to approximately 7,000.- euros.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his first
name, last name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le 28 décembre.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
MASCO EUROPE S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par la loi du Grand-Duché du Lu-
xembourg, ayant son siège social au 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché du Luxembourg sous le numéro B 68.104.
MASCO EUROPE INC., une société constituée et régie par les lois de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique),
ayant son siège social au 21001 Van Board Road, Taylor, Michigan 48180, Etats-Unis d'Amérique, inscrite auprès du
Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 2143248,
Les deux parties comparantes, ici représentées par Régis Galiotto, juriste, ayant son adresse professionnelle à Lu-
xembourg, en vertu de deux procurations données sous seing privé le 27 décembre 2006.
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le représentant des comparantes et le notaire instrumentant,
resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentaire,
annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lequelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Les comparantes sont les associées (ci-après les «Associées») de MASCO EUROPE INC FINANCIAL SCS, une
société en commandite simple constituée et régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg le 23 décembre 2005 par
M
e
Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations N° 429, ayant son siège social au 22, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxem-
bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg, section B, sous le numéro
114.183 (ci-après la «Société»).
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par cinquante
(50) parts d'intérêt d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
36079
III. Les Associées ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associées ont décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent vingt-six millions neuf
cent quatorze mille euros (EUR 326.914.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR
50.000,-) à trois cent vingt-six millions neuf cent soixante-quatre mille euros (EUR 326.964.000,-) par la création et
l'émission de trois cent vingt-six mille neuf cent quatorze (326.914) nouvelles parts d'intérêt d'une valeur nominale de
mille euros (EUR 1.000,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts d'intérêt existantes, ces parts
d'intérêt devant être entièrement libérées, avec une prime d'émission d'un montant total d'un milliard huit cent cinquante-
deux millions cinq cent onze mille quatre cent euros et soixante cents (EUR 1.852.511.400,60) entièrement libérée.
<i>Deuxième résolution / Souscription - Paiementi>
MASCO EUROPE S.à r.l., susmentionnée, par son mandataire, déclare souscrire aux trois cent vingt-six mille neuf cent
quatorze (326.914) nouvelles parts d'intérêt d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, et de les libérer
entièrement avec une prime d'émission d'un montant total de d'un milliard huit cent cinquante-deux millions cinq cent
onze mille quatre cent euros et soixante cents (EUR 1.852.511.400,60) entièrement libéré par un apport en nature
consistant dans le transfert de 100% des parts sociales de MASCO INTERNATIONAL SERVICES BVBA, une société
constitué et régie selon les lois de Belgique, ayant son siège social au Heulentakstraat 1, 3650 Dilsen-Stokkem, Belgique,
inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et du Registre du Commerce belge sous le numéro d'entreprise
0466.780.529.
Preuve du transfert des parts sociales a été donnée au notaire instrumentaire, au moyen d'une copie du contrat d'apport
entre la Société et MASCO EUROPE S.à r.l.
Ledit contrat d'apport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire,
restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
<i>Troisième résolutioni>
Conformément à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à trois cent vingt-six millions neuf cent soixante-quatre mille euros (EUR
326.964.000,-) représenté par trois cent vingt-six mille neuf cent soixante-quatre (326.964) parts d'intérêts d'une valeur
nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées.
Le Commandité détient une (1) part d'intérêt de la Société.
Le Commanditaire détient trois cent vingt-six mille neuf cent soixante-trois (326.963) parts d'intérêt de la Société.
Chaque part d'intérêt de commandité ou part d'intérêt de commanditaire donne droit à une voix dans les délibérations
des assemblées générales, annuelles ou extraordinaires.»
<i>Requête d'exemption au pro rata de la taxe sur l'apporti>
Compte tenu qu'il s'agit de l'apport en nature des parts sociales d'une société résidente de l'Union européenne (c.-à-
d. MASCO INTERNATIONAL SERVICES BVBA) à une société résidente au Grand-Duché de Luxembourg (c.-à-d. la
Société), la Société requiert expressément l'exonération du droit proportionnel d'apport sur la base de l'article 4.2. de
la loi luxembourgeoise du 29 décembre 1971, modifiée par la loi du 3 décembre 1986, prévoyant en pareil hypothèse le
paiement d'un droit fixe d'enregistrement.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à environ 7.000,- euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé avec nous notaire, le présent acte.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, vol. 157S, fol. 17, case 2. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007035675/211/158.
(070031854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
36080
Leaders Motors Luxembourg S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2628 Luxembourg, 19, rue des Trévires.
R.C.S. Luxembourg B 52.181.
Mod'in Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 28.898.
S.D.C.H. Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 29.942.
CLÔTURES DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement du 1
er
février 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6
e
chambre, a déclaré closes
pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme LEADERS MOTORS LUXEMBOURG S.A.,
dont le siège social à L-2628 Luxembourg, 19, rue des Trévires, a été dénoncé en date du 3 juin 1999. Ce même jugement
a ordonné la publication du dispositif par extrait au Mémorial, ainsi que dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt.
Il a également mis les frais à charge du Trésor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Maître M. Lentz
<i>Liquidateuri>
<i>Extraiti>
Par jugement du 1
er
février 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6
e
chambre, a déclaré closes
pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée MOD'IN LUX S.à r.l., dont le
siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 11 juin 1990. Ce même jugement a
ordonné la publication du dispositif par extrait au Mémorial, ainsi que dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt.
Il a également mis les frais à charge du Trésor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Maître M. Lentz
<i>Liquidateuri>
<i>Extraiti>
Par jugement du 1
er
février 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6
e
chambre, a déclaré closes
pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme S.D.C.H. HOLDING S.A., dont le siège social
à L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal, a été dénoncé en date du 1
er
octobre 1992. Ce même jugement a ordonné
la publication du dispositif par extrait au Mémorial, ainsi que dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt. Il a
également mis les frais à charge du Trésor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Maître M. Lentz
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2007035538/5107/49.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00482. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00484. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00486. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
(070030940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
(070030942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
36081
Fondation Lydie Schmit, Fondation.
Siège social: L-7243 Bereldange, 65, rue du X octobre.
R.C.S. Luxembourg G 62.
BILAN DE CLÔTURE AU 31 DECEMBRE 2006
<i>Actifi>
2006
2005
<i>Passifi>
2006
2005
(EUR)
(EUR)
(EUR)
(EUR)
Actif circulant
Capitaux propres
Avoirs en banque
592.078,03
580.796,82
Fonds social
577.393,91
577.393,91
Intérêts courus
10.664,47
7.655,34
Résultats reportés
11.058,25
35,52
Résultat de l'exercice
14.290,34
11.022,73
Total . . . . . . . . . . .
602.742,50
588.452,16
Total . . . . . . . . . . . . .
602.742,50
588.452,16
COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 2006
<i>Chargesi>
2006
2005
<i>Produitsi>
2006
2005
(EUR)
(EUR)
(EUR)
(EUR)
Bourses d'études
néant
néant
Intérêts créditeurs
14.869,10
11.934,51
Fiduciaire Jean-Paul
Elvinger
336,00
336,00
Publication des
comptes annuels
224,10
244,50
Frais de banque
4,45
12,80
Frais de secrétariat
14,21
11,96
Oldenburg Verlag
0,00
306,52
Excédent des pro-
duits
14.290,34
11.022,73
Total . . . . . . . . . . .
14.869,10
11.934,51
Total . . . . . . . . . . .
14.869,10
11.934,51
BUDGET POUR L'EXERCICE 2006
<i>Chargesi>
<i>Produitsi>
(EUR)
(EUR)
Bourses d'études . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000,-
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.000,-
Honoraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500,-
Annonces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400,-
Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400,-
Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,-
11.400,-
13.000,-
Pour mention, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007035455/230/45.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06320. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Epicure Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2160 Luxembourg, 28, rue de Munster.
R.C.S. Luxembourg B 91.759.
L'an deux mille sept, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Olivier Tilmant; cuisinier, né à La Louvière (B), le 22 septembre 1970, demeurant à L-8551 Noerdange, 11
A, Batzent, ici représenté par Monsieur Paul Diederich, comptable, demeurant à L-8368 Hagen, 20, an der Laach,
en vertu d'une procuration annexée au présent acte.
36082
unique associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle EPICURE S.à r.l. (R.C.B N
o
91.759), avec siège à
L-8551 Noêrdange, 11 A, Batzent, constituée suivant acte notarié du 3 février 2003, publié au Mémorial C N
o
300 du
20 mars 2003.
Lequel comparant a requis le notaire d'acter ce qui suit:
<i>1. Cession de partsi>
Monsieur Olivier Tilmant, préqualifié, cède par les présentes 20 parts de la prédite société à Monsieur Denis Delcroix;
gérant de sociétés, né à Charleroi (B), le 16 août 1968, demeurant à L-8391 Nospelt, 8, rue des Fleurs, au prix de 2.000,-
EUR, dont quittance, lequel accepte.
Suite à ce changement, l'article 5 alinéa 2 aura désormais la teneur suivante:
Le capital social est souscrit comme suit:
Parts
- Monsieur Olivier Tilmant; préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
- Monsieur Denis Delcroix; préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
<i>2. Transfert du siègei>
Le siège social est transféré de Noerdange à Luxembourg
L'adresse du siège est: L-2160 Luxembourg, 28, rue de Munster.
Suite à ce changement, l'article 2 première phrase aura désormais la teneur suivante:
Art. 2. première phrase. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
<i>3. Gérancei>
Sont nommés gérants:
gérant administratif: Monsieur Olivier Tilmant, préqualifié,
gérant technique: Monsieur Denis Delcroix; préqualifié,
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
<i>Fraisi>
Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cent vingt euro.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: P. Diederich, G. d'Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 2007, vol. 924, fol. 58, case 3. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 5 février 2007.
G. d'Huart.
Référence de publication: 2007035206/207/46.
(070031361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
March Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 89.116.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45232 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Référence de publication: 2007036226/211/9.
(070032470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2007.
Paunsdorf Centre Luxco, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R.C.S. Luxembourg B 109.927.
<i>Extraits des résolutions et décisions prises lors de l'Assemblé Générale des actionnaires tenue en date du 16 octobre 2006i>
Il a été décidé:
de nommer:
- Madame Jacqueline Kost, née le 26 mars 1961, à Montréal, Canada, résidant à 13, rue Gaaschtbierg, L-8230 Marner,
au poste de Gérant de la société, avec effet immédiat, pour un mandat à durée indéterminée,
36083
en plus de Messieurs les Gérants Paul Chehab, John Comery et Kuy Ly Ang.
Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007035524/2270/18.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01519. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070031075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Zwickau Arcaden Luxco, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R.C.S. Luxembourg B 109.926.
<i>Extraits des résolutions et décisions prises lors de l'Assemblé Générale des actionnaires tenue en date du 16 octobre 2006i>
Il a été décidé:
de nommer:
- Madame Jacqueline Kost, née le 26 mars 1961, à Montréal, Canada, résidant à 13, rue Gaaschtbierg, L-8230 Mamer,
au poste de Gérant de la société, avec effet immédiat, pour un mandat à durée indéterminée,
en plus de Messieurs les Gérants Paul Chehab, John Comery et Kuy Ly Ang.
Luxembourg, le 29 novembre 2006.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007035522/2270/18.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2006, réf. LSO-BX01500. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070031078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Next Future Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 81.886.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 21 février 2007i>
La démission de Monsieur De Bernardi Angelo de son poste d'administrateur de la société est acceptée.
Monsieur Robert Reggiori expert-comptable, né le 15 novembre 1966 à Metz (France), domicilié professionnellement
au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société. Son mandat viendra à échéance
lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.
Pour extrait sincère et conforme
NEXT FUTURE HOLDING S.A.
R. Reggiori / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007035551/545/19.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06319. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
Kateco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 44.829.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 20 février 2007i>
La démission de Monsieur De Bernardi Angelo de son poste d'administrateur de la société est acceptée.
36084
Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né le 13 décembre 1975 à Luxembourg, domicilié
professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société. Son
mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.
Pour extrait sincère et conforme
KATECO S.A.
A. De Bernardi / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007035552/545/19.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06321. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
Société Immobilière Pandy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1409 Luxembourg, 18, rue Edmond Dune.
R.C.S. Luxembourg B 42.259.
Statuts coordonnés suivant l'acte n
o
193 du 14 février 2007 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007035535/230/12.
(070031036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Rom Top 1 Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 124.652.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 28 février 2007.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>M. Goeres
<i>Déléguée par Maître J. Seckleri>
Référence de publication: 2007035539/231/14.
(070031012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Medest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 52.885.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007035540/734/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06500. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
Lubow Illsen S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 90.179.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
36085
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2007.
SOFINTER S.A.
Signature
Référence de publication: 2007035566/820/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04609. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
Filiaris S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 62.397.
<i>Extrait des décisions de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue extraordinairement en date du 19 février 2007i>
1) Jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2009, la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l.,
R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été
nommée commissaire aux comptes, (en remplacement de la société à responsabilité limitée COMMISERV S.à r.l., démis-
sionnaire).
2) Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1
er
, à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 20 février 2007.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FILIARIS S.A.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007035565/29/21.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05633. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
Glibro Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 47.584.
<i>Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 10 janvier 2007i>
1. Le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
2. Jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2012, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d'Administration:i>
M. Frank Gleeson, administrateur de sociétés, né en Irlande à Ballinasloe, le 20 juin 1953,ayant son domicile en Grande-
Bretagne, à Middlesex HAI 3PB, Harrow, Collingwood, South Hill Avenue, président du Conseil d'Administration.
M. John Gleeson, administrateur de sociétés, né en Irlande à Offaly, le 18 juillet 1954, ayant son domicile en Irlande, à
Dublin 4, 85, Ailesbury Road, administrateur-délégué.
La société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT S. à r. l., R.C.S. Luxembourg B n
o
58.324, avec siège social
à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
<i>Commissaire aux comptes:i>
La société KPMG FIDES PEAT, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Zurich sous le numéro
CH-020.3001.933-8/, avec siège social à CH-1206 Genève, 14, chemin De-Normandie.
Luxembourg, le 19 février 2007.
36086
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour GLIBRO HOLDING S.A.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007035561/29/28.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05638. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
Eylau - Raymond Poincaré «Paris 75116» S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 107.464.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 12 février 2007i>
1. Le siège social de la Société est transféré du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, au 121, avenue de la Faïencerie,
L-1511 Luxembourg.
2. Les démissions de Mme Géraldine Schmit et de M. José Correia en tant que gérants de la Société ont été acceptées.
3. Monsieur Alain Heinz, expert-comptable, né le 17 mai 1968 à F-Forbach, domicilié professionnellement à L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 14 février 2007.
Pour extrait sincère et conforme
<i>EYLAU - RAYMOND POINCARE «PARIS 75116» S.àr.l.
i>PARIS PREMIER PROPERTIES S.à r.l.
A. Heinz
<i>Géranti>
Référence de publication: 2007035577/6341/21.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04551. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
AKS (Holdings) S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 69.485.
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 22 décembre 2006 prend à l'unanimité des voix les réso-
lutions suivantes:
- Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans
à l'ancien siège social de la société.
- L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme AKS (HOLDINGS) S.A. a
définitivement cessé d'exister.
Luxembourg, le 22 décembre 2006.
<i>Pour AKS (HOLDINGS) S.A.
i>SOFINEX S.A.
Signature
Référence de publication: 2007035616/783/21.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2007, réf. LSO-CA01441. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070031862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
L.B.G. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6182 Gonderange, 34, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 42.098.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
36087
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007035604/1682/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB07084. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
SAP Luxembourg Succursale de NV SAP Belgium SA, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 58.803.
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>SAP LUXEMBOURG SUCCURSALE DE NV SAP BELGIUM S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2007035605/1649/1682/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB07091. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
Brodequin Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 70.161.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007035603/664/13.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06541. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
Nordviking Gesellschaft Reederei S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 50.372.
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de clôture de liquidation de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,
(Grand-Duché de Luxembourg), en date du 28 décembre 2006, enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2007, volume
540, folio 61, case 2:
I.- Que l'assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et qu'elle a constaté que la société à responsabilité limitée
NORD VIKING GESELLSCHAFT REEDEREI S.A. en liquidation a cessé d'exister.
2.- Que l'assemblée a décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans au
moins à l'ancien siège de la société, de même qu'y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éven-
tuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n'aurait pu leur avoir été faite.
Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 28 février 2007.
J. Seckler
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007035602/231/21.
(070031635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
36088
MobiLease S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 86.088.
AUFLÖSUNG
<i>Auszugi>
Aus einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. November 2006, beurkundet durch Notar Henri Beck,
mit dem Amtswohnsitze in Echternach, einregistriert in Echternach am 27. November 2006, volume 362, folio 85, case
12, geht hervor dass die Liquidation der Gesellschaft somit definitiv abgeschlossen ist, und dass die Bücher der Gesellschaft
fünf Jahren an der Privatanschrift von Herrn Axel Friedhoff aufbewahrt werden.
Echternach, den 21. Februar 2007.
H. Beck
Référence de publication: 2007035606/201/14.
(070031820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
SAP Luxembourg Succursale de NV SAP Belgium SA, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 58.803.
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>SAP LUXEMBOURG SUCCURSALE DE NV SAP BELGIUM S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2007035607/1682/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB07087. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
Alcentra Mezzanine QPAM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 114.912.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil de Gérance en date du 9 février 2007i>
Le Siège social de la société a été transféré du L-1855 Luxembourg, 46a, avenue John F. Kennedy au L-2340 Luxem-
bourg, 6, rue Philippe II.
<i>Pour ALCENTRA MEZZANINE QPAM S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007035597/1649/16.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06629. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
Ismat International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 58.569.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
36089
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007035596/664/13.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06552. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
Dragonera S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 72.966.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007035598/664/13.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06536. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
Fargo Investment Holdings S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 32.866.
<i>Extrait des délibérations portant a publication de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de lai>
<i>société en date du 6 juin 2006 à 11.00 heuresi>
<i>Décisionsi>
L'assemblée, à l'unanimité, a décidé:
- de reconduire Clive Godfrey, Jean-Pierre Higuet et Stéphane Biver dans leurs mandats d'administrateurs jusqu'à
l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2007.
- de remplacer Laurence Mathieu dans ses fonctions de commissaire aux comptes.
- de nommer en remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes, la société anonyme de droit luxembour-
geois DATA GRAPHIC S.A. dont le siège est établi au 128, boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg, immatriculée
au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 42166 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007035631/4286/24.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02166. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070031738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
Behedam (Holdings) S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 79.124.
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 22 décembre 2006 prend à l'unanimité des voix les réso-
lutions suivantes:
- Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans
à l'ancien siège social de la société.
- L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme BEHEDAM (HOLDINGS) S.A.
a définitivement cessé d'exister.
36090
Luxembourg, le 22 décembre 2006.
<i>Pour BEHEDAM (HOLDINGS) S.A.
i>SOFINEX S.A.
Signature
Référence de publication: 2007035620/783/21.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2007, réf. LSO-CA01443. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070031865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
Tolub Chamszadeh Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 9, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 65.939.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour TOULB CHAMSZADEH SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures
Référence de publication: 2007035617/514/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06332. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
Albert Seyler et Compagnie, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof/Koerich, 20, ancienne route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 29.426.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ALBERT SEYLER ET COMPAGNIE SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures
Référence de publication: 2007035615/514/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06335. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
Ava Invest S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 79.655.
AUFLÖSUNG
<i>Auszugi>
Aus einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. November 2006, beurkundet durch Notar Henri Beck,
mit dem Amtswohnsitze in Echternach, einregistriert in Echternach am 27. November 2006, volume 362, folio 86, case
3, geht hervor dass die Liquidation der Gesellschaft definitiv abgeschlossen ist und dass die Bücher der Gesellschaft fünf
Jahren am Sitz der Fiduciaire de l'Est aufbewahrt werden.
Echternach, den 21. Februar 2007.
H. Beck
Référence de publication: 2007035610/201/14.
(070031822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
36091
Elisabeth Stëftung, Fondation.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 24, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg G 126.
<i>Comptes annuels révisés pour la période du 13 juin 2006 au 31 décembre 2006i>
<i>Rapport sur les comptes annuelsi>
Nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de ELISABETH STËFTUNG, comprenant le bilan au 31
décembre 2006 ainsi que le compte de profits et pertes pour la période du 13 juin 2006 au 31 décembre 2006, et des
annexes contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.
<i>Responsabilité du Conseil d'Administration dans l'établissement et la présentation des comptes annuelsi>
Le Conseil d'Administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels,
conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels
en vigueur au Luxembourg. Cette responsabilité comprend: la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation sincère de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs; le choix et l'application de principes et méthodes comptables appropriés; ainsi
que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.
<i>Responsabilité du Réviseur d'entreprisesi>
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et réaliser l'audit pour obtenir
une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants
et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du Réviseur d'entre-
prises, de même que l'évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, le Réviseur d'entreprises prend en compte
le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels afin de
définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité
de celui-ci.
Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère
raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d'Administration, de même que l'appréciation de la présen-
tation d'ensemble des comptes annuels. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.
<i>Opinioni>
A notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de ELISABETH
STËFTUNG au 31 décembre 2006, ainsi que des résultats pour la période du 13 juin 2006 au 31 décembre 2006, con-
formément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en
vigueur au Luxembourg.
Luxembourg, le 14 février 2007.
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l.
L. Henzig
BILAN ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2006
<i>(exprimés en EURO)i>
<i>Actifi>
31 décembre 2006
<i>Passifi>
31 décembre 2006
A. Frais d'établissement (annexe 3.2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.076,63
A. Fonds Propres . . . . . . . . . . . . . .
142.371,89
B. Actif Circulant . . . . . . . . . . . . . .
148.100,54
I. Dotation initiale . . . . . . . . . . . . . .
125.000,00
Avoirs en banque, CCP, Chèques et
Encaisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148.100,54
II. Résultat de l'exercice . . . . . . . . .
-5.978,61
IV. Fonds disponibles pour projets
futurs (annexe 3.1) . . . . . . . . . . . . . . .
23.350,50
C. Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.805,28
Dettes sur achats et prestations de
services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.805,28
Total Actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149.177,17
Total Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149.177,17
L'annexe fait parti intégrante des comptes annuels.
36092
Signatures.
COMPTE DE PROFITS ET PERTES ANNUEL DU 13 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2006
<i>(exprimés en EURO)i>
31 décembre 2006
A. Produits d'exploitation
Dons reçus (annexe 3.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.350,50
Variation des fonds disponibles pour projets futurs (annexe 3.1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-23.350,50
Sous-total A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
A'. Charges d'exploitation
Achats de matières premières et autres approvisionnements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-29,91
Achats de matières premières et autres approvisionnements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-29,91
Autres Charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-5.100,00
Impôts Taxes et versements assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-75,00
Dotations aux amortissements et aux provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-153,80
Sur immobilisations: dotations aux amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-153,80
Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-1.600,37
Sous-total A' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-6.959,08
A-A' Résultat d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-6.959,08
B. Produits financiers, escomptes
Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.136,92
Sous-Total B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.136,92
B'. Charges financières
Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-156,45
Sous-Total B' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-156,45
B-B'. Résultat financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
980,47
Résultat de l'exercice (A+B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-5.978,61
L'annexe fait parti intégrante des comptes annuels.
Signatures.
<i>Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2006i>
<i>1. Généralitési>
ELISABETH STËFTUNG ci-après «fondation» a été constituée avec effet au 13 juin 2006 conformément à la loi du 21
avril 1928 sur les associations et fondation sans but lucratif.
La durée de l'association est illimitée.
Le siège social de l'association est établi à Luxembourg.
Le premier exercice commence le 13 juin 2006 et se clôture le 31 décembre 2006.
La fondation a pour objet:
- La promotion, le soutien, la sauvegarde et la création d'institutions d'accueil, d'hébergement, de soins pour enfants
et jeunes gens, personnes âgées, personnes dépendantes et handicapées, et des structures d'enseignement mise en place
ou gérées par la Congrégation des Sœurs de Sainte Elisabeth, ainsi que la promotion de l'encadrement religieux, social
et culturel des personnes y accueillies.
- Le soutien de projets et initiatives oeuvrant dans le domaine social, socio-éducatif, pédagogique, thérapeutique et
des soins de santé.
<i>2. Principes Comptablesi>
2.1. Généralités
Les comptes annuels sont établis suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg ainsi que
les pratiques comptables généralement admises.
2.2. Conversions devises
L'association tient ses comptes en EURO. Le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés dans cette devise.
2.2 Frais d'établissement
L'association a engagé des frais pour la création de la fondation. Les frais d'établissement sont amortis sur une durée
de 4 ans (25%).
2.3 Dettes
36093
Les dettes sont exprimées à leur valeur nominale.
2.4 Reconnaissances des dons
Le conseil d'Administration décide de la façon suivante sur la reconnaissance des dons:
- Fonds disponibles pour projets futurs
Les dons reçus non affectés pendant l'exercice, sont comptabilisés au passif comme «Fonds disponibles pour projets
futurs». Le Conseil d'Administration peut décider sur les projets que la fondation veut soutenir dans les années suivantes.
Les institutions de la Congrégation des Sœurs de Sainte Elisabeth doivent à cet effet remettre à la fondation des projets.
Le Conseil d'Administration jugera sur l'opportunité de soutenir les divers projets remis et versera la somme accordée
sur base de factures et d'un décompte de frais.
2.5 Affectations de résultat
Le résultat de l'exercice, après approbation des comptes annuels, est systématiquement affecté aux fonds propres.
<i>3. Notes sur le bilani>
3.1 Fonds disponibles pour projets futurs / Variation des fonds disponibles pour projets futurs
Description
2006
Dons reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.350,
-
Variation des fonds disponibles pour projets futurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.350,
-
2006
Fonds disponibles pour projets futurs début d'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
Variation des fonds disponibles pour projets futurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.350,
-
Fonds disponibles pour projets futurs début d'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.350,
-
La variation des fonds disponibles pour projets futurs d'un montant de 23.257,- est affecté au poste des fonds dispo-
nibles pour projets futurs en fin d'année. Ces fonds seront destinés pour les projets futurs subventionnés par la fondation.
3.2 Frais d'établissement
Description
2006
Acquisition au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
Acquisition au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.230,
-
Total Acquisition fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.230,
-
Amortissement au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
Amortissement au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -154,-
Total Amortissement à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -154,-
Total net des frais d'établissement
1.076,
-
3.3 Situation du personnel
Au 31 décembre 2006 la fondation n'a pas engagé du personnel.
3.4 Engagements
La fondation n'a pas d'engagements significatifs au 31 décembre 2006.
BUDGET 2007
<i>(exprimés en EURO)i>
Comptes de résultats
Budget 2007
A. Produits d'exploitation
Autres produits d'exploitation (Dons Reçus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.000,00
Sous-total A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.000,00
A'. Charges d'exploitation
Achats de matières premières et autres approvisionnements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-3.500,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-3.500,00
Autres Charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-10.000,00
Impôts Taxes et versements assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-150,00
36094
Dotations aux amortissements et aux provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-307,61
Sur immobilisations: dotations aux amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-307,61
Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-3.000,00
Sous-total A' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-16.957,61
A-A' Résultat d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133.042,39
B. Produits financiers, escomptes
Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.750,00
Sous-Total C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.750,00
B'. Charges financières
Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-800,00
Sous-Total C' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-800,00
B-B' Résultat financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.950,00
Dons à allouer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135.992,39
Signatures.
Référence de publication: 2007034316/4275/190.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06958. - Reçu 103 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06960. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070029989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.
Infomail S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 8A, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 60.600.
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 15 décembre 2006i>
L'article 3 des statuts coordonnés de la société stipule que le siège social peut être transféré par simple décision du
Conseil d'Administration [...] dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
[...]
«Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social avec effet immédiat au 8A, avenue Monterey à L-2163
Luxembourg, conformément au pouvoir lui attribué dans ce sens par l'article 3 des statuts.»
Certifié conforme
M. Gross / L. Zeches
<i>Président du Conseil d'Administrationi> / <i>Vice-Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2007036175/1196/18.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01412. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070032564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2007.
Geholux Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 48.322.
RECTIFICATIF
Le soussigné Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, déclare par la présente que dans le procès-
verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de société anonyme GEHOLUX HOLDING S.A. docu-
menté par acte de son ministère, en date du 28 décembre 2006, enregistré à Mersch, 5 janvier 2007, volume 440 folio
72 case 3, une erreur s'est glissée dans la quatrième résolution relative à la date d'effet de la scission.
La quatrième résolution est donc à lire comme suit:
<i>«Quatrième résolutioni>
L'assemblée constate que conformément aux articles 288 et 307 de la loi sur les sociétés commerciales, la scission est
devenue définitive avec effet au 29 décembre 2006. En conséquence, l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société
scindée, rien excepté ni réservé, est par suite de sa dissolution sans liquidation transféré aux deux sociétés à constituer
avec effet au 29 décembre 2006, sans préjudice des dispositions de l'article 302 sur les effets de la scission à l'égard des
tiers.
36095
D'un point de vue comptable, les opérations de la société scindée sont considérées comme accomplies pour le compte
des nouvelles sociétés à compter du 29 décembre 2006.
Les deux nouvelles sociétés ainsi constituées ont la forme de sociétés anonymes. Elles porteront respectivement les
dénominations sociales:
RUSKY S.A.
LAND LAD S.A.»
Mersch, le 13 février 2007.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007035678/242/30.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04970. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2007.
Doria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 992.850,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 112.723.
<i>Extrait des Résolutions des Associés du 10 février 2007i>
Les associés de DORIA S.à r.l. (la «Société»), ont décidé comme suit:
- D'accepter la démission du gérant de catégorie A suivant avec effet immédiat:
<i>Gérant de catégorie A:i>
- Jan-Dries Mulder, né le 7 février 1973 à Vendaam, Pays-Bas, demeurant professionnellement à Kabelweg 37, Coen-
gebouw, 1014 BA Amsterdam, Pays-Bas;
- De nommer le gérant de catégorie A suivant avec effet immédiat:
- Martijn Bosch, né le 28 octobre 1976 à Hengelo, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 6B, route de Trêves,
L-2633 Senningerberg, Luxembourg.
Les gérants actuels sont:
- Martijn Bosch - gérant de catégorie A
- Thijs van Ingen - gérant de catégorie B
- Mark Beckett - gérant de catégorie B
- Alberto Meloni - gérant de catégorie C
Luxembourg, le 27 février 2007.
T. van Ingen.
Référence de publication: 2007036260/710/25.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB07065. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070032286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2007.
IAP Immobilière S.àr.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Baticeram, S.à r.l.).
Siège social: L-4323 Esch-sur-Alzette, 2, rue C. M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 89.476.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007036151/7457/13.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2007, réf. LSO-CC01272. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070032311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
36096
AKS (Holdings) S.A.
Albert Seyler et Compagnie
Alcentra Mezzanine QPAM S.à r.l.
Ava Invest S.A.
Baticeram, S.à r.l.
Behedam (Holdings) S.A.
Brodequin Finance S.A.
CGM Lux 2 S.à r.l.
Copernicus Finance Buffer S.à r.l.
Doria S.à r.l.
Dragonera S.A.
Elisabeth Stëftung
Epicure Sàrl
EPI Oakwood GP 5 S.à.r.l.
European Property Fund (Radans) S.à r.l.
Eylau - Raymond Poincaré «Paris 75116» S.à r.l.
Fargo Investment Holdings S.A.
Filiaris S.A.
Fondation Greenpeace Luxembourg, Etablissement d'Utilité Publique
Fondation Lydie Schmit
Geholux Holding S.A.
Glibro Holding S.A.
IAP Immobilière S.àr.l.
Infomail S.A.
Ismat International S.A.
Kateco S.A.
L.B.G. S.à.r.l.
Leaders Motors Luxembourg S.A.
Lubow Illsen S.C.A.
March Europe S.A.
Masco Europe INC Financial S.C.S.
Medest S.A.
MobiLease S.A.
Mod'in Lux S.à r.l.
Next Future Holding SA
Nordviking Gesellschaft Reederei S.A.
Paunsdorf Centre Luxco
Rom Top 1 Sàrl
SAP Luxembourg Succursale de NV SAP Belgium SA
SAP Luxembourg Succursale de NV SAP Belgium SA
S.D.C.H. Holding S.A.
Société Immobilière Pandy S.A.
Tolub Chamszadeh Sàrl
Zwickau Arcaden Luxco