This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 736
27 avril 2007
SOMMAIRE
Abellio Luxco 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35294
ABN AMRO Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35327
Adviser II Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35314
Aérologic S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35324
ARHS developments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
35328
Atlantic International Assets S.A. . . . . . . .
35320
Baupart A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35313
Bertelsmann Digital Media Investments
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35327
British Vita (Lux III) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
35315
British Vita (Lux IV) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
35316
British Vita (Lux V) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
35316
Cera Chem S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35327
Christa Intershipping S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .
35328
Deutsche Bank (PWM) Sicav . . . . . . . . . . . .
35323
Diangle Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35320
D.M. Trans Road S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
35325
Eastern Telecom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35319
Eastern Telecom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35328
E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35323
E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35320
E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35324
E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35323
Euring S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35312
Eye 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35317
Ferrero Trading Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
35321
Finance et Développement . . . . . . . . . . . . .
35313
Fralimo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35311
Global Mineral Resources S.à r.l. . . . . . . . .
35297
Icaro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35318
Immobilière Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35318
ITGroup S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35311
Izarus Investment B.V. S.à r.l. . . . . . . . . . . .
35282
Keens Equity Investments S.A. . . . . . . . . . .
35319
Klammer Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
35319
LuxiPrivilège Conseil S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
35324
Oniva Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35327
Panlogistic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35312
Patron Weghell II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
35299
Patron Weghell I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
35305
Positronia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35321
Pronutri S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35315
Qualtec S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35317
Robin One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35314
Rosalia HealthCare AG . . . . . . . . . . . . . . . . .
35314
Serfin Gestion S.A. (Services Financiers et
de Gestion S.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35312
Sophaur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35311
Suisse Alpine Energie Nouvelle S.A. . . . . .
35322
Temporary Venture Holding S.A. . . . . . . .
35328
Temporary Venture Holding S.A. . . . . . . .
35322
Unirack Western Group S.A. . . . . . . . . . . .
35316
United Utilities (Luxembourg) S.à.r.l. . . . .
35317
35281
Izarus Investment B.V. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège de direction effectif: L-8010 Strassen, 206-210, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 106.923.
In the year two thousand and six, on the 11th, October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the private limited liability company with registered office in Amsterdam,
The Netherlands and with effective management seat in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, under the denomi-
nation of IZARUS INVESTMENT B. V., incorporated pursuant to a deed of the notary Nicole Corine Van Smaalen, residing
in Rotterdam, dated January 10, 2002, deed modified the last time on July 28, 2005 before Maître André Schwachtgen,
notary residing in Luxembourg, deed published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
o
1345 of December
8, 2005.
The Extraordinary General Meeting is chaired by Mr Hervé Poncin, company director, with professional address in
Strassen, 206-210, route d'Arlon,
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Charles Duro, lawyer, with professional address in L-1114
Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
The Meeting elects as scrutineer Mrs Karine Mastinu, lawyer, with professional address in L-1114 Luxembourg, 3, rue
de la Chapelle.
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the eight hundred
one (801) shares of a par value of twenty-five (25.-) euro each, representing the entire paid up issued capital of twenty
thousand and twenty-five (20,025.-) euro are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted
and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having
agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders present, the proxy holders of the shareholders represented, the
members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies
and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II.- The agenda of the Meeting is worded as follows:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of the Corporate object of the Company;
2. Transfer of the Effective management seat of the Company from L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer (Grand
Duchy of Luxembourg), to L-8010 Strassen, 206- 210, route d'Arlon (Grand Duchy of Luxembourg);
3. Suppression of the authority for the General Assembly to assign its rights to issue shares in the Company;
4. Suppression of the Class A managers and Class B managers of the Company and subsequent modification of the
representation authority of the Company;
5. Deletion of the notion of «depository receipts» in article 19 of the Articles of association;
6. Removal of the reference to a place of meetings for the General Meetings in the Articles of association;
7. Decision to remodel the Articles of association in order to reflect the above mentioned decisions;
8. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The Extraordinary General Meeting resolves to suppress the last paragraph to article two and to add the following
paragraphs to article two in order to enlarge the Corporate object of the Company, as follows:
«The Company may enter into guarantee, pledge or any other form of security agreement, whether by personal
covenant or by mortgage or charge upon all or part of the Company's property assets within the limits of its corporate
object and Luxembourg Law, it being understood that the Company will not enter into any transaction which could cause
it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.
It may lend and borrow with or without interests in any form, proceed to the issuance of bonds and debentures and
obtain guarantees, pledges or any other form of securities.»
<i>Second resolutioni>
The Extraordinary General Meeting resolves to transfer the seat of effective management from its actual address to
the following address: 206-210, route d'Arlon at L-8010 Strassen (Grand Duchy of Luxembourg).
35282
<i>Third resolutioni>
The Extraordinary General Meeting resolves to remove the authority for the General Meeting to assign its rights to
issue shares in the Company actually foreseen in article six of the Articles of association.
<i>Fourth resolutioni>
The Extraordinary General Meeting resolves to suppress the classes of managers in the Company, namely Class A
managers and Class B managers of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
Following the suppression of the classes of managers in the Company, the Extraordinary General Meeting resolves
that the Company shall be represented as long as there is only one manager by his sole signature and as soon as there
are two or more managers by the joint signature of any two managers.
The Extraordinary General Meeting further resolves to suppress article fourteen subparagraph three of the Articles
of association related to the distinction between representative from the Company who are a holder of all of the shares,
or a participant in a marital community of which all of the shares form a par, and the other kinds of representative.
<i>Sixth resolutioni>
The Extraordinary General Meeting resolves to remove any reference to «the depository receipts» in article nineteen
of the Articles of association.
<i>Seventh resolutioni>
The Extraordinary General Meeting resolves to remove any reference to the place of meeting of General Meetings in
the Articles of association.
<i>Eighth resolutioni>
Following the above decisions, the Extraordinary General Meeting decides to remodel the Articles of association and
adopts the Articles of association of the Company, which will have henceforth the following wording:
Chapter I. Name - Duration - Object - Registered office
Art. 1. Name and Duration. There exists a private limited liability company, which will be governed by the laws
pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial
companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»)
under the name of IZARUS INVESTMENT B.V., S.à r.l.
The Company is formed and continued for an unlimited period of time.
Art. 2. Corporate Object. The object of the Company is the holding of participations, directly or indirectly in any form
whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of
these participations.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,
participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.
It may enter into guarantee, pledge or any other form of security agreement, whether by personal covenant or by
mortgage or charge upon all or part of the Company's property assets within the limits of its corporate object and
Luxembourg Law, it being understood that the Company will not enter into any transaction which could cause it to be
engaged in any activity that would be considered as a banking activity.
It may lend and borrow with or without interests in any form, proceed to the issuance of bonds and debentures and
obtain guarantees, pledges or any other form of securities.
It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may
take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose.
Art. 3. Registered office. The registered office of the Company is established in Amsterdam, The Netherlands.
The Company has its principal place of establishment and its effective management seat in Strassen, (Grand-Duchy of
Luxembourg).
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. Corporate capital - Member's register - Shares
Art. 4. Corporate Capital.
1. The Company's issued share capital is fixed at twenty thousand and twenty-five euro (EUR 20,025.-) divided into
eight hundred and one (801) shares having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, entirely paid in.
2. All shares are registered shares. No share certificates shall be issued.
35283
Art. 5. Member's register.
1. The Management board shall keep a register in which the names and addresses of all members are recorded, showing
the date on which they acquired the shares, the date of the acknowledgement or notification, and the amount paid on
each share.
The names and addresses of those with a right of usufruct or a pledge on the shares shall also be entered in the register,
stating the date on which they acquired the right, and the date of acknowledgement or notification.
2. The register shall be kept up to date. All entries and notes in the register shall be signed by a member of the
Management board.
Art. 6. Issuance of shares.
1. The issuance of shares may only be effected pursuant to a resolution of the General Meeting of members (hereinafter:
«the General Meeting»).
The resolution for the issuance of shares shall stipulate the price and further conditions of issuance.
2. Upon issuance of shares, each member shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nominal
amount of his shares, subject to the limitations set by Law.
3. The preceding provisions of this article shall also apply to granting rights to subscribe for shares, but these provisions
shall not apply to the issuance of shares to someone exercising a subscription right obtained previously.
4. The full nominal amount of each share must be paid in on issue.
5. The issuance of shares shall require a deed drawn up for that purpose in the presence of a notary.
Art. 7. Own shares.
1. When issuing shares, the company shall not be entitled to subscribe for its own shares.
2. The Company may acquire fully paid in shares in its own capital subject to the relevant provisions of the Law.
3. Disposal of own shares held by the Company shall require a resolution of the General Meeting. The resolution to
dispose shall state the conditions of the disposal.
Art. 8. Guarantee - Loans.
1. With a view to the subscription for shares in its capital or acquisition of shares in its capital by others, the Company
may not give a guarantee or a price guarantee, or assume joint and/or several liabilities together with or on behalf of
others.
2. The Company may give loans with a view to the subscription for or acquisition of shares in its capital, but only up
to the amount of the distributable reserves and within the limits fixed by Law. The Company shall keep a non-distributable
reserve up to the outstanding loans referred to in the preceding sentence.
Art. 9. Community of Property. If shares belong to a community of property, the joint partners may only have them-
selves represented vis-à-vis the Company by a person designated to that effect by them in writing. The joint partners may
also designate more than one person.
The joint partners may - provided this is unanimous - also determine, upon said designation or at a later date, that if
a partner so desire, a number of votes shall be cast on his behalf equal to the share in the community of property to
which he is entitled.
Art. 10. Usufruct - Pledge. A share may be given in usufruct and may be pledged. The voting right cannot be assigned
to the usufructuary or to the pledgee.
Art. 11. Transfer of shares.
1. In order to be valid any transfer of shares shall require the approval of the General Meeting in accordance with the
provisions of this article and within the limits fixed by Law.
2. However, no approval is required if all members have approved the intended transfer in writing and the transfer is
made within three months after they all have granted their approval.
3. A member who wishes to transfer shares (in this article also referred to as the applicant) shall give notice of such
intention to the Management board which notice shall specify the number of shares he wishes to transfer and the person
or the persons to whom he wishes to transfer the shares.
4. The Management board shall be obliged to convene and to hold a General Meeting within six weeks from the date
of receipt of the notice referred to in the preceding paragraph. The contents of such notice shall be stated in the con-
vocation.
5. If:
a. no such Meeting as referred to in paragraph 4 has been held within the term mentioned in that paragraph;
b. at that Meeting no resolution has been adopted regarding the request for approval;
c. such approval has been refused without the Meeting having informed the applicant, at the same time as the refusal,
of one or more interested parties who are prepared to purchase all the shares to which the request for approval relates,
35284
against payment in cash, the approval requested shall be deemed to have been granted and, in the case mentioned under
a, shall be deemed to have been granted on the final day on which the Meeting should have been held.
The Company itself can only be an interested party as referred to in this article with the consent of the applicant.
6. If the Meeting has granted the approval as requested or such approval is deemed to have been granted, the transfer
is required to be effected within three months thereafter.
7. Unless the applicant and the party (parties) interested designated by the General Meeting and accepted by him agree
otherwise as to the price or the determination of the price, the purchase price of the shares shall be determined by three
independent experts, appointed at the request of the most willing party by the chairman of the Chamber of Commerce
in whose district the Company has its corporate seat.
8. The experts referred to in the preceding paragraph shall be authorized to inspect all books and records of the
Company and to receive all such information as may be useful in their determination of the price.
9. The applicant as well as the interested party (parties) designated by the General Meeting and accepted by the applicant
shall remain entitled to withdraw by means of notification to the Management board until the expiry of a month after
they have been informed in writing of said determination of the price. The Management board shall forthwith notify all
parties involved of the withdrawal.
10. If one of the. interested parties withdraws and if the other interested parties are not prepared within two weeks
after the expiry of the period referred to in the preceding paragraph by means of notification in writing to the Management
board, to also take over the shares becoming available as a result of the withdrawal, the applicant shall be at liberty to
transfer all shares, provided within three months after it has been established that not all shares are purchased by the
interested parties.
11. The costs of determining the price shall be borne:
a. by the applicant if he withdraws;
b. by the applicant as to one half and the purchasers as to the other half if the shares are purchased by the interested
parties, on the understanding that each purchaser shall contribute in proportion to the number of shares purchased by
him;
c. by the Company in cases not falling under a or b.
12. All statements and notices referred to in this article shall be made by registered letter or against a receipt.
13. The provisions of this article shall also apply to the subscription right on shares.
14. The provisions of this article shall not apply if the member pursuant to the law is under an obligation to transfer
his shares to a previous member.
Chapter III. Management
Art. 12. Management board.
1. The management of the Company shall be constituted by a Management board, consisting of one or more members.
2. The General Meeting shall appoint the members of the Management board.
3. A member of the Management board may at any time be suspended or dismissed by the General Meeting.
4. The General Meeting shall determine the remuneration and further conditions of employment for each member of
the Board.
5. If a member of the Management board is absent or prevented from performing his duties, the remaining members
or member of the Management board shall be temporarily entrusted with the management of the Company. If all members
of the Management board, or the sole member of the Management board, are absent or prevented from performing their
duties, the management of the Company shall be temporarily entrusted to the person designated for this purpose by the
General Meeting.
Art. 13. Duties of the Management board.
1. Subject to the restrictions imposed by these Articles of association, the Management board shall be entrusted with
the management of the Company.
2. The Management board shall have a meeting whenever required by a member of the Management board. Every
member of the Management board has one vote at the meeting. Resolutions of the Management board shall be adopted
by an absolute majority of the votes of all members of the Management board in office.
3. Every member of the Management board may have himself be represented at the meetings of the Board, but only
by another member of the Management board. Such representation shall require a proxy in writing. The expression in
writing shall include any document transmitted by current means of communication and received in writing.
4. Resolutions of the Management board may also be adopted in writing without recourse to a Management board
meeting, provided all members of the Management board have been consulted and none of them opposes to this method
of adopting resolutions.
35285
5. Any and all managers may participate in any meeting of the Board of managers by telephone or video conference
call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
6. The Board may determine rules of management containing regulations as to matters concerning the board internally.
The Management board may further determine, by means of rules or otherwise, the duties to be discharged by each of
them and shall inform the General Meeting thereof.
7. The Management board shall observe the directives that may given by the General Meeting concerning the general
lines of the financial, social, economic and staff policy.
8. The General Meeting is entitled to require resolutions of the Management board to be subject to its approval. These
resolutions shall be clearly specified and notified to the Management board in writing.
9. The lack of approval referred to in the preceding paragraph does not affect the authority of the Management board
or its members to represent the Company.
Art. 14. Representation of the Company.
1. The Management board shall be authorised to represent the Company. Towards third parties, the Company shall
be bound as long as there is only one manager by his sole signature and as soon as there are two or more managers by
the joint signature of any two managers.
2. The Management board may appoint staff members with general or limited power to represent the Company. Each
staff member shall be competent to represent the Company with due observance of any restrictions imposed on him.
The Management board shall determine their titles.
3. If a member of the Management board in his private capacity enters into an agreement with the Company or in his
private capacity conducts legal proceedings as against the Company, the Company shall be represented by a member of
the Management board to be designated by the General Meeting. Also the person to whom the conflict of interest relates
may be designated. If a member of the Management board in any way other than provided for in the first sentence of this
paragraph has an interest conflicting with the interests of the Company, such member as well as every other member of
the Management board may represent the Company.
Art. 15. Liability of members of the Management board. The member (s) or the Management board (as the case may
be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them
in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles of Association of the Company
as well as the applicable provisions of the Law.
Chapter IV. Financial year - Financial statement - Profit sharing
Art. 16. Accounting year. The Company's financial year starts on the first of August and ends on the thirty-first of July
of each year.
Art. 17. Financial statements.
1. Annually, not later than five months after the end of the financial year, unless by reason of special circumstances
this term is extended by the General Meeting by not more than six months, the Management board shall draw up annual
accounts and an annual report.
2. The annual accounts shall be signed by all the members of the Management board. If the signature of one or more
of them is lacking, this shall be stated and reasons given.
3. The General Meeting of members shall adopt the annual accounts.
4. The General Meeting of members may decide to constitute a discharge of the managers with respect to their
management insofar as such management is reflected in the annual accounts and / or annual report. However, the General
Meeting may resolve that such discharge shall not be granted at all or partly. The scope of a discharge granted shall be
subject to limitations by virtue of the Law.
Art. 18. Inspection of documents. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's
registered office.
Art. 19. Appropriation of profits, reserves.
1. The General Meeting shall determine the allocation of accrued profits.
2. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated
to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
3. Dividends may be paid only in so far as the Company's equity exceeds the paid-up and called part of the share capital
increased by the reserves to be kept by virtue of the Law or the Articles of association.
4. Dividends shall be paid after adoption of the annual accounts from which it appears that payment of dividends is
permissible.
5. Dividends shall not be paid on behalf of the Company on shares in its capital thereof that have been acquired by the
Company.
35286
6. The General Meeting may, with due observance of the present article and within the limits fixed by the Law, resolve
to pay an interim dividend and may resolve to make payments at the charge of a reserve.
Chapter V. General Meetings of members
Art. 20. General Meetings of members.
1. The Annual Meeting shall be held annually, and not later than six months after the end of the financial year.
The agenda of that Meeting shall contain inter alia the following subject matters:
a. adoption of the annual accounts and determination of the allocation of the profits;
b. the annual report.
The agenda does not have to include these items, if the term for the preparation of the annual accounts and submitting
the annual report has been extended or a proposal thereto has been placed on the agenda.
2. Other General Meetings of members shall be convoked by the Management board failing which by members jointly
representing at least one tenth of the issued capital, by letter mailed to the addresses of the members as shown in the
register of members.
The convocation shall take place no later than on the fifteenth day prior to the date of the Meeting.
The convocation shall specify in the notice of Meeting the place, date and hour where the general meeting will be held.
3. As long as the entire issued capital is represented at a General Meeting of members valid resolutions can be adopted
on all subjects brought up for discussion, even if the formalities prescribed by Law or by the Articles of association for
the convocation and holding of meetings have not been complied with, provided such resolutions are adopted unani-
mously.
4. The General Meetings shall itself appoint its chairman. Until that moment a member of the Management board shall
act as chairman and in the absence of such a member the eldest person present at the Meeting shall act as chairman.
5. A secretary to be designated by the chairman shall keep minutes of the business transacted at the Meeting. The
minutes shall be confirmed in the same Meeting or the next Meeting and shall in witness thereof be signed by the chairman
and secretary of that Meeting.
6. The chairman or the party having convened the Meeting may determine that a notarial record is made of the business
transacted at the Meeting. The notarial record shall also be signed by the chairman.
7. The Management board shall keep a record of resolutions made. If the Management board is not represented at the
meeting, the Management board as soon as possible after the meeting shall be provided with a copy of the resolutions
made by or on behalf of the chairman. The records shall be deposited at the office of the Company for inspection by the
members. Upon request each of them shall be provided with a copy or an extract of such record at not more than the
actual costs.
8. Each member shall have the right to attend the General Meeting or to have himself be represented at the Meeting
by proxy in writing, to address the Meeting and to exercise the voting right.
9. Each share confers the right to cast one vote. Blank votes and invalid votes are deemed not to have been cast.
10. At the General Meeting no votes can be cast in respect of a share owned by the Company or a subsidiary of the
Company.
11. When determining to which extent the members cast votes, are present or represented, or to which extent the
share capital is provided or represented, the shares in respect of which the Law provides that no votes can be cast in
respect thereof, shall not be taken into account.
12. A single member assumes all powers conferred to the General Members' Meeting. In case of a plurality of members,
each member may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each member
has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are
adopted by members owning more than half of the share capital.
13. However, resolutions to alter the Articles of association may only be adopted by the majority of the members
owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
14. The members of the Management board shall, as such, have an advisory vote at the General Meeting if the members
so wishes.
Art. 21. Resolutions outside of Meetings.
1. Resolutions of members may also be adopted in writing without recourse to a General Meeting of members, provided
they are adopted by a unanimous vote representing the entire issued capital. In this case, each member shall be sent an
explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing.
2. The Management board shall keep a record of the resolutions thus made. Each of the members must procure that
the Management board is informed in writing of the resolutions made in accordance with paragraph 1 as soon as possible.
The records shall be deposited at the office of the Company for inspection by the members. Upon request each of them
shall be provided with a copy or an extract of such record at not more than the actual costs.
35287
Chapter VI. Dissolution - Liquidation
Art. 22. Dissolution.
1. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of
the single member or of one of the members.
2. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, members
or not, appointed by the members who shall determine their powers and remuneration, the Management board may be
appointed to carry out the liquidation of the business of the Company.
3. During liquidation the provisions of these Articles of association shall remain in force as far as possible.
4. The balance remaining after payment of debts shall be transferred to the members in proportion to the aggregate
amount of their shareholdings.
5. The liquidation shall furthermore be subject to the provisions of the Law.
Chapter VII. Governing Law
Art. 23. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no
specific provision is made in these Articles.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the mandatory of the person appearing, he signed
together with Us the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le onze octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée IZARUS INVESTMENT B. V.,
ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas et son principal siège administratif et de direction effective à Luxembourg,
Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Nicole Corme Van Smaalen, notaire de résidence
à Rotterdam, en date du 10 janvier 2002, acte modifié pour la dernière fois le 28 juillet 2005 par devant Maître André
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
n
o
1345 du 8 décembre 2005.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hervé Poncin, administrateur, avec adresse professionnelle à
Strassen, 206-210, route d'Arlon, Président de l'assemblée.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Charles Duro, avocat, avec adresse professionnelle L-1114
Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
L'Assemblée élit comme scrutateur Madame Karine Mastinu, avocat, avec adresse professionnelle à L-1114 Luxem-
bourg, 3, rue de la Chapelle.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les huit cent une (801)
actions d'une valeur nominale de vingt cinq (25,-) euro chacune représentant l'intégralité du capital social libéré et émis
de vingt mille vingt-cinq (20.025,-) euro sont dûment représentées à la présente Assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregis-
trement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'objet social de la Société;
2. Transfert du siège de direction effective de la Société de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer (Grand Duché
de Luxembourg), à L-8010 Strassen, 206-210, route d'Arlon (Grand Duché de Luxembourg);
3. Suppression de l'autorisation à l'Assemblée de déléguer l'émission de parts sociales de la Société;
4. Suppression des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B et modification subséquente du mode de
représentation de la Société;
35288
5. Suppression de toute référence à la notion de «depository receipts» à l'article 19 des statuts;
6. Suppression de toute référence au lieu de réunion des Assemblées générales des associés dans les statuts;
7. Décision de refondre les statuts existants de la Société suite aux décisions prises;
8. Divers.
II.- L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement con-
stituée, aborde les points précités de l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide supprimer le dernier alinéa de l'article deux et de rajouter les alinéas
suivants à l'article deux afin d'élargir l'Objet social de la Société de la manière suivante:
«La Société peut donner des garanties, des cautionnements ou toute autre forme de sûretés, que ce soit par engage-
ment personnel ou par hypothèque ou par charge sur tout ou partie des biens de la Société dans les limites de son objet
social et de la loi luxembourgeoise, étant entendu que la Société n'entrera dans aucune transaction qui pourrait avoir
pour effet qu'elle soit engagée dans une quelconque activité qui pourrait être considérée comme une activité bancaire.
La Société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, procéder à l'émission d'obligations
et obtenir des garanties, des cautionnements ou toute autre forme de sûretés.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de transférer le siège de direction effective de son adresse actuelle à
l'adresse suivante: L-8010 Strassen, 206-210, route d'Arlon (Grand Duché de Luxembourg);
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de supprimer la possibilité pour l'Assemblée générale de déléguer ses
droits à émettre des parts sociales dans la Société dont il est fait référence à l'article six des statuts.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de supprimer les catégories de gérants dans la Société, à savoir les gérants
de catégorie A et les gérants de catégorie B.
<i>Cinquième résolutioni>
Consécutivement à la suppression des catégories de gérants, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide que la Société
sera valablement engagée, aussi longtemps qu'il n'y a qu'un seul gérant par sa seule signature et en cas de pluralité de
gérants par la signature conjointe de deux des gérants.
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide par ailleurs de supprimer l'article quatorze alinéa quatre des statuts qui
fait référence à la distinction opérée entre les représentants de la Société qui sont un associé unique ou une personne
bénéficiaire d'une communauté de biens dans laquelle toutes les parts sociales font partie, et tout autre représentant de
la Société.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de supprimer toute référence aux «depository receipts» figurant à l'article
dix-neuf des statuts.
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de supprimer toute référence au lieu de réunion des Assemblées géné-
rales des associés dans les statuts.
<i>Huitième résolutioni>
Suite aux décisions prises, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de procéder à une refonte des statuts et
d'adopter de nouveaux statuts comme suit:
Chapitre I
er
. Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Nom et Durée. II existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle
entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée
(ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), sous la dénomination de IZARUS
INVESTMENT B.V., S.à r.l.
La Société est formée et continuée pour une durée illimitée.
Art. 2. Objet social. La Société a pour objet la prise de participations directement ou indirectement, sous quelque
forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise
en valeur de ces participations.
La Société peut acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute
autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.
35289
La Société peut donner des garanties, des cautionnements ou toute autre forme de sûretés, que ce soit par engagement
personnel ou par hypothèque ou par charge sur tout ou partie des biens de la Société dans les limites de son objet social
et de la loi luxembourgeoise, étant entendu que la Société n'entrera dans aucune transaction qui pourrait avoir pour effet
qu'elle soit engagée dans une quelconque activité qui pourrait être considérée comme une activité bancaire.
La Société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, procéder à l'émission d'obligations
et obtenir des garanties, des cautionnements ou toute autre forme de sûretés.
La Société peut exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une façon
générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles
à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. Siège social. La Société a son siège social à Amsterdam, Pays-Bas.
Elle a son principal siège administratif et de direction effective à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.
La Société peut avoir d'autres bureaux et succursales à la fois au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.
Chapitre II. Capital social - Registre d'associés - Parts sociales
Art. 4. Capital social.
1. Le Capital social émis de la Société est fixé à vingt mille vingt-cinq euros (EUR 20.025,-) divisé en huit cent et une
(801) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.
2. Toutes les parts sociales sont nominatives. Aucun certificat de parts sociales ne sera émis.
Art. 5. Registre d'associés.
1. Le Conseil de gérance tiendra un registre dans lequel seront inscrits les noms et adresses de tous les associés, avec
indication de la date à laquelle ils ont acquis les parts sociales, la date de réception ou de notification et le montant payé
pour chacune des parts sociales.
Les noms et adresses de ceux ayant un droit d'usufruit ou un nantissement sur les parts sociales seront également
inscrits, avec indication de la date à laquelle ils ont acquis les dits droits et la date de réception ou de notification.
2. Le registre sera tenu à jour. Toute entrée et annotation dans le registre devra être signée par un membre du Conseil
de gérance.
Art. 6. Emission de parts sociales.
1. L'émission de parts sociales pourra seulement s'effectuer par le biais d'une résolution de l'Assemblée générale des
associés (ci après «l'Assemblée générale»).
Une telle résolution stipulera le prix et les conditions d'une telle émission.
2. Lors de l'émission de parts sociales, chaque associé aura un droit de préemption proportionnel au montant total
des parts sociales qu'il détient dans les limites légales.
3. Les dispositions précédentes de cet article s'appliqueront également aux droits de souscription de parts sociales,
mais elles ne s'appliquent pas à l'émission de parts sociales à une personne exerçant un droit de souscription acquis
précédemment
4. Le montant nominal de chaque part sociale devra entièrement être libéré lors de l'émission.
5. L'émission de parts sociales requiert un acte notarié.
Art. 7. Parts sociales propres.
1. Lors de l'émission de parts sociales, la Société ne pourra souscrire à ses propres parts sociales.
2. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales dans son propre capital social, conformément aux dispositions
légales.
3. La cession de parts sociales propres par la Société requiert une résolution de l'Assemblée générale qui déterminera
les conditions d'une telle cession.
Art. 8. Garanties - Prêts.
1. Dans le cadre de la souscription de parts sociales dans le capital de la Société ou de l'acquisition de parts sociales
dans son capital, la Société ne pourra accorder ni garantie, ni assumer une quelconque responsabilité conjointement ou
individuellement avec ou pour le compte de tiers.
2. La Société pourra accorder des prêts dans le cadre de souscription ou d'acquisition de parts sociales dans son capital
dans les limites des réserves distribuables et dans les limites fixées par la loi. La Société maintiendra une réserve non-
distribuable d'un montant équivalent aux prêts ainsi accordés.
Art. 9. Propriété commune. Si des parts sociales appartiennent à une communauté de propriétaires, les associés
communs ne pourront se faire représenter envers la Société que par une personne désignée à cet effet par écrit. Les
associés communs pourront de même désigner plus d'une personne.
Les associés communs pourront aussi - pourvu que ce soit à l'unanimité - décider lors de cette désignation ou ulté-
rieurement, que si un associé le désire, un nombre de votes égal à la partie du capital auquel il a droit lui sera attribué.
35290
Art. 10. Usufruit - Nantissement. Une part sociale peut être donnée en usufruit et faire l'objet d'un nantissement Les
droits de vote attachés ne pourront être accordés à l'usufruitier ou au bénéficiaire du nantissement.
Art. 11. Cession de parts sociales.
1. Afin d'être valide, toute cession de parts sociales requiert l'approbation de l'Assemblée générale conformément aux
dispositions de cet article et aux dispositions légales.
2. Cependant, aucune approbation n'est requise si tous les associés ont approuvé la cession par écrit et si la dite cession
est réalisée dans les trois mois de l'approbation des associés.
3. Un associé qui désire céder des parts sociales (ci-après le «Requérant») notifiera cette intention au Conseil de
gérance, en spécifiant le nombre de parts sociales qu'il désire transférer et la / les personne(s) à qui il désire transférer
les parts sociales.
4. Le Conseil de gérance devra réunir et tenir une Assemblée générale dans les six semaines à dater de la réception
de la notification mentionnée dans le paragraphe précédent. Le contenu de la notification sera repris dans la convocation.
5. Si:
a. aucune Assemblée telle que mentionnée au paragraphe 4 n'a été tenue dans le délai mentionné dans ce paragraphe;
b. aucune décision n'a été adoptée pendant l'Assemblée, au sujet de la demande d'approbation;
c. une telle approbation a été refusée sans que l'Assemblée n'en ait informé le Requérant, au même moment que le
refus, par une ou plusieurs parties intéressés préparées à acquérir toutes les parts sociales avec paiement en espèces, et
dont la requête en approbation se rapporte, l'approbation demandée sera réputée avoir été accordée et, dans le cas
mentionné sous le point a, sera réputée avoir été accordée le dernier jour ou l'Assemblée aurait du être tenue.
La Société elle-même peut seulement être une partie intéressée comme mentionné dans cet article, avec le consen-
tement du Requérant.
6. Si l'Assemblée a donné son approbation comme requis ou si cette approbation est réputée avoir été accordée, le
transfert devra être effectué dans les trois mois.
7. Sauf si le Requérant et la/les partie(s) intéressées désignés par l'Assemblée générale et acceptée par le Requérant
en conviennent autrement quant au prix ou à la détermination du prix, le prix d'acquisition des parts sociales sera dé-
termine par trois experts indépendants, nommés à la demande de la partie la plus diligente par le président de la Chambre
de Commerce de la juridiction où la Société a son siège social.
8. Les experts mentionnés dans le paragraphe précédent seront autorisés à inspecter tous les livres et documents de
la Société et à recevoir toute information pouvant être utile à la détermination du prix.
9. Le Requérant, ainsi que la /les partie(s) intéressées désignées par l'Assemblée générale et acceptées par le Requérant
seront autorisés à se désister au moyen d'une notification adressée au Conseil de gérance jusqu'à l'expiration d'un mois
après qu'ils aient été informés par écrit d'une telle détermination du prix. Le Conseil de gérance notifiera immédiatement
cette décision à toutes les parties concernées par le désistement.
10. Si une des parties intéressées se désiste et si les autres parties intéressées ne sont pas préparées dans les deux
semaines après l'expiration de la période mentionnée au paragraphe précédent, au moyen d'une notification par écrit au
Conseil de gérance, à reprendre également les parts sociales devenues disponibles à la suite du désistement, le Requérant
aura la liberté de transférer toutes les parts sociales, dans les trois mois après qu'il ai été établi que toute les parts sociales
ne sont pas acquises par les parties intéressées.
11. Les coûts de la détermination du prix seront supportés par:
a. Le Requérant s'il se désiste;
b. Le Requérant pour une moitié et les acheteurs pour l'autre moitié si les parts sociales sont achetées par les parties
intéressées, étant entendu que chaque acheteur contribuera aux coûts en proportion du nombre de parts sociales ache-
tées par lui.
c. la Société pour les autres cas de figure non compris sub a ou b.
12. Toutes les déclarations et notifications mentionnées dans cet article seront effectuées par lettre recommandée ou
avec accusé de réception.
13. Les dispositions de cet article s'appliqueront aussi aux droits de souscription sur les parts sociales.
14. Les dispositions de cet article ne s'appliqueront pas si l'associé est, conformément à la Loi, obligé de transférer ses
parts sociales à un associé précédent.
Chapitre III. Gestion
Art. 12. Conseil de gérance.
1. La Société est gérée par un Conseil de gérance, composé d'un ou plusieurs membres.
2. L'Assemblée générale nomme les membres du Conseil de gérance.
3. Un membre du Conseil de gérance peut à tout moment être suspendu ou révoqué par l'Assemblée générale.
4. L'Assemblée générale déterminera les rémunérations et les conditions d'emploi éventuelles de chacun des membres
du conseil.
35291
5. Si un membre du Conseil de gérance est absent ou empêché pour l'accomplissement de ses missions, les ou les
membres restants seront provisoirement en charge de la gestion de la Société. Si tous les membres du Conseil de gérance,
ou le seul membre du Conseil de gérance, sont absents ou empêchés pour l'accomplissement de leurs missions, la gestion
de la Société sera provisoirement confiée à la personne désignée pour les besoins par l'Assemblée générale.
Art. 13. Attributions du Conseil de gérance.
1. Sous réserve des dispositions des présents statuts, le Conseil de gérance sera chargé de la gestion de la Société.
2. Le Conseil se réunira à chaque fois qu'un membre du Conseil le requiert. Chaque membre dispose d'une voix lors
d'une réunion du Conseil. Les résolutions du Conseil sont adoptées à la majorité de tous les membres du Conseil de
gérance en fonctions.
3. Chaque membre du Conseil peut se faire représenter à une réunion du Conseil, mais seulement par un autre membre
du Conseil. Une telle représentation requiert une procuration écrite. La notion d'écrit englobe tout document transmis
par les moyens actuels de communication et reçu par écrit.
4. Les résolutions du Conseil pourront être également prises par écrit sans recourir à une réunion du Conseil, sous
réserve que chacun des membres ait été consulté et qu'aucun d'entre eux ne s'est opposé à cette méthode de prise de
résolutions.
5. Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du Conseil par conférence call par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au Conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne
à la réunion.
6. Le Conseil pourra déterminer les règles de gestion et mesures incluant les affaires internes au Conseil. Le Conseil
pourra également déterminer par voie de directives ou autrement, les règles d'attribution des missions allouées à chacun
de ses membres et en informera l'Assemblée générale en conséquence.
7. Le Conseil suivra les directives fixées par l'assemblée générale en ce qui concerne les aspects financiers, sociaux,
économiques et de gestion du personnel.
8. L'Assemblée générale peut requérir que certaines résolutions du Conseil lui soient soumises pour approbation. De
telles résolutions devront clairement être spécifiées et notifiées au Conseil.
9. L'absence d'approbation de la procédure du paragraphe précédent n'affecte pas l'autorité du Conseil ni le rôle de
représentation dévolus à ses membres.
Art. 14. Représentation de la Société.
1. Le Conseil est autorisé à représenter la société. La Société est valablement engagée, aussi longtemps qu'il n'y a qu'un
seul gérant par sa seule signature et en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux des gérants.
2. Le Conseil peut nommer des agents avec des pouvoirs généraux ou spécifiques pour représenter la société. Chaque
agent est compétent pour représenter la Société sous respect des contraintes lui imposées. Le Conseil déterminera leur
titres respectifs.
3. Si un membre du Conseil de gérance, s'engage personnellement dans un contrat avec la Société ou engage des
poursuites contre la Société, la Société sera représentée par un membre du Conseil de gérance désigné par l'Assemblée
générale. La personne concernée par le conflit d'intérêt pourra être désignée. En dehors des cas prévus par la première
phrase de cet article, le membre du Conseil qui a un intérêt conflictuel avec ceux de la Société pourra ainsi que tout autre
membre du Conseil représenter la Société.
Art. 15. Responsabilité des membres du Conseil de gérance. Le ou les membres du Conseil de gérance ne contractent
à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de
la Société, dans la mesure où de tels engagements sont en conformité avec les statuts et les dispositions applicables de
la Loi.
Chapitre IV. Exercice social - Etats comptables - Distribution des profits
Art. 16. Exercice social. L'année sociale commence le premier août et se termine le trente et un juillet de chaque
année.
Art. 17. Etats comptables.
1. Chaque année, et ceci au plus tard cinq mois après l'approbation des comptes annuels, sauf circonstances excep-
tionnelles ou le terme pourra être étendue a six mois, le Conseil de gérance établira les comptes annuels et un rapport
de gestion.
2. Les comptes annuels seront signés par tous les membres du Conseil de gérance. Si la signature de l'un d'entre eux
est manquante, les raisons en devront être données.
3. L'Assemblée générale adopte les comptes annuels.
4. L'Assemblée générale peut décider de donner décharge aux gérants pour leur gestion pour autant que cette gérance
soit reflétée dans les comptes annuels/ ou rapport annuel. Néanmoins l'Assemblée générale peut décider de ne pas donner
décharge ou décharge partielle. La portée de la décharge sera soumise aux limitations légales.
35292
Art. 18. Vérification des documents. Chaque associé pourra inspecter les inventaires précités ainsi que les comptes
annuels au siège de la Société.
Art. 19. Appropriation des bénéfices, réserves.
1. L'Assemblée générale déterminera l'allocation des bénéfices cumulés.
2. Les bénéfices bruts de la Société, tels qu'ils apparaissent dans les comptes annuels, après déduction des dépenses
générales, amortissement et dépenses, représentent les bénéfices nets. Un montant équivalent à cinq pour cents (5%)
des bénéfices nets de la Société est alloué à la réserve légale, jusqu'à ce que cette dernière atteigne dix pour cent (10%)
du capital social de la Société.
3. Les dividendes ne peuvent être distribués que si les actifs nets de la Société excédent le capital souscrit augmenté
des réserves rendues obligatoires par la Loi ou les statuts.
4. Les dividendes seront distribués après l'adoption des comptes annuels, desquels il apparaît que la distribution de
dividendes est permise.
5. Les dividendes ne seront pas distribués pour le compte de la Société sur les parts sociales de son capital détenues
par la Société elle-même.
6. L'Assemblée Générale peut, dans le respect du présent article et dans les limites fixées par la Loi, décider de payer
un dividende intérimaire et peut également décider d'allouer des montants à la réserve.
Chapitre V. Assemblées générales des associés
Art. 20. Assemblées générales des associés.
1. L'Assemblée annuelle sera tenue chaque année, dans les six mois suivant la fin de l'année sociale.
L'ordre du jour de l'Assemblée contiendra entre autres les points suivants:
a. adoption des comptes annuels et détermination de l'allocation des profits;
b. le rapport annuel.
L'ordre du jour ne devra pas comprendre ces sujets si le délai pour la préparation des comptes annuels et pour la
présentation du rapport annuel a été étendu ou si une proposition en ce sens se trouve dans l'ordre du jour.
2. Les autres Assemblées générales des associés seront convoquées par le Conseil de gérance ou à défaut par les
associés représentant ensemble au moins un dixième du capital souscrit, par courrier envoyé aux adresses des associés
telles qu'elles apparaissent dans le registre des associés.
La convocation aura lieu au plus tard le quinzième jour précédant la date de l'Assemblée.
Il sera indiqué dans l'avis de convocation le lieu la date et l'heure où l'Assemblée générale sera tenue.
3. Si l'entièreté du capital social souscrit est représentée à l'Assemblée générale des associés, des décisions pourront
valablement être prises sur tous les sujets dont les associés veulent discuter, même si les formalités prescrites par la loi
ou les statuts pour la convocation et la tenue des Assemblées n'ont pas été respectées, à la condition que ces décisions
aient été adoptées à l'unanimité.
4. Chaque Assemblée désignera elle-même son Président. Jusqu'à ce moment, un membre du Conseil de gérance actera
comme Président et en l'absence de ce membre, la personne la plus âgée de l'assemblée actera comme Président.
5. Un secrétaire sera nommé par le Président et établira un procès-verbal des sujets discutés lors de l'Assemblée. Le
procès-verbal sera confirmé lors de la même Assemblée ou lors de la prochaine Assemblée et sera signé par le Président
et le secrétaire de l'Assemblée, en foi de quoi.
6. Le Président ou la partie ayant convoqué l'Assemblée pourra décider d'établir un procès-verbal notarié des sujets
discutés lors de l'Assemblée. Le procès-verbal notarié sera également signé par le Président.
7. Le Conseil de gérance conservera toutes les décisions. Si le Conseil de gérance n'est pas représenté à l'Assemblée,
une copie des décisions prises en Assemblée des associés lui sera fournie par le Président. Ces décisions seront consignées
au siège social de la Société pour inspection par les associés. Chaque associé pourra s'il le demande obtenir une copie
ou un extrait des décisions consignées et ceci au prix coûtant.
8. Chaque associé aura le droit de participer à l'Assemblée générale ou de s'y faire représenter par une procuration
écrite, d'y prendre la parole et d'y exercer son droit de vote.
9. Chaque part sociale donne droit à un vote. Les votes en blanc ou les votes non valables seront réputés ne pas avoir
été émis.
10. Lors de l'Assemblée générale, aucun vote ne pourra être émis sur les parts sociales détenue par la Société ou par
une filiale de la Société.
11. Pour la détermination des votes, les parts sociales pour lesquelles la Loi prévoit qu'aucun vote ne pourra être
autorisé ne seront pas prises en compte.
12. L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée générale des associés. En cas de pluralité d'as-
sociés, chaque associé prend part aux décisions collectives, indépendamment du nombre de parts sociales qu'il détient.
Chaque associé a des droits de vote proportionnels à sa participation. Les décisions collectives ne sont valablement prises
que si elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
35293
13. Cependant, les décisions de modifier les statuts peuvent seulement être adoptées par la majorité des associés
détenant au moins trois-quart du capital social de la Société, conformément à la Loi.
14. Les gérants peuvent émettre un vote consultatif lors de l'Assemblée générale, si les associés le désirent.
Art. 21. Décisions prises en dehors des Assemblées.
1. Les décisions des associés peuvent également être adoptées par écrit, sans avoir recours à une Assemblée générale,
à condition qu'elles soient adoptées par un vote unanime des associés l'entièreté du capital souscrit. Dans ce cas, chaque
associé recevra un projet explicite de la décision à passer, et votera par écrit.
2. Le Conseil de gérance consignera les décisions ainsi adoptées. Chaque associé doit veiller dans les meilleurs délais
à informer le Conseil de gérance par écrit des décisions adoptées conformément au paragraphe 1. Les actes seront
déposés au siège de la Société pour être soumis au contrôle des associés. Chaque associé pourra demander une copie
ou un extrait de ces actes à prix coûtant.
Chapitre VI. Dissolution - Liquidation
Art. 22. Dissolution.
1. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite
de l'associé unique ou d'un des associés.
2. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou
non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. Le Conseil de gérance peut être désigné
pour procéder à la liquidation des activités de la Société.
3. Pendant la liquidation, les dispositions des statuts resteront applicables dans la mesure du possible.
4. Le solde subsistant après paiement des dettes sera transféré aux associés proportionnellement au montant cumulé
de leurs participations.
5. La liquidation sera régie par les dispositions de la Loi.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 23. Référence aux dispositions légales. Référence est faite aux dispositions de la Loi pour toutes les matières non
spécifiquement régies par les présents statuts.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. Poncin, C. Duro, K.Mastinu, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, vol. 155S, fol. 71, case 10. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ffi> . (signé): Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007001042/211/692.
(060132541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2006.
Abellio Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.168.625,00.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 114.372.
In the year two thousand and six, on the twenty-eighth of December.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Merch, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
ABELLIO LUXCO 1 S.àr.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its
registered office at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
trade and Companies Register under number B 114.175 (the «Sole Shareholder») in its capacity of Sole Shareholder of
ABELLIO LUXCO 2 S.à R.L., a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered office at 7, Val Ste Croix,
L-1371 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 114.372 (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notaiy on 29 December
2005, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations dated 9 May 2006, number 906, page 43481 and
35294
whose articles of association (the «Articles») have been amended by a deed of the undersigned notary on 15 February
2006, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations dated 20 June 2006 number 1197, page 57452.
hereby takes the following resolutions in accordance with the provisions of article 17 of the Articles and of article
200-2 of the Luxembourg consolidated law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.
The Sole Shareholder is here represented by Mr Van Hees, jurist, residing professionally at Mersch, by virtue of proxy
given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Resolutionsi>
<i>1. First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of EUR 3,143,600.- (three millions
one hundred forty-three thousand and six hundred Euros), in order to raise it from its current amount of EUR 25,025.-
(twenty-five thousand twenty-five Euros) to EUR 3,168,625.- (three millions one hundred sixty-eight thousand six hundred
twenty-five Euros) by creating and issuing 125,744 (one hundred twenty-five thousand seven hundred forty-four) new
shares each with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euros) (the «New Shares») plus the payment of a share premium
of EUR 12,574,400.- (twelve millions five hundred seventy-four thousand and four hundred Euros).
The Sole Shareholder acknowledges that the total share premium paid from the date of the incorporation of the
Company is in the amount of EUR 21,602,975.- (twenty-one million six hundred thousand nine hundred and seventy-five
Euros).
<i>Subscription and paymenti>
ABELLIO FEEDER LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership established in England whose principal place of
business is at 6th Floor, 33 Cavendish Square, London WIG 0PW, United Kingdom (acting by its general partner STAR
GENERAL PARTNER LIMITED)
here represented by Mr Patrick Van Hees, residing professionally in Mersch and declared to fully subscribe and pay in
the New Shares and the related share premium as follows:
Subscriber
Number
Nominal
Share
of Shares
Share Capital
Premium
(EUR)
(EUR)
ABELLIO FEEDER LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125,744
3,143,600.- 12,574,400.-
The New Shares and the share premium paid on it have been fully paid up by contribution in kind consisting in one
share with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) of the share capital of ABELLIO GmbH, a limited liability
company, organised under the laws of Germany, registered with the commercial register of the lower court of Essen
under registration number HRB 14707 and having its corporate domicile at Bredeneyer Strasse 2, 45133 Essen (ABELLIO
GmbH) (the «Contributed Share»).
As it appears from the valuation report presented to the notary, the management of the Company has evaluated such
contribution in kind for the payment of the New Shares and the related share premium at EUR 15,718,000.- (fifteen
million seven hundred and eighteen thousand Euros).
<i>Acknowledgment:i>
The Sole Shareholder declares to renounce to subscribe for new shares in the Company and to participate in the share
capital increase.
<i>Pro rata contribution tax payment exemption requesti>
Considering that prior to the capital increase the Company holds 100 % of the shares of ABELLIO GmbH, i.e. more
than 65% of all outstanding shares of ABELLIO GmbH, the Company hereby expressly requests the proportional capital
duty exemption pursuant to Article 4-2 of the Act dated 29 December 1971, as amended, which provide for a fixed
registration tax perception in such a case.
<i>2. Second resolutioni>
The Sole Shareholder further resolves to amend Article 5.1 of the Company's Articles which shall read as follows:
«The corporate capital is fixed at EUR 3,168,625.- (three millions one hundred sixty-eight thousand six hundred twenty-
five Euros) represented by 126,745 (one hundred twenty-six thousand seven hundred and forty-five) shares (the «Shares»)
of EUR 25.- (twenty-five Euros) each. The holders of the Shares are referred to as the «Shareholders».»
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately seven thousand euros.
35295
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille six, le vingt-huit décembre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Merch, Grand-Duché du Luxembourg,
Est apparent :
ABELLIO LUXCO 1, une société à responsabilité de droit luxembourgeois ayant son siège social au 7, Val de Ste Croix,
L-1371 Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 114.175 (l'«Associé Unique») en sa capacité d'Associé Unique de ABELLIO LUXCO 2 S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, Val de Ste Croix, L-1371 Lu-
xembourg, Grand-duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 114.372 (la «Société»), constituée selon un acte notarié du notaire instrumentant le 29 décembre 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 9 mai 2006, numéro 906, page 43481 et dont les
statuts (les «Statuts») ont été modifiés par un acte du notaire instrumentant le 15 février 2006, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations en date du 20 juin 2006, numéro 1197, page 57452.
Adopte les résolutions écrites suivantes conformément aux dispositions de l'article 17 des Statuts et de l'article 200-2
de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée.
L'Associé Unique est représenté à la présente assemblée par Mr Van Hees, juriste, domicilié professionnellement à
Mersch, en vertu de la procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être enregistée avec lui.
<i>1. Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 3.143.600,- EUR (trois millions
cent quarante-trois mille six cents euros), pour le monter de son montant actuel de 25.025,- EUR (vingt-cinq mille vingt-
cinq euros) à 3.168.625 (trois millions cent soixante-huit mille six cent vingt-cinq euros) par la création et l'émission de
125.744 (cent vingt-cinq mille sept cent quarante-quatre) parts sociales, chacune d'une valeur de 25,- EUR (vingt-cinq
euros) (les «Nouvelles Parts») plus une prime d'émission d'un montant de 12.574.400,- EUR (douze millions cinq cent
soixante-quatorze mille quatre cents euros).
L'Associé Unique prend acte que la prime d'émission totale payée depuis la constitution de la Société est d'un montant
de EUR 21.602.975,- (vingt et un millions six cent deux mille neuf cent soixante-quinze mille euros).
<i>Souscription et payementi>
ABELLIO FEEDER LIMITED PARTNERSHIP, une société limitée établie en Angleterre dont l'établissement principal
est au 6
ième
étage, 33 Cavendish Square, London WIG OPW, United Kingdom (agissant par son gérant STAR GENERAL
PARTNER LIMITED) ici représenté par Mr Patrick Van Hees, résidant professionnellement à Mersch et déclare souscrire
intégralement et payer les Nouvelles Parts et la prime d'émission y étant attachée, comme suit:
Souscripteur
Nombre
Capital Social
Prime
de Parts
Nominal d'Emmission
(EUR)
(EUR)
ABELLIO FEEDER LIMITED PARTNERSHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.744
3.143.600,- 12.574.400,-
Les Nouvelles Parts et la prime d'émission payée dessus ont été intégralement payées par contribution en nature
consistant en une part sociale d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) du capital social de ABELLIO GmbH, une
société à responsabilité limitée, organisée selon le droit allemand, immatriculé au Registre de la Cour Basse d'Essen sous
le numéro HRB 14707 et ayant son siège social à Bredeneyer Strasse 2, 45133 Essen (ABELLIO GmbH) (la («Part Ap-
portée»).
Tel qu'il apparaît dans le rapport d'évaluation présenté au notaire, la gérance de la Société a évalué cette contribution
en nature pour le payement des Nouvelles Parts et de la prime d'émission y relative à un montant de 15.718.000,- EUR
(quinze millions sept cent dix-huit mille euros).
<i>Reconnaissancei>
L'Associé Unique décide de renoncer à souscrire les Nouvelle Parts dans la société et à participer à l'augmentation de
capital social.
35296
<i>Demande d'exemption du paiement de droit d'apport proportionneli>
Considérant que suite à l'augmentation de capital la Société détient 100 % des parts sociales d'ABELLIO GmbH, soit
plus de 65% de toutes les parts d'ABELLIO GmbH, la Société demande expressément l'exemption de droit d'apport
proportionnel conformément à l'Article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit le paiement
d'un droit fixe dans un tel cas.
<i>Second résolutioni>
L'Associé Unique décide ensuite de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société ayant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 3.168.625,- EUR (trois millions cent soixante-huit mille six cent vingt-cinq euros) représenté
par 26.745 (vingt-six mille sept cent quarante-cinq) parts sociales (les «Parts Sociales») de 25,- EUR (vingt-cinq euros)
chacune. Les détenteurs des Parts Sociales sont appelés les «Associés».»
<i>Estimation des coûtsi>
Le montant des dépenses, des coûts, des rémunérations ou des frais, sous quelle forme que ce soit, qui incombent à
la Société en raison du présent acte sont estimés à approximativement sept mille euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, comprenant et parlant anglais, déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte
est rédigé en Anglais, suivi d'une version française, sur demande de la même comparant, et en cas de divergences entre
les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, le présent acte notarial a été préparé à Luxembourg, au jour mentionné au début de ce document.
Le document ayant été lu par la comparante, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et de résidence, ladite
comparante ainsi que le notaire ont signé le présent contrat.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 janvier 2007, vol. 440, fol. 70, case 1. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 15 février 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007034415/242/150.
(070030037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.
Global Mineral Resources S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 85.873.
DISSOLUTION
In the year two thousand and six, on the sixth day of July,
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
EUROPEAN GOLDFIELDS GREECE B.V., a private limited liability company incorporated and existing under the laws
of The Netherlands, with registered office at Atrium, Strawinskylaan 3105, P.O. Box 71744, 1077 ZX Amsterdam, The
Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 33.284.299 (EUROPEAN GOLD-
FIELDS GREECE),
here represented by Mrs Rachel Uhl, lawyer, with professional address at Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given under private seal.
Said proxy, having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
Such appearing party, through its representative, has requested the notary to state that:
- The appearing party is the sole shareholder of GLOBAL MINERAL RESOURCES S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
with registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 85.873, incorporated under the denomination BOULBOU INVESTMENTS S.à r.l. pursuant to
a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing at that time in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg), dated January
16, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
o
762 of May 18, 2002, the articles of
association of which have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated February
6, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
o
366 of April 2, 2004 (the Company).
35297
- The share capital of the Company is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into one
hundred twenty-five (125) shares, having a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each.
- EUROPEAN GOLDFIELDS GREECE has decided to dissolve the Company with immediate effect.
- EUROPEAN GOLDFIELDS GREECE assumes the role of liquidator of the Company.
- The appearing party as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the
known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that EUROPEAN GOLDFIELDS GREECE is
vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any)
of the Company, in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company
before any payment to itself.
- Consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed.
- It has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the financial situation of
the Company.
- It grants full discharge is granted to the managers of the Company for the exercise of their mandate.
- The books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five (5) years at the Company's
former registered office located at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us,
the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le six juillet,
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
EUROPEAN GOLDFIELDS GREECE B.V., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois
des Pays-Bas, avec son siège social à Atrium, Strawinskylaan 3105, P.O. Box 71744, 1077 ZX Amsterdam, les Pays-Bas,
immatriculée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 33.284.299 (EUROPEAN GOLDFIELDS
GREECE),
dûment représentée par Mme Rachel Uhl, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration émise sous seing privé.
Laquelle procuration après signature ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera
annexée au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
- la partie comparante est l'associé unique de GLOBAL MINERAL RESOURCES S.à r.l., une société à responsabilité
limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 12, rue Léon Thyes,
L-2636 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.873,
constituée sous la dénomination de BOULBOU INVESTMENTS S.à r.l. en vertu d'un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 16 janvier 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
o
762 du 18 mai 2002, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte du notaire soussigné en
date du 6 février 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 366 du 2 avril 2004 (la Société).
- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq
(125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune;
- EUROPEAN GOLDFIELDS GREECE a décidé de dissoudre la Société avec effet immédiat.
- EUROPEAN GOLDFIELDS GREECE assume le rôle de liquidateur de la Société.
- La partie comparante, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le
passif connu de la Société a été payé ou provisionné, que EUROPEAN GOLDFIELDS GREECE est investie de tout l'actif
et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la
Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne.
- Partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
- Elle a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de la Société.
- Elle accorde décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats.
- Les documents et pièces de la Société seront conservés à l'ancien siège social de la Société situé au 12, rue Léon
Thyes, L-2636 Luxembourg pour une période de cinq (5) ans.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
35298
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été
établi en anglais, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version
anglaise fera foi.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, vol. 154S, fol. 51, case 12. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007035217/211/93.
(070030977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Patron Weghell II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 124.572.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the second day of February.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in
replacement of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily
absent, the latter remaining depositary of the present minutes.
There appeared:
PATRON WEGHELL HOLDING Sarl, a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered
office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg
here represented by Mr Michael Vandeloise private employee, with professional address in L-1116 Luxembourg, 6,
rue Adolphe,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 2nd February 2007.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the
deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Company») which
shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles
of incorporation.
Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition,
development and exploitation of any immovable property located in European Union, as well as the acquisition of par-
ticipations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
these participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies. The Company
may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to
acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale,
transfer, exchange or otherwise.
The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise
create security over some or all its assets. The Company may also grant loans to subsidiaries, affiliated companies or third
parties. The Company may borrow in any form and in particular privately issue bonds.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of PATRON WEGHELL II S. à r. l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general
meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
35299
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.
Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, who need not necessarily be
shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of one sole member of the
board of management. The managers may be dismissed freely at any time.
The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among
its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of management.
In dealings with third parties, the board of management has the most extensive powers to act in the name of the
Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object.
The board of management shall meet upon call by the chairman, or one of its members, at the place indicated in the
notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of management, but in his absence, the board
of management may appoint another of its members as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of management must be given to its members twenty-four hours at least
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member of the
board of management in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A
special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of management.
Any member of the board of management may act at any meeting of the board of management by appointing in writing
or by cable, telegram, telex or facsimile another member of the board of management as his proxy. Any member of the
board of management may represent more than one of his colleagues.
Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of man-
agement is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority of
votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.
The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence,
by the vice-chairman, or by one member of the board of management. Copies or extracts of such minutes which may be
produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one member of the board of man-
agement.
Art. 15. The death or resignation of the sole manager or of a member of the board of management, for any reason
whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
35300
Art. 16. The sole manager or the members of the board of management do not assume, by reason of its/their position,
any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised agents
only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-
sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first day of December of each year and ends on the last day of
November of the following year.
Art. 21. Each year on the last day of November, the accounts are closed and the sole manager or the board of
management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.
The sole manager or the board of management is authorized to distribute interim dividends in case the funds available
for distribution are sufficient.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
All five hundred (500) shares are subscribed by PATRON WEGHELL HOLDING Sarl, aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 30th day of
November 2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred (1,900.-) euro.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder representing the entirety of the subscribed
capital of the Company has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as members of the board of management of the Company for an indefinite
period:
- Mrs Géraldine Schmit, director of company, born on 12th November 1969, in Messancy (Belgium), with professional
address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
- Mr Michael Vandeloise, private employee, born on 16th July 1982 in Messancy (Belgium), with professional address
at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
35301
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the proxyholder
of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of
the same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the German text, the English version
will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, the said proxyholder appearing
signed together with Us the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundsieben, den zweiten Februar.
Vor der unterzeichneten Notarin Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Remich, Großherzogtum Luxemburg, han-
delnd in Vertretung von Notar André Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, zur Zeit
abwesend, welch Letzterer Depositar der gegenwärtigen Urkunde bleibt.
Ist erschienen:
PATRON WEGHELL HOLDING Sarl eine Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
hier vertreten durch Herrn Michael Vandeloise Privateangestellte, mit berufsmäßiger Anschrift in L-1116 Luxembourg,
6, rue Adolphe,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxembourg, am 2. Februar 2007.
Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten der erschienenen Partei und den
unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die erschienene Partei, handelnd aufgrund obiger Ermächtigung, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit zu gründen beabsichtigt, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Es wird hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (société à responsabilité
limitée), (die «Gesellschaft») der sie die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.
Art. 2. Den Gegenstand der Gesellschaft bilden die Durchführung aller Transaktionen, die im direkten oder indirekten
Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Verwertung unbeweglicher Vermögenswerte in der Europä-
ischen Union stehen, sowie der Erwerb von Beteiligungen an Unternehmungen jeglicher Form und die Leitung, Bewirt-
schaftung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen, ohne in den Geltungsbereich des Gesetzes vom 31. Juli 1929
über reine Holdinggesellschaften zu fallen. Die Gesellschaft darf ihre Mittel für den Aufbau, die Bewirtschaftung, die
Entwicklung und die Veräußerung eines Portfolios von Wertpapieren und Patenten jeglichen Ursprungs, für den Erwerb
von Wertpapieren und Patenten durch Anlage, Zeichnung, Übernahme oder Option und für deren Verwertung im Wege
des Verkaufs, der Übertragung, des Austauschs oder in anderer Weise verwenden.
Die Gesellschaft darf außerdem Bürgschaften und Sicherheiten zu Gunsten Dritter leisten, um ihre Obligationen oder
die Obligationen von Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder jeglichen anderen Gesellschaften zu besi-
chern. Sie darf ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in anderer Weise als Sicherheit
verwenden. Die Gesellschaft darf darüber hinaus Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder Dritten Kre-
dite gewähren. Die Gesellschaft darf Kredite in jeglicher Form aufnehmen und insbesondere Anleihen privat platzieren.
Die Gesellschaft darf alle gewerblichen, industriellen, finanziellen, privaten und Immobilientransaktionen durchführen,
die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihre Entwicklung begünstigen können.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung PATRON WEGHELL II S. à r. l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt
werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, voraus-
gesetzt, daß die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils
müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.
35302
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt mit einer
Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
Art. 11. Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Ver-
mögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die Dauer
des Mandates fest.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung, dessen Mitglieder nicht
unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die
Unterschrift von einem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu jedem
Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.
Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an
eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.
Art. 13. Die Geschäftsführung wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit,
einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied der
Geschäftsführung sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.
Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Na-
men der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang
stehen.
Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-
schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung der Geschäftsführung; in seiner
Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung er-
nennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der
Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Te-
lefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes der Geschäfts-
führung, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich
für Sitzungen der Geschäftsführung, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen
Beschluß der Geschäftsführung festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich in der Sitzung der Geschäftsführung aufgrund einer schriftlich, durch
Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten
lassen. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehrere andere Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten
ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefaßt.
Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-
licher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als
Nachweis der Beschlußfassung gilt.
Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Aus-
züge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet.
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Mitgliedes der Geschäftsführung, aus welchem
Grund auch immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Der alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder der Geschäftsführung haften aufgrund der Ausübung ihrer
Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Er / Sie sind nur für die Ausübung
ihres Mandates verantwortlich.
35303
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Haupversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ange-
hören.
E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monat Dezember eines jeden Jahres und endet
am letzten Tag des Monats November des darauffolgenden Jahres.
Art. 21. Am 30. November eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder
die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Ge-
sellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ist berechtigt, Interimdividenden zu verteilen, soweit ausrei-
chende Mittel zur Verteilung verfügbar sind.
F. Gesellschaftsauflösung- Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt deren
Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der
Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital aufgeteilt.
Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig von der vorbenannten PATRON WEGHELL HOLDING Sarl ge-
zeichnet.
Die Gesamteinlage von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) besteht aus einer Kapitaleinlage von zwölftau-
sendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist nun für die Gesellschaft verfügbar, so wie es dem Notar bewiesen worden
ist.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. Tag des Monats November 2007.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorar und Auslagen werden auf eintausend-
neunhundert (1.900,-) Euro geschätzt.
<i>Hauptversammlungi>
Der Gesellschafter der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, hat unverzüglich nach der Gründung der
Gesellschaft die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Der Gesellschaftssitz befindet sich 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder der Geschäftsführung ernannt. Die Mitglieder der Geschäftsführung
sind auf unbestimmte Zeit ernannt:
- Frau Géraldine Schmit, Gesellschaftsverwalterin, geboren in Messancy (Belgien) am 12. November 1969, berufsmäßig
wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
- Herrn Michael Vandeloise, Privatbeamter, geboren in Messancy (Belgien), am 16. Juli 1982, berufsmäßig wohnhaft in
6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
35304
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Bevollmächtigten der
vorgenannten Partei, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache.
Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei hat derselbe mit
Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Signé: M. Vandeloise, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, vol. 31CS, fol. 95, case 9. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2007.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007034463/230/321.
(070029988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.
Patron Weghell I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 124.582.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the second day of February.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in
replacement of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily
absent, the latter remaining depositary of the present minutes.
There appeared:
PATRON WEGHELL HOLDING Sarl, a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered
office at 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg
here represented by Mr Michael Vandeloise private employee, with professional address in L-1116 Luxembourg, 6,
rue Adolphe,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 2
nd
February 2007.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the
deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Company») which
shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles
of incorporation.
Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition,
development and exploitation of any immovable property located in European Union, as well as the acquisition of par-
ticipations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
these participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies. The Company
may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to
acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale,
transfer, exchange or otherwise.
The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise
create security over some or all its assets. The Company may also grant loans to subsidiaries, affiliated companies or third
parties. The Company may borrow in any form and in particular privately issue bonds.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of PATRON WEGHELL I S. à r. l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general
meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
35305
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.
Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, who need not necessarily be
shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of one sole member of the
board of management. The managers may be dismissed freely at any time.
The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among
its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of management.
In dealings with third parties, the board of management has the most extensive powers to act in the name of the
Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object.
The board of management shall meet upon call by the chairman, or one of its members, at the place indicated in the
notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of management, but in his absence, the board
of management may appoint another of its members as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of management must be given to its members twenty-four hours at least
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member of the
board of management in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A
special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of management.
Any member of the board of management may act at any meeting of the board of management by appointing in writing
or by cable, telegram, telex or facsimile another member of the board of management as his proxy. Any member of the
board of management may represent more than one of his colleagues.
Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of man-
agement is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority of
votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.
The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence,
by the vice-chairman, or by one member of the board of management. Copies or extracts of such minutes which may be
produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one member of the board of man-
agement.
Art. 15. The death or resignation of the sole manager or of a member of the board of management, for any reason
whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
35306
Art. 16. The sole manager or the members of the board of management do not assume, by reason of its/their position,
any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised agents
only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the Sole Shareholder - Collective Decisions of the Shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-
sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first day of December of each year and ends on the last day of
November of the following year.
Art. 21. Each year on the last day of November, the accounts are closed and the sole manager or the board of
management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.
The sole manager or the board of management is authorized to distribute interim dividends in case the funds available
for distribution are sufficient.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
All five hundred (500) shares are subscribed by PATRON WEGHELL HOLDING Sarl, aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 30
th
day of
November 2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred (1,900.-) euro.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder representing the entirety of the subscribed
capital of the Company has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as members of the board of management of the Company for an indefinite
period:
- Mrs Géraldine Schmit, director of company, born on 12th November 1969, in Messancy (Belgium), with professional
address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
- Mr Michael Vandeloise, private employee, born on 16
th
July 1982 in Messancy (Belgium), with professional address
at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
35307
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the proxyholder
of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of
the same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the German text, the English version
will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, the said proxyholder appearing
signed together with Us the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundsieben, den zweiten Februar.
Vor der unterzeichneten Notarin Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Remich, Großherzogtum Luxemburg, han-
delnd in Vertretung von Notar André Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, zur Zeit
abwesend, welch Letzterer Depositar der gegenwärtigen Urkunde bleibt.
Ist erschienen:
PATRON WEGHELL HOLDING Sarl eine Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg
hier vertreten durch Herrn Michael Vandeloise Privateangestellte, mit berufsmäßiger Anschrift in L-1116 Luxembourg,
6, rue Adolphe,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxembourg, am 2. Februar 2007.
Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten der erschienenen Partei und den
unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die erschienene Partei, handelnd aufgrund obiger Ermächtigung, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit zu gründen beabsichtigt, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Es wird hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (société à responsabilité
limitée), (die «Gesellschaft») der sie die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.
Art. 2. Den Gegenstand der Gesellschaft bilden die Durchführung aller Transaktionen, die im direkten oder indirekten
Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Verwertung unbeweglicher Vermögenswerte in der Europä-
ischen Union stehen, sowie der Erwerb von Beteiligungen an Unternehmungen jeglicher Form und die Leitung, Bewirt-
schaftung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen, ohne in den Geltungsbereich des Gesetzes vom 31. Juli 1929
über reine Holdinggesellschaften zu fallen. Die Gesellschaft darf ihre Mittel für den Aufbau, die Bewirtschaftung, die
Entwicklung und die Veräußerung eines Portfolios von Wertpapieren und Patenten jeglichen Ursprungs, für den Erwerb
von Wertpapieren und Patenten durch Anlage, Zeichnung, Übernahme oder Option und für deren Verwertung im Wege
des Verkaufs, der Übertragung, des Austauschs oder in anderer Weise verwenden.
Die Gesellschaft darf außerdem Bürgschaften und Sicherheiten zu Gunsten Dritter leisten, um ihre Obligationen oder
die Obligationen von Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder jeglichen anderen Gesellschaften zu besi-
chern. Sie darf ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in anderer Weise als Sicherheit
verwenden. Die Gesellschaft darf darüber hinaus Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder Dritten Kre-
dite gewähren. Die Gesellschaft darf Kredite in jeglicher Form aufnehmen und insbesondere Anleihen privat platzieren.
Die Gesellschaft darf alle gewerblichen, industriellen, finanziellen, privaten und Immobilientransaktionen durchführen,
die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihre Entwicklung begünstigen können.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung PATRON WEGHELL I S. à r. l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt
werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, voraus-
gesetzt, daß die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils
müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.
35308
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt mit einer
Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
Art. 11. Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Ver-
mögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die Dauer
des Mandates fest.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung, dessen Mitglieder nicht
unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die
Unterschrift von einem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu jedem
Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.
Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an
eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.
Art. 13. Die Geschäftsführung wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit,
einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied der
Geschäftsführung sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.
Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Na-
men der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang
stehen.
Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-
schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung der Geschäftsführung; in seiner
Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung er-
nennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der
Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Te-
lefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes der Geschäfts-
führung, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich
für Sitzungen der Geschäftsführung, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen
Beschluß der Geschäftsführung festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich in der Sitzung der Geschäftsführung aufgrund einer schriftlich, durch
Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten
lassen. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehrere andere Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten
ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefaßt.
Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-
licher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefaßt werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als
Nachweis der Beschlußfassung gilt.
Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Aus-
züge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet.
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Mitgliedes der Geschäftsführung, aus welchem
Grund auch immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Der alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder der Geschäftsführung haften aufgrund der Ausübung ihrer
Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Er / Sie sind nur für die Ausübung
ihres Mandates verantwortlich.
35309
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Haupversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ange-
hören.
E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monat Dezember eines jeden Jahres und endet
am letzten Tag des Monats November des darauffolgenden Jahres.
Art. 21. Am 30. November eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder
die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Ge-
sellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ist berechtigt, Interimdividenden zu verteilen, soweit ausrei-
chende Mittel zur Verteilung verfügbar sind.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt deren
Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der
Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital aufgeteilt.
Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig von der vorbenannten PATRON WEGHELL HOLDING Sarl ge-
zeichnet.
Die Gesamteinlage von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) besteht aus einer Kapitaleinlage von zwölftau-
sendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist nun für die Gesellschaft verfügbar, so wie es dem Notar bewiesen worden
ist.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. Tag des Monats November 2007.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorar und Auslagen werden auf eintausend-
neunhundert (1.900,-) Euro geschätzt.
<i>Hauptversammlungi>
Der Gesellschafter der das gesamte gezeichnete Gesellschafts-kapital vertritt, hat unverzüglich nach der Gründung der
Gesellschaft die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Der Gesellschaftssitz befindet sich 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder der Geschäftsführung ernannt. Die Mitglieder der Geschäftsführung
sind auf unbestimmte Zeit ernannt:
- Frau Géraldine Schmit, Gesellschaftsverwalterin, geboren in Messancy (Belgien) am 12. November 1969, berufsmäßig
wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
- Herrn Michael Vandeloise, Privatbeamter, geboren in Messancy (Belgien), am 16. Juli 1982, berufsmäßig wohnhaft in
6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
35310
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Bevollmächtigten der
vorgenannten Partei, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache.
Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei hat derselbe mit
Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Signé: M. Vandeloise, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, vol. 31CS, fol. 95, case 8. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2007.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007034465/230/321.
(070030032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.
ITGroup S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 40.862.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 juillet 1992, acte publié au
Mémorial C n
o
522 du 12 novembre 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 février 1994, acte
publié au Mémorial C n
o
218 du 3 juin 1994, mise en liquidation par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence
à Junglinster en date du 30 décembre 2005, acte publié au Mémorial C n
o
849 du 28 avril 2006.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour IT GROUP S.A.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007034760/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05948. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Fralimo Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 67.828.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007035404/4286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06693. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Sophaur S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 38.849.
Constituée par-devant M
e
Camille Hellinckx, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1991,
acte publié au Mémorial C n
o
212 du 20 mai 1992. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé le 31
juillet 2000; l'avis afférent a été publié au Mémorial C n
o
306 du 26 avril 2001.
Le bilan au 31 mars 2006 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
35311
<i>Pour SOPHAUR S.A
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007034697/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05642. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Panlogistic S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 87.068.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 10 avril 2002, acte publié au
Mémorial C n
o
1045 du 9 juillet 2002.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PANLOGISTIC S.A.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007034762/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05945. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Euring S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 68.121.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2007.
<i>Pour EURING S.A.
i>V. Dohogne / C. Schweitzer
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007034764/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05937. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Serfin Gestion S.A. (Services Financiers et de Gestion S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 61.931.
Constituée en date du 5 novembre 1997 par-devant M
e
Schroeder, notaire alors de résidence à Mersch, acte publié
au Mémorial C n
o
145 du 9 mars 1998.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
35312
<i>Pour SERFIN GESTION S.A.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007034766/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05954. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Baupart A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 88.062.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 janvier 2007, que l'Assemblée a pris, entre
autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Salvatore Desiderio en qualité d'Administrateur de la société,
en remplacement de Monsieur Sergio Vandi, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date
du 8 août 2006. L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Salvatore Desiderio en qualité d'Administrateur de la
société. Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale de
ce jour.
Le mandat des administrateurs expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de nommer, pour un terme de - 4 -
(quatre) ans:
- Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité d'Admi-
nistrateur et Président du Conseil d'Administration.
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg et Monsieur Davide
Murari, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité d'Administrateur.
Le mandat ainsi conféré aux administrateurs et au Président du Conseil d'Administration prendra fin lors de l'Assemblée
Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.
Le mandat du Commissaire expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de renommer, pour un terme de - 1 -
(un) an, FIDUCIAIRE MEVEA Sàrl, 45, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg, en tant que Commissaire.
Le mandat ainsi conféré au Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice
clôturé au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2007.
<i>Le conseil d'administration
i>J.-P. Fiorucci / S. Desiderio
Référence de publication: 2007035001/43/33.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05536. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Finance et Développement, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 73.425.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 8 décembre 1999, acte publié
au Mémorial C n
o
179 du 29 février 2000.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
35313
<i>Pour FINANCE ET DEVELOPPEMENT
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007034769/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05943. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Adviser II Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 116.177.
Hiermit teilen wir mit, dass mit Wirkung zum 17. Januar 2007 Herr
Andreas Raschdorf, geschäftsansässig in Deutschland, D-81241 München, Landsberger Strass 428
das Verwaltungsratsmandat der Gesellschaft niedergelegt hat.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Memorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für ADVISER II FUNDS
i>GESCHÄFTSFÜHRUNG AXXION SA
R. Mertes
Référence de publication: 2007034812/6633/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06497. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Robin One S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 87.315.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. Februar 2007i>
Die außerordentliche Hauptversammlung der ROBIN ONE S.A. hat mit Wirkung zum 8. Februar 2007 folgende Bes-
chlüsse gefasst:
1. In Abweichung von Artikel 6 der Statuten wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift
von jedem einzelnen Verwaltungsratsmitglied vertreten.
Zwecks Eintragung und Veröffentlichung im Amtsblatt (Memorial C), Recueil des Sociétés et Associations.
Leudelange, den 12. Februar 2007.
<i>Für den Verwaltungsrat
i>U. Holbach / H. Gottschalk
Référence de publication: 2007034815/680/18.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06476. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Rosalia HealthCare AG, Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 112.112.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Januar 2007i>
Die außerordentliche Hauptversammlung der ROSALIA HealthCare AG hat mit Wirkung zum 31. Januar 2007 folgende
Beschlüsse gefasst:
1. Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes mit sofortiger Wirkung
Herr Volker Wentz, Diplom-Kaufmann, geschäftsansässig in L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval,
2. Neubestellung eines Mitgliedes des Verwaltungsrates mit sofortiger Wirkung
Frau Heike Gottschalk, Diplom-Betriebswirtin, geschäftsansässig in L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval, wurde zum
Verwaltungsratsmitglied bestellt. Das Mandat erlischt automatisch mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2010.
35314
3. Die Zeichnungberechtigung bleibt unberührt, so dass für alle Mitglieder folgende Berechtigung gilt:
In Abweichung von Artikel 10 der Statuten wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift
von jedem einzelnen Verwaltungsratsmitglied vertreten.
Zwecks Eintragung und Veröffentlichung im Amtsblatt (Memorial, Recueil des Sociétés et Associations).
Leudelange, den 31. Januar 2007.
<i>Für den Verwaltungsrat
i>U. Holbach / J. Ting
Référence de publication: 2007034813/680/24.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06474. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
British Vita (Lux III) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.470.480,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 107.582.
Par résolution signée en date du 25 janvier 2007, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Madame Bénédicte Herlinvaux, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, de son poste de gérant de classe B avec effet immédiat.
- Nomination de Monsieur Antony Bonmariage, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg, en tant que gérant de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007034873/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB06085. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Pronutri S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 122.634.
<i>Extrait de la résolution adoptée par l'associé unique de la Société le 20 février 2007i>
Il résulte de la résolution de l'associé unique du 20 février 2007 que l'associé unique a accepté la démission de M.
Philippe Robert, en tant que gérant de la Société, avec effet immédiat.
Il en résulte qu'à compter du 20 février 2007, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- Séverine Michel
- Paul Guilbert
- Philip Muelder
S. Michel
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2007035347/3794/19.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB06014. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
35315
British Vita (Lux IV) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 318.692,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 107.581.
Par résolution signée en date du 25 janvier 2007, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Madame Bénédicte Herlinvaux, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, de son poste de gérant de classe B avec effet immédiat.
- Nomination de Monsieur Antony Bonmariage, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg, en tant que gérant de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007034874/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB06084. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
British Vita (Lux V) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 108.614.
Par résolution signée en date du 25 janvier 2007, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Madame Bénédicte Herlinvaux, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, de son poste de gérant de classe B avec effet immédiat.
- Nomination de Monsieur Antony Bonmariage, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg, en tant que gérant de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007034875/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB06082. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Unirack Western Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 43.634.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 février 2007i>
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Sébastien Schaack, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT Sàrl, ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX KONZERN Sàrl, ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège
social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes
de l'exercice 2006.
Luxembourg, le 12 février 2007.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007034878/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04185. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
35316
United Utilities (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 161.554.225,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 116.044.
En date du 22 mars 2006, UNITED UTILITIES INVESTMENTS (N.3) LIMITED a cédé la totalité de ses 6.461.669 parts
sociales à la société UNITED UTILITIES PLC.
Dès lors, UNITED UTILITIES PLC devient l'associé unique et détient la totalité des 6.462.169 part sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007034876/581/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB06080. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Eye 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 111.138.
Lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 26 mai 2006, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Alistair Peel, avec adresse au 73, Woburn Avenue, CM16 7JR Essex,
Royaume-Uni, en tant qu'administrateur de classe A avec effet immédiat.
De plus, les administrateurs suivants ont été renouvelés avec effet immédiat et pour une période venant à échéance
lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes se terminant au 31 décembre 2006 et qui aura lieu
en 2007:
<i>Administrateurs de catégorie A:i>
- Monsieur Cyril Zivre
- Monsieur Cyrille Chevrillon
- Monsieur Nils Stoesser
- Monsieur Frank Przygodda
<i>Administrateurs de catégorie B:i>
- Monsieur Benoît Bazire
- Monsieur Richard Ivimey-Cook
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007034877/581/25.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2007, réf. LSO-CB03564. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Qualtec S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 114.143.
Le bilan établi au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
35317
<i>Pour QUALTEC SARL
i>FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature
Référence de publication: 2007035436/4906/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06215. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Icaro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 91.863.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007i>
Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel
administrateur:
- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement
au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Catherine Guffanti, comptable, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au
207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-
naire statutaire qui procédera aux élections définitives.
Pour extrait sincère et conforme
ICARO S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007034972/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02790. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Immobilière Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 77.305.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007i>
Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel
administrateur:
- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement
au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France) demeurant professionnellement
au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-
naire statutaire qui procédera aux élections définitives.
Pour extrait sincère et conforme
IMMOBILIERE LUX S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007034975/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02783. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
35318
Klammer Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 115.319.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007i>
Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel
administrateur:
- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement
au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France) demeurant professionnellement
au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-
naire statutaire qui procédera aux élections définitives.
Pour extrait sincère et conforme
KLAMMER INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007034977/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02752. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Keens Equity Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 82.744.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007i>
Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel
administrateur:
- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement
au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Jean Lambert,
- Mme Catherine Guffanti, comptable, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au
207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-
naire statutaire qui procédera aux élections définitives.
Pour extrait sincère et conforme
KEENS EQUITY INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007034979/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02748. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Eastern Telecom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 89.617.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
35319
Luxembourg, le 2 mars 2007.
FIDUCIAIRE DI FINO & ASSOCIES S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007035515/4507/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06686. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Diangle Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 106.472.
<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 23 février 2007i>
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée rappelle les décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'était tenue extraordinairement
en date du 5 septembre 2005 et confirme la nomination de Madame Géraldine Schmit au poste d'administrateur de
catégorie B.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de transférer le siège social du Commissaire aux Comptes, à savoir WOOD, APPLETON, OLIVER
EXPERTS COMPTABLES, du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg
et ce avec effet au 24 avril 2006.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007034982/587/22.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05488. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Atlantic International Assets S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 72.958.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1
er
décembre 2005 que:
- Le siège social a été transféré du 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg au 38, avenue de la Faïencerie L-1510
Luxembourg.
Luxembourg, le 16 février 2007.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007035023/5878/16.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04642. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6738 Grevenmacher, 15, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 50.469.
Les comptes annuels établis au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
35320
<i>Pour la société
EC HANDELSAGENTUR-EURO-CUISINES SA
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
Référence de publication: 2007035391/745/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05672. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Positronia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 88.779.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 29 décembre 2006, que l'Assemblée a pris, entre
autres, les résolutions suivantes:
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Salvatore Desiderio en qualité d'Administrateur et Président
du Conseil d'administration de la société, en remplacement de Monsieur Sergio Vandi démissionnaire, cooptation décidée
par le Conseil d'Administration en date du 8 août 2006. L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Salvatore Desiderio
en qualité d'Administrateur et Président du Conseil d'administration de la société. Le mandat ainsi conféré, à l'instar du
mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale de ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
Le mandat des administrateurs expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de nommer:
Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et
Président du Conseil d'Administration;
Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
Davide Murari, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat ainsi conféré aux administrateurs et au Président du Conseil d'Administration prendra fin lors de l'Assemblée
Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.
Le mandat du Commissaire expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Vincent
Thill et de nommer, pour un terme de - 1 - (un) an, FIDUCIAIRE MEVEA Sàrl, 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg
en tant que Commissaire.
Le mandat ainsi conféré au Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice
clôturé au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2007.
<i>Le Conseil d'administration
i>J.-P. Fiorucci / S. Desiderio
Référence de publication: 2007035000/43/34.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05009. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Ferrero Trading Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 46.117.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 10 janvier 2007 que l'Assemblée décide
à l'unanimité:
* d'élire Monsieur Bruno Ferroni, demeurant en Italie, Via del Lago, Arenano, I-16011 comme administrateur de la
société;
* d'élire Monsieur Nunzio Pulvirenti, demeurant à I-10129 Torino, Corso Stati Uniti 41, comme administrateur de la
société;
* de reconduire les mandats des administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes annuels de
2007 ou à l'élection d'un successeur.
35321
- Giuseppe Marano: administrateur-délégué;
- Arduino Borgogno: administrateur-délégué;
- Fillippo Ferrua: administrateur;
* de confirmer la nomination de Monsieur Guiseppe Marano en tant qu'administrateur-délégué et responsable de la
«Commercial Division».
* de confirmer la nomination de Monsieur Arduino Borgogno en tant qu'administrateur-délégué et responsable de la
«Procurement Division».
Le Conseil se compose dorénavant comme suit:
- Giuseppe Marano: administrateur-délégué, et responsable de la «Commercial Division»;
- Arduino Borgogno: administrateur-délégué, et responsable de la «Procurement Division»;
- Fillippo Ferrua: administrateur;
- Bruno Ferroni: administrateur;
- Nunzio Pulvirenti: administrateur.
* de reconduire le mandat de Commissaire aux Comptes de la société DELOITTE S.A. ayant son siège social à L-2220
Luxembourg, 560, rue de Neudorf, jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes annuels de 2007.
Luxembourg, le 15 février 2007.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007035009/304/37.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04847. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Temporary Venture Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 61.701.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007035442/637/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06782. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Suisse Alpine Energie Nouvelle S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 106.842.
Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 29 janvier 2007, que le
Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Eric Giacometti (Annexe
1.) de sa fonction d'administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec
effet immédiat, Monsieur Stefano De Meo, employé privé, demeurant à 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en
remplacement de Monsieur Eric Giacometti, démissionnaire. L'administrateur coopté termine le mandat de son prédé-
cesseur qui expirera à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2006.
En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomi-
nation définitive.
<i>Deuxième résolutioni>
Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité de voix, de transférer le siège social de la société du 9, rue Goethe,
L-1637 Luxembourg au 5, rue CM. Spoo, L-2546 Luxembourg, avec effet au 29 janvier 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
35322
Luxembourg, le 19 février 2007.
Le Conseil d'Administration
J.-P. Fiorucci / S. De Meo
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007035033/43/27.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05021. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6738 Grevenmacher, 15, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 50.469.
Les comptes annuels établis au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
<i>Pour la société EC HANDELSAGENTUR-EURO-CUISINES SA
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
Référence de publication: 2007035369/745/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05678. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6738 Grevenmacher, 15, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 50.469.
Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
<i>Pour la société EC HANDELSAGENTUR - EURO-CUISINES SA
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
Référence de publication: 2007035395/745/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05668. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Deutsche Bank (PWM) Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 97.749.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 26 janvier 2007i>
L'Assemblée Générale Ordinaire:
- Prend note de la démission de Monsieur John Alexander en tant qu'Administrateur en date du 5 décembre 2006.
- Décide le renouvellement, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui
se tiendra en 2008, du mandat des administrateurs suivants:
- Monsieur Mark Smallwood
- Monsieur Martyn Surguy
- Monsieur Stefan Molter
- Décide le renouvellement, pour une nouvelle période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2008, du mandat du Réviseur d'Entreprises, KPMG AUDIT.
35323
A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Mark Smallwood
- Monsieur Martyn Surguy
- Monsieur Stefan Molter
<i>Réviseur d'Entreprises:i>
KPMG AUDIT, ayant son siège social à L - 2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
Luxembourg, le 22 février 2007.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
T. Loechner-Ernst / F. Nilles
<i>Mandataire Commerciali> / <i>Sous-Directeur Principali>
Référence de publication: 2007035015/1183/30.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06407. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Aérologic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach, 50, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 103.846.
Les comptes annuels établis au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
<i>Pour la société AEROLOGIC SARL
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
Référence de publication: 2007035366/745/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05647. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6738 Grevenmacher, 15, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 50.469.
Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
<i>Pour la société EC HANDELSAGENTUR - EURO -CUISINES S.A.
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
Référence de publication: 2007035401/745/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05664. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
LuxiPrivilège Conseil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 46.389.
Affectation du résultat de l'exercice par l'assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2007 a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
35324
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>LuxiPrivilège CONSEIL S.A.
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>M. Bus / C. Defendi
Référence de publication: 2007035450/24/16.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2007, réf. LSO-CB00260. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
D.M. Trans Road S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3333 Hellange, 8, rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 124.637.
STATUTS
L'an deux mille sept, le seize février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Duarte Manuel Marques Paula, chauffeur, né à Cacia/Aveiro (Portugal) le 19 juin 1968, demeurant à L-3333
Hellange, 8, rue de Bettembourg.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée qu'il déclare constituer:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que
par les présents statuts.
Art. 2. La Société prend la dénomination de D.M. TRANS ROAD S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet le transport routier, les services de transport de marchandises pour le compte propre
ou pour le compte d'autrui, la location de véhicules pour le transport routier de marchandises, commissionnaire de
transport et commissionnaire en douane.
Elle a pour objet également le transport de personnes tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou
civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.
Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Hellange, Commune de Frisange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Commune par simple décision du gérant, qui aura tous pouvoirs
d'adapter le présent article.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)
parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Duarte Manuel Marques Paula prénommé.
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.
35325
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des
descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Titre IV.- Dissolution - liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ mille deux cents Euros (1.200,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqué,
s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-3333 Hellange, Commune de Frisange, 8, rue de Bettembourg.
2.- L'assemblée désigne comme gérant de la Société:
Madame Adriana Totaro, employée privée, née à Luxembourg le 21 novembre 1968, demeurant à L-3333 Hellange,
8, rue de Bettembourg.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant. Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D.M. Marques Paula, G. Lecuit.
35326
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, vol. 32CS, fol. 11, case 11. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007035144/220/100.
(070030894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Cera Chem S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6684 Mertert, 1A, rue du Parc.
R.C.S. Luxembourg B 83.756.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
<i>Pour CERA CHEM S. à r. l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature
Référence de publication: 2007035451/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05828. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
ABN AMRO Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 47.072.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 18 décembre 2006i>
1. Acceptation de la démission de M. Richard Goddard avec adresse professionnelle au 46, avenue JF Kennedy, L-1855
Luxembourg, avec effet au 18 décembre 2006.
2. Co-optation en son remplacement de M. Wayne Dove avec adresse professionnelle au 99-197 De Entree NL-1101
HE, Amsterdam, aux fonctions d'administrateur, avec effet au 18 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Conseil d'Administration
i>S. Leinkauf-Schiltz
Référence de publication: 2007034588/44/17.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06262. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070029761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.
Bertelsmann Digital Media Investments S.A., Société Anonyme,
(anc. Oniva Music).
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 10.088.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007035406/1005/13.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06687. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
35327
Temporary Venture Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 61.701.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007035439/637/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06779. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
ARHS developments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 92.986.
Le bilan et l'annexe au 31 juillet 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2007.
<i>Pour ARHS DEVELOPMENTS S.A.
i>P. Noël / J. Serderidis
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007035453/565/16.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06947. - Reçu 42 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Christa Intershipping S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 62.982.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007035444/637/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06786. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Eastern Telecom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 89.617.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2007.
FIDUCIAIRE DI FINO & ASSOCIES S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007035519/4507/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06688. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
35328
Abellio Luxco 2 S.à r.l.
ABN AMRO Funds
Adviser II Funds
Aérologic S.à r.l.
ARHS developments S.A.
Atlantic International Assets S.A.
Baupart A.G.
Bertelsmann Digital Media Investments S.A.
British Vita (Lux III) S.à r.l.
British Vita (Lux IV) S.à r.l.
British Vita (Lux V) S.à r.l.
Cera Chem S. à r. l.
Christa Intershipping S.à.r.l.
Deutsche Bank (PWM) Sicav
Diangle Holding S.A.
D.M. Trans Road S.à r.l.
Eastern Telecom S.A.
Eastern Telecom S.A.
E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A.
E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A.
E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A.
E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A.
Euring S.A.
Eye 2 S.A.
Ferrero Trading Lux S.A.
Finance et Développement
Fralimo Holding S.A.
Global Mineral Resources S.à r.l.
Icaro S.A.
Immobilière Lux S.A.
ITGroup S.A.
Izarus Investment B.V. S.à r.l.
Keens Equity Investments S.A.
Klammer Investments S.A.
LuxiPrivilège Conseil S.A.
Oniva Music
Panlogistic S.A.
Patron Weghell II S.à r.l.
Patron Weghell I S.à r.l.
Positronia S.A.
Pronutri S.à r.l.
Qualtec S.à.r.l.
Robin One S.A.
Rosalia HealthCare AG
Serfin Gestion S.A. (Services Financiers et de Gestion S.A.)
Sophaur S.A.
Suisse Alpine Energie Nouvelle S.A.
Temporary Venture Holding S.A.
Temporary Venture Holding S.A.
Unirack Western Group S.A.
United Utilities (Luxembourg) S.à.r.l.