logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 721

26 avril 2007

SOMMAIRE

Aclee S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34594

Actum S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34607

Aerium Sinsheim S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

34582

agraferm technologies luxembourg s.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34600

Amon Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34599

Apioil International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

34581

Artemis Fine Arts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34599

Athem Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

34593

Belux Bois S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34587

Blairnet S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34587

Bloomed Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

34580

Ciyow International S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

34579

Copagest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34600

Dematic Holding S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

34579

Dux S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34590

Dux S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34608

Ermitage Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

34589

Euro Media 2000 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34586

Fidecs Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34600

For You 2, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34591

For You 2, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34594

Franklin Templeton International Services

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34588

Galilehorn Asset Management S.à r.l.  . . . .

34563

General Consult S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34588

G.N. Research S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34578

Grizelle S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34578

GS Construction S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34600

HB Maritime S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34585

Hema S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34608

Holding de l'Est  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34608

IAM Strategic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34594

Ici Paris XL (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . .

34591

Immobilière Calista S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

34587

International Product Company S.A.  . . . .

34583

Interprom S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34607

Italfondiario Investments S.à r.l.  . . . . . . . . .

34591

Laax Investments Ltd.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34589

Luxluce S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34584

Marmont International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

34593

Milai Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34586

Musical Instruments Luxembourg S.A.  . . .

34599

Nicky International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

34592

Norstar Property S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34585

Patron Weghell IX S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . .

34572

Patron Weghell VIII S. à r. l.  . . . . . . . . . . . .

34601

Patron Weghell X S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . .

34565

Pontoon Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34581

Prisma Energy Global Investments S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34589

Prisma Energy Luxembourg S.à r.l.  . . . . . .

34588

Private Holdings of Investments Luxem-

bourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34592

Scandinavian Bullet S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

34581

Silverhope Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

34584

SIX Consulting & Engineering S.A  . . . . . . .

34562

Société Européenne de Participations et

Investissements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34585

Société Lonigo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34590

Société pour l'Aménagement de la Place

de l'Etoile à Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

34571

TK II Colnvest S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34580

Valhamar S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34584

Varolux Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . .

34592

Voyages Arosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34586

Vue du Golfe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34607

WCC Plauen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34563

Zama (Windhoek) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

34590

34561

SIX Consulting & Engineering S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 6, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 111.113.

L'an deux mille six, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIX CONSULTING & ENGINEERING

S.A., avec siège social au 23A, Grand'rue, L-8372 Hobscheid, immatriculée au registre de commerce et des sociétés section
B numéro 111.113 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 octobre 2005 publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 9 février 2006 numéro 295.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur André Godinas, ingénieur civil, demeurant au 9, rue des

Grands Champs, B-4181 Hamoir,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Colaux, dessinateur, demeurant à B-5575 Patignies, 11, rue de l'Ecole.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Elise Jeanbaptiste, dessinatrice, demeurant à B-5575 Vencimont, 10A,

rue du Presbytère.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social au 6, rue d'Arlon à L-8399 Windhof
2. Modification subséquente de l'article 2 première phrase des statuts.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent (100%) du capital social, est régulièrement constituée et

peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée  décide  de  transférer  le  siège  social  du  23A,  Grand'rue,  L-8372  Hobscheid  au  6,  rue  d'Arlon,  L-8399

Windhof (Koerich).

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l'article 2 première phrase des statuts de la Société est modifié et aura la teneur

suivante:

« Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Koerich.»
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de huit cent cinquante euros (€ 850,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: A. Godinas, P. Colaux, E. Jeanbaptiste, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, vol. 157S, fol. 70, case 5. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

34562

Senningerberg, le 26 février 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007034505/202/55.
(070029618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

WCC Plauen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.790.300,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 121.377.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 29 janvier 2007, l'associé unique a pris les décisions

suivantes:

- Acceptation de la démission de Monsieur Pierre Gervasi, avec adresse au 10, rue Cimarosa, F-75116 Paris, France,

de son poste de gérant de classe B avec effet au 30 janvier 2007.

- Nomination de Monsieur Derek Mc Donald, avec adresse au 8, Glen Sannox Grove, Craigmarloch, Cumbernauld,

G68 0GH, Royaume-Uni, en tant que gérant de classe B avec effet au 30 janvier 2007 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007034149/581/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05708. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Galilehorn Asset Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 86A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 111.049.

In the year two thousand and seven, on the sixth day of February.
Before us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- Mr Ely Michel Ruimy, General Director of LEONARD DE VINCI GROUP, born in Casablanca, Morocco, on De-

cember 31, 1964, residing professionally at 121, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, France, here represented by
Mrs Sylvie Lexa, private employee, residing professionally in Senningerberg, by virtue of a proxy given under private seal;
and

- AERIUM HOLDINGS S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 96.764, here represented
by Mrs Sylvie Lexa, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

The proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their capacities as shareholders, (the «Shareholders») of GALILEHORN ASSET MAN-

AGEMENT S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 111.049, incorporated under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, on September 21, 2005, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 153 of January 23, 2006 (the «Company»). The articles of

incorporation have been amended by deed of the undersigned notary on 1st day of February 2007, not yet published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The  Shareholders,  representing  the  entire  share  capital  of  the  Company,  have  requested  the  notary  to  state  the

following resolutions:

<i>Resolutions

The Shareholders decide to transfer the registered office of the Company from 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717

Luxembourg to 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg and to amend article 5 of the articles of incorporation as
follows:

« Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven. It may be transferred

to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad».

34563

The other articles of the articles of incorporation of the Company will remain unchanged.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall borne by the Company as a result

of the modification of its articles of incorporation are estimated at nine thousand Euro (EUR 900.-).

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

parties represented as stated above, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of
the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be
prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le six février.
Par-devant Maître Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- M. Ely Michel Ruimy, Président-Directeur-Général du GROUPE LEONARD DE VINCI, né à Casablanca, Maroc, le

31 décembre 1964, demeurant professionnellement au 121, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, France, ici repré-
senté  par  Madame  Sylvie  Lexa,  employée  privée,  demeurant  professionnellement  à  Senningerberg,  en  vertu  d'une
procuration sous seing privé lui délivrée; et

- AERIUM HOLDINGS S.A., une société anonyme, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, et immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.764, ici représentée par Madame Sylvie Lexa, précitée,
en vertu d'une procuration sous sein privé lui délivrée.

Les procurations, signées ne varietur par la mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées

au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité d'associés, (les «Associés») de GALILEHORN ASSET MANAGEMENT

S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 111.049, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant un acte du
notaire instrumentant en date du 21 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

153 du 23 janvier 2006 (la «Société»). Les statuts de la société ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date
du 1 

er

 février 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

Les Associés, représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont requis le notaire instrumentant de constater

les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

Les Associés décident de transférer le siège social de la Société de L-1717 Luxembourg, rue, 8-10, Mathias Hardt au

6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg et de modifier en conséquence l'article 5 des statuts comme suit:

« Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven. Il peut être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou suc-
cursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays».

Les autres articles des statuts de la Société demeurent inchangés.

<i>Dépenses

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de

la Société en raison de la modification de ses statuts est estimé environ à neuf cents euros (EUR 900,-).

Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants représentés comme

dit ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants
et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Lexa, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007,vol. 31CS, fol. 90, case 5. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

34564

Senningerberg, le 27 février 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007034507/202/92.
(070030115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Patron Weghell X S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 124.579.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the second day of February.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in

replacement of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily
absent, the latter remaining depositary of the present minutes.

There appeared:

PATRON WEGHELL HOLDING Sàrl, a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered

office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

here represented by Mr. Michael Vandeloise private employee, with professional address in L-1116 Luxembourg, 6,

rue Adolphe,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 2nd February 2007.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Company») which
shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles
of incorporation.

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition,

development and exploitation of any immovable property located in European Union, as well as the acquisition of par-
ticipations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
these participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies. The Company
may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to
acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale,
transfer, exchange or otherwise.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise
create security over some or all its assets. The Company may also grant loans to subsidiaries, affiliated companies or third
parties. The Company may borrow in any form and in particular privately issue bonds.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of PATRON WEGHELL X S. à r. l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general

meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

34565

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, who need not necessarily be

shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of one sole member of the
board of management. The managers may be dismissed freely at any time.

The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among

its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of management.

In dealings with third parties, the board of management has the most extensive powers to act in the name of the

Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object.

The board of management shall meet upon call by the chairman, or one of its members, at the place indicated in the

notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of management, but in his absence, the board
of management may appoint another of its members as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of management must be given to its members twenty-four hours at least

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member of the
board of management in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A
special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of management.

Any member of the board of management may act at any meeting of the board of management by appointing in writing

or by cable, telegram, telex or facsimile another member of the board of management as his proxy. Any member of the
board of management may represent more than one of his colleagues.

Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-

call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of man-
agement is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority of
votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.

The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence,

by the vice-chairman, or by one member of the board of management. Copies or extracts of such minutes which may be
produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one member of the board of man-
agement.

Art. 15. The death or resignation of the sole manager or of a member of the board of management, for any reason

whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 16. The sole manager or the members of the board of management do not assume, by reason of its/their position,

any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised agents
only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

34566

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first day of December of each year and ends on the last day of

November of the following year.

Art. 21. Each year on the last day of November, the accounts are closed and the sole manager or the board of

management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.

The sole manager or the board of management is authorized to distribute interim dividends in case the funds available

for distribution are sufficient.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

All five hundred (500) shares are subscribed by PATRON WEGHELL HOLDING Sàrl, aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 30th day of

November 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred (1,900.-) euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder representing the entirety of the subscribed

capital of the Company has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as members of the board of management of the Company for an indefinite

period:

- Mrs. Géraldine Schmit, director of company, born on 12th November 1969, in Messancy (Belgium), with professional

address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;

- Mr. Michael Vandeloise, private employee, born on 16th July 1982 in Messancy (Belgium), with professional address

at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the proxyholder

of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of
the same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the German text, the English version
will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, the said proxyholder appearing

signed together with Us the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundsieben, den zweiten Februar.
Vor der unterzeichneten Notarin Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Remich, Großherzogtum Luxemburg, han-

delnd in Vertretung von Notar André Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, zurzeit
abwesend, welch Letzterer Depositar der gegenwärtigen Urkunde bleibt.

34567

Ist erschienen:

PATRON WEGHELL HOLDING Sàrl eine Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
hier vertreten durch Herrn Michael Vandeloise Privateangestellte, mit berufsmäßiger Anschrift in L-1116 Luxembourg,

6, rue Adolphe,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxembourg, am 2. Februar 2007.
Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten der erschienenen Partei und den

unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd aufgrund obiger Ermächtigung, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit zu gründen beabsichtigt, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Es wird hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft Ge-

sellschafter  werden,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (société  à  responsabilité
limitée), (die «Gesellschaft») der sie die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.

Art. 2. Den Gegenstand der Gesellschaft bilden die Durchführung aller Transaktionen, die im direkten oder indirekten

Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Verwertung unbeweglicher Vermögenswerte in der Europä-
ischen Union stehen, sowie der Erwerb von Beteiligungen an Unternehmungen jeglicher Form und die Leitung, Bewirt-
schaftung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen, ohne in den Geltungsbereich des Gesetzes vom 31. Juli 1929
über  reine  Holdinggesellschaften  zu  fallen.  Die  Gesellschaft  darf  ihre  Mittel  für  den  Aufbau,  die  Bewirtschaftung,  die
Entwicklung und die Veräußerung eines Portfolios von Wertpapieren und Patenten jeglichen Ursprungs, für den Erwerb
von Wertpapieren und Patenten durch Anlage, Zeichnung, Übernahme oder Option und für deren Verwertung im Wege
des Verkaufs, der Übertragung, des Austauschs oder in anderer Weise verwenden.

Die Gesellschaft darf außerdem Bürgschaften und Sicherheiten zu Gunsten Dritter leisten, um ihre Obligationen oder

die Obligationen von Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder jeglichen anderen Gesellschaften zu besi-
chern. Sie darf ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in anderer Weise als Sicherheit
verwenden. Die Gesellschaft darf darüber hinaus Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder Dritten Kre-
dite gewähren. Die Gesellschaft darf Kredite in jeglicher Form aufnehmen und insbesondere Anleihen privat platzieren.

Die Gesellschaft darf alle gewerblichen, industriellen, finanziellen, privaten und Immobilientransaktionen durchführen,

die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihre Entwicklung begünstigen können.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung PATRON WEGHELL X S. à r. l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt

werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, voraus-

gesetzt, dass die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils

müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt mit einer
Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Ver-

mögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die Dauer

des Mandates fest.

34568

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung, dessen Mitglieder nicht

unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die
Unterschrift von einem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu jedem
Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an

eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.

Art. 13. Die Geschäftsführung wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit,

einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied der
Geschäftsführung sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.

Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Na-

men der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang
stehen.

Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung der Geschäftsführung; in seiner
Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung er-
nennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der

Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Te-
lefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes der Geschäfts-
führung, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich
für Sitzungen der Geschäftsführung, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen
Beschluß der Geschäftsführung festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich in der Sitzung der Geschäftsführung aufgrund einer schriftlich, durch

Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten
lassen. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehrere andere Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten
ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-

licher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als
Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Aus-
züge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Mitgliedes der Geschäftsführung, aus welchem

Grund auch immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Der alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder der Geschäftsführung haften aufgrund der Ausübung ihrer

Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Er/ Sie sind nur für die Ausübung
ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Haupversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese we-

nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ange-
hören.

34569

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres und endet

am letzten Tag des Monats November des darauffolgenden Jahres.

Art. 21. Am 30. November eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder

die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Ge-

sellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ist berechtigt, Interimdividenden zu verteilen, soweit ausrei-

chende Mittel zur Verteilung verfügbar sind.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt deren
Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der

Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital aufgeteilt.

Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig von der vorbenannten PATRON WEGHELL HOLDING Sàrl ge-

zeichnet.

Die Gesamteinlage von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) besteht aus einer Kapitaleinlage von zwölftau-

sendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist nun für die Gesellschaft verfügbar, so wie es dem Notar bewiesen worden
ist.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. Tag des Monats November 2007.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorar und Auslagen werden auf eintausend-

neunhundert (1.900,-) Euro geschätzt.

<i>Hauptversammlung

Der Gesellschafter der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, hat unverzüglich nach der Gründung der

Gesellschaft die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder der Geschäftsführung ernannt. Die Mitglieder der Geschäftsführung

sind auf unbestimmte Zeit ernannt:

- Frau Géraldine Schmit, Gesellschaftsverwalterin, geboren in Messancy (Belgien) am 12. November 1969, berufsmäßig

wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

- Herrn Michael Vandeloise, Privatbeamter, geboren in Messancy (Belgien), am 16. Juli 1982, berufsmäßig wohnhaft in

6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Bevollmächtigten der

vorgenannten Partei, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache.
Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei hat derselbe mit

Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: M. Vandeloise, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, vol. 31CS, fol. 96, case 5. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

34570

Luxembourg, le 20 février 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007034226/230/321.
(070030024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

SAPEL S.à r.l., Société pour l'Aménagement de la Place de l'Etoile à Luxembourg, Société à responsabilité

limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 67.017.

L'an deux mille sept, le neuf février.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur- Alzette.

A comparu:

- La société NEWCOOP S.A. avec siège social à L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau, inscrite au registre du commerce

et des sociétés sous le numéro B 69.280, ici représentée par son unique administrateur: Monsieur John C. Jones, admi-
nistrateur de société, demeurant à UK, 1 Courtenay Lodge, Courtenay Terrace, Hove, BN3 2WF.

Laquelle comparante déclare qu'elle est l'unique associée de la société à responsabilité limitée SOCIETE POUR L'AME-

NAGEMENT  DE  LA  PLACE  DE  L'ETOILE  A  LUXEMBOURG,  en  abrégé  SAPEL  S.àr.l,  avec  siège  social  à  L-1637
Luxembourg, 30, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Capellen,
en date du 30 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 33, en date du
21 janvier 1999, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 avril 1999,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 470 en date du 21 juin 1999.

Ceci exposé, l'associée représentant l'intégralité du capital social, a déclaré vouloir se considérer comme dûment

convoquée en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont elle reconnaît avoir eu connaissance
parfaite dès avant ce jour, a pris les résolutions suivantes sur l'ordre du jour suivant:

1.- Elargissement de l'objet social de la société et modification afférente de l'article deux des statuts.
2.- Fixation de l'adresse du siège social.
3.- Acceptation de la démission du gérant unique et décharge à donner au gérant pour l'exécution de ses fonctions.
4.- Nomination d'un nouveau gérant unique.
5.- Engagement de la société vis-à-vis des tiers.

<i>Première résolution

L'associée unique décide d'élargir l'objet social de la société et de modifier par conséquent l'article deux des statuts

qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet la construction, la promotion, la vente et la gérance d'un complexe d'habitation et de

commerce formant l'ensemble du plan d'Aménagement Particulier de la place de l'Etoile à Luxembourg.

En outre la société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et indivisible vis-à-vis de tierces personnes.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, immobilières ou

financières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation.
Elle peut s'intéresser en outre par n'importe quelle voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
analogue, similaire ou connexe.

<i>Deuxième résolution

L'associée unique décide de fixer l'adresse du siège social à L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

<i>Troisième résolution

L'associée unique décide d'accepter à compter de ce jour la démission du gérant unique, savoir: Monsieur Willy Hein,

indépendant, demeurant à Luxembourg et lui accorde décharge pour l'accomplissement de son mandat.

<i>Quatrième résolution

L'associée unique décide de nommer à compter de ce jour, pour une durée indéterminée dans la fonction de gérant

unique:

- Monsieur John C. Jones, prédit.

<i>Cinquième résolution

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués

approximativement à mille cent euro (1.100,- EURO).

34571

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la présente assemblée à été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes à 9h10.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.C. Jones, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 février 2007. EAC/2007/863. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de Publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 février 2007.

A. Biel.

Référence de publication: 2007034421/203/64.
(070029978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Patron Weghell IX S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 124.578.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the second day of February.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in

replacement of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily
absent, the latter remaining depositary of the present minutes.

There appeared:

PATRON WEGHELL HOLDING Sarl, a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered

office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

here represented by Mr. Michael Vandeloise private employee, with professional address in L-1116 Luxembourg, 6,

rue Adolphe,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 2nd February 2007.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Company») which
shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles
of incorporation.

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition,

development and exploitation of any immovable property located in European Union, as well as the acquisition of par-
ticipations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
these participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies. The Company
may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to
acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale,
transfer, exchange or otherwise.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise
create security over some or all its assets. The Company may also grant loans to subsidiaries, affiliated companies or third
parties. The Company may borrow in any form and in particular privately issue bonds.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of PATRON WEGHELL IX S. à r. l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.

34572

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general

meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, who need not necessarily be

shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of one sole member of the
board of management. The managers may be dismissed freely at any time.

The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among

its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of management.

In dealings with third parties, the board of management has the most extensive powers to act in the name of the

Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object.

The board of management shall meet upon call by the chairman, or one of its members, at the place indicated in the

notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of management, but in his absence, the board
of management may appoint another of its members as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of management must be given to its members twenty-four hours at least

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member of the
board of management in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A
special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of management.

Any member of the board of management may act at any meeting of the board of management by appointing in writing

or by cable, telegram, telex or facsimile another member of the board of management as his proxy. Any member of the
board of management may represent more than one of his colleagues.

Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-

call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of man-
agement is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority of
votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.

The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence,

by the vice-chairman, or by one member of the board of management. Copies or extracts of such minutes which may be
produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one member of the board of man-
agement.

Art. 15. The death or resignation of the sole manager or of a member of the board of management, for any reason

whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

34573

Art. 16. The sole manager or the members of the board of management do not assume, by reason of its/their position,

any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised agents
only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first day of December of each year and ends on the last day of

November of the following year.

Art. 21. Each year on the last day of November, the accounts are closed and the sole manager or the board of

management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.

The sole manager or the board of management is authorized to distribute interim dividends in case the funds available

for distribution are sufficient.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

All five hundred (500) shares are subscribed by PATRON WEGHELL HOLDING Sàrl, aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 30th day of

November 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred (1,900.-) euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder representing the entirety of the subscribed

capital of the Company has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as members of the board of management of the Company for an indefinite

period:

- Mrs. Géraldine Schmit, director of company, born on 12th November 1969, in Messancy (Belgium), with professional

address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;

- Mr. Michael Vandeloise, private employee, born on 16th July 1982 in Messancy (Belgium), with professional address

at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

34574

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the proxyholder

of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of
the same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the German text, the English version
will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, the said proxyholder appearing

signed together with Us the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundsieben, den zweiten Februar.
Vor der unterzeichneten Notarin Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Remich, Großherzogtum Luxemburg, han-

delnd in Vertretung von Notar André Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, zur Zeit
abwesend, welch Letzterer Depositar der gegenwärtigen Urkunde bleibt.

ist erschienen:

PATRON WEGHELL HOLDING Sarl eine Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
hier vertreten durch Herrn Michael Vandeloise Privateangestellte, mit berufsmäßiger Anschrift in L-1116 Luxembourg,

6, rue Adolphe,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxembourg, am 2. Februar 2007.
Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten der erschienenen Partei und den

unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd aufgrund obiger Ermächtigung, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit zu gründen beabsichtigt, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Es wird hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft Ge-

sellschafter  werden,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (société  à  responsabilité
limitée), (die «Gesellschaft») der sie die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.

Art. 2. Den Gegenstand der Gesellschaft bilden die Durchführung aller Transaktionen, die im direkten oder indirekten

Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Verwertung unbeweglicher Vermögenswerte in der Europä-
ischen Union stehen, sowie der Erwerb von Beteiligungen an Unternehmungen jeglicher Form und die Leitung, Bewirt-
schaftung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen, ohne in den Geltungsbereich des Gesetzes vom 31. Juli 1929
über  reine  Holdinggesellschaften  zu  fallen.  Die  Gesellschaft  darf  ihre  Mittel  für  den  Aufbau,  die  Bewirtschaftung,  die
Entwicklung und die Veräußerung eines Portfolios von Wertpapieren und Patenten jeglichen Ursprungs, für den Erwerb
von Wertpapieren und Patenten durch Anlage, Zeichnung, Übernahme oder Option und für deren Verwertung im Wege
des Verkaufs, der Übertragung, des Austauschs oder in anderer Weise verwenden.

Die Gesellschaft darf außerdem Bürgschaften und Sicherheiten zu Gunsten Dritter leisten, um ihre Obligationen oder

die Obligationen von Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder jeglichen anderen Gesellschaften zu besi-
chern. Sie darf ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in anderer Weise als Sicherheit
verwenden. Die Gesellschaft darf darüber hinaus Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder Dritten Kre-
dite gewähren. Die Gesellschaft darf Kredite in jeglicher Form aufnehmen und insbesondere Anleihen privat platzieren.

Die Gesellschaft darf alle gewerblichen, industriellen, finanziellen, privaten und Immobilientransaktionen durchführen,

die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihre Entwicklung begünstigen können.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung PATRON WEGHELL IX S. à r. l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt

werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter geändert werden, voraus-

gesetzt, dass die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils

müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.

34575

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt mit einer
Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Ver-

mögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die Dauer

des Mandates fest.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung, dessen Mitglieder nicht

unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die
Unterschrift von einem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu jedem
Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an

eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.

Art. 13. Die Geschäftsführung wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit,

einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied der
Geschäftsführung sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.

Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Na-

men der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang
stehen.

Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung der Geschäftsführung; in seiner
Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung er-
nennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der

Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Te-
lefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes der Geschäfts-
führung, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich
für Sitzungen der Geschäftsführung, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen
Beschluß der Geschäftsführung festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich in der Sitzung der Geschäftsführung aufgrund einer schriftlich, durch

Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten
lassen. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehrere andere Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten
ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-

licher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als
Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Aus-
züge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Mitgliedes der Geschäftsführung, aus welchem

Grund auch immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Der alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder der Geschäftsführung haften aufgrund der Ausübung ihrer

Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Er/ Sie sind nur für die Ausübung
ihres Mandates verantwortlich.

34576

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Haupversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese we-

nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ange-
hören.

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monat Dezember eines jeden Jahres und endet

am letzten Tag des Monats November des darauffolgenden Jahres.

Art. 21. Am 30. November eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder

die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Ge-

sellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ist berechtigt, Interimdividenden zu verteilen, soweit ausrei-

chende Mittel zur Verteilung verfügbar sind.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt deren
Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der

Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital aufgeteilt.

Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig von der vorbenannten PATRON WEGHELL HOLDING Sàrl ge-

zeichnet.

Die Gesamteinlage von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) besteht aus einer Kapitaleinlage von zwölftau-

sendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist nun für die Gesellschaft verfügbar, so wie es dem Notar bewiesen worden
ist.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. Tag des Monats November 2007.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorar und Auslagen werden auf eintausend-

neunhundert (1.900,-) Euro geschätzt.

<i>Hauptversammlung

Der Gesellschafter der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, hat unverzüglich nach der Gründung der

Gesellschaft die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder der Geschäftsführung ernannt. Die Mitglieder der Geschäftsführung

sind auf unbestimmte Zeit ernannt:

- Frau Géraldine Schmit, Gesellschaftsverwalterin, geboren in Messancy (Belgien) am 12. November 1969, berufsmäßig

wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

- Herrn Michael Vandeloise, Privatbeamter, geboren in Messancy (Belgien), am 16. Juli 1982, berufsmäßig wohnhaft in

6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

34577

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Bevollmächtigten der

vorgenannten Partei, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache.
Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei hat derselbe mit

Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: M. Vandeloise, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, vol. 31CS, fol. 96, case 4. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007034227/230/321.
(070030022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

G.N. Research S.A., Société Anonyme,

(anc. Grizelle S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.822.

L'an deux mille sept, le cinq février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRIZELLE S.A., avec siège social au 47,

boulevard Royal, L 2449 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés section B numéro 114.822
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 février 2006, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 1056 du 31 mai 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Ana Dias, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Stéphane Hépineuze, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Ana Dias, précitée.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'exercice social en cours de la Société ayant commencé le premier octobre 2006 en le prolongeant

exceptionnellement jusqu'au 31 décembre 2007, les exercices sociaux de la Société suivants commenceront dorénavant
le 1 

er

 janvier et finiront le 31 décembre;

2. Modification subséquente de l'article 14 des statuts;
3. Modification de la dénomination sociale en G.N. RESEARCH S.A.;
4. Modification subséquente de l'article 1 

er

 des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent (100%) du capital social, est régulièrement constituée et

peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de prolonger exceptionnellement l'exercice social de la Société ayant commencé le 1 

er

 octobre

2006 afin qu'il se clôture le 31 décembre 2007. Les exercices sociaux suivants commenceront le 1 

er

 janvier et se ter-

mineront le 31 décembre de chaque année.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l'article 14 des statuts de la Société est modifié et aura la teneur suivante:
« Art. 14. L'année sociale de la société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.»

34578

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la Société en G.N. RESEARCH S.A.

<i>Quatrième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l'article 1 

er

 des statuts de la Société est modifié et aura la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de G.N. RESEARCH S.A. (la «Société»)».

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (€ 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: A. Dias, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, vol. 31CS, fol. 87, case 4. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 26 février 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007034563/202/64.
(070030058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Dematic Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 112.618.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique/des associés prises en date du 16 février 2007

1) Le siège social a été transféré de L-1855 Luxembourg 46a, avenue John F Kennedy à L-2340 Luxembourg 6, rue

Philippe II.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DEMATIC HOLDING S.à.r.l
C. Cahuzac

Référence de publication: 2007034241/1649/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05475. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Ciyow International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5975 Itzig, 24, Cité Bernard Simminger.

R.C.S. Luxembourg B 81.045.

L'an deux mille sept, le deux février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Suleymaan Cabdulle Ciyow, commerçant, demeurant à L-5975 Itzig, 24, Cité Bernard Simminger.
Lequel comparant déclare être seul et unique associé de la société à responsabilité limitée CIYOW INTERNATIONAL,

S.à r.l. ayant son siège social à L-5326 Contern, Z.A.E. Weiergewan, 5b, rue de l'Etang.

Constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 février 2001, publié au Mémorial C numéro

874 du 12 octobre 2001, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la section B numéro 81.045.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 décembre

2003, publié au Mémorial C du 26 janvier 2004, numéro 99.

34579

L'associé a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé décide de transférer le siège social de la société de L-5326 Contern, Z.A.E. Weiergewan, 5b, rue de l'Etang

à L-5975 Itzig, 24, Cité Bernard Simminger, et en conséquence modifie l'article 3 des statuts comme suit:

« Art. 3. Le siège social est établi à Itzig. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg

de l'accord des associés.»

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide l'exploitation de l'activité commerciale de la société sous l'enseigne commerciale AYA.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 2 des statuts sera désormais rédigé comme suit:
« Art. 2. La société prend la dénomination de CIYOW INTERNATIONAL, S.à r.l.
L'exploitation de l'activité commerciale se fait sous l'enseigne AYA.»

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (900,- EUR).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure,

le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. C. Ciyow, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, vol. 31CS, fol. 86, case 8. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 26 février 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007034569/202/40.
(070029959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Bloomed Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 117.112.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique/des associés prises en date du 16 février 2007

1) Le siège social a été transféré de L-1855 Luxembourg 46a, avenue John F Kennedy à L-2340 Luxembourg 6, rue

Philippe II.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BLOOMED HOLDCO S.à.r.l
C. Cahuzac

Référence de publication: 2007034242/1649/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05477. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

TK II Colnvest S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 117.553.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique/des associés prises en date du 16 février 2007

1) Le siège social a été transféré de L-1855 Luxembourg 46a, avenue John F Kennedy à L-2340 Luxembourg 6, rue

Philippe II.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

34580

<i>Pour TK II CoInvest S.à.r.l
C. Cahuzac

Référence de publication: 2007034243/1649/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05493. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Apioil International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 85.632.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 19 février 2007

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour

la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006/2007 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

MM. Sergio Bertasi, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Umberto Scarimboli, employé privé, demeurant à Rome (Italie), vice-président;
Claudio Capizzi, employé privé, demeurant à Rome (Italie), administrateur;
Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A. 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007034280/24/25.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05818. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Pontoon Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 117.246.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique/des associés prises en date du 16 février 2007

1) Le siège social a été transféré de L-1855 Luxembourg 46a, avenue John F Kennedy à L-2340 Luxembourg 6, rue

Philippe II.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PONTOON S.à.r.l
C. Cahuzac

Référence de publication: 2007034244/1649/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05495. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Scandinavian Bullet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 122.235.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique/des associés prises en date du 16 février 2007

1) Le siège social a été transféré de L-1855 Luxembourg 46a, avenue John F Kennedy à L-2340 Luxembourg 6, rue

Philippe II.

34581

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SCANDINAVIAN BULLET S.à.r.l
C. Cahuzac

Référence de publication: 2007034245/1649/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05497. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Aerium Sinsheim S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 113.361.

In the year two thousand and seven, on the thirtieth day of January.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

LDV OPPORTUNITY I PROPERTIES, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 117.987, here represented by Mrs
Sylvie Lexa, companies director, residing professionally in Senningerberg, by virtue of a profil, given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the attorney in fact of the appearing person and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, declaring to act in its capacity as sole shareholder (the «Sole

Shareholder») of AERIUM SINSHEIM, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having
its registered office at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies  Register  under  number  B  113.361  (the  «Company»),  incorporated  under  the  laws  of  the  Grand  Duchy  of
Luxembourg by deed of the undersigned notary dated on the 6th day of January 2006, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 685 of 4th day of April 2006, has required the undersigned notary to state
its resolutions as follows:

<i>Resolutions

The sole partner decides to transfer the registered office of the company from L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de

la Foire to 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg and to amend the first sentence of article 5 of the articles of
incorporation as follows:

« Art. 5. first sentence. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven».

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall borne by the Company as a result

of the modification of its articles of incorporation are estimated at one thousand euro (EUR 1,000.-).

<i>Declaration

The appearing party, represented as stated hereabove declares that the registered office of the Company is transferred

with effect as of 1st January 2007.

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person represented as stated hereabove and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the attorney of the person appearing known to the notary by her name, first name,

civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le trente janvier,
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

LDV OPPORTUNITY I PROPERTIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée au
registre de commerce et des sociétés section B numéro 117.987, ici représentée par Madame Sylvie Lexa, administrateur
de sociétés, demeurant professionnellement à Senningerberg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

34582

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclarant agir en sa qualité d'associé unique (l'«Associé Unique»)

de AERIUM SINSHEIM, S.à r.l, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au L-1528 Luxembourg, 5,
boulevard de la Foire, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.361
(la «Société»), constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire instrumentant en date
du 6 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 685 en date du 4 avril 2006, a
requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire au

6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 5 des statuts
comme suit:

« Art. 5. première phrase. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ mille euros ( EUR
1.000,-).

<i>Déclaration

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare donner effet rétroactif au premier janvier 2007 audit

transfert du siège social.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante représentée

comme dit ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même
partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par

nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Lexa, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, vol. 157S, fol. 71, case 6. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 26 février 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007034499/202/80.
(070029969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

International Product Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 146A, route de Stavelot.

R.C.S. Luxembourg B 93.215.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 1 

<i>er

<i> février 2007

Transfert du siège social de la société de Maison 50 L-9990 Weiswampach à Résidence Wampich appartement 105,

route de Stavelot 146A L-9991 Weiswampach

Fixation de l'adresse du siège social à Résidence Wampich appartement 105, route de Stavelot 146A L-9991 Weis-

wampach

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2007034247/1197/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00822. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

34583

Valhamar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 107.677.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 15 décembre 2006 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 560 A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au 85-91, route de

Thionville, L-2611 Luxembourg, en date du 1 

er

 janvier 2007.

Luxembourg, le 15 février 2007.

Pour extrait conforme
Signatures

Référence de publication: 2007034248/802/17.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05870. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070030082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Luxluce S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 37.761.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires réunie en date du 21 décembre 2006 au siège social de la société

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, l'Assemblée décide d'appeler aux fonctions d'Administrateurs:
- Monsieur Carlo Reding, réviseur d'entreprises, demeurant à 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg.
- Monsieur Romain Bontemps, expert-comptable, demeurant à 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg.
- Monsieur Ronald Weber, expert-comptable, demeurant à 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'an 2007.
Le mandat du Commissaire, étant venu à échéance l'Assemblée décide d'appeler à la fonction de Commissaire:
PFK ABAX AUDIT S.A.R.L sis 6, Place de Nancy L-2212 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'an 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
PKF WEBER &amp; BONTEMPS S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007034266/592/22.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB06081. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Silverhope Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 116.937.

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu le 30 mai 2006 entre SILVERHOPE HOLDING SA (la société) et CITCO (LU-

XEMBOURG) S.A. a été résilié avec effet immédiat.

Fait à Luxembourg, le 18 janvier 2007.

CITCO (LUXEMBOURG) SA
Signatures

Référence de publication: 2007034249/710/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05278. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

34584

Norstar Property S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 114.061.

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu le 30 mai 2006 entre NORSTAR PROPERTY SA (la société) et CITCO (LUXEM-

BOURG) S.A. a été résilié avec effet immédiat.

Fait à Luxembourg, le 18 janvier 2007.

CITCO (LUXEMBOURG) SA
Signatures

Référence de publication: 2007034250/710/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05265. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070029941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

HB Maritime S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 78.578.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 16 février 2007 que:
- Les mandats des membres du Conseil d'Administration cités ci-après étant arrivés à terme sont reconduits jusqu'à

l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2011:

- La société anonyme MARE-LUX S.A., établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la

Pétrusse, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 62.985;

- Madame Andrea Maria Wessels, née le 8 octobre 1963 à Hambourg (Allemagne), demeurant à CH-8044 Zurich,

Schneckenmannstrasse 25;

- Monsieur Hubertus Hans Bahlsen, né le 13 août 1959 en Allemagne, demeurant à CH-8044 Zurich, Schnecken-

mannstrasse 25.

- Le mandat de commissaire aux comptes cité ci-après étant arrivé à terme est reconduit jusqu'à l'assemblée générale

ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2011:

- Monsieur André Harpes, né le 17 mars 1960 à Luxembourg, demeurant à L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la

Pétrusse.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007034276/1285/27.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05579. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

SEPINVEST S.A., Société Européenne de Participations et Investissements, Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 37.082.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 26 janvier 2007 que:
- Le siège social de la société est transféré de son ancienne adresse au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association.

Luxembourg, le 13 février 2007.

34585

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007034252/6312/16.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, réf. LSO-CB04027. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Euro Media 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 64.832.

<i>Extrait de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 janvier 2007

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 28, boulevard Joseph II L-1840 Lu-

xembourg

Luxembourg, le 17 janvier 2007.

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2007034253/657/16.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07275. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070029567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Voyages Arosa, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 43, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 48.331.

Les associés de la société à responsabilité limitée VOYAGES AROSA RC B N 

o

 48.331 - 43, rue du Brill - L-4041 Esch-

sur-Alzette ont tenu une assemblée générale extraordinaire:

<i>Ordre du jour:

- décès du gérant technique
- nomination d'un nouveau gérant technique

<i>Première résolution

Décès de Madame De Jesus Carvalho Da Silva Rosa demeurant 15, rue des Bois, L-3910 Mondercange
Mademoiselle Silva Da rosa Jessica - étudiante - demeurant 15, rue des Bois,L-3910 Mondercange est nommée gérante

unique de la société VOYAGES AROSA S.à r.l. en remplacement de Madame De Jesus Carvalho Da Silva Rosa à compter
du 12 février 2007.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16.00 heures.

Le 20 février 2007.

J. Silva Da Rosa / M. J. De Oliveira Da Rosa
<i>Associé 1 / Associé 2

Référence de publication: 2007034599/2468/23.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB06095. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Milai Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 107.534.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 15 février 2007

1) Jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2010, la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l.,

R.C.S. Luxembourg B n 

o

 58.545, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a

été nommée Commissaire aux Comptes, en remplacement de la société à responsabilité limitée INTERAUDIT S.à r.l.,
démissionnaire.

34586

2) Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1 

er

 , à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 16 février 2007.

Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour MILAI FINANCE S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007034231/29/21.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04492. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Immobilière Calista S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 87.929.

<i>Extrait de la délibération du Conseil d'Administration en date du 12 février 2007

Le Conseil d'Administration de la société IMMOBILIERE CALISTA SA décide de transférer le siège social à l'adresse

suivante:

47, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg
Cette décision prend effet dès aujourd'hui.

M. Blankenberg
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2007034235/1969/16.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06199. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Belux Bois S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8820 Holtz, 9, rue des Bois.

R.C.S. Luxembourg B 104.374.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire relative aux comptes annuels de 2005,

<i>assemblée tenue de manière extraordinaire en date du 31 octobre 2006

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale confirme que la nomination en date du 20 octobre 2004 de Monsieur Dominique Maquet en tant

qu'administrateur est à considérer également comme nomination en qualité d'administrateur délégué.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 16.00 heures.

Strassen, le 18 décembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2007034256/578/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06407. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070030089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Blairnet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 24, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 103.543.

EXTRAIT

Il résulte d'une Assemblée Générale de la Société à responsabilité limitée BLAIRNET S.à r.l., reçu par le notaire Henri

Beck de résidence à Echternach en date du 19 janvier 2007, enregistré à Echternach le 24 janvier 2007, volume 364, folio
11, case 6, que:

a) Monsieur Claude Bormann, employé privé, demeurant à L-7232 Bereldange, 46, rue des Jardins a été nommé gérant

administratif pour une durée indéterminée,

34587

b) les mandats de Messieurs Jacques Krau et Sidney Schamburger, en tant de gérant administratif respectivement gérant

technique sont confirmés pour une durée indéterminée,

La société sera valablement engagée par les signatures conjointes du gérant technique avec un des gérants administratifs,
c) Monsieur Claude Bormann a pouvoir de représenter la société dans les contrats de réservation et compromis à

conclure entre tiers sous l'assistance de la société.

Echternach, le 26 janvier 2007.

H. Beck
<i>Notaire

Référence de publication: 2007034260/201/21.
(070029898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Franklin Templeton International Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 36.979.

Le bilan au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007034262/1284/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06212. - Reçu 50 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

General Consult S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 66.952.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 15 février 2007, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la GENERAL CONSULT
S.A., dont le siège social à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, a été dénoncé en date du 2 juin 2006.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Jean-Paul Meyers, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxem-

bourg, et liquidateur Maître Jonathan Burger, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe du Tribunal de commerce de et à Luxem-

bourg avant le 7 mars 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
J. Burger
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2007034317/250/22.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05366. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Prisma Energy Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 103.181.

<i>Résolution de l'Associé unique

L'associé unique de la société a décidé en date du 29 janvier 2007, d'accepter:
- la démission avec effet au 29 janvier 2007 de M. George Wasaff en tant qu'Administrateur avec adresse au 1221,

Lamar Street, Suite 800, Houston, Texas 77010, U.S.A

34588

- la nomination avec effet au 29 janvier 2007 de M. John G. Fulton en tant qu'Administrateur avec adresse au 1606

Klimer Way, Houston, Texas 77077, U.S.A

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007034264/1012/18.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB06065. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Prisma Energy Global Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.000,00.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 88.318.

<i>Résolution de l'Associé unique

L'associé unique de la société a décidé en date du 29 janvier 2007, d'accepter:
- la démission avec effet au 29 janvier 2007 de M. George Wasaff en tant qu'Administrateur avec adresse au 1221,

Lamar Street, Suite 800, Houston, Texas 77010, U.S.A

- la nomination avec effet au 29 janvier 2007 de M. John G. Fulton en tant qu'Administrateur avec adresse au 1606

Klimer Way, Houston, Texas 77077, U.S.A

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007034265/1012/18.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB06066. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Laax Investments Ltd., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.027.

<i>Extrait des décisions de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 15 février 2007

1. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a démissionné de sa fonction de Commissaire aux Comptes.
2. La société à responsabilité limitée KOHNEN &amp; ASSOCIES S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n 

o

 114.190, avec siège

social à L-2128 Luxembourg, 66, rue Marie-Adélaïde, a été nommée Commissaire aux Comptes jusqu'à l'issue de l'As-
semblée Générale Statutaire de 2011.

Luxembourg, le 15 février 2007.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LAAX INVESTMENTS LTD.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007034291/29/19.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04490. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Ermitage Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 59.648.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société ERMITAGE HOLDINGS SA qui s'est

tenue en date du 15 février 2007 que:

Les mandats des administrateurs M. Alexandre Dorski demeurant à 92, avenue Kleber, Paris, France, de la société

VILMART INVESTMENTS INC., ayant son siège social à Jasmine Court, 35A Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City,

34589

Belize et la société MERPICK OVERSEAS LIMITED, ayant son siège social à Jasmine Court, 35A Regent Street, P.O. Box
1777, Belize City, Belize ont été reconduites jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, 15 février 2007.

Pour extrait conforme
Par mandat
Signature

Référence de publication: 2007034267/803/20.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB06087. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Société Lonigo S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 71.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 97.601.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 février 2007:
- La démission de Mme Maria Florencia Streuli en tant qu'Administrateur A de la société est accordée avec effet

immédiat;

- Mme Betina Serra, domiciliée au Wolfbachstrasse 18, CH-8032 Zürich, est élue nouvel Administrateur A avec effet

immédiat. Elle terminera le mandat de l'Administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de
2009.

Luxembourg, le 20 février 2007.

Pour extrait conforme
R. P. Pels

Référence de publication: 2007034269/724/20.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05993. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Dux S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 73.918.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2007.

<i>Pour DUX S.A. HOLDING
ECOGEST SA
Signature

Référence de publication: 2007034364/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB04993. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Zama (Windhoek) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 111.375.

EXTRAIT

En date du 13 mai 2006, l'associé unique de la Société, LUXGATE S.àr.l., une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois ayant son siège social au 14 a, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, enregistrée auprès du RCS Luxembourg
sous le numéro B 105.092, a transféré les 500 parts de la Société à MARATHON S.àr.l., une société à responsabilité

34590

limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 12 a, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, enregistrée auprès du
RCS Luxembourg sous le numéro B 111.374.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2007.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2007034270/260/20.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05891. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Italfondiario Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.012.500,00.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 114.819.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat d'apport daté du 22 février 2006 que FORTRESS REGISTERED INVESTMENT TRUST, une

société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, DE
19801, Etats-Unis d'Amérique, a transféré toutes les 1.600.000 parts sociales qu'elle détient dans la société à FORTRESS
INVESTMENT FUND SISTER COMPANY LLC, une société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son
siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique, de sorte que FORTRESS INVEST-
MENT FUND SISTER COMPANY LLC détient toutes les 1.600.500 parts sociales de la Société depuis le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2006.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2007034274/260/21.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05894. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

For You 2, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1424 Luxembourg, 16, rue André Duchscher.

R.C.S. Luxembourg B 116.390.

Suite à une lettre envoyée le 19 décembre 2006, Mme Lara Anceriz Coutinho, née le 30 juin 1978 et demeurant à

L-8293 Keispelt, 9, rue de Meispelt démissionne de son poste de gérante technique avec effet au 10 janvier 2007.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
Signature

Référence de publication: 2007034283/2266/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05905. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Ici Paris XL (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 92.955.

<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 février 2007

Se sont réunis les actionnaires de la société ICI PARIS XL (LUXEMBOURG) S.A. en assemblée générale extraordinaire

en date du 14 février 2007 et ont pris la résolution suivante:

La société AUDITSERV S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.384 et

demeurant à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1 

er

 , est nommée commissaire aux comptes en remplacement

de la société PricewaterhouseCoopers S.à r.l., demeurant à 400, route d'Esch à L-1471 Luxembourg.

34591

Luxembourg, le 15 février 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007034277/728/18.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04373. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Private Holdings of Investments Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 71.358.

Le Conseil d'Administration tenu le 21 février 2007 a décidé:
Suite à la démission de Madame Federica Bacci de sa fonction d'administeur, de coopter comme nouveau administra-

teur, avec effet à partir du 21 février 2007, Monsieur Sebastien Felici né le 31 mai 1978 à Villerupt en France, résident
professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance
que celui de son prédécesseur

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
PRIVATE HOLDINGS OF INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007034278/24/18.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05821. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Varolux Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 85.006.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 6 juin 2006 à 14.00 heures

L'Assemblée Générale nomme les Administrateurs: Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et Madame

Elise Lethuillier et le Commissaire aux Comptes, HRT REVISION S.à r.l, pour une durée de 6 années. Leur mandat prendra
fin à l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2007034348/817/19.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB06045. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Nicky International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 15.259.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2007

Nomination de Monsieur Aniel Gallo, né le 6 février 1962 à Torre Annunziata, demaurant au 53, route d'Arlon, L-8211

Mamer au poste d'administrateur.

Renouvellement du mandat d'administrateur pour une durée de 6 ans de la S.A. JANFOR, dont le siège social est établi

au 191, boulevard du souverain B-1160 Auderghem.

Renouvellement du mandat d'administrateur pour une durée de 6 ans de Monsieur Leopold Lequeux né le 19 février

1945 à Waha, demeurant avenue Henry Dunant 3/B20, B-1140 Evere

34592

Renouvellement du mandat d'administrateur délégué pour une durée de 6 ans de Monsieur Leopold Lequeux né le 19

février 1945 à Waha, demeurant avenue Henry Dunant 3/B20, B-1140 Evere.

Nomination de FIDUCIAIRE &amp; EXPERTISES (LUXEMBOURG) S.A., RC Luxembourg B 70.909, 53, route d'Arlon,

L-8211 Mamer, est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le bureau
I. Deschuytter / S. Pache / S. livoir
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2007034281/1197/24.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04217. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070030035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Marmont International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 10.797.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14 février 2007

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

MM. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Marco Gostoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Marc Léonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A. 35, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007034279/24/24.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05820. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Athem Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 107.008.

EXTRAIT

Il résulte de la cession de parts intervenue en date du 12 janvier 2007 que:
- la société BIZNEST LIMITED, ayant son siège social au 4th floor, Discovery House, Saint Jean Road, Quatre Bornes,

Mauritius, a cédé 250 parts sociales de catégorie B qu'elle détenait dans la société ATHEM INVESTMENTS S. à r.l., ayant
son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg à Monsieur Petros Vastardis, demeurant à Etolias 3,
15231 Halandri, Athènes, Grèce.

Cette cession de parts a été notifiée et acceptée par la société ATHEM INVESTMENTS S. à r.l. en date du 12 janvier

2007 conformément à l'article 1690 du Code Civil et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Suite à cette cession, le capital social de la société ATHEM INVESTMENTS S. à r.l. est détenu comme suit:
BIZNEST LIMITED, ayant son siège social au 4th floor, Discovery House, Saint Jean Road, Quatre Bornes, Mauritius:

250 parts catégorie A

Petros Vastardis, demeurant à Etolias 3, 15231 Halandri, Athènes, Grèce: 250 parts catégorie B

34593

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007034282/534/24.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05598. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

For You 2, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1424 Luxembourg, 16, rue André Duchscher.

R.C.S. Luxembourg B 116.390.

<i>Assemblée générale extraordinaire des associés du 29 janvier 2007

Suite à une cession des parts sociales la répartition du capital se présente comme suite

Mme Vera Rodrigues Ribeiro Anceriz, demeurant à L-5866 Hespérange, 3, rue Sangen . . . . . . . . . 100 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

V. Rodrigues Ribeiro Anceriz.

Référence de publication: 2007034284/2266/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, réf. LSO-CB05904. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

IAM Strategic S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 685.047,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 101.930.

Mr Jakob Kjelgaard resigned from his function as a day-to-day manager with effect as of 1 July 2006.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

M. Jakob Kjelgaard a démissionné en tant que délégué à la gestion journalière avec effet au 1 

er

 juillet 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IAM STATEGIC S.A.
Signature

Référence de publication: 2007034285/250/16.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04593. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Aclee S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 116.667.

In the year two thousand and seven, on the twenty-fifth of January
Before us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

AOF II (CAYMAN HOLDINGS) LTD, a company governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office

at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY 1-9002, Cayman Islands, registered with the Cayman
Islands Registrar of Companies under number 169047,

hereby represented by Ms Elisabeth Guisart, attorney-at-law, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
by virtue of a power of attorney given on January 24, 2007.
The said power of attorney shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
I. The appearing party declares that it is the sole shareholder of ACLEE S.à r.l, a private limited liability company,

incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 25A, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated by a deed of 17 May 2006 of Maître Henri Hellinckx, notary,

34594

then residing in Mersch, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on the 26 July 2006 under
number B. 116.667 (the «Company»). The Company's Articles of Incorporation have been amended by a deed of 22 June
2006 of Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations on the 27 September 2006 and by a deed of 3 July 2006 before the undersigned
notary published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on the 26 September 2006.

II. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to

be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the Company's share capital by an amount of four hundred sixty-two thousand two hundred fifty euros

(EUR 462,250.-) so as to raise it from its current amount of eight hundred twenty-three thousand two hundred fifty euros
(EUR 823,250.-), divided into six thousand five hundred eighty-six (6,586) shares, with a nominal value of one hundred
twenty-five euros (EUR 125.-) each, to one million two hundred eighty-five thousand five hundred euros (EUR 1,285,500.-),
divided into ten thousand two hundred eighty-four (10,284) shares, with a nominal value of one hundred twenty-five
euros (EUR 125.-) each.

2. To issue three thousand six hundred ninety-eight (3,698) shares, with a nominal value of one hundred twenty-five

euros (EUR 125.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to
dividends as from the day of the decision of the sole shareholder resolving on the proposed share capital increase.

3. To accept the subscription of three thousand six hundred ninety-eight (3,698) new shares, with a nominal value of

one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each by AOF II (CAYMAN HOLDINGS) LTD, prenamed, by a contribution
in cash.

4. To allocate three thousand six hundred ninety-eight (3,698) newly issued shares to AOF II (CAYMAN HOLDINGS)

LTD, prenamed, in consideration for its contribution in cash.

5. To amend article 6 of the Company's Articles of Incorporation so as to reflect the resolutions taken under item 1

to 4.

6. To amend article 12 of the Company's Articles of Incorporation (creation of Class A and Class B Managers).
7. To appoint Class A and Class B Managers for an undetermined period.
8. To grant specific signature power to the Class A Managers.
9. Miscellaneous.
The sole shareholder then passed the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of four hundred sixty-two thou-

sand two hundred fifty euros (EUR 462,250.-) so as to raise it from its current amount of eight hundred twenty-three
thousand two hundred fifty euros (EUR 823,250.-), divided into six thousand five hundred eighty-six (6,586) shares, with
a nominal value of one hundred twenty-five euros (EUR 125.-) each, to one million two hundred eighty-five thousand five
hundred euros (EUR 1,285,500.-), divided into ten thousand two hundred eighty-four (10,284) shares, with a nominal
value of one hundred twenty-five euros (EUR 125.-) each.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to issue three thousand six hundred ninety-eight (3,698) shares, with a nominal value

of one hundred twenty-five euros (EUR 125.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing
shares and entitling to dividends as from the day of the decision of the sole shareholder resolving on the proposed share
capital increase.

<i>Subscription - Payment

There now appeared Ms Elisabeth Guissart, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of AOF II (CAY-

MAN HOLDINGS) LTD, prenamed.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of AOF II (CAYMAN HOLDINGS) LTD,

prenamed, to three thousand six hundred ninety-eight (3,698) new shares of the Company, with a nominal value of one
hundred twenty-five euros (EUR 125.-) each, and to make payment in full for such newly subscribed shares by a contri-
bution in cash.

The person appearing declared and all the participants to the extraordinary general meeting recognise that the newly

issued shares have been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the total amount of four hundred
sixty-two thousand two hundred fifty euros (EUR 462,250.-), proof of which is given to the undersigned notary who
expressly records this statement.

Thereupon the sole shareholder resolves to accept the subscription and payment of the newly issued shares and to

allot the three thousand six hundred ninety-eight (3,698) newly issued shares of the Company to AOF II (CAYMAN
HOLDINGS) LTD, prenamed.

34595

<i>Third resolution

As a result of the resolutions taken under item 1 to 4, the sole shareholder resolves to amend article 6 of the Company's

Articles of Incorporation, which shall forthwith read as follows:

« Art. 6. The capital is set at one million two hundred eighty-five thousand five hundred euros (EUR 1,285,500.-),

divided into ten thousand two hundred eighty-four (10,284) shares with a nominal value of one hundred twenty-five euros
(EUR 125.-) each.»

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolves to amend article 12, first paragraph of the Company's Articles of Incorporation, which

shall forthwith read as follows:

«The Company is managed y one or more managers who need not to be shareholders. The managers will be elected

by the shareholders. The shareholders may decide to appoint one or several Class A Managers and one or several Class
B Managers.»

The sole shareholder resolves to amend article 12, sixth paragraph of the Company's Articles of Incorporation, which

shall forthwith read as follows:

«The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers. However, if the partners have appointed one or several
Class A Manager and one or several Class B Manager the Company will be bound towards third parties by the joint
signature of one Class A Manager and one Class B Manager or by the joint signature of two Class A Managers or by the
joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of
managers, within the limits of such power.»

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolves to appoint the following as Class A and Class B Managers for an undetermined period:

<i>Class A Managers:

- Mr Alan Botfield, accountant, born in Stirling (United Kingdom), on December 22nd, 1970, residing at 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg; and

- Mr Hille-Paul Schut, manager, born in Den Hage (the Netherlands), on September 29th, 1977, residing at 20, rue de

la Poste, L-2346 Luxembourg.

<i>Class B Manager:

- Mr Simon Bell, director, born in Staplehurst (United Kingdom), on September 2nd, 1968, residing at FT B 35/F Tower

2, 28, Bel-Air Avenue, Residence Bel-Air Island South, Wah-Fu Hong Kong.

<i>Sixth resolution

The sole shareholder resolves to authorise any Class Manager A of the Company, each acting individually, in order to:
1. execute and file the wage tax, corporate tax, capital tax, dividend tax and VAT returns, as well as correspondence

in relation thereto;

2. execute and file the documents with the Luxembourg Trade and Companies Register;
3. fulfil the collection from the postal authorities of all mail addressed to the Company;
4. negotiate, sign, execute and file Central Bank Licenses, reports, as well as all correspondence in relation thereto;
5. operate and act as an authorized signatory of the Company's bank accounts according to the mandate approved by

the board of managers;

6. approve payments of day to day operational expenses of the Company which are included in the annual budget

approved by the board of managers and the amount of each individual item which does not exceed the budgeted amount;
and

7. negotiate, sign and execute office lease agreement of the Company and employee employment contracts as far as

the lease payments and the monthly payroll do not deviate from the budgeted amounts.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the mandatory of the person appearing, he signed together with the notary the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

34596

A comparu:

AOF II (CAYMAN HOLDINGS) LTD, une société constituée sous les lois des Iles Cayman, établie et ayant son siège

social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY 1-9002, Iles Cayman, enregistrée au registre
des sociétés des Iles Cayman sous le numéro 169047,

ici représentée par Mademoiselle Elisabeth Guissart, avocat, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
en vertu d'une procuration donnée le 24 janvier 2007.
Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumise aux fins d'enregistrement.
I. La comparante déclare qu'elle est l'associé unique de ACLEE S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée

selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
(Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte du notaire Maître Henri Hellinckx, résidant à Mersch en date du
17 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 26 juillet 2006. Les Statuts de la Société ont
été modifies en date du 22 juin 2006 par acte du notaire Maître Joseph Elvinger, résidant à Luxembourg, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations le 27 septembre 2006 et en date du 3 juillet 2006 par acte du notaire soussigné
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 26 septembre 2006 (la «Société»).

II. La comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, reconnaît être entièrement informée des résolutions à

prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre cent soixante-deux mille deux cent cinquante

euros (EUR 462.250,-) de manière à le porter de son montant actuel de huit cent vingt-trois mille deux cent cinquante
euros (EUR 823.250,-), divisé en six mille cinq cent quatre-vingt-six (6.586) parts sociales, ayant une valeur nominale de
cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, à un montant de un million deux cent quatre-vingt-cinq mille cinq cents euros
(EUR 1.285.500,-), divisé en dix mille deux cent quatre-vingt-quatre (10.284) parts sociales, ayant une valeur nominale de
cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

2. Emission de trois mille six cent quatre-vingt-dix-huit (3.698) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent vingt-

cinq euros (EUR 125,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et
participant aux bénéfices de la Société à compter du jour de la décision de l'associé unique se prononçant sur l'augmen-
tation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription par AOF II (CAYMAN HOLDINGS) LTD, précitée, de trois mille six cent quatre-

vingt-dix-huit (3.698) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune,
par un apport en espèces.

4. Attribution des trois mille six cent quatre-vingt-dix-huit (3.698) nouvelles parts sociales émises à AOF II (CAYMAN

HOLDINGS) LTD, précitée, en contrepartie d'un apport en espèces.

5. Modification de l'article 6 des Statuts de la Société afin de refléter les résolutions prises sous les points 1 à 4.
6. Modification de l'article 12 des Statuts de la Société (création de Gérants de catégorie A et B).
7. Désignation de Gérants de catégorie A et B.
8. Octroi d'un pouvoir spécifique de signature aux Gérants de catégorie A.
9. Divers.
L'actionnaire unique a abordé l'ordre du jour et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre cent soixante-deux mille

deux cent cinquante euros (EUR 462.250,-) de manière à le porter de son montant actuel de huit cent vingt-trois mille
deux cent cinquante euros (EUR 823.250,-), divisé en six mille cinq cent quatre-vingt-six (6.586) parts sociales, ayant une
valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, à un montant de un million deux cent quatre-vingt-cinq
mille cinq cents euros (EUR 1.285.500,-), divisé en dix mille deux cent quatre-vingt-quatre (10.284) parts sociales, ayant
une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide d'émettre trois mille six cent quatre-vingt-dix-huit (3.698) parts sociales, ayant une valeur

nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts
sociales existantes et participant aux bénéfices de la Société à compter du jour de la décision de l'associé unique se
prononçant sur l'augmentation de capital proposée.

<i>Souscription - Paiement

Est ensuite intervenu Mademoiselle Elisabeth Guissart, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de AOF

II (CAYMAN HOLDINGS) LTD, précitée.

Laquelle comparante a déclaré souscrire au nom et pour le compte de AOF II (CAYMAN HOLDINGS) LTD, précitée,

à trois mille six cent quatre-vingt-dix-huit (3.698) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de cent

34597

vingt-cinq euros (EUR 125,-), et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales souscrites par un apport
en espèces.

La comparante a déclaré et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire reconnaissent

que chaque nouvelle part sociale a été libérée entièrement en espèces et que la somme totale de quatre cent soixante-
deux mille deux cent cinquante euros (EUR 462.250,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.

L'associé unique, décide d'accepter ladite souscription et la libération par le souscripteur et d'attribuer trois mille six

cent quatre-vingt-dix-huit (3.698) nouvelles parts sociales de la Société à AOF II (CAYMAN HOLDINGS) LTD, précitée.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions prises sous les points 1 à 4, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des Statuts de la Société,

qui devra désormais être lu comme suivant:

« Art. 6. Le capital s'élève à un million deux cent quatre-vingt-cinq mille cinq cents euros (EUR 1.285.500,-) parts

sociales ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.»

<i>Quatrième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 12, premier paragraphe des Statuts de la Société qui devra désormais être

lu comme suivant:

«L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider de désigner un ou plusieurs Gérants de catégorie

A et un ou plusieurs Gérants de catégorie B.»

L'associé unique décide de modifier l'article 12, paragraphe 6, des Statuts de la Société qui devra désormais être lu

comme suivant:

«La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Néanmoins, si l'associé unique ou les associés ont
désigné un ou plusieurs Gérants de catégorie A ou un ou plusieurs Gérants de catégorie B, la Société sera engagée vis-
à-vis des tiers par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B ou par la signature
conjointe de deux Gérants de catégorie A ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à
qui le pouvoir de signature a été délégué par le Conseil de Gérance endéans les limites de ce pouvoir.»

<i>Cinquième résolution

L'associé unique décide de nommer comme Gérants de catégorie A et B pour une période indéterminée:

<i>Gérants de catégorie A:

- M. Alan Botfield, conseiller, né à Stirling (Royaume-Uni), le 22 décembre 1970, domicilié au 20, rue de la Poste, L-2346

Luxembourg; et

- M. Hille-Paul Schut, gérant, né à La Haye (Pays-Bas), le 29 septembre 1977, domicilié au 20, rue de la Poste, L-2346

Luxembourg;

<i>Gérant de catégorie B:

- M. Simon Bell, avocat conseil, né à Stirling (Royaume-Uni), le 2 septembre 1968, domicilié au FT B 35/F Tower 2, 28,

Bel-Air Avenue, Residence Bel-Air Island South, Wah-Fu Hong Kong.

<i>Sixième résolution

L'associé unique décide d'autoriser tout Gérant de catégorie A, chacun agissant individuellement, de:
1. exécuter et déposer les déclarations fiscales relatives aux charges salariales, à l'impôt sur le revenu, sur la fortune,

sur les dividendes, à la TVA, ainsi que toute correspondance s'y rapportant;

2. exécuter et déposer tout document au Registre de Commerce et des Sociétés;
3. remplir toutes les exigences émanant des autorités postales en rapport avec toute correspondance adressée à la

Société;

4. négocier, signer, exécuter et déposer les autorisations de la Banque Centrale, les rapports ainsi que toute corres-

pondance s'y rapportant;

5. gérer et agir en tant que signataire autorisé pour les comptes bancaires de la Société conformément au mandat

approuvé par le conseil de gérance;

6. approuver les payements des dépenses quotidiennes de la Société qui sont incluses dans le budget annuel tel qu'ap-

prouvé par le conseil de gérance et le montant de chaque poste individuel qui ne dépasse pas le montant budgétisé; et

7. négocier, signer et exécuter tout contrat de leasing de bureau de la Société et tout contrat de travail des employés

pour autant que les payements sous le contrat de leasing et les salaires mensuels ne dévient pas des montants budgétisés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

34598

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: E. Guisart, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2007, vol. 157S, fol. 58, case 9. — Reçu 4.625 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007034577/230/244.
(070029846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Amon Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 109.417.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 28 décembre 2006

- Nomination en tant que Président du Conseil d'Administration de Monsieur Paolo Necci, Via Furci Siculo, 10 à Rome

pour une nouvelle période de trois ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2009.

Fait le 28 décembre 2006.

Certifié sincère et conforme
AMON PROPERTIES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007034286/795/18.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2007, réf. LSO-CA08199. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070030171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Artemis Fine Arts, Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 8.935.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 2 février 2007, la décision des Administrateurs du 2 juin 2006 de

coopter M. Robert Byrne Noonan au Conseil d'administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel administrateur défini-
tivement élu s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

M. Ian Rosenblatt, Cobbles Barn, The Cross, Buckland Dinham, Frome Somerset, GB-BALL 2QS, a été nommé admi-

nistrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

La démission de l'administrateur M. Noel Richardson du 6 novembre 2006 a été ratifiée.
Le mandat de l'auditeur indépendant MOORE STEPHENS S.à r.l., Luxembourg, a été renouvelé pour une durée d'un

an, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

Luxembourg, le 16 février 2007.

<i>Pour ARTEMIS FINE ARTS
EXPERTA LUXEMBOURG
L. Heck / S. Wallers

Référence de publication: 2007034341/1017/21.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05174. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Musical Instruments Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4734 Pétange, 8, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 88.627.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

34599

Strassen, le 23 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007034292/578/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05145. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

GS Construction S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1A, rue de la Laiterie.

R.C.S. Luxembourg B 100.559.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 23 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007034293/578/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05147. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070030091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Fidecs Group, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 34.389.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2007.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

Référence de publication: 2007034294/230/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04271. - Reçu 0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Copagest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 35.687.

Par  décision  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  du  3  novembre  2006,  la  société  AUDIT-TRUST  S.A.,  société

anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes avec effet au 23 mars 2006,
en remplacement de REVILUX S.A., L-Luxembourg, et la démission en date du 16 mars 2006 de M. Marcel Nickmans de
son poste d'administrateur a été ratifiée.

Luxembourg, le 16 février 2007.

<i>Pour COPAGEST S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
L. Heck / S. Wallers

Référence de publication: 2007034343/1017/17.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05172. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

agraferm technologies luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7650 Heffingen, 3, um Haff.

R.C.S. Luxembourg B 114.867.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

34600

Luxembourg, le 26 février 2007.

SOFINTER S.A.
Signature

Référence de publication: 2007034295/820/14.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05142. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Patron Weghell VIII S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 124.577.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the second day of February.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in

replacement of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily
absent, the latter remaining depositary of the present minutes.

There appeared:

PATRON WEGHELL HOLDING Sàrl, a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered

office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg

here represented by Mr Michael Vandeloise private employee, with professional address in L-1116 Luxembourg, 6,

rue Adolphe,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 2nd February 2007.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (the «Company») which
shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles
of incorporation.

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition,

development and exploitation of any immovable property located in European Union, as well as the acquisition of par-
ticipations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
these participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies. The Company
may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to
acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale,
transfer, exchange or otherwise.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise
create security over some or all its assets. The Company may also grant loans to subsidiaries, affiliated companies or third
parties. The Company may borrow in any form and in particular privately issue bonds.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of PATRON WEGHELL VIII S. à r. l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general

meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

34601

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of management, who need not necessarily be

shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of one sole member of the
board of management. The managers may be dismissed freely at any time.

The board of management may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of management shall choose from among its members a chairman, and may choose from among

its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of management.

In dealings with third parties, the board of management has the most extensive powers to act in the name of the

Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object.

The board of management shall meet upon call by the chairman, or one of its members, at the place indicated in the

notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of management, but in his absence, the board
of management may appoint another of its members as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of management must be given to its members twenty-four hours at least

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member of the
board of management in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A
special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of management.

Any member of the board of management may act at any meeting of the board of management by appointing in writing

or by cable, telegram, telex or facsimile another member of the board of management as his proxy. Any member of the
board of management may represent more than one of his colleagues.

Any member of the board of management may participate in any meeting of the board of management by conference-

call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of management can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of man-
agement is present or represented at a meeting of the board of management. Decisions shall be taken by a majority of
votes of the members of the board of management present or represented at such meeting.

The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence,

by the vice-chairman, or by one member of the board of management. Copies or extracts of such minutes which may be
produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one member of the board of man-
agement.

Art. 15. The death or resignation of the sole manager or of a member of the board of management, for any reason

whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 16. The sole manager or the members of the board of management do not assume, by reason of its/their position,

any personal liability in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised agents
only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the Sole Shareholder - Collective decisions of the Shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

34602

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first day of December of each year and ends on the last day of

November of the following year.

Art. 21. Each year on the last day of November, the accounts are closed and the sole manager or the board of

management prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.

The sole manager or the board of management is authorized to distribute interim dividends in case the funds available

for distribution are sufficient.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

All five hundred (500) shares are subscribed by PATRON WEGHELL HOLDING Sàrl, aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12.500,-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 30th day of

November 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred (1,900.-) euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder representing the entirety of the subscribed

capital of the Company has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as members of the board of management of the Company for an indefinite

period:

- Mrs Géraldine Schmit, director of company, born on 12th November 1969, in Messancy (Belgium), with professional

address at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;

- Mr Michael Vandeloise, private employee, born on 16th July 1982 in Messancy (Belgium), with professional address

at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the proxyholder

of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of
the same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the German text, the English version
will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, the said proxyholder appearing

signed together with Us the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundsieben, den zweiten Februar.

34603

Vor der unterzeichneten Notarin Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Remich, Großherzogtum Luxemburg, han-

delnd in Vertretung von Notar André Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, zur Zeit
abwesend, welch Letzterer Depositar der gegenwärtigen Urkunde bleibt.

Ist erschienen:

PATRON WEGHELL HOLDING Sàrl eine Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
hier vertreten durch Herrn Michael Vandeloise Privateangestellte, mit berufsmäßiger Anschrift in L-1116 Luxembourg,

6, rue Adolphe,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxembourg, am 2. Februar 2007.
Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten der erschienenen Partei und den

unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd aufgrund obiger Ermächtigung, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit zu gründen beabsichtigt, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Es wird hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und all denen, die in Zukunft Ge-

sellschafter  werden,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (société  à  responsabilité
limitée), (die «Gesellschaft») der sie die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.

Art. 2. Den Gegenstand der Gesellschaft bilden die Durchführung aller Transaktionen, die im direkten oder indirekten

Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Verwertung unbeweglicher Vermögenswerte in der Europä-
ischen Union stehen, sowie der Erwerb von Beteiligungen an Unternehmungen jeglicher Form und die Leitung, Bewirt-
schaftung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen, ohne in den Geltungsbereich des Gesetzes vom 31. Juli 1929
über  reine  Holdinggesellschaften  zu  fallen.  Die  Gesellschaft  darf  ihre  Mittel  für  den  Aufbau,  die  Bewirtschaftung,  die
Entwicklung und die Veräußerung eines Portfolios von Wertpapieren und Patenten jeglichen Ursprungs, für den Erwerb
von Wertpapieren und Patenten durch Anlage, Zeichnung, Übernahme oder Option und für deren Verwertung im Wege
des Verkaufs, der Übertragung, des Austauschs oder in anderer Weise verwenden.

Die Gesellschaft darf außerdem Bürgschaften und Sicherheiten zu Gunsten Dritter leisten, um ihre Obligationen oder

die Obligationen von Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder jeglichen anderen Gesellschaften zu besi-
chern. Sie darf ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in anderer Weise als Sicherheit
verwenden. Die Gesellschaft darf darüber hinaus Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder Dritten Kre-
dite gewähren. Die Gesellschaft darf Kredite in jeglicher Form aufnehmen und insbesondere Anleihen privat platzieren.

Die Gesellschaft darf alle gewerblichen, industriellen, finanziellen, privaten und Immobilientransaktionen durchführen,

die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihre Entwicklung begünstigen können.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung PATRON WEGHELL VIII S. à r. l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt

werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, voraus-

gesetzt, daß die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils

müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlußfassung erfolgt mit einer
Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Weder Gläubiger noch Rechtsnachfolger können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Ver-

mögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

34604

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung hält auch die Dauer

des Mandates fest.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung, dessen Mitglieder nicht

unbedingt Gesellschafter sein müssen, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft in allen Gelegenheiten durch die
Unterschrift von einem Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu jedem
Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an

eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.

Art. 13. Die Geschäftsführung wählt aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit,

einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied der
Geschäftsführung sein muß, und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.

Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Na-

men der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang
stehen.

Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung der Geschäftsführung; in seiner
Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung er-
nennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der

Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser
Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Te-
lefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes der Geschäfts-
führung, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich
für Sitzungen der Geschäftsführung, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen
Beschluß der Geschäftsführung festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich in der Sitzung der Geschäftsführung aufgrund einer schriftlich, durch

Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten
lassen. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehrere andere Mitglieder der Geschäftsführung vertreten.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser
Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten
ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-

licher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden,
vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als
Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Aus-
züge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
einem Mitglied der Geschäftsführung unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Mitgliedes der Geschäftsführung, aus welchem

Grund auch immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Der alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder der Geschäftsführung haften aufgrund der Ausübung ihrer

Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Er/ Sie sind nur für die Ausübung
ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Haupversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

34605

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese we-

nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ange-
hören.

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres und endet

am letzten Tag des Monats November des darauffolgenden Jahres.

Art. 21. Am 30. November eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der alleinige Geschäftsführer oder

die Geschäftsführung stellen das Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft
aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Ge-

sellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ist berechtigt, Interimdividenden zu verteilen, soweit ausrei-

chende Mittel zur Verteilung verfügbar sind.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt deren
Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der
Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Das verbleibende Guthaben, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten der

Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital aufgeteilt.

Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig von der vorbenannten PATRON WEGHELL HOLDING Sàrl ge-

zeichnet.

Die Gesamteinlage von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) besteht aus einer Kapitaleinlage von zwölftau-

sendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist nun für die Gesellschaft verfügbar, so wie es dem Notar bewiesen worden
ist.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. Tag des Monats November 2007.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorar und Auslagen werden auf eintausend-

neunhundert (1.900,-) Euro geschätzt.

<i>Hauptversammlung

Der Gesellschafter der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, hat unverzüglich nach der Gründung der

Gesellschaft die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
2. Die folgenden Personen werden als Mitglieder der Geschäftsführung ernannt. Die Mitglieder der Geschäftsführung

sind auf unbestimmte Zeit ernannt:

- Frau Géraldine Schmit, Gesellschaftsverwalterin, geboren in Messancy (Belgien) am 12. November 1969, berufsmäßig

wohnhaft in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

- Herrn Michael Vandeloise, Privatbeamter, geboren in Messancy (Belgien), am 16. Juli 1982, berufsmäßig wohnhaft in

6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Bevollmächtigten der

vorgenannten Partei, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache.
Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei hat derselbe mit

Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: M. Vandeloise, M. Schaeffer.

34606

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, vol. 31CS, fol. 96, case 3. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007034228/230/321.
(070030021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Vue du Golfe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 59.275.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007034296/1268/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01357. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070029817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Interprom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 18, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 45.556.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 2 février 2007 le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VIe section, siégeant en matière

commerciale, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée
INTERPROM s.à r.l., ayant eu son siège social à L-4210 Esch-sur-AIzette, et a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
N. Glesener
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2007034322/4937/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02377. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Actum S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 44.926.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 15 février 2007, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société ACTUM S.A.,
dont le siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, a été dénoncé en date du 20 octobre 2003.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Jean-Paul Meyers, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxem-

bourg, et liquidateur Maître Jonathan Burger, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe du Tribunal de commerce de et à Luxem-

bourg avant le 7 mars 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

34607

Pour extrait conforme
J. Burger
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2007034320/250/22.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05358. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Holding de l'Est, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 3.324.

Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2006, la décision des Administrateurs du 26 juin 2006 de

coopter M. Guy Baumann au Conseil d'Administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel Administrateur définitivement
élu s'achèvera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

Luxembourg, le 16 février 2007.

<i>Pour HOLDING DE L'EST
EXPERTA LUXEMBOURG
L. Heck / S. Wallers

Référence de publication: 2007034337/1017/16.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05171. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Hema S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 10.756.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 1987, Messieurs Jean Krier, Jean Seywert et Georges Zimmer

ne font plus partie du Conseil d'Administration de la société.

Par décision de cette même assemblée, le commissaire aux comptes Monsieur Jean-Louis Klein a été remplacé.

Luxembourg, le 16 février 2007.

<i>Pour HEMA S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
L. Heck / S. Wallers

Référence de publication: 2007034342/1017/16.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05173. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070030174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Dux S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 73.918.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2007.

<i>Pour DUX SA HOLDING
ECOGEST SA
Signature

Référence de publication: 2007034365/3083/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB04994. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070029715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

34608


Document Outline

Aclee S.à r.l.

Actum S.A.

Aerium Sinsheim S.à r.l.

agraferm technologies luxembourg s.à r.l.

Amon Properties S.A.

Apioil International S.A.

Artemis Fine Arts

Athem Investments S.à r.l.

Belux Bois S.A.

Blairnet S.à r.l.

Bloomed Holdco S.à r.l.

Ciyow International S.à.r.l.

Copagest S.A.

Dematic Holding S.à.r.l.

Dux S.A. Holding

Dux S.A. Holding

Ermitage Holdings S.A.

Euro Media 2000 S.A.

Fidecs Group

For You 2, s.à r.l.

For You 2, s.à r.l.

Franklin Templeton International Services S.A.

Galilehorn Asset Management S.à r.l.

General Consult S.A.

G.N. Research S.A.

Grizelle S.A.

GS Construction S.A.

HB Maritime S.A.

Hema S.A.

Holding de l'Est

IAM Strategic S.A.

Ici Paris XL (Luxembourg) S.A.

Immobilière Calista S.A.

International Product Company S.A.

Interprom S.à r.l.

Italfondiario Investments S.à r.l.

Laax Investments Ltd.

Luxluce S.A.

Marmont International S.A.

Milai Finance S.A.

Musical Instruments Luxembourg S.A.

Nicky International S.A.

Norstar Property S.A.

Patron Weghell IX S. à r. l.

Patron Weghell VIII S. à r. l.

Patron Weghell X S. à r. l.

Pontoon Luxco S.à r.l.

Prisma Energy Global Investments S.à r.l.

Prisma Energy Luxembourg S.à r.l.

Private Holdings of Investments Luxembourg S.A.

Scandinavian Bullet S.à r.l.

Silverhope Holding S.A.

SIX Consulting &amp; Engineering S.A

Société Européenne de Participations et Investissements

Société Lonigo S.A.

Société pour l'Aménagement de la Place de l'Etoile à Luxembourg

TK II Colnvest S. à r.l.

Valhamar S.à r.l.

Varolux Participations S.A.

Voyages Arosa

Vue du Golfe S.A.

WCC Plauen S.à r.l.

Zama (Windhoek) S.à r.l.