logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 671

20 avril 2007

SOMMAIRE

Agrifin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32199

Arno Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32201

Bistrot Nicolas S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32195

Blufin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32193

Bourse Immobilière de Luxembourg . . . . .

32195

Carloalberto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32198

Dacomi Investissements S.A. . . . . . . . . . . . .

32203

De Hauke Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32190

Dixor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32199

Dominvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32198

Ducal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32197

Due Esse S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32193

Dunas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32197

Duran and Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

32200

Eastern Overseas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32191

Eleven Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32190

Eliop International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32188

Envipro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32208

Esmeralda S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32189

Espro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32207

Eurinvestex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32195

Eurobrick Participations Holding S.A. . . . .

32194

Evendine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32194

Even RX Properties S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . .

32162

Finalfe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32192

Findata S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32192

Finstyle - Promotion Industrielle et Finan-

cière - S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32192

Foncière CG & Associés S.A.  . . . . . . . . . . . .

32189

Four and Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32201

Gesin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32196

Header Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32208

Immobilière Azur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32191

Immobilière Centenaire S.A. . . . . . . . . . . . .

32205

IN.A.MA Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32187

IN.A.MA S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32162

International Consultant Company S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32187

Internationale Beteiligungen Holding AG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32202

Loca-Physio Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32191

Luxgala S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32205

Marbo Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32199

Mass Metropolitan International AG  . . . . .

32206

Orellana S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32208

Picarus N.V. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32207

Picoty Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32202

Positronia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32193

Recholding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32196

Regana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32189

Sabinade S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32206

"Sagewood Finance S.A."  . . . . . . . . . . . . . . .

32204

SANZAR Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

32203

S.E.T.I. Société Européenne de Transac-

tions Immobilières S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

32188

Solidal Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

32188

Soloverte Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32204

Targa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32194

Transocean Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . .

32197

Tymara Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32200

Velodo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32202

York S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32206

32161

IN.A.MA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 62.325.

Les comptes annuels au 31 août 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007032342/267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04608. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070026904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Even RX Properties S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 124.378.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the fifth of February.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

1. EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à r.l., a limited liability company, société à responsabilité limitée, incor-

porated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg by a deed of notary Paul Frieders dated November 3rd,
2006, published in the Mémorial C, number 2429 on December 29, 2006, having its registered office at 73, Côte d'Eich,
L-1450 Luxembourg, registered at the Register of commerce of Luxembourg section B, number 121.666, represented by
Marcus Peter, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on February 2nd, 2007, and

2. SYCAMORE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, a company incorporated under the laws of Luxembourg by a

deed of the undersigned notary on June 9th, 2006, published in the Mémorial C, number 1644 on August 30th, 2006,
having its registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, registered at the Register of commerce of Luxembourg
section B, number 117.449, represented by Marcus Peter, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on February 2nd, 2007.

Which proxies shall be signed ne varietur by the attorney(s) of the above named persons and the undersigned notary

and shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.

The above named parties, represented as mentioned above, have declared their intention to constitute by the present

deed a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions) and to draw up its articles of
association as follows:

Art. 1. Form. There exists a Luxembourg partnership limited by shares, société en commandite par actions, under the

name of EVEN RX PROPERTIES S.C.A. (hereinafter the «Company») among the incorporating parties and all those who
may become holders of shares of the Company.

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited period.
The Company will have an investment cycle of eight (8) years, which may be extended by 1 or 2 years to maximize

returns on the sale of assets in relation to the prevalent economic circumstances by decision of the manager of the
Company (the «Manager»).

The Company shall not be dissolved on the dissolution or bankruptcy of the Manager or the unlimited shareholder

(the «Unlimited Shareholder»).

Art. 3. Object. The principal business activity of the Company will be the investment in properties and real estate in

Germany and Switzerland.

Investment may be in health care real estate as well as in health care operators.
The object of the Company is (i) the holding of interests or participations, in any form whatsoever, be directly and/or

indirectly, in Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription or in any other manner or
the transfer by sale, exchange or otherwise of real estate, stock, bonds, debentures, notes and other securities of any
kind, and (iii) the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may participate in the establishment and development of financial, industrial and commercial enterprises

of any corporate nature.

The Company may borrow money in any form, issue bonds and other debt instruments, including without limitation

convertible preferred equity certificates («CPECs») and preferred equity certificates («PECs») and similar subordinated

32162

debt instruments, as applicable, which may or may not bear interest. The Company may further lend the proceeds of
such borrowings to its subsidiaries and investee companies and may give security for any borrowings.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, commercial and industrial

operation whether related to real estate assets or otherwise which it may deem useful for the accomplishment and
development of its purpose.

Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It can be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the Unlimited Share-

holder and limited shareholders (the «Limited Shareholders») (Unlimited and Limited Shareholders together hereinafter
are referred to as «Shareholders») deliberating and resolving in the manner provided herein and by Luxembourg law for
the amendment of these Articles.

The Manager may decide to establish branches or other offices of the Company within the Grand-Duchy of Luxem-

bourg or abroad except for Germany.

If extraordinary political or economic events or similar abnormal circumstances occur or are imminent, which might

interfere with or impair the normal activity of the Company at the registered office, or the communication between the
registered office and abroad, the Manager may decide and declare that the registered office shall be deemed to have been
provisionally transferred abroad until the complete cessation of such abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the Manager of the Company.

Art. 5. Issued and Authorised Share Capital. The Company has an issued capital of thirty-one thousand one hundred

twenty-five euro (EUR 31,125.-) divided into twenty-four thousand nine hundred (24,900) shares (the «Shares») com-
prising:

I) one (1) «A» share having a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25), allocated to the Limited Share-

holder(s) (the «A Shares»);

II) twenty-four thousand seven hundred ninety-nine (24,799) «B» shares having a par value of one euro and twenty-

five cents (EUR 1.25) each, allocated to the Unlimited Shareholder (the «B Shares»); and

III) one hundred (100) «C» shares having a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «C

Shares»)

In addition to the issued capital, issue premium for a total amount of ninety-eight point seventy-five euro (EUR 98.75)

have been paid on the A Share.

The total of the issue premiums shall be allocated to a special reserve, which, upon a resolution of the Shareholders

in General Meeting, may be distributed to the Shareholders.

The Company shall have an authorised share capital of up to one hundred and one million euro (EUR 101,000,000.-)

divided into eighty million (80,000,000) A Shares having a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each,
twenty million (20,000,000) B Shares having a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each and eight
hundred thousand (800,000) C Shares having a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.

The Manager is hereby authorised for a period of three (3) years beginning on the date of incorporation of the Company

to issue, from time to time, further A Shares with or without issue premium and B and C Shares without issue premium
to bring the total issued share capital of the Company up to the total authorised share capital. The Manager may issue
new A Shares, B Shares and C Shares referring to the total or a part of the amount of the authorised share capital as the
Manager in its discretion may determine. The Manager may further accept subscriptions for such newly issued A Shares,
B Shares and C Shares.

The time period of authorisation may be extended by resolution of the Shareholders in general meeting from time to

time, in the manner required for amendment of these Articles.

The Manager is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for A Shares, B Shares and C

Shares from time to time.

The Manager is authorised to issue such A Shares, B Shares and C Shares under and during the period referred to

above by suppressing or disregarding any existing preferential subscription rights of Shareholders.

When the Manager effects a whole or partial increase in the share capital of the Company pursuant to the preceding

paragraphs of this Article, it shall be obliged to take steps to amend this Article to record the change and the Manager is
authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance
with Luxembourg law.

The authorised or issued capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg

legal requirements.

The terms «Share» and «Shares» or «Shareholder» and «Shareholders» shall, in these Articles, unless otherwise ex-

plicitly or implicitly stated, include respectively the A Shares and the B Shares and the C Shares and the holders of the A
Shares and the B Shares and the C Shares.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by Luxembourg law, purchase its own Shares.

32163

Art. 6. Payments. Should CPECs and/or PECs be issued, the A Shares shall together with such CPECs and/or PECs

constitute units («Unit(s)»), each Unit comprising one (1) A Share and ninety-nine (99) CPECs and/or PECs, respectively,
as determined by the Manager.

The subscription price of Units shall be paid in full on issue.
The Unlimited Shareholder, the subscribers and all those who may become Shareholders, may, from time to time,

enter into a shareholders' agreement (hereinafter the «Shareholders' Agreement»), as amended from time to time. Such
Shareholders' Agreement may contain commitments by the Limited Shareholders to subscribe (i) a certain amount of
Units upon becoming a Limited Shareholder, or (ii) additional Units during the period of being a Limited Shareholder (the
commitments under (i) and (ii) are hereinafter referred to as «Committed Contributions»).

Failure to comply with requests from the Manager to pay up in full any amount undertaken in the Committed Con-

tributions shall be subject to the penalties stipulated in this Article and in the Shareholders' Agreement.

The existing Units (including the A Shares) of a Limited Shareholder who did not comply with the requests from the

Manager to pay up in full any amount undertaken in the respective Committed Contributions within ten (10) Business
Days after the dispatch of a written payment request issued by the Manager (the «Defaulting Limited Shareholder(s)»)
shall, upon the occurrence of such event of default be forfeited and no further distributions pursuant to these Articles
shall be made to such Defaulting Limited Shareholder under the Units held by such Defaulting Limited Shareholder.

The rights of a Defaulting Limited Shareholder shall be limited to repayment of A Shares held by such Defaulting Limited

Shareholder at their issue price and repayment in redemption of his CPECs and/or PECs at their par value.

Such repayments shall be effected on the termination date of the Company and only after all other Shareholders

(including the Unlimited Shareholder) shall have received the distributions as foreseen in these Articles.

Defaulting Limited Shareholder(s) shall have no right to attend or vote at any general meetings of Shareholders.
A failure to comply with requests from the Manager to pay up any amount undertaken in the Committed Contributions

which shall have occurred cannot be remedied and shall be final and binding as from the date of such occurrence.

In these Articles the term «Business Day» shall mean any day, which is not a Saturday, a Sunday or a public holiday in

Luxembourg or in Germany.

Art. 7. Liability of Shareholders. Holders of B Shares are jointly and severally responsible for all liabilities incurred by

the Company and which cannot be remedied out of the assets of the Company. As between holders of B Shares, such
liability shall be borne pro rata in the proportion of their respective holdings of B Shares.

A holder of A and C Shares shall only be liable for the repayment of debts, liabilities and obligations incurred by the

Company up the amount of the nominal value of A Shares (including allocated issue premiums) and C Shares, respectively,
held by such holder regardless whether the A and C Shares were already fully paid up or not at the time of the liability
event. As between holders of A and C Shares, such liability shall be divided among Limited Shareholder's pro rata with
view to the nominal value of all A and C Shares held by Limited Shareholders.

The  liability  of  a  holder  of  A  and  C  Shares  who  undertakes  any  act  of  management  (whether  authorised  or  not

authorised by the Manager) or signs on behalf of the Company hereby creating a commitment by the Company towards
a third party or another Shareholder shall be fully liable towards such third party or Shareholders for the amount of such
commitment. The liability of a Limited Shareholder under this paragraph is therefore not limited to the amount of the
nominal value of all A Shares (including share premium) and C Shares, respectively, held by such Limited Shareholder.

Art. 8. Form of Shares. Shares will only be issued in registered form and shall be issued only upon acceptance of the

subscriptions and subject to the receipt of payment in full in respect of such Shares.

Upon request, any Shareholder will, following acceptance of the subscription and receipt of payment in respect of such

Shares by the Company, be sent a confirmation of its shareholding.

All issued Shares shall be registered in the register of Shareholders (the «Register»), which shall be kept by the Manager

(or by one or more persons designated for such purpose by the Manager) and the Register shall contain the name of each
Shareholder, his address details, the number and classes of Shares held by it and the amount paid up on each of such
Share.

Every transfer of Shares (including, but not limited to the sale, assignment, transfer, pledge, contribution, merger, spin-

off, liquidation or dissolution) shall be effected by written declaration of transfer to be inscribed in the Register, such
declaration to be dated and signed by the transferor and the transferee, or by persons holding suitable powers of attorney
to act therefore.

The Company may accept, and inscribe into the Register any transfer resulting from correspondence or other docu-

ments establishing the agreement of the transferor and the transferee.

Every  Shareholder  must  provide  the  Manager  with  an  address  to  which  all  notices  and  announcements  from  the

Company may be sent. Such address will be the address entered in the Register.

Each Limited Shareholder will, without undue delay, notify the Company at its registered office in writing of any changes

to his or its name or address details to allow proper amendment of the Register.

If a Shareholder does not provide such address details, the Manager (or one or more persons designated for such

purpose by the Manager) will enter such circumstance in the Register and the Shareholder's address will be deemed to

32164

be at the registered office of the Company or such other address as may be so entered in the Register by the Manager
from time to time, until another address shall be provided to the Manager by such non-notifying Shareholder.

Art. 9. Transfer of Units - Transfer Restrictions - Redemption. Every transfer of Units shall be effected by written

declaration of transfer to be inscribed in the Register, such declaration to be dated and signed by the transferor and the
transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. The Manager (or one or more persons
designated for such purpose by the Manager) may accept, and inscribe into the Register, any transfer resulting from
correspondence or other documents establishing the agreement of the transferor and the transferee.

A Shares  shall  only  be  transferred to the extent  that  the  proportionate  number  of  CPECs  and/or  PECs  are also

transferred thus always resulting in the transfer of Unit(s).

C Shares are freely transferable subject to the prior approval by the Unlimited Shareholder.
9.1 Pre-emption Right
A Limited Shareholder (the «Selling Shareholder») wishing to sell any or all of its Units (the «Offered Units») to another

Shareholder or to a bona fide third party offeror (the «Offeror») must give written notice of such offer (the «Offer») to
the Manager. Such notice must set out the details of the, upon acceptance, binding Offer including the number of the
Offered Units and the sales price per Offered Unit (the «Agreed Terms»).

The Manager shall, within ten (10) Business Days of receipt of such notice, offer the Offered Units to the other Limited

Shareholders on the Agreed Terms in proportion to their respective amounts of Committed Contributions. Such notice
to the other Limited Shareholders shall be dispatched by registered letter. The Offered Units shall be offered for a period
as the Manager shall reasonably determine, however, being not less than ten (10) Business Days and no more than thirty
(30) Business Days beginning from the date of receipt of the registered letter.

Other Limited Shareholders wishing to accept the Offer shall notify the Manager of the number of Offered Units (up

to their maximum entitlement) following the instructions given in the notice dispatched by the Manager. Such Limited
Shareholder(s) should also indicate whether and how many additional Offered Units it would be willing to purchase on
the Agreed Terms.

If not all of the other Limited Shareholders accept the Offer in full, the Manager shall arrange that the excess Offered

Units shall be sold to those Limited Shareholders which have indicated, pursuant to the preceding paragraph, their will-
ingness to purchase additional Offered Units. Such additional Offered Units shall be sold to such Limited Shareholders in
proportion to their respective Committed Contributions and, as to any extra, in proportion to the number of further
Offered Units each such Limited Shareholder is willing to purchase.

The Manager shall, as soon as the Offer closes, notify the Selling Shareholder of the number of the Offered Units,

which the other Limited Shareholders have agreed to purchase. The Selling Shareholder shall then sell such number of
the Offered Units and additional Offered Units to the other Limited Shareholders.

The Selling Shareholder may then sell the remainder Offered Units, if any, or all Offered Units if no other Limited

Shareholder indicated its willingness to purchase Offered Units, to the Offeror provided that, within ten (10) Business
Days following the end of the period indicated in the above-mentioned registered letter dispatched by the Manager to
the other Limited Shareholders, (i) such sale is effected on Agreed Terms including respective payment of the Offered
Units by the Offeror, (ii) the Offeror provides sufficient identification documentation to identify its ultimate beneficial
owners (know-your-customer) to the Manager, (iii) the Offeror becomes a party to the Shareholders' Agreement, and
(iv) the Manager's approval of the transfer, as further described in the below paragraph, is not denied.

Any transfer of Units whether to the other Limited Shareholders or to the Offeror shall require the prior approval

of the Manager. The Manager may however only deny approving or registering such transfer within the time period
mentioned in the preceding paragraph if reasons reveal, which indicate that such transfer would be harmful or diametrical
to (i) the proper economic development of the Company, (ii) the investment interests of existing Shareholders, and (iii)
the accomplishment of the corporate object of the Company. In case of denial of the transfer, the Manager shall offer the
Offered Units on Agreed Terms to the Unlimited Shareholder or any other person including the Company subject to
applicable Luxembourg law.

Upon effect of the transfer of the Offered Units to a new Limited Shareholder and its adherence to the Shareholders'

Agreement, the Limited Shareholder will take over all Committed Contributions of the Selling Shareholder, regardless
whether such Committed Contributions are yet fully paid and/or completely or partly called for drawdown by the Manager
in accordance with these Articles and the provisions of the Shareholders' Agreement. In case the Manager denies approval
and registration of the transfer as described in the preceding paragraph, the Selling Shareholder will remain liable for full
payment of the Committed Contributions.

The provisions of this Article 9.1 shall not apply in case of transfer of Units by a Selling Shareholder to a legal entity

Controlled by such Selling Shareholder (or by the legal entity Controlling such Selling Shareholder). The Manager shall
have the right to verify the existence of such relationship between the Selling Shareholder and the Offeror. In order to
carry out verification, the Selling Shareholder shall provide the Manager with all relevant, necessary and reasonable in-
formation enabling the Manager to clarify on the Control and structure situation of the Selling Shareholder's relationship
to the Offeror. If such information will not be provided or deemed to be insufficient to clarify on the Control situation
by the Manager, the exemption established by this paragraph will not apply. For the purpose of this paragraph, «Control»,

32165

«Controlled», or «Controlling» shall mean the ownership of more than fifty per cent (50%) of the voting rights of a
company.

9.2 Drag-Along Right
If a firm offer from a bona fide third party purchaser (the «Purchaser») to purchase at least sixty-six per cent (66%)

of the existing Units of the Company (the «Purchased Units») is received by a Shareholder (the «Dragging Shareholder»),
the Dragging Shareholder shall be entitled, by serving a written notice to the Manager (the «Drag Along Notice»), to
require the other Limited Shareholders to sell, in proportion to their respective shareholding in the Company, all or part
of their Units, at the same terms and conditions (including the consideration per Purchased Unit) as specified by the
Purchaser in its offer to the Dragging Shareholder.

The written notice to the Manager must sufficiently identify the Purchaser, refer to the purchase price per Unit and

indicate the date and venue of the closing of the purchase and payment of the purchase price («Offer Terms»).

The Manager will inform the other Limited Shareholders on the offer to purchase the Purchased Units in writing by

registered letter. Such registered letter must be dispatched within ten (10) Business Days upon receipt of the Drag Along
Notice dispatched by the Dragging Shareholder.

On the date of closing as identified in the written notice and the registered letter, the other Limited Shareholders shall

deliver their Units to the Purchaser, together with all other documents relating to such Units, e.g. CPECs and/or PECs
documentation. The other Limited Shareholders will further indicate the bank account details for the payment of the
purchase price by the Purchaser.

Promptly after the conclusion of the purchase, the Dragging Shareholder shall provide the other Limited Shareholders

with written evidence of such purchase and confirm that the respective payments for the purchase price were valued to
the other Limited Shareholders bank accounts.

All costs and expenses in connection with such purchase shall be borne by the Dragging Shareholder and the other

Shareholders pro rata to the number of Units included by each of the Shareholders in such purchase.

9.3 Tag-Along Right
If at any time a Limited Shareholder (the «Transferring Shareholder») transfers to any third party (the «Buyer») fifty

per cent (50%) or more of the total amount of Units in the Company (the «Sale»), the other Limited Shareholders will
have the right to sell their own Units to the Buyer in proportion to the number of Units transferred by the Transferring
Shareholder.

In such a case the Transferring Shareholder shall provide the Manager with an offer notice sufficiently identifying the

name  and  residence  of  the  Buyer  and  the  terms  and  conditions  of  the  Sale  as  negotiated  between  the  Transferring
Shareholder and the Buyer.

The Manager will inform the other Limited Shareholders in writing by registered letter on the Sale and their right to

sell their Units to the Buyer. Such registered letter must be dispatched within ten (10) Business Days upon receipt of the
written notice by the Transferring Shareholder.

The other Limited Shareholders have the right to agree to sell their respective Units by informing the Manager in

writing hereof within thirty (30) Business Days following the receipt of the Manager's registered letter. The Manager shall
inform the Transferring Shareholder immediately after the lapse of the thirty (30) Business Days on any reply notices
received from other Limited Shareholders. For every such Limited Shareholder having thus confirmed to sell its respective
Units as part of the Sale, the Transferring Shareholder shall be obliged to include in the Sale the number of Units set forth
in the reply notice(s) of the other Limited Shareholders at not less than one hundred per cent (100%) of the purchase
price per Unit as specified in the offer notice sent by the Transferring Shareholder to the Manager, and in any event on
substantially the same terms and conditions set forth in such offer notice.

If none of the other Limited Shareholders replies within thirty (30) Business Days of receipt of the Manager's registered

letter or renounce the use of their tag-along right, the Transferring Shareholder may sell its Units to the Buyer. After
closing the Sale, the Transferring Shareholder shall inform the other Limited Shareholders on the sale by written evidence.

Upon effect of the transfer of the Transferring Shareholder's Units to the Buyer, such Buyer will sign a form of ad-

herence to accede to the Shareholders' Agreement and the Buyer will take over all Committed Contributions of the
Transferring Shareholder, regardless whether such Committed Contributions are yet fully paid and/or completely or
partly called for drawdown by the Manager in accordance with these Articles and the provisions of the Shareholders'
Agreement.

All costs and expenses in connection with the Sale shall be borne by the Transferring Shareholder and the other Limited

Shareholders pro-rata based on the number of Units included by each of the Limited Shareholders in the Sale.

9.4 Transfers initiated by Manager
Upon  request  by  a  Limited  Shareholder  to  search  a  purchaser  of  all  or  some  of  its  Units,  the  Manager  shall  use

reasonable endeavours to find a purchaser or purchasers for such Units. In such case, the Manager shall conduct any
negotiations for the sale of all or some of such Units. The requesting Limited Shareholder is obliged to compensate the
Manager for all reasonable costs and expenses incurred as a consequence of conducting the Limited Shareholders request
regardless whether the Units will be sold or not.

32166

If the Manager successfully initiates, negotiates and completes (i) a sale as mentioned in the preceding paragraph, or

(ii) any other sale of Units from a Limited Shareholder to a third party without having received a preliminary request by
a Limited Shareholder, the Manager shall be entitled to charge to the selling Limited Shareholder a fee amounting to two
per cent (2%) of the aggregate sales price paid for such Units.

Art. 10. Further Restriction on the Units. The Limited Shareholders will procure that their Units will not become

subject to and the Manager will not permit to have the Units become subject to any liens, charges, security interests or
encumbrances, except as set forth in these Articles and the Shareholders' Agreement.

Art. 11. Voting Rights. Each Share carries one vote at all general meetings of Shareholders.
All Shares will vote as one class except on any proposed amendments to the Articles exclusively affecting the respective

rights of one share class.

Art. 12. General Meetings of Shareholders. Annual and extraordinary general meetings of Shareholders have the power

to resolve on any matters attributed to the general meeting by Luxembourg law. In addition, the general meeting shall
resolve on all matters for which the Manager is not given decisive competency in these Articles.

The annual general meeting of Shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or

at such other place in Luxembourg as may be designated in the notice of the meeting, which is to be dispatched by the
Manager, at least eight (8) Business Days before the annual general meeting is held, by way of registered letter addressed
to each Shareholder using address details of Shareholders as are shown in the Register.

The annual general meeting is to be held on the third Wednesday of March of each year at 2 p.m. If such day is not a

Business Day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following Business Day in Luxembourg.

The Unlimited Shareholder and the Manager may, whenever they think fit, convene an extraordinary general meeting

of Shareholders. In addition, the Manager shall convene an extraordinary general meeting upon written request (indicating
the proposed agenda of the meeting) of Limited Shareholders holding at least ten per cent (10%) of the total issued share
capital of the Company.

Extraordinary general meetings may be held at such place and time in Luxembourg as may be specified in the respective

convening notices, which notices are to be dispatched by the Manager as registered letters at the latest eight (8) Business
Days before such extraordinary general meeting is held.

Art. 13. Conduct of General Meetings. All general meetings shall be presided over by the Unlimited Shareholder or a

representative appointed by the Unlimited Shareholder.

The quorum and voting majority required by Luxembourg law shall govern the general meetings of Shareholders of

the Company, unless otherwise provided herein.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a general meeting of Shareholders

duly convened will be passed by a simple majority of those Shareholders present or represented, it being further under-
stood that any resolution shall validly be adopted only with the approval of the Unlimited Shareholder.

The Unlimited Shareholder may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take

part in any meeting of Shareholders.

Art. 14. Management of the Company. The Manager may exercise all powers given to it under these Articles. In addition

it may exercise all powers not given to the general meeting of Shareholders by the Articles or by mandatory Luxembourg
law.

The Manager undertakes not to resign from its capacity as manager of the Company.
The Manager may not be removed from its capacity as manager of the Company in any event except in the case of (i)

a material breach of the Articles, or (ii) gross negligence or wilful misconduct in exercising its powers under these Articles.

In such cases removal may be undertaken by decision of the Limited Shareholders taken in general meeting of Limited

Shareholders deliberating with the attendance quorum of two-thirds (2/3) of the issued A shares and the voting majority
of two-thirds (2/3) of the votes present or represented at such general meeting of Limited Shareholders. The resolution
taken in such Limited Shareholders general meeting shall be validly passed without the approval of the Unlimited Share-
holder.

In case of removal of the Manager, the Unlimited Shareholder shall also procure that any B Shares held by it at the

time it is removed from office are forthwith transferred to any successor manager that may appointed for the management
of the Company and shall sign all acts, contracts and deeds and in general do all things that may be necessary to implement
such transfer.

In case of removal as well as in the event of the Manager legal incapacity or inability to act, the supervisory board

(Conseil de Surveillance) of the Company (the «Supervisory Board») will appoint an administrator, who may or may not
be  a  Shareholder,  who  shall  adopt  urgent  measures  and  those  of  ordinary  administration  until  a  general  meeting  of
Shareholders is held appointing a new manager. The administrator shall, within fifteen (15) Business Days of his appoint-
ment, convene a general meeting of Shareholders in accordance with these Articles, having on its agenda to elect another
Manager of the Company also becoming Unlimited Shareholder, it being understood that, in derogation to Article 12,

32167

resolutions of the Shareholders' meeting shall be validly passed without the favourable vote of the former Unlimited
Shareholder.

Semi-annually, the Manager shall provide the Supervisory Board with a statement summarising the assets and liabilities

of the Company.

Art. 15. Powers of the Manager. The Manager shall have exclusive responsibility for the management and control of

the business and affairs of the Company and shall have the power and authority to do all things necessary to carry out
the purposes of the Company and shall devote as much of its time and attention thereto as shall reasonably be required
for the management of the business and affairs of the Company and shall carry on and manage the same with the assistance
from time to time of such agents, assistants or other employees of the Company as it shall deem necessary.

The Manager may therefore resolve on all matters assigned to him by these Articles and Luxembourg law except for

any powers to be exercised by the general meeting of Shareholders under mandatory Luxembourg law.

The Manager shall have the right to delegate such of its powers and authorities as are set out in this Article to special

attorneys, provided that the Manager shall not be entitled to delegate any of the decisions regarding investment strategy
set out in letters (b), (c) and (d) below of this Article.

The Limited Shareholders are not authorised to perform any act related to the management or control of the business

and affairs of the Company and shall have no right or authority to act for the Company or to take any part in, or in any
way to interfere in, the conduct or management of the Company other than by exercising their voting rights as Limited
Shareholders.

Without prejudice to the generality of the above-mentioned paragraphs of this Article and without limitation, the

Manager shall have full power and authority on behalf of the Company (including the power to bind the Company):

a) to disburse in advance the administrative costs associated with the establishment of the Company, including, but

not limited to, legal, tax, accounting, consulting, duplicating, and printing, telephone, telex and facsimile, postage, air freight,
travel and other expenses and fees paid to or incurred to third parties by the Manager in organising the Company, the
filing for granting of all necessary authorization and registration of the Company, and any fund raising activity including
third party fund raising commission, and the promotion of investments in the Company, but shall be entitled to a refund
of such expenses by the Company up to an amount of three hundred fifty-five thousand euro (EUR 355,000.-).

Costs in excess of this amount pertaining to the establishment of the Company shall be borne by the Manager in its

capacity as Unlimited Shareholder of the Company.

b)  To,  at  its  own  discretion,  implement  the  investment  policy  of  the  Company  on  the  basis  of  the  advice  of  the

Investment Committee and Advisor (both terms as defined further below) and the contents of the investment memo-
randum of the Company (the «Information Memorandum») as amended from time to time and to purchase, sell, exchange
or otherwise dispose of investments for the account of the Company and, where appropriate, to give warranties and
indemnities on behalf of the Company in connection with any such sale, exchange or disposal;

c) To evaluate and to negotiate investment opportunities and to monitor investee companies;
d) To enter into underwriting commitments to acquire investments in a syndicate with other Limited Shareholders

and to acquire investments in excess of the requirements of the Company with a view to selling the excess to other
Limited Shareholders;

e) To participate in the management and control of investee companies, where appropriate;
f) To provide or procure office facilities and executive staff and office equipment to facilitate the carrying on of the

business of the Company;

g) To issue drawdown notices in connection with Units, to receive payments for Shares and Units subscribed by Limited

Shareholders and to receive investment income and other funds arising from investments. For the purposes of the present
Articles, «Drawdown Notice» shall mean a written drawdown notice issued by the Manager and addressed to the Limited
Shareholders at their address as mentioned in the Register, this notion may be specified by the terms of a Shareholders'
Agreement;

h) To open, maintain and close bank accounts for the Company and to draw cheques and other orders for the payment

of moneys;

i) To enter into, make and perform such deeds, contracts, agreements and other undertakings and to give guarantees

on behalf of the Company and to do all such other acts as it may deem necessary and advisable for or as may be incidental
to the conduct of the business of the Company;

j) To borrow money under short-term borrowing and, without limitation, to make, issue, accept, endorse and execute

promissory notes, drafts, bills of exchange and other instruments and evidence of indebtedness, and to secure the payment
thereof by mortgage, pledge or assignment of or security interest in all or in part of the securities and other property
then owned or thereafter acquired by the Company;

k) To issue, redeem and convert CPECs and/or PECs and any other debt instrument;
l) To pay any expenses incurred in relation to the business of the Company including, without limitation, all the costs

and expenses referred to in these Articles in fine as to be borne by the Company;

m) To commence or defend litigation that pertains to the Company or to any of the Company assets;

32168

n) To maintain the Company's records and books of account at the Company's principal place of business;
o) To make distributions of cash and in specie to the Limited Shareholders and the Unlimited Shareholder in accordance

with the terms of both any Shareholders' Agreement and these Articles as resolved by the Shareholders' general meeting;

p) To enter into investment advisory agreements and management agreements and related agreements;
q) To engage employees, independent agents, lawyers, accountants, custodians, financial advisers and consultants as it

may deem necessary or advisable in relation to the affairs of the Company, including without limitation, any company
affiliated with the Unlimited Shareholder, to perform all or any of the activities set forth in this Article;

r) Generally to communicate with the Limited Shareholders and to report to the Limited Shareholders at such times

as it shall think fit, provided all Limited Shareholders are treated equally, and to represent the Company in all things;

s) To carry out periodic valuations of the Company assets and to furnish such valuations and other financial statements

to the Limited Shareholders;

t) To admit additional Limited Shareholders to the Company and to admit substitute Limited Shareholders to the

Company in accordance with these Articles and the provisions of the Shareholders' Agreement;

u) Pending investment in accordance with the objectives described in such documents the Manager or Unlimited

Shareholder may agree with the Limited Shareholders, to place amounts drawn down in such deposit accounts or to
invest the said amounts in such instruments as the Manager may determine;

v) To carry out such checks and procedures with regard to Limited Shareholders as may be required by any relevant

money laundering rules, regulations or guidelines set out by governmental bodies or financial institutions;

w) Subject to any restrictions contained in these Articles, to do all or any other acts as are required to be carried out

by the Manager or as are necessary or desirable in the reasonable opinion of the Manager in furtherance of the foregoing
provisions for the purposes of implementing the corporate object of the Company, the present Articles, and any Share-
holders' Agreement, as applicable.

Art. 16. Indemnification of the Manager. The Manager and its officers, managers, shareholders, agents, advisors and

employees and any person nominated by the Manager to be a director or manager of any company in which the Company
holds or held an investment shall each be entitled to be indemnified out of the assets of the Company in the case of any
liabilities, actions, proceedings, claims, costs, demands and expenses (including legal fees) incurred or threatened by reason
of it or him being or having been an officer, shareholder, partner, agent, advisor or employee of the Manager or a director
or manager of any company in which the Company holds or held an investment or a member of the Investment Committee
(as defined below) provided, however, that such person shall not be so indemnified in respect of any matter resulting
from its wilful misconduct, bad faith or reckless disregard for its or his obligations or duties in relation to the Company
or, in the case of the Manager, its gross negligence or wilful misconduct.

The Manager shall not be liable to any Limited Shareholder or to the Company for any loss to the Company or the

Limited Shareholder arising in connection with the services to be performed by it save in respect of any matter resulting
from its gross negligence or wilful misconduct. The Manager will not be liable to any Limited Shareholder or to the
Company for the dishonesty or bad faith of any agent acting for the Manager or for the Company provided that such
agent was selected, engaged and retained by the Manager, as the case may be, applying reasonable care.

The Manager shall advance the administrative costs associated with the establishment of the Company, including, but

not limited to, legal, tax, accounting, consulting, duplicating, and printing, telephone, telex and facsimile, postage, air freight,
travel and other expenses and fees paid to or incurred to third parties by the Manager in organising the Company, the
filing for granting of all necessary authorisation and registration of the Company, and any fund raising activity including
third party fund raising commission, but shall be entitled to a refund of such expenses by the Company up to an amount
of three hundred fifty-five thousand euro (EUR 355,000.-). Costs exceeding this amount shall be borne by the Manager.

The Manager will bear the administrative and other costs associated with its general duties including the overhead of

the Manager's board of managers and shall not be entitled to recover those from the Company. The Company will bear
all other expenses relating to its operation, including fees, costs and expenses related to the purchase, holding and sale
of portfolio Investments, unconsummated transaction expenses and broken deals fees, taxes, fees of auditors, legal coun-
sels, custodians, consultants and expenses incurred in connection with meetings of the Investment Committee (as defined
below). The Company will bear third party fees and expenses incurred by the Company such as legal, audit, printing,
taxation of the Company, the costs of acquiring or disposing of Investments and costs associated with uncompleted
transactions, to the extent that these are not borne by investee companies.

Art. 17. Remuneration of the Manager. For the remuneration of its services rendered to the Company, the Manager

will be paid a placement fee (the «Placement Fee») at his own discretion. The Placement Fee can amount up to two per
cent (2%) of the total amount of Committed Contributions of the Limited Shareholders and is payable upon drawdown
(s) of parts or the total of the Committed Contributions.

The Manager will further be paid an annual management fee (the «Management Fee») equal to two percent (2%) of

the aggregate par value of the paid-up Units subscribed by Shareholders, plus any taxes to be paid by the Manager on the
Management Fee. The Management Fee is subject to semi-annual adjustment to reflect changes in the consolidated fair
market value of the Units based on the Company's most recent approved and published financials, which will take into
account any asset revaluations based on third party valuations. Such Management Fee shall be paid by the Company to

32169

the Manager each year starting from the incorporation of the Company until the Company's dissolution. The Management
Fee may be paid in advance on a semi-annual basis at the discretion of the Manager but not prior to the beginning of any
respective semester.

The Manager will further be paid a commitment fee (the «Commitment Fee») equal to zero point five percent (0.5%)

per annum on the yet unpaid amount of the Committed Contributions. Should any taxes become payable on the Com-
mitment Fee, then such taxes shall be grossed up with, and not deducted from, such Commitment Fee. The Commitment
Fee begins to accrue on the date of the signing of a commitment letter by each Limited Shareholder and ends when the
acquisition period lapses, being on March 31, 2010.

In circumstances where a third party real estate broker would have customarily be retained but could be avoided due

to the intervention of the Manager or one of its affiliated companies, the latter or one of its affiliated companies will be
paid a brokerage fee (the «Brokerage Fee») of up to 1% plus any VAT or similar taxes based on the Investment or
divestment volume of such transaction.

Upon  request  by  a  Limited  Shareholder  to  search  a  purchaser  of  all  or  some  of  its  Units,  the  Manager  shall  use

reasonable endeavours to find a purchaser or purchasers for such Units. In such case, the Manager shall conduct any
negotiations for the sale of all or some of such Units. The requesting Limited Shareholder is obliged to compensate the
Manager for all reasonable costs and expenses incurred as a consequence of conducting the Limited Shareholders request
regardless whether the Units will be sold or not. If the Manager successfully initiates, negotiates and completes (i) a sale
as mentioned in this paragraph, or (ii) any other sale of Units from a Limited Shareholder to a third party without having
received a preliminary request by a Limited Shareholder, the Manager shall be entitled to charge to the selling Limited
Shareholder a fee amounting to two per cent (2%) of the aggregate sales price paid for such Units plus any VAT or similar
taxes.

Art. 18. Signatories. The Company will be bound by the signature of the Manager or any person or persons designated

for signature on a general or specific basis by the Manager.

Art. 19. Supervisory Board (Conseil de Surveillance). The affairs of the Company and its financial situation including

particularly its books and accounts and any financial operation shall be supervised by the Supervisory Board composed
of at least three (3) members.

The members of the Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of Shareholders subject to the

approving vote of all holders of B Shares for a period of one (1) year or until their successors are elected, provided
however, that any of the members of the Supervisory Board may be removed with or without cause and/or replaced at
any time by a resolution of the general meeting of Shareholders adopted by the majority of Shareholders present or
represented at such general meeting.

Auditors appointed by the general meeting of Shareholders may assist the Supervisory Board in the performance of

its duties.

The Supervisory Board may be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine and may

authorise any actions of the manager that may, pursuant to law or regulations or under these Articles of the Company,
exceed the powers of the Manager.

The general meeting of Shareholders at which the members of the Supervisory Board are appointed shall also determine

the remuneration of the members of the Supervisory Board.

The Supervisory Board shall be convened from time to time at the discretion of each of its members or the Manager.
Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at

least eight (8) Business Days in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which
case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent
in writing or by cable or telegram or telex or telefax of each member. Separate notice shall not be required for the
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the Supervisory Board.

Any member may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing or by cable or telegram, telex,

telefax or other electronic transmission another member of the Supervisory Board as his representative.

The Supervisory Board may only deliberate or act validly if at least the majority of its members are present either in

person or by proxy. Any member of the Supervisory Board who participates in the proceedings of a meeting of the
Supervisory Board by means of a communications device (including a telephone), which allows all the other members of
the Supervisory Board present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communi-
cations device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting
and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members of the Supervisory Board present

either in person or by proxy at such meeting.

The Supervisory Board may inspect, but not remove, the books, correspondence, minutes and, in general, all the

records of the Company.

Semi-annually, the Manager shall provide the Supervisory Board with a statement summarising the assets and liabilities

of the Company.

32170

The Supervisory Board must report to the general meeting of Shareholders on the results of the mandate entrusted

to it, making such recommendations as it considers fit, and must inform the Shareholders meeting on the method adopted
by it for the verification of the accounts of the Company.

The Supervisory Board may give its opinion on any matters that the Manager refers to it.

Art. 20. Investment Committee and Advisor. The Manager, in carrying out its management functions shall be assisted

by an investment committee (the «Investment Committee») and by one or more advisors (hereinafter indistinctly the
«Advisor»).

20.1 Investment Committee
The Manager has the power to establish and to dissolve the Investment Committee. The Manager has further the

power to appoint and remove any member of the Investment Committee ad nutum.

The Investment Committee shall be composed of a number of members, either natural persons or legal entities, ranging

from three (3) to seven (7). The Investment Committee will consist of (i) at least two (2) members of the board of
managers of the Manager and (ii) recognized real estate and financial specialists to be named by the Manager. Members
of the Investment Committee are appointed for a term of three (3) years.

The Investment Committee shall scrutinize, review and evaluate every investment and divestment decision of the

Company and shall adopt a framework policy for all investment proposals. It shall provide the Manager with investment
guidelines, which shall apply to identifying, researching and prospecting different investment opportunities in a specific
field.

The Investment Committee will meet on a regular basis (at least four (4) times a year) and as necessary from time to

time to carry out its duties.

Each member of the Investment Committee shall remain in office until the end of his office in the board of managers

of the Manager.

If any of the members of the Investment Committee ceases from his/her office, for any reason whatsoever, a new

member appointed by the Manager shall promptly replace such member.

The Manager may participate in the meetings of the Investment Committee, but it will not be entitled to cast votes in

the same meeting, nor shall it be accounted for the purposes of the reaching a quorum.

The Investment Committee shall adopt any resolutions with the favourable vote of the majority of its members.
The Company will not have any obligation to invest in any company or asset identified by the Investment Committee

nor shall it in any way be bound to follow advice given by the Investment Committee to the Manager.

The Company shall compensate the members of the Investment Committee for the performance of their duties as

indicated herein and the expenses incurred in connection with the review and due diligence of the investment opportu-
nities, including costs of external advisors, travel, accommodation and offices expenses; provided that the total compen-
sation  shall  not  exceed  an  amount  of  EUR  350,000.-  per  annum.  Any  expense  on  top  of  this  fixed  amount  shall  be
exclusively borne by the Investment Committee, respectively its members.

20.2 Advisor
The Advisor is appointed and removed by the Manager.
The Advisor shall advise the Manager with respect to investment and divestment decisions, strategic focus, investment

objectives and investment policy. The Company will not have any obligation to invest in any company or asset identified
by the Advisor nor shall it in any way be bound to follow advice given by the Advisor to the Manager.

The Advisor may work together with a pool of external advisors. The Advisor shall propose the appointment of

external advisors to the Manager for approval.

The Advisor may participate in meetings of the Investment Committee unless otherwise decided by the Investment

Committee.

The Advisor has no voting power with respect to any decisions made by the Investment Committee or the Manager.
Neither the Advisor nor any of its employees will be authorised to enter into any contract on behalf of the Manager

of the Company, to carry on binding negotiations or otherwise to act on behalf of or engage or commit the Manager or
the Company.

Art. 21. Accounting year, Accounts. The accounting period of the Company shall begin on the first of October of each

year and shall terminate on the thirtieth of September of the following year, with the exception that the first accounting
year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall end on September 30, 2007.

The term «Accounting Period» used herein shall mean a period ending on (and including) the Accounting Date and

beginning on the day of incorporation or the day following the preceding Accounting Date. The term «Accounting Date»
used herein shall mean September 30, 2007 and September 30 of each year thereafter or (in the case of the last accounting
Period) the date of the closing of the liquidation of the Company.

The Manager shall prepare, or shall procure some duly qualified firm or person to prepare the financial statements of

the Company in respect of each Accounting Period in accordance with generally accepted accounting principles and the
provisions of Luxembourg law, including a balance sheet and profit and loss account.

32171

The accounts shall be denominated in euro. The Manager will cause such accounts to be audited by the Auditor selected

by the Manager and appointed by the general meeting of Shareholders. A set of the audited accounts including the report
of the Auditors shall be furnished to each Shareholder at least fifteen (15) Business Days prior to the annual general
meeting of the Company.

In addition, within ninety (90) Business Days after the end of each semester of an Accounting Period and within six

(6) months after the end of each Accounting Period, the Manager shall prepare and send, or procure to be prepared and
sent, to each Shareholder a report comprising a statement on the investments and asset situation of the Company as at
the end of such period and details of the investments purchased and of the investments sold and otherwise disposed of
during the relevant period. The report relating to the end of each Accounting Period shall be audited by the Auditor.

Art. 22. Legal Reserves - Payment of Interest and Dividends - Distributions. From the annual net profits of the Company,

five per cent (5%) shall be deducted and appropriated to the legal reserve. This deduction shall cease to be compulsory
when the amount of the legal reserve fund has reached ten per cent (10%) of the subscribed share capital (excluding any
issue premium).

Each year and for the first time within eighteen (18) months after the first investment, the Manager shall propose that,

after deduction of the amount allocated to the legal reserve as well as of any sums that the Manager deems appropriate
to allocate to a special reserve, the balance of the distributable sums shall be distributed in the following order:

1) Firstly, to all Limited Shareholders in proportion to their Committed Contributions yet paid to the Company until

the cumulative amount distributed equals the aggregate of the following:

a. Paid in Committed Contributions; and
b. A preferred return (the «Preferred Return») on amounts paid in under point 1) a. above at the rate of eight per

cent (8%) per annum from the date of drawdown of the paid in Committed Contributions; and

2) Secondly, one hundred per cent (100%) of the remainder to the holder(s) of C Shares until the holder(s) of C Shares

has received twenty per cent (20%) of the aggregate amount distributed to the Limited Shareholders pursuant to 1) b.
above; and

3) Thirdly, following distribution under 1) and 2) above, eighty per cent (80%) of the remainder of the distributable

sums shall be paid to all Limited Shareholders in proportion to their paid in Committed Contributions and twenty per
cent (20%) of the remainder shall be paid to the holder(s) of C Shares as dividend incentive; and

4) Fourthly, any outstanding balance after payment of sums under 1) through 3) above, if any, shall remain at the

disposition of the general meeting of Shareholders.

Distributions under 1) through 3) above shall be paid at such time as determined by the Manager and distributions

under 4) above shall be paid at such time as determined by the general meeting of Shareholders.

Distributions may be paid in cash or by way in specie during the life of the Company starting at the end of each financial

year and at the end of the Investment Period as the Manager shall, subject to the provisions set out below, determine
from time to time.

Distributions under 1) through 4) above shall be arranged for in the following manner:
- the Manager shall first give the Shareholders written notice of a contemplated distribution at least ten (10) Business

Days prior to the proposed date of distribution, specifying the date of the proposed distribution, the assets to be dis-
tributed (subject to any confidentiality obligations) and the value to be attributed to the assets in question (or an indication
of the basis on which such value is to be calculated as at the date of the proposed distribution);

- distributions in specie of securities of any class shall be made on the same basis as distributions of cash such that any

recipient Shareholder shall receive a proportionate amount of the total securities of such class available for distribution,
or (if such method of distribution is for any reason impracticable) such that each such Shareholder shall receive as nearly
as possible a proportionate amount of the total securities of such class available for distribution together with a balancing
payment in cash in the case of any Shareholder who shall not receive the full proportionate amount of securities to which
he would otherwise be entitled under this Article; and

- any such distribution in specie shall be applied in the order set out hereinabove at the value of the assets concerned.
For the purpose of this Article, a reference to payments or distributions to the Limited Shareholders or the Unlimited

Shareholder shall be a reference to the gross payments or distributions to such persons, taking no account of amounts
required to be withheld by the Company in respect of such payments.

Art. 23. Termination and Liquidation. The Company will be wound-up upon the happening of any of the following

events:

(a) the removal of the Manager in its capacity as the manager pursuant to Luxembourg law and the provisions of these

Articles, unless it is immediately replaced by another manager as described in these Articles; or

(b) at any time upon a resolution of the Shareholders' general meeting following a proposal made by the Manager or

Unlimited Shareholder.

In the event of a winding up of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may

be physical persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders effecting such winding up. Such meeting shall
determine their powers and their remuneration.

32172

For the purpose of these Articles «Investment Period» means the period commencing on the incorporation of the

Company and ending on March 31, 2015 or on any date thereafter in case of extension by the Manager.

Liquidators shall distribute the net proceeds of liquidation whether consisting in cash or in any assets in the following

order:

1) Firstly, full repayment of the par value of the CPECs and/or PECs (except in respect of those CPECs held by

Defaulting Limited Shareholders);

2) Secondly, full repayment of the issue price of the A and C Shares, (except in respect of those A Shares and C Shares

held by Defaulting Limited Shareholders);

3) Thirdly, full repayment of the issue price of the B Shares;
4) Fourthly, full repayment of the issue price of the A and C Shares and the par value of the CPECs and/or PECs held

by Defaulting Limited Shareholders; and

5) Fifthly, the remainder shall be paid to the holders (at the date of termination of the Company) of A and C Shares

(except in respect of those A and C Shares held by Defaulting Limited Shareholders) and B Shares in accordance with
the order provided in Article 22 1) through 4) of the present Articles.

Upon winding-up of the Company, the liquidators named by the general meeting of the Shareholders shall be entitled

to make distribution of assets in specie subject to the relevant provisions of Luxembourg law.

In the event of insolvency of the Company, the liability of the Limited Shareholders shall be limited to the amount of

the Committed Contributions regardless whether fully paid in or not.

Art. 24. Amendment of the Articles. These Articles may be amended from time to time by decision of the general

meeting of Shareholders and in accordance with Luxembourg law.

Amendments of the Articles require a quorum of at least fifty per cent (50%) of the existing share capital and a majority

of two-thirds (2/3) of the voting rights present or represented at the general meeting.

Art. 25. Laws Applicable. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the

Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, and related provisions.

<i>Transitional Provision

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the 30th of September

2008.

<i>Subscription

The Articles having thus been established, the appearing parties declare to subscribe to the entire capital as follows:

SYCAMORE LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Class «A» Share

EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,799 Class «B» Shares
EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 Class «C» Shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,900 Shares

The twenty-four thousand nine hundred (24,900) Shares have been fully paid up to the amount of one euro and twenty-

five cents (EUR 1.25) per share being thirty-one thousand one hundred twenty-five euro (EUR 31,125.-) and this amount
together with issue premium of ninety-eight euro and seventy-five cents (EUR 98.75) paid on the Class A Share results
in a total contribution in cash to the Company of thirty-one thousand two hundred twenty-three euro and seventy-five
cents (EUR 31,223.75).

As a result, the amount of thirty-one thousand two hundred twenty-three euro and seventy-five cents (EUR 31,223.75)

is as of now at the disposal of the Company as has been certified to the notary executing this deed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of its organization, are estimated at approximately four thousand euro (€ 4,000.-).

<i>Extraordinary General Meeting

After the Articles have thus been drawn up, the above named Shareholders have immediately proceeded to hold an

extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, the Shareholders passed the following
resolutions:

1) The registered office of the Company is fixed at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;
2) Has been elected Manager of the Company for an undetermined term:
EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à r.l., a limited liability company, société à responsabilité limitée, incorpo-

rated  under  the  laws  of  the  Grand-Duchy  of  Luxembourg,  having  its  registered  office  at  73,  Côte  d'Eich,  L-1450
Luxembourg.

3) Have been elected members of the Supervisory Board for an undetermined term:
a) Mr Fabien Wannier, born on July 18, 1977 in Bern (Switzerland), financial analyst, residing at Tour Eglantines/1075,

CH-3963 Aminona;

32173

b) Mr Stephan Wörnle, born on April 5, 1969, in Lausanne (Switzerland), financial analyst, residing at 30C, Chemin da

Pré Langard, CH-1223 Cologny; and

c) Mr Dan Amar, born on March 27, 1982 in Geneva (Switzerland), financial analyst, residing at 16, rue Le Corbusier,

CH-1208 Geneva.

4) Has been elected external auditor of the Company for purposes as mentioned in the articles of incorporation for

the accounting period until including September 30th, 2008:

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, registered at the Register of commerce of

Luxembourg section B, number 65.477.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English followed by a German version, on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present deed.

Follows the german version:

Im Jahre zweitausendundsieben am fünften Februar.
Vor Maître Paul Bettingen, Notar mit Amtssitz in Niederanven.

Erschienen:

1. EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, société à responsabilité

limitée,  gegründet  nach  dem  Recht  des  Großherzogtums  Luxemburg  durch  Gründungsurkunde  aufgenommen  durch
Notar Paul Frieders am 3. November 2006, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2429 vom 29. Dezember 2006, mit
Gesellschaftssitz in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer
B 121.666, hier vertreten durch Marcus Peter, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, durch eine am 2. Februar 2007
erteilte Vollmacht, und

2. SYCAMORE LUXEMBOURG S.A., eine Aktiengesellschaft, société anonyme, gegründet nach dem Recht des Groß-

herzogtums Luxemburg durch Gründungsurkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 9. Juni 2006,
veröffentlicht im Mémorial C unter der Nummer 1644 am 30. August 2006, mit Gesellschaftssitz in 73, Côte d'Eich,
L-1450  Luxemburg,  eingetragen  im  Handelsregister  Luxemburg  unter  der  Nummer  B  117.449,  hier  vertreten  durch
Marcus Peter, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, durch eine am 2. Februar 2007 erteilte Vollmacht.

Welche Vollmachten von dem Vertreter der oben benannten Parteien und dem unterzeichnenden Nota ne varietur

gezeichnet wurden und dieser Gründungsurkunde angeheftet bleiben, um mit dieser zusammen registriert zu werden.

Die oben benannten Parteien, vertreten wie oben angegeben, haben ihren Willen erklärt, durch diese Urkunde eine

Kommanditgesellschaft auf Aktien luxemburgischen Rechts, société en commandite par actions, zu gründen und die Sat-
zung dieser Gesellschaft wie folgt aufzuzeichnen:

Art. 1. Form. Es wird eine Kommanditgesellschaft auf Aktien luxemburgischen Rechts, société en commandite par

actions, mit der Firma EVEN RX PROPERTIES S.C.A. (im Folgenden die «Gesellschaft») zwischen den Gründungsparteien
und denjenigen Personen gegründet, welche der Gesellschaft in der Zukunft als Aktionär beitreten.

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Die Gesellschaft wird einen Investitionsperiode von acht (8) Jahren haben, welcher durch Entscheidung des Managers

(der «Manager») für eine Dauer von 1 oder 2 Jahren entsprechend der wirtschaftlichen Gegebenheiten verlängert werden
kann, um die Gewinne der Gesellschaft durch den Verkauf von Gesellschaftsvermögen zu optimieren.

Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst, sollte der Manager oder der Komplementär («Komplementär») insolvent werden

oder auf andere Weise aufgelöst und liquidiert werden.

Art. 3. Gesellschaftszweck. Das Kerngeschäft der Gesellschaft wird aus Investitionen in Grundstück und Immobilien

in der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz bestehen.

Investitionen können in Immobilienobjekte mit Bezug zu Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsbetreuung oder in

Anbieter im Gesundheitssektor getätigt werden.

Der Zweck der Gesellschaft ist (i) das Halten von Anteilen oder Beteiligungen, in jeglicher Form, entweder direkt oder

indirekt, in luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, (ii) der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder in anderer
Weise oder die Übertragung durch Verkauf, Austausch, oder sonst wie von Immobilien, Aktien, Schuldverschreibungen,
Schuldscheinen, Schuldtiteln und anderen Wertpapieren jeglicher Art, und (iii) die Ausübung der Eigentümerstellung,
Verwaltung, Entwicklung und des Managements dieser Portfolios.

Die Gesellschaft kann in der Begründung und Entwicklung finanzieller, industrieller und wirtschaftlicher Gesellschaften

jeglicher Gesellschaftsform partizipieren.

Die Gesellschaft kann in jeder Form Geld leihen, Schuldscheine und andere Schuldtitel ausgeben - eingeschlossen ohne

es  darauf  zu  begrenzen  -  Wandelschuldanleihen  («CPECS»),  Schuldanleihen  («PECs»)  oder  ähnliche  untergeordnete

32174

Schuldinstrumente mit oder ohne Zins. Die Gesellschaft kann des weiteren die Erträge, welche sie aufgrund der Ausgabe
dieser Schuldtitel erhält, nutzen, um diese den Tochtergesellschaften und Investmentvehikel der Gesellschaft zukommen
zu lassen und die Gesellschaft kann Sicherheiten für jede Art der Geldleihe begeben.

Generell kann die Gesellschaft jede kontrollierende und aufsichtsrelevante Maßnahme ergreifen und jegliche finanzielle,

wirtschaftliche und industrielle Operation, unabhängig davon, ob diese mit Immobilien oder Grundstücken in Zusam-
menhang steht, ausführen, welche die Gesellschaft für notwendig erachtet, um den Gesellschaftszweck zu erreichen und
zu entwickeln.

Art. 4. Gesellschaftssitz. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg begründet.
Der Gesellschaftssitz kann an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg durch gemeinsamen Beschluss des

Komplementärs und der Kommanditisten (die «Kommanditisten») (Komplementär und Kommanditisten werden hiernach
zusammen als «Aktionäre» bezeichnet) verlegt werden, wobei ein solcher Beschluss unter den Quorums- und Abstim-
mungsmechanismen gefasst werden muss, welche durch das luxemburgische Recht für den Fall einer Änderung der Satzung
vorgesehen sind.

Der Manager kann entscheiden, Zweigstellen oder andere Büros der Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg oder

im Ausland, ausgenommen Deutschland, einzurichten.

Sollten außergewöhnliche politische und wirtschaftliche Ereignisse oder ähnliche abnormale Umstände, welche die

normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Geschäftssitz oder die Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz
und  dem  Ausland  beeinträchtigen  oder  verhindern,  eintreten  oder  akut  sein,  so  kann  der  Manager  entscheiden  und
erklären, dass der Gesellschafssitz als vorübergehend ins Ausland verlegt gelten soll, bis diese außergewöhnlichen oder
abnormalen Umstände nicht mehr vorliegen.

Eine solche Entscheidung hat jedoch keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Eine solche Entscheidung

über den Transfer des Gesellschaftssitzes soll durch den Manager Drittparteien bekannt gemacht werden.

Art. 5. Aktienkapital und Genehmigtes Kapital. Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital in Höhe von einunddreissigtau-

send einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 31.125,-) eingeteilt in vierundzwanzigtausendneunhundert (24.900) Aktien
(die «Aktien») bestehend aus:

I) Einer (1) Klasse «A» Aktie mit einem Nominalwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25), ausge-

geben an den gründenden Kommanditisten (die «A Aktie(n)»);

II) vierundzwanzigtausend siebenundertneunundneunzig (24.799) Klasse «B» Aktien mit einem jeweiligen Nominalwert

von einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25), ausgegeben an den Komplementär (die «B Aktien»); und

III) einhundert (100) Klasse «C» Aktien mit einem jeweiligen Nominalwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cents

(EUR 1,25), (die «C Aktien»).

Zusätzlich zu dem ausgegebenen Aktienkapital wurde ein Aktienagio in Höhe von achtundneunzig Euro und fünfund-

siebzig Cents (EUR 98,75) auf die A Aktie eingezahlt.

Das gesamte Aktienagio wird einer speziellen Reserve zugeführt, welche, aufgrund und im Einklang mit einer in einer

Hauptversammlung der Aktionäre getroffenen Entscheidung, ausgeschüttet werden kann.

Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Kapital in Höhe von bis zu einhundert und eine Million Euro (EUR 101.000.000,-)

eingeteilt in achtzig Millionen (80.000.000) A Aktien mit einem jeweiligen Nominalwert von einem Euro und fünfund-
zwanzig Cents (EUR 1,25), zwanzig Millionen (20.000.000) B Aktien mit einem jeweiligen Nominalwert von einem Euro
und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) und achthunderttausend (800.000) C Aktien mit einem jeweiligen Nominalwert
von einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25).

Der  Manager  ist  für  eine  Periode  von  drei  (3)  Jahren,  beginnend  an  dem  Datum  der  Gründung  der  Gesellschaft,

bevollmächtigt, von Zeit zu Zeit weitere A Aktien mit oder ohne Aktienagio sowie weitere B und C Aktien ohne Akti-
enagio auszugeben, um das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft bis zur Höhe des genehmigten Kapitals zu erhöhen.
Der Manager kann, nach eigener Entscheidung, neue A,B und C Aktien ausgeben, welche entweder gesamt oder zum Teil
dem Wert des genehmigten Kapitals entsprechen. Der Manager kann außerdem Zeichnungsaufträge für die Ausgabe
solcher A, B und C Aktien annehmen.

Die Zeitperiode der Bevollmächtigung kann durch einen während einer Hauptversammlung der Aktionäre durch diese

gefassten Beschluss verlängert werden, wobei dieser Beschluss in Quorums- und Abstimmungsmechanismus unterliegt,
welchen das luxemburgische Recht für die Änderung dieser Satzung vorsieht.

Der Manager ist bevollmächtigt, von Zeit zu Zeit, die für die neu gezeichneten A, B und C Aktien maßgeblichen Rechte

und Bedingungen festzulegen.

Der Manager ist bevollmächtigt, solche neuen A, B und C Aktien unter und während der oben benannten Zeitperiode

auszugeben, wobei er hierbei die Vorzugsrechte von bereits existierenden Aktionären ganz oder teilweise einschränken
kann.

Sollte der Manager, im Einklang mit den oben benannten Paragraphen dieses Artikels, eine teilweise oder gesamte

Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft beschließen, hat der Manager die Pflicht, die notwendigen Schritte einzu-
leiten und abzuschließen, um diese Änderung aufzuzeichnen oder diese Aufzeichnung zu autorisieren und im Einklang mit
dem luxemburgischen Recht solche Änderungen zu veröffentlichen.

32175

Das  genehmigte  Kapital  und  das  Aktienkapital  der  Gesellschaft  können  in  Übereinstimmung  mit  luxemburgischen

rechtlichen Bestimmungen erhöht oder verringert werden.

In dieser Satzung sollen die Begriffe «Aktie» und «Aktien» oder «Aktionär» oder «Aktionäre» die A Aktien und die B

Aktien und die C Aktien sowie die Halter aller A und B und C Aktien bezeichnen und meinen.

Die Gesellschaft kann unter den Bedingungen des luxemburgischen Rechts eigene Aktien erwerben.

Art. 6. Zahlungen. Sollten CPECs und/oder PECs ausgegeben werden, so sollen die A Aktien zusammen mit den CPECs

und/oder PECs Einheiten («Einheit(en)») ergeben, wobei jede Einheit eine (1) A Aktie und neunundneunzig (99) CPECs
und/oder PECs, wie vom Manager bestimmt, umfasst.

Der Zeichnungspreis für jede Einheit soll bei Ausgabe der Einheit voll eingezahlt werden.
Der Komplementär, die Zeichnenden und diejenigen, welche Aktionäre der Gesellschaft werden, können, von Zeit zu

Zeit, einen Aktionärsvertrag unterzeichnen (hiernach der «Aktionärsvertrag») welcher von Zeit zu Zeit abgeändert wer-
den kann. Der Aktionärsvertrag kann Verpflichtungen für die Kommanditisten enthalten, welche diese bei Zeichnung
verpflichten, (i) eine bestimmte Anzahl von Einheiten zu zeichnen wenn sie Kommanditist werden, (ii) und weitere Ein-
heiten  zu  zeichnen,  während  sie  Kommanditisten  sind  (die  Verpflichtungen  unter  (i)  und  (ii)  werden  hiernach  als
«Verpflichtungsbeitrag» bezeichnet).

Sollte ein Kommanditist der Aufforderung des Managers, alle Verpflichtungsbeiträge voll einzuzahlen, nicht nachkom-

men, so ist er den Konsequenzen und Folgen ausgesetzt, welche diese Satzung und der Aktionärsvertrag für einen solchen
Fall vorsehen.

Die existierenden Einheiten (A Aktien eingeschlossen) eines Kommanditisten, welcher der Zahlungsaufforderung des

Managers, seine Verpflichtungsbeiträge innerhalb einer Frist von zehn (10) Geschäftstagen voll einzubezahlen, nicht nach-
kommt (der «Pflichtverletzende Kommanditist»), sollen nach dem Eintritt einer solchen Situation gesperrt werden und
auf diese Einheiten des Pflichtverletzenden Kommanditisten sollen keine weiteren Ausschüttungen folgend dieser Satzung
vorgenommen werden.

Die verbleibenden Rechte eines Pflichtverletzenden Kommanditisten sollen darauf begrenzt sein, dass dieser Pflicht-

verletzende Kommanditist lediglich den Nominalwert seiner von ihm gehaltenen A Aktien und den Nominalwert der von
ihm gehaltenen CPECS und/oder PECs zurückerhält.

Solche Rückzahlungen sollen allerdings nur an dem Tag durchgeführt werden, an dem die Gesellschaft liquidiert und

aufgelöst wird und auch erst dann, wenn alle anderen Aktionäre (so auch der Komplementär) alle ihre Ausschüttungen
im Einklang mit den Vorschriften dieser Satzung erhalten haben.

Pflichtverletzende Kommanditisten haben kein Recht, an Hauptversammlungen der Aktionäre teilzunehmen und ab-

zustimmen.

Die Nichtbefolgung der Aufforderung des Managers, Verpflichtungsbeiträge in jeglicher Höhe einzuzahlen, kann nicht

wieder gutgemacht oder ausgeglichen werden und soll als endgültig und bindend ab dem Datum eines solchen Ereignisses
gelten.

In dieser Satzung soll der Begriff «Geschäftstag» jeden Tag meinen, der kein Samstag, Sonntag oder gesetzlicher Feiertag

in Luxemburg oder Deutschland ist.

Art. 7. Haftung der Aktionäre.  Halter  von  B  Aktien  sind  gemeinschaftlich  und  gesamtschuldnerisch  für  diejenigen

Verpflichtungen der Gesellschaft haftbar, welche nicht aus dem Vermögen der Gesellschaft beglichen werden können.
Zwischen mehreren Haltern von B Aktien ist die Haftung pro rata, basierend auf der jeweiligen Anzahl gehaltener B
Aktien, aufgeteilt.

Halter von A und C Aktien sind für die Rückzahlung von Schulden, Haftungsbeträgen und anderer Verpflichtungen der

Gesellschaft nur bis zur Höhe des Nominalwertes der von ihnen jeweils gehaltenen A Aktien (inklusive Aktienagio) und
C Aktien haftbar, unabhängig davon ob diese A oder C Aktien zum Zeitpunkt des Haftungsfalles bereits voll oder nur
zum Teil eingezahlt sind. Zwischen mehreren Haltern von A und C Aktien ist die Haftung pro rata, basierend auf der
jeweiligen Anzahl gehaltener A und C Aktien, aufgeteilt.

Die Haftung der Halter von A und C Aktien, welche in irgendeiner Form Verwaltungs- oder Geschäftsführungstätigkeit

für die Gesellschaft ausüben (egal ob vom Manager hierzu bevollmächtigt oder nicht) oder für die Gesellschaft unter-
zeichnen und hierdurch eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Drittparteien oder anderen Aktionären herstellen,
sind gegenüber solchen Drittparteien oder Aktionären voll haftbar in Höhe dieser Verpflichtung(en). Die Haftung eines
Kommanditisten unter diesem Paragraph ist somit nicht auf den Nominalwert (inklusive Aktienagio) der von diesem
Kommanditisten gehaltenen A und C Aktien, entsprechend, beschränkt.

Art. 8. Eigenschaften der Aktien. Aktien werden nur in Form von Nennwertaktien und gegen Annahme der Zeichnung

und voller Einzahlung des Zeichnungspreises für solche Aktien ausgegeben.

Auf Anfrage eines Aktionärs wird die Gesellschaft als Folge der Annahme der Zeichnung und des Erhalts des Zeich-

nungspreises dem Aktionär eine Bestätigung über seine Beteiligung an der Gesellschaft zusenden.

Alle ausgegebenen Aktien werden im Aktienregister der Gesellschaft (das «Register»), welches durch den Manager

(oder durch von ihm dafür beauftragte Personen) geführt wird eingetragen, und das Register soll den Namen und die

32176

Adresse eines jeden Aktionärs sowie die Anzahl, Klasse und eingezahlten Betrag hinsichtlich der von ihnen gehaltenen
Aktien enthalten.

Jede Übertragung von Aktien (eingeschlossen, aber nicht darauf begrenzt, Verkauf, Abtretung, Transfer, Pfändung,

Schenkung, Fusion, Abtrennung, Liquidation oder Auflösung) soll mittels einer schriftlichen Übertragungserklärung in das
Register eingetragen werden, wobei eine solche Erklärung mit einem Datum versehen und vom Übertragenden und dem
Übertragungsempfänger, oder deren Vertretern, unterzeichnet werden soll.

Die Gesellschaft kann eine Übertragung, welche durch andere Dokumente zwischen dem Übertragenden und dem

Übertragungsempfänger vertraglich vereinbart wurde, akzeptieren und in das Register eintragen.

Jeder Aktionär muss den Manager mit Adresseninformationen versorgen, zu welcher Adresse dann alle Anzeigen und

Bekanntmachungen der Gesellschaft versendet werden können. Diese Adresse wird im Register vermerkt.

Jeder Kommanditist wird, ohne Verzögerung, die Gesellschaft am Gesellschaftssitz schriftlich benachrichtigen, sollten

sich sein Name oder seine Adressdetails ändern, womit die Adressdetails dieses Kommanditisten im Register angepasst
werden.

Sollte ein Aktionär seine Adressdetails der Gesellschaft nicht zur Verfügung stellen, kann der Manager (oder eine

hierfür vom Manager beauftragte Person) diesen Umstand in das Register eintragen und die Adresse eines solchen Akti-
onärs soll als am Sitz der Gesellschaft gelegen gelten oder an einem anderen Ort, wie vom Manager in das Register
eingetragen wird, bis dieser Aktionär seine Adressdetails übermittelt.

Art. 9. Übertragung von Einheiten - Übertragungsbeschränkungen - Rückkauf. Jede Übertragung von Einheiten soll

durch schriftliche Übertragungserklärung, welche in das Register eingetragen wird, erfolgen und solche Erklärung soll mit
einem Datum versehen und von dem Übertragenden und dem Übertragungsempfänger, oder deren Vertretern, unter-
zeichnet werden. Der Manager kann eine Übertragung, welche durch andere Dokumente zwischen dem Übertragenden
und dem Übertragungsempfänger vertraglich vereinbart wurde, akzeptieren und in das Register eintragen.

Eine A Aktie kann nur in der Weise übertragen werden, dass zusammen mit ihr die entsprechende Anzahl von CPECs

und/oder PECs ebenfalls übertragen wird, wodurch eine solche Übertragung immer in der Übertragung einer Einheit oder
mehrere Einheiten erfolgt.

C Aktien sind frei übertragbar, wobei der Komplementär eine jede Übertragung vorher genehmigen muss.
9.1 Vorkaufsrecht
Ein Kommanditist (der «Verkaufende Aktionär»), welcher einige oder alle seiner Einheiten (die «Kaufeinheiten») an

einen anderen Aktionär oder eine bona fide Drittpartei (der «Käufer») verkaufen möchte, muss über dieses Angebot (das
«Angebot») den Manager schriftlich informieren. Eine solche Anzeige muss die, bei Annahme des Angebots, bindenden
Bedingungen des Angebots enthalten eingeschlossen der Anzahl der Kaufeinheiten und des Kaufpreises für die Kaufein-
heiten («Kaufbedingungen»).

Innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach Erhalt der schriftlichen Anzeige, soll der Manager die Kaufeinheiten den

anderen Kommanditisten zu den Kaufbedingungen im Verhältnis zu deren Verpflichtungsbeträgen anbieten. Dieses An-
gebot an die anderen Kommanditisten soll im Wege eines Briefes per Einsschreiben versendet werden. Die Kaufeinheiten
sollen für eine vom Manager festzulegende Zeitperiode den Kommanditisten angeboten werden, wobei eine solche Zeit-
periode nicht weniger als zehn (10) und nicht mehr als dreißig (30) Geschäftstage, beginnend vom Datum des Erhalts des
Einschreibbriefes, sein darf.

Andere Kommanditisten, welche das Angebot annehmen wollen, informieren den Manager über die Anzahl der von

Ihnen zu erwerbenden Kaufeinheiten (bis zu dem höchstmöglichen Anspruch) folgend den in dem vom Manager versen-
deten Einschreibebrief festgelegten Anweisungen. Solche Kommanditisten sollen auch angeben, ob und wie viele zusätz-
liche Kaufeinheiten sie zu den Kaufbedingungen erwerben wollen würden.

Sollten nicht alle anderen Kommanditisten das Angebot voll akzeptieren, sorgt der Manager dafür vor, dass die ver-

bleibenden Kaufeinheiten an diejenigen Kommanditisten verkauft werden, welche ihren Willen zum Kauf zusätzlicher
Kaufeinheiten im Sinne des vorherigen Paragraphen an den Manager übersendet haben. Solche zusätzlichen Kaufeinheiten
werden daraufhin vom Manager im Verhältnis zu den entsprechenden Verpflichtungsbeiträgen und, bezüglich eines wei-
teren Überflusses, im Verhältnis zu der von den Kommanditisten gewünschten Anzahl weiteren Kaufeinheiten an diese
Kommanditisten verkauft.

Sobald das Angebot schließt, soll der Manager den Verkaufenden Aktionär über die Anzahl der Kaufeinheiten infor-

mieren, welche die anderen Kommanditisten erwerben wollen. Der Verkaufende Aktionär soll dann diese Anzahl von
Kaufeinheiten und zusätzliche Kaufeinheiten an die anderen Kommanditisten verkaufen.

Der Verkaufende Aktionär kann dann im Folgenden den Rest der Kaufeinheiten, wenn es noch solche gibt, oder alle

Kaufeinheiten, wenn kein anderer Kommanditist seine Bereitschaft zum Erwerb von Kaufeinheiten angezeigt hatte, an
den Käufer verkaufen, vorausgesetzt, dass innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach Ablauf der im oben benannten
Einschreibebrief des Managers an die anderen Kommanditisten erwähnten Frist (i) der Kauf zu den Kaufbedingungen und
durch vollständige Zahlung des Kaufpreises durchgeführt wird, (ii) der Käufer ausreichende Dokumente an den Manager
übersendet, welche ihn als ultimativen Nutznießer (know-your-customer) identifizieren, (iii) der Käufer Partei des Akti-
onärsvertrags wird, und (iv) der Manager den Transfer im Einklang mit dem folgenden Paragraph nicht verweigert.

32177

Jeder Übertragung von Einheiten, egal ob an andere Kommanditisten oder an den Käufer, muss der Manager im Voraus

zustimmen. Der Manager kann jedoch seine Zustimmung zur Übertragung und Registrierung derselben innerhalb der im
vorherigen Paragraph benannten Frist nur verweigern, wenn Umstände erscheinen, welche deutlich machen, dass die
Übertragung schädlich oder beeinträchtigend sind für die (i) gewöhnliche wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft,
(ii) Investitionsinteressen bestehender Aktionäre, und (iii) Erreichung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft. Im Falle
der Verweigerung der Zustimmung kann der Manager die Kaufeinheiten zu den Kaufbedingungen an den Komplementär
oder eine andere Person, eingeschlossen der Gesellschaft, zu den Bedingungen des luxemburgischen Rechts verkaufen.

Nach der Ausführung der Übertragung der Kaufeinheiten an einen neuen Kommanditisten und dessen Beitritt zum

Aktionärsvertrag, übernimmt der neue Kommanditist alle Verpflichtungsbeiträge des Verkaufenden Aktionärs zu den
Bedingungen dieser Satzung und den Regeln des Aktionärsvertrages, unabhängig davon ob die Verpflichtungsbeiträge ganz
oder zum Teil eingezahlt oder vom Manager eingefordert sind oder werden. Sollte der Manager seine Zustimmung zu
der Übertragung und Registrierung im Einklang mit dem vorherigen Paragraph verweigern, bleibt der Verkaufende Akti-
onär für die Bezahlung seiner Verpflichtungsbeiträge voll haftbar.

Die Vorschrift dieses Artikels 9.1 soll nicht für den Fall Anwendung finden, wenn die Übertragung vom Verkaufenden

Aktionär an eine juristische Person geschieht, welche vom Verkaufenden Aktionär Kontrolliert wird (oder welche den
Verkaufenden Aktionär Kontrolliert oder Kontrollierend auf diesen einwirkt). Der Manager hat das Recht, die Existenz
der Beziehung zwischen dem Verkaufenden Aktionär und dem Käufer zu überprüfen. Um diese Prüfung durchzuführen,
wird der Verkaufende Aktionär dem Manager alle relevanten Unterlagen zukommen lassen, welche es vernünftiger- und
notwendigerweise erlauben, die Situation der Kontrolle und Struktur der Beziehung zwischen Verkaufendem Aktionär
und Käufer deutlich zu erkennen. Sollte solche Information nicht zur Verfügung gestellt werden, findet die in diesem
Paragraph festgelegte Ausnahme auf diesen Einheitenverkauf keine Anwendung. Für die Zwecke dieses Paragraphen be-
deuten  die  Worte  «Kontrolle»,  «Kontrolliert»,  oder  «Kontrollierend»  eine  Eigentümerstellung  von  mehr  als  fünfzig
Prozent (50%) der Stimmrechte der jeweiligen juristischen Person.

9.2 Mitkaufsrecht
Sollte ein Aktionär («Mitkäufer») ein vernünftiges Angebot über den Erwerb von mindestens sechsundsechzig Prozent

(66%) der Einheiten («Mitkaufeinheiten») der Gesellschaft von einer bona fide Drittpartei («Ankäufer») erhalten, so ist
der Mitkäufer berechtigt, durch Übersendung einer schriftlichen Mitteilung an den Manager («Mitkaufsnotiz»), die anderen
Kommanditisten zu verpflichten, ihre Einheiten im Verhältnis zu ihren Beteiligungen in der Gesellschaft, unter den gleichen
Bedingungen wie enthalten in der Notiz des Ankäufers an den Mitkäufer (inklusive des Kaufpreises per Mitkaufeinheit)
an den Ankäufer zu verkaufen.

Die Mitkaufsnotiz muss den Ankäufer ausreichend identifizieren, außerdem den Kaufpreis per Mitkaufeinheit benennen

und den Tag und Ort der Ausführung der Übertragung und der Zahlung des Kaufpreises darstellen («Mitkaufbedingun-
gen»).

Der Manager wird die anderen Kommanditisten über das Angebot, die Mitkaufeinheiten zu verkaufen, schriftlich im

Wege eines Einschreibebriefes informieren. Der Einschreibebrief muss innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach Erhalt
der Mitkaufsnotiz abgesendet werden.

Zum Datum des Abschlusses der Übertragung, wie dieses in der Mitkaufsnotiz und dem Einschreibebrief benannt ist,

sollen die anderen Kommanditisten ihre respektiven Mitkaufseinheiten zusammen mit jeglicher relevanter Dokumenta-
tion, z.B. CPECs und PECs Dokumentation, an den Ankäufer übertragen und übermitteln. Die anderen Kommanditisten
werden des weiteren die Angaben zu den Bankkonten übermitteln, auf welche der Kaufpreise durch den Ankäufer gezahlt
werden soll.

Sofort nach der Vollziehung des Verkaufs wird der Mitkäufer die anderen Kommanditisten mit einer schriftlichen

Bestätigung versorgen, welche bestätigt, dass der Verkauf vollzogen ist und dass die entsprechende Kaufpreise auf die
Bankkonten der anderen Kommanditisten übertragen wurden.

Alle Kosten und Ausgaben in Verbindung mit einem solchen Verkauf werden von dem Mitkäufer und den anderen

Aktionären pro rate im Verhältnis zu der Anzahl der für jeden Aktionär in diesem Verkauf enthaltenen Mitkaufseinheiten
getragen.

9.3 Transferkaufrecht
Sollte zu jeder Zeit ein Kommanditist (der «Transferkommanditist») an eine Drittpartei (der «Transferkäufer») fünfzig

Prozent (50%) oder mehr der Gesamtanzahl der Einheiten der Gesellschaft übertragen (der «Transfer»), so haben die
anderen Kommanditisten das Recht, ihre eigenen Einheiten an den Transferkäufer im Verhältnis zu den von dem Trans-
ferkommanditist übertragen Einheiten zu übertragen.

In einem solchen Falle muss der Transferkommanditist den Manager durch schriftliche Notiz über die Identität, den

Namen, und die Adresse des Transferkäufers und die Bedingungen des Transfers, wie diese zwischen dem Transferkom-
manditisten und dem Transferkäufer ausgehandelt wurden, informieren.

Der Manager wird die anderen Kommanditisten per Einschreibebrief über den Transfer und deren Recht zur Über-

tragung ihrer Einheiten an den Transferkäufer informieren. Ein solcher Einschreibebrief muss innerhalb von zehn (10)
Geschäftstagen nach Erhalt der schriftlichen Notiz vom Transferkommanditisten durch den Manager erfolgen.

32178

Die anderen Kommanditisten haben dann das Recht, dem Verkauf ihrer Einheiten an den Transferkäufer zuzustimmen,

indem sie den Manager schriftlich hierüber innerhalb von dreißig (30) Geschäftstagen folgend des Erhalts des Einschrei-
bebriefes vom Manager informieren. Der Manager informiert daraufhin den Transferkommanditisten umgehend nach
Ablauf der dreißig (30) Tagefrist sofern er Nachrichten von anderen Kommanditisten erhalten hat. Für jeden Komman-
ditisten, der seine Einheiten im Zuge des Transfers verkaufen will und das in seiner Notiz an den Manager angegeben hat,
muss der Transferkommanditist diese Einheiten in den Transfer einbeziehen und zu nicht weniger als einhundert Prozent
(100%) des Verkaufspreises wie er in der Notiz an den Manager benannt ist, und in jedem Falle zu den inhaltlich gleichen
Bedingungen wie in seiner Notiz an den Manager angegeben, verkaufen.

Sollte keiner der Kommanditisten innerhalb von dreißig (30) Geschäftstagen nach Erhalt des Einschreibebriefes vom

Manager antworten oder alle auf ihr Transferrecht verzichten, kann der Transferkommanditist seine Einheiten an den
Transferkäufer  verkaufen.  Nachdem  der  Verkauf  abgeschlossen  und  vollzogen  ist,  soll  der  Transferkommanditist  die
anderen Kommanditisten über den Transfer schriftlich informieren.

Nach der Ausführung der Übertragung der Kaufeinheiten an den Transferkäufer und dessen Beitritt zum Aktionärs-

vertrag übernimmt der Transferkäufer alle Verpflichtungsbeiträge des Transferkommanditisten zu den Bedingungen dieser
Satzung und den Regeln des Aktionärsvertrages, unabhängig davon ob die Verpflichtungsbeiträge ganz oder zum Teil
eingezahlt oder vom Manager eingefordert sind oder werden. Sollte der Manager seine Zustimmung zu der Übertragung
und Registrierung im Einklang mit dem vorherigen Paragraph verweigern, bleibt der Transferkommanditist für die Be-
zahlung seiner Verpflichtungsbeiträge voll haftbar.

Alle  Kosten  und  Ausgaben  in  Verbindung  mit  einem  solchen  Transfer  werden  von  dem  Transferkäufer  und  dem

Transferkommanditisten sowie von den möglichen anderen partizipierenden Kommanditisten pro rate im Verhältnis zu
der Anzahl der für jeden Kommanditisten in diesem Verkauf enthaltenen Mitkaufseinheiten getragen.

9.4 Vom Manager initiierte Übertragungen
Auf Anfrage eines Kommanditisten an den Manager, einen Käufer für alle oder einige seiner Einheiten zu suchen, soll

der Manager alles mögliche und notwendige unternehmen, um einen Käufer oder mehrere Käufer für solche Einheiten
zu finden. In einem solchen Fall führt der Manager die Verkaufsverhandlungen für den Verkauf der Einheiten. Der anfra-
gende Kommanditist ist verpflichtet, den Manager für alle vernünftigen Kosten und Aufwendungen, welche aufgrund der
Ausführung seines Mandats entstehen, zu entschädigen, egal, ob die Einheiten letztendlich verkauft werden oder nicht.

Sollte der Manager erfolgreich (i) einen Verkauf im Sinne des vorherigen Paragraphen, oder (ii) einen anderen Verkauf

von Einheiten eines Kommanditisten an eine Drittpartei ohne vorherige Anfrage dieses Kommanditisten anbahnen, ver-
handeln und abschließen, so hat er das Recht, von diesem Kommanditisten eine Gebühr in Höhe von zwei Prozent (2%)
des gesamten Verkaufspreises, welcher für diese Einheiten bezahlt wurde, zu fordern.

Art. 10. Weitere Beschränkungen für Einheiten. Die Kommanditisten stellen sicher, dass ihre Einheiten nicht, und der

Manager wird nicht erlauben, dass die Einheiten belastet, gepfändet oder mit irgend einer anderen Sicherheit belegt sind,
außer wie in dieser Satzung und dem Aktienregister vorgesehen.

Art. 11. Stimmrechte. Jede Aktie beinhaltet das Recht zur Abgabe einer Stimme bei allen Hauptversammlungen der

Aktionäre.

Alle Aktien stimmen als eine Klasse außer für Änderungen dieser Satzung welche ausschließlich bestimmte Aktien-

klassen betreffen.

Art. 12. Hauptversammlungen der Aktionäre. Jährliche und außerordentliche Hauptversammlungen der Aktionäre

haben die Kompetenz über alle Angelegenheiten zu entscheiden, welche durch luxemburgisches Recht den Aktionären
zugewiesen sind. Des weiteren kann die Hauptversammlung der Aktionäre in allen anderen Angelegenheiten entscheiden,
für welche nicht dem Manager durch diese Satzung Kompetenz zugewiesen wurde.

Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre wird in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft, oder an einem anderen

Ort in Luxemburg wie durch die Einladung zur Hauptversammlung vorgesehen, abgehalten. Die Einladung muss durch
den Manager mindestens acht (8) Geschäftstage vor der jährlichen Hauptversammlung als Einschreiben an die Aktionäre
unter den für diese im Register angegebenen Adressen abgesendet werden.

Die jährliche Hauptversammlung wird jedes Jahr am dritten Mittwoch im Monat März um 14 Uhr abgehalten. Sollte

ein solcher Tag kein Geschäftstag in Luxemburg sein, findet die jährliche Hauptersammlung am nächstfolgenden Ge-
schäftstag in Luxemburg statt.

Der Komplementär und der Manager können jederzeit, wenn sie dies für notwendig erachten, eine außerordentliche

Hauptversammlung der Aktionäre einberufen. Außerdem muss der Manager eine außerordentliche Hauptversammlung
dann einberufen, wenn dies von Aktionären, die mindestens zehn Prozent (10%) des gesamten ausgegebenen Aktienka-
pitals der Gesellschaft besitzen, schriftlich (unter Angabe der Tagesordnung) verlangt wird.

Außerordentliche Hauptversammlungen können an solchen Orten und zu solchen Zeiten in Luxemburg abgehalten

werden, wie dies in der Einladung zu solchen besonderen Hauptversammlungen festgehalten ist, als solche Einladung durch
den Manager mindestens acht (8) Geschäftstage vor der jährlichen Hauptversammlung als Einschreiben an die Aktionäre
unter den für diese im Register angegebenen Adressen abgesendet werden müssen.

32179

Art. 13. Ablauf der Hauptversammlungen. Den Vorsitz auf allen Hauptversammlungen führt der Komplementär oder

ein von diesem hierfür eingesetzter Vertreter.

Für jede Hauptversammlung gelten das Quorum und die Stimmmehrheitserfordernisse, welche durch das luxembur-

gische Recht oder diese Satzung verlangt werden.

Außer wenn anderweitig durch ein Gesetz oder diese Satzung bestimmt, werden Beschlüsse einer wirksam zusam-

mengetretenen Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder wirksam vertretenen Aktionäre gefasst,
wobei der Komplementär jedem Beschluss ausdrücklich zustimmen muss.

Der Komplementär kann alle anderen Bedingungen bestimmen, welche durch Aktionäre erfüllt werden müssen, um

an einer Hauptversammlung teilnehmen zu können.

Art. 14. Management der Gesellschaft. Der Manager kann alle Kompetenzen ausüben, die ihm durch diese Satzung

verliehen werden. Außerdem kann er alle Kompetenzen wahrnehmen, welche nicht durch diese Satzung oder durch
zwingendes luxemburgisches Recht der Hauptversammlung der Aktionäre zugewiesen sind.

Der Manager wird nicht von seinem Posten als Manager der Gesellschaft zurücktreten.
Der Manager kann nicht von seinem Posten als Manager abgewählt werden, es sei denn, (i) er hat die Vorschriften

dieser Satzung in grober Weise verletzt, oder (ii) er hat die ihm unter dieser Satzung eingeräumten Kompetenzen in einer
grob fahrlässigen oder schuldhaften Weise ausgeübt.

In solchen Fällen kann die Abwahl nur durch einen Beschluss der Kommanditisten erfolgen, welcher in der Hauptver-

sammlung der Kommanditisten gefasst wird und ein Quorum von 2/3 der ausgegebenen A Aktien und eine Mehrheit von
2/3 der anwesenden und vertretenen Kommanditisten umfassen muss. Ein solcher Beschluss kann wirksam gefasst werden
ohne die Zustimmung des Komplementärs.

Im Falle der Abwahl des Managers, soll der Komplementär sicherstellen, dass alle zu diesem Zeitpunkt der Abwahl

vom Manager gehaltenen B Aktien an einen Nachfolge-Manager übertragen werden, welcher für die Zwecke der Ver-
waltung der Gesellschaft ernannt worden ist und alle Akten, Verträge, Urkunden sollen unterzeichnet werden und alles
notwendige soll generell unternommen werden, was notwendig erscheint, um diesen Übergang zu implementieren.

Im Falle der Abwahl und auch in dem Fall, dass der Manager rechtlich unfähig ist oder es ihm unmöglich ist, als Manager

zu agieren, soll der Aufsichtsrat (Conseil de Surveillance) der Gesellschaft (der «Aufsichtsrat») einen Verwalter ernennen,
welcher Aktionär sein kann oder nicht und welcher dringenden Maßnahmen und andere für die ordentliche Verwaltung
der Gesellschaft notwendige Maßnahmen ergreifen soll, bis die Hauptversammlung der Aktionäre einen neuen Manager
gewählt hat. Der Verwalter soll innerhalb von fünfzehn (15) Geschäftstagen ab seiner Ernennung eine Hauptversammlung
der Aktionäre im Einklang mit den Bestimmungen dieser Satzung einberufen, welche als Tagesordnungspunkt die Wahl
eines neuen Managers der Gesellschaft vorsieht, der dann auch Komplementär der Gesellschaft wird, was so zu verstehen
ist, dass, unter Nichtbeachtung des Artikel 12, ein solcher Beschluss der Hauptversammlung auch ohne die Zustimmung
des ausscheidenden Managers wirksam ist.

Halbjährlich wird der Manager den Aufsichtsrat mit einer Erklärung versorgen, welche das Vermögen und die Schulden

der Gesellschaft wiedergibt.

Art. 15. Kompetenzen des Managers. Der Manager hat die ausschließliche Verantwortung für die Verwaltung und

Kontrolle der wirtschaftlichen Aktivitäten der Gesellschaft und hat weiterhin die Kompetenz und Autorität, alle not-
wendigen Schritte zu unternehmen, um den Zweck der Gesellschaft zu erreichen und er soll seine gesamte Zeit und
seinen Einsatz dafür hergeben, dass die Verwaltung der Gesellschaft vernünftig und notwendigerweise ausgeführt wird
und er kann diese Kompetenz von Zeit zu Zeit unter Mithilfe von ernannten Agenten, Assistenten oder Angestellten der
Gesellschaft ausführen, falls er dies für notwendig erachtet.

Der Manager kann somit hinsichtlich all denjenigen Sachen entscheiden, welche ihm durch diese Satzung und luxem-

burgisches Recht übertragen sind, außer den Angelegenheiten, welche nach luxemburgischem Recht durch die Haupt-
versammlung der Aktionäre entschieden werden müssen.

Der  Manager  hat  das  Recht,  seine  Kompetenzen  und  Autoritäten  an  spezielle  Bevollmächtigte  im  Rahmen  dieser

Satzung zu delegieren, vorausgesetzt, dass der Manager nicht ermächtigt ist, seine Kompetenzen unter Buchstaben (b),
(c) und (d) dieses Artikels zu delegieren.

Die Kommanditisten sind nicht autorisiert, irgendeine Art von Verwaltungsarbeit oder kontrollierende Arbeit hin-

sichtlich der wirtschaftlichen Vorgänge für die Gesellschaft auszuüben und sie haben kein Recht und keine Autorität, für
die Gesellschaft zu handeln oder, auf welche Art auch immer, in die Verwaltung oder Kontrolle der Gesellschaft einzu-
greifen außer durch Ausübung ihres Stimmrechtes in der Hauptversammlung.

Ohne Beeinträchtigung des generellen Charakters der oben stehenden Paragraphen dieses Artikels und ohne sich

darauf zu beschränken, hat der Manager die volle Ermächtigung und Autorität, im Namen der Gesellschaft (eingeschlossen
der Kompetenz, die Gesellschaft zu binden), um:

a) im Voraus die Verwaltungskosten, welche mit der Gründung der Gesellschaft zusammenhängen auszulegen, unter

anderem, aber nicht beschränkt auf, Rechtskosten, Steuern, Buchhaltung, Beratung, Vervielfältigung, Druckkosten, Tele-
fon, Telefax, Post, Luftfracht, Reisekosten und andere Ausgaben und Gebühren, welche an Drittparteien während der
Organisation der Gesellschaft gezahlt worden sind, Kosten für die Registrierung der Gesellschaft, fund-raising Kosten,

32180

inklusive Gebühren für das fund-raising und die Promotion der Investitionen der Gesellschaft, wobei der Anspruch auf
Rückzahlung dieser Kosten gegen die Gesellschaft auf einen Betrag von dreihundertfünfundfünfzigtausend Euro (EUR
355.000,-) begrenzt ist;

Kosten, welche diesen Betrag hinsichtlich der Gründung der Gesellschaft übersteigen, sollen durch den Manager in

seiner Kapazität als Komplementär der Gesellschaft getragen werden;

b) in seiner eigenen Verantwortung, die Investitionspolitik der Gesellschaft zu implementieren, auf Grundlage der

Beratung des Investitionskomitees und von Beratern (beide Begriffe wie später definiert) und folgend dem Inhalt des
Investitionsprospekts der Gesellschaft (das «Prospekt»), wie es von Zeit zu Zeit abgeändert wird und des weiteren soll
der Manager Investitionsobjekte im Namen der Gesellschaft ankaufen, verkaufen, austauschen oder auf ähnlich Weise
betreiben, und, wo notwendig, Zusagen machen und Entschädigungen zahlen, im Namen der Gesellschaft und im Zusam-
menhang mit dem Verkauf, Austausch und der Absetzung;

c) Investitionsmöglichkeiten zu bewerten und auszuhandeln und Investmentgesellschaften zu beobachten;
d) Schriftliche Verpflichtungserklärungen abzugeben bezüglich des Erwerbs von Investitionen zusammen als Syndikat

mit den Kommanditisten und Investitionen zu erwerben, auch im Übermaß, unter den Bedingungen der Gesellschaften,
um dieses Übermaß an die Kommanditisten zu verkaufen;

e) An der Verwaltung und der Kontrolle der Investmentgesellschaften, wo notwendig, teilzunehmen;
f) Büroräume bereitzustellen und Angestellte und Büromaterialen zu verpflichten, um das Geschäft der Gesellschaft

auszuführen;

g) Zahlungsaufforderungen im Zusammenhang mit der Bezahlung der Einheiten zu versenden und solche Zahlungen

für Aktien und Einheiten, welche von Kommanditisten gezeichnet werden, sowie Investitionserträge und andere Beträge,
welche aus den Investitionen resultieren, entgegenzunehmen. Für den Zweck dieser Satzung bedeutet der Begriff «Zah-
lungsaufforderungsschreiben» eine schriftliche Notiz des Managers an die Kommanditisten an ihre im Register angegebene
Adresse, wie näher im Aktionärsvertrag festgeschrieben;

h) Bankkonten für die Gesellschaft zu öffnen, zu unterhalten und zu schließen sowie Schecks einzulösen und andere

Aufträge für Zahlungen von Geldern zu erteilen;

i) Urkunden, Verträge und Abkommen und weitere Verpflichtungen zu unterzeichnen und Sicherheiten zu begeben

im Namen der Gesellschaft und alle sonstigen notwendigen Handlungen vorzunehmen welche der Manager für notwendig
und empfehlenswert erachtet, weil sie für die Durchführung des Gesellschaftszwecks unablässig sind;

j) Geld auf kurzfristiger Basis zu leihen und, ohne Einschränkung hierfür, Schuldverschreibungen, Entwürfe, Austausch-

noten und andere Schuldinstrumente und Nachweise für Schuld herzustellen, zu emittieren, zu akzeptieren, einzulösen
und auszuführen, und die Bezahlung und Besicherung solcher Instrumente sicherzustellen, unter anderem im Wege von
Grundschulden, Hypotheken, Abtretungen oder sonstigem Begeben von Sicherheiten durch Wertpapiere oder anderen
Besitz, welche die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt besitzt oder in der Zukunft erwirbt;

k) CPECs und/oder PECs oder andere Schuldinstrumente zu emittieren, zurückzukaufen oder umzuwandeln;
l) Ausgaben zu bezahlen, welche aufgrund der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft entstehen, eingeschlossen ohne darauf

begrenzt zu sein, alle Kosten und Ausgaben, auf welche in dieser Satzung Bezug genommen wird, und welche, in fine, von
der Gesellschaft zu tragen sind;

m) Streitigkeiten zu beginnen oder zu verteidigen welche sich auf das Vermögen der Gesellschaft beziehen;
n) Die Bücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft am Gesellschaftssitz aufzubewahren;
o) Ausschüttungen durchzuführen, welche in bar oder als Sachleistung an die Kommanditisten und den Komplementär

in Einklang mit dieser Satzung und dem Aktionärsvertrag und wie durch die Hauptversammlung der Aktionäre beschlossen,
gezahlt werden können;

p) Beratungsverträge, Verwaltungsverträge und ähnliche Verträge abzuschließen;
q) Angestellte, unabhängige Agenten, Rechtsanwälte, Buchhalter, Depositare, Finanzberater und Berater zu engagieren,

wie es der Manager für notwendig und empfehlenswert mit Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft ansieht, einge-
schlossen, aber nicht darauf begrenzt, jegliche Gesellschaft, welcher zur Gesellschaft in Beziehung steht, und alle oder
jegliche Aktivität durchzuführen, wie sie in diesem Artikel vorgesehen ist;

r) Generell mit den Kommanditisten zu kommunizieren und ihnen Bericht zu erstatten, zu den vom Manager notwendig

erachteten Zeitpunkten, vorausgesetzt, dass alle Kommanditisten gleichwertig behandelt werden und um die Gesellschaft
in allen Dingen zu vertreten;

s) Periodische Berechnungen hinsichtlich des Vermögens der Gesellschaft durchzuführen und solche Berechnungen

und Finanzerklärungen den Kommanditisten zukommen zu lassen;

t) Neue Kommanditisten und Ersatzkommanditisten zur Gesellschaft zuzulassen im Einklang mit dieser Satzung und

den Vorgaben des Aktionärsvertrages;

u) Schwebende Investitionen im Einklang mit den Vorgaben von Dokumenten des Managers und des Komplementärs

durchzuführen nach Rücksprache mit den Kommanditisten und solche Summen in Depots zu platzieren oder in Instru-
mente investieren, wie es der Manager für notwendig erachtete und bestimmt;

32181

v) Kontrollen und Prozesse mit Blick auf Kommanditisten durchzuführen, wie diese durch Geldwäschevorschriften

oder ähnliche Regelungen von Regierungen oder Finanzinstitutionen gefordert werden; und

w) gegenständlich jeglicher Beschränkung in dieser Satzung, alle notwendigen Handlungen vorzunehmen, die gefordert

sind durch den Manager ausgeführt zu werden, oder welche notwendig und wünschenswert nach vernünftiger Auffassung
des Managers sind, im Einklang mit den vorhergehenden Punkten, um den Gesellschaftszweck der Gesellschaft, diese
Satzung und die Vorschriften des Aktionärsvertrages, wie anwendbar, zu implementieren.

Art. 16. Entschädigung des Managers. Der Manager und seine Mitarbeiter, Geschäftsführer, Aktionäre, Agenten, Be-

rater oder Angestellten und jede Person, welche vom Manager als Vorstand oder Geschäftsführer einer jeden Gesellschaft,
in welcher die Gesellschaft ein Investment hält, ernannt wurden haben Anspruch auf Entschädigungszahlungen aus dem
Vermögen der Gesellschaft für jede Haftung, Handlungen, Prozessen, Forderungen, Kosten, Fragen oder Ausgaben (ein-
geschlossen Rechtsberatungskosten), welche durch diese Personen eingegangen wurden oder durch eine solche Person
zu bezahlen sind, weil er Mitarbeiter, Aktionär, Partner, Geschäftsführer, Agent, Berater oder Angestellter des Managers
oder Vorstand/Geschäftsführer einer Gesellschaft ist, in der die Gesellschaft ein Investment hält, oder weil er Mitglied
des Investitionskomitees (wie unten definiert) ist, vorausgesetzt jedoch, dass eine solche Person nicht entschädigt wird
hinsichtlich einer jeglichen Schuld/Haftung, die unter vorsätzlichem schuldfähigen Handeln, bösen Glaubens oder grob
fahrlässigen Verhaltens während des Handelns für die Gesellschaft begründet wurde, und, hinsichtlich des Managers, einer
Handlung von grober Fahrlässigkeit und vorsätzlichem Handeln.

Der Manager ist nicht haftbar gegenüber einem Kommanditisten oder der Gesellschaft für jeglichen Verlust für die

Gesellschaft oder einen Kommanditisten, welcher aufgrund seiner Dienstleistungen entsteht, außer, wenn dieser Verlust
aufgrund grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichen Handelns entstanden ist. Der Manager ist gegenüber der Gesellschaft
oder Kommanditisten nicht haftbar für Unehrlichkeit oder bösen Glauben eines seiner Agenten oder eines Agenten der
Gesellschaft vorausgesetzt, dass ein solcher Agent vom Manager ausgesucht und engagiert wurde, wie die Sache sei, unter
Anwendung von vernünftiger Vorsicht und Umsicht.

Der Manager legt im Voraus die Verwaltungskosten, welche mit der Gründung der Gesellschaft zusammenhängen, aus,

unter anderem aber nicht beschränkt auf, Rechtskosten, Steuern, Buchhaltung, Beratung, Vervielfältigung, Druckkosten,
Telefon, Telefax, Post, Luftfracht, Reisekosten und andere Ausgaben und Gebühren, welche an Drittparteien während
der Organisation der Gesellschaft gezahlt worden sind, Kosten für die Registrierung der Gesellschaft, fund-raising Kosten,
inklusive Gebühren für das fund-raising und die Promotion der Investitionen der Gesellschaft, wobei der Anspruch auf
Rückzahlung dieser Kosten gegen die Gesellschaft auf einen Betrag von dreihundertfünfundfünfzigtausend Euro (EUR
355.000,-) begrenzt ist. Kosten, welche diesen Betrag hinsichtlich der Gründung der Gesellschaft übersteigen, sollen durch
den Manager getragen werden.

Der Manager trägt die Verwaltungskosten und andere Kosten, welche mit seinen generellen Aufgaben verbunden sind,

eingeschlossen der Gesamtkosten für den Vorstand des Managers und der Manager hat keinen Anspruch Ersatz für diese
Kosten von der Gesellschaft zu verlangen. Die Gesellschaft trägt alle Kosten, welche mit ihrer Betreibung verbunden sind,
eingeschlossen aller Kosten, Gebühren und Ausgaben, welche im Zusammenhang mit dem Ankauf, Halten und dem Ver-
kauf von Investmentportfolios stehen, ebenso unvollendeten Transaktionen, Kosten und Ausgaben für abgesagte Ge-
schäfte,  Steuern,  Prüfungskosten,  Rechtskosten,  Depositarkosten,  Beraterkosten  und  Kosten  für  Treffen  des
Investitionskomitees (wie unten definiert). Die Gesellschaft trägt Gebühren und Kosten von Drittparteien, welche sich
auf Rechtskosten, Prüfungskosten, Druckkosten und Steuern der Gesellschaft beziehen, welche diese im Zusammenhang
mit dem Kauf und Verkauf von Investitionen eingegangen ist, zu dem Ausmaß, dass diese Kosten nicht bereits von den
Investitionsgesellschaften getragen werden.

Art. 17. Vergütung des Managers. Als Entschädigung für seine geleisteten Dienste für die Gesellschaft, hat der Manager

Anspruch auf Zahlung einer Platzierungsgebühr («Platzierungsgebühr») in eigener Bestimmung. Die Platzierungsgebühr
kann bis zu zwei Prozent (2%) der gesamten Verpflichtungsbeiträge der Kommanditisten umfassen und ist bei der Zu-
stellung  von  Zahlungsaufforderungsschreiben  für  die  Zahlung  eines  Teils  oder  aller  Verpflichtungsbeiträge  von  der
Gesellschaft zu bezahlen.

Dem Manager wird des weiteren eine jährliche Managementgebühr bezahlt (die «Managementgebühr»), welche zwei

Prozent (2%) des Gesamtbetrags aller voll eingezahlten Einheiten entspricht, plus jeglicher Steuern, welche auf die Ma-
nagementgebühr zu zahlen sind. Die Managementgebühr wird halbjährlich revidiert, um die Veränderungen im fairen
Marktwert der Einheiten wiederzuspiegeln, gemessen an den kürzlich genehmigten und veröffentlichten Bilanzen der
Gesellschaft, welche die Bewertung von Drittparteien einschließen. Die Managementgebühr ist durch die Gesellschaft an
den Manager in jedem Jahr bis zur Liquidation der Gesellschaft, beginnend mit dem Jahr der Gesellschaftsgründung, zu
zahlen. Die Managementgebühr ist im Voraus halbjährlich nach Bestimmung des Managers zu zahlen, allerdings nicht vor
Beginn des entsprechenden nächsten Semesters.

Der Manager erhält des weiteren eine Verpflichtungsgebühr (die «Verpflichtungsgebühr»), welche null Komma fünf

Prozent (0,5%) per Jahr umfasst und auf die noch nicht eingezahlten Verpflichtungsbeiträge berechnet wird. Sollten Steuern
auf die Verpflichtungsgebühr zu zahlen sein, werden diese Steuern auf die Verpflichtungsgebühr aufgeschlagen und nicht
von ihr abgezogen. Die Verpflichtungsgebühr wird an dem Tag fällig, an dem der Verpflichtungsbrief von jedem Kom-
manditisten unterzeichnet wurde und seine Fälligkeit endet wenn die Akquisitionsperiode endet, also am 31. März 2010.

32182

Sollten Umstände auftreten, in denen ein Drittpartei Immobilienmakler normalerweise eingeschaltet werden würde,

aber dieser Immobilienmakler aufgrund der Intervention des Managers oder eines seiner verbundenen Unternehmen
nicht benötigt wurde, so erhält der Manager oder das verbundene Unternehmen eine Maklergebühr («Maklergebühr»)
von bis zu 1% zzgl. MwSt. oder ähnlichen Steuern errechnet auf Basis des Volumens der Investition oder De-Investition
der jeweiligen Transaktion.

Auf Verlangen eines Kommanditisten, einen Käufer für alle oder einige seiner Einheiten zu finden, soll der Manager

alles vernünftig Mögliche unternehmen, um einen Käufer für die Einheiten zu finden. In einem solchen Falle soll der Manager
alle Verhandlungen führen, welche zum Verkauf aller oder einiger Einheiten führen. Der verlangende Kommanditist ist
verpflichtet, den Manager für alle vernünftigen Kosten und Ausgaben zu entschädigen, egal ob die Einheiten verkauft
werden oder nicht. Sollte der Manager mit Erfolg (i) den Verkauf wie in diesem Paragraph beschrieben, oder (ii) jeden
anderen Verkauf von Einheiten eines Kommanditisten an eine Drittpartei ohne Verlangen eines Kommanditisten initiieren,
verhandeln und vervollständigen, so ist der Manager berechtigt, von dem Kommanditisten eine Gebühr in Höhe von zwei
Prozent (2%) des Gesamtkaufpreises der Einheiten zzgl. der MwSt. oder ähnlicher Steuern zu verlangen.

Art. 18. Unterschriften. Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des Managers oder jeder Person, welche für

diesen Zweck speziell oder generell vom Manager delegiert wurde, rechtlich gebunden.

Art. 19. Aufsichtsrat (Conseil de Surveillance). Die Geschäfte der Gesellschaft und ihre finanzielle Situation, insbeson-

dere ihre Bücher und Konten und Finanzoperationen werden durch einen Aufsichtsrat, welcher aus mindestens drei (3)
Personen besteht, überwacht.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates werd3en durch die Hauptversammlung der Aktionäre für ein (1) Jahr oder bis Nach-

folger benannt werden, ernannt, vorausgesetzt, dass die Halter von B Aktien zustimmen. Mitglieder des Aufsichtsrates
können mit oder ohne Angabe von Gründen abgewählt oder ersetzt werden und zwar zu jeder Zeit durch einen Beschluss
der Hauptversammlung der Aktionäre, wobei ein solcher Beschluss durch die Mehrheit der anwesenden und vertretenen
Aktionäre beschlossen werden muss.

Prüfer, welche durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, können den Aufsichtsrat in Ausführung

dessen Kompetenzen unterstützen.

Der Aufsichtsrat kann durch den Manager konsultiert werden, und zwar in allen Angelegenheiten, welche der Manager

bestimmt und der Aufsichtsrat kann alle Handlungen des Managers genehmigen, welche die Kompetenz des Managers
folgend dieser Satzung überschreiten.

Die Hauptversammlung der Aktionäre, welche die Mitglieder des Aufsichtsrates ernennt, entscheide auch über die

Entschädigung der Mitglieder des Aufsichtrates.

Der Aufsichtsrat trifft sich von Zeit zu Zeit in eigener Bestimmung eines jeden Mitglieds des Aufsichtsrates oder des

Managers.

Die schriftliche Einladung zu Sitzungen des Aufsichtsrates sollen an alle Mitglieder des Aufsichtsrates mindestens acht

(8) Geschäftstage vor dem Tag eines solchen Treffens versendet werden, außer in dringenden Fällen, in welchem Falle
solche Umstände in der Einladung benannt werden sollen. Der Einladungszwang kann unter Einstimmigkeit aufgehoben
werden, was durch jedes Mitglied schriftlich, durch Kabel, durch Telegramm, Telex oder Telefax kommuniziert werden
kann. Sollte ein Treffensplan durch den Aufsichtsrat entworfen werden, welcher genau die Daten und Plätze der Treffen
wiedergibt, so ist eine Einladung zu jeder Sitzung nicht notwendig.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann während einer Sitzung durch einen Vertreter teilnehmen, welcher auch Mitglied

des Aufsichtrates sein muss und die Ernennung des Vertreters kann durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere
elektronische Kommunikation erfolgen.

Der Aufsichtsrat kann nur dann wirksam entscheiden, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder

vertreten ist. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates, welches an einem Treffen durch Kommunikationsmittel (eingeschlossen
Telefon) teilnimmt, welches es den anderen Mitgliedern des Aufsichtsrates (die selbst anwesend sind oder auch durch
ein Kommunikationsmittel teilnehmen) erlaubt, das andere Mitglied jederzeit zu hören und selbst jederzeit gehört zu
werden, soll als anwesend gelten und soll für die Ermittlung eines Quorums und zwecks Stimmabgabe mitgezählt werden.

Beschlüsse werden durch Mehrheitsentscheidung der anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Aufsichtsrates

beschlossen.

Der Aufsichtsrat kann die Bücher, Korrespondenz, Protokolle und ganz generell alle Dokumente der Gesellschaft

einsehen, aber diese nicht vom Gesellschaftssitz entfernen.

Halbjährlich  soll  der  Manager  den  Aufsichtsrat  mittels  einer  Erklärung  über  die  Vermögenslage  und  Schulden  der

Gesellschaft informieren.

Der Aufsichtsrat muss der Hauptversammlung der Aktionäre Bericht über die Ausübung seines Mandats erstatten und

er muss Empfehlungen aussprechen, die er für notwendig erachtet und er muss die Aktionäre über die Methode infor-
mieren, welcher er sich zwecks Prüfung der Konten der Gesellschaft benützt.

Der Aufsichtsrat kann seine Meinung zu allen Angelegenheiten äußern, welche der Manager dem Aufsichtsrat zukom-

men lässt.

32183

Art. 20. Investitionskomitee und Advisor. Der Manager wird in der Ausübung seiner Managertätigkeit durch ein In-

vestitionskomitee unterstützt (das «Investitionskomitee») und durch einen oder mehrere Berater (hiernach jeweils die
«Berater»).

20.1 Investitionskomitee
Der Manager ist ermächtigt, dass Investitionskomitee zu begründen und aufzulösen. Der Manager hat des weiteren

die Kompetenz, Mitglieder des Investitionskomitees ohne Grund zu benennen und abzuberufen.

Das Investitionskomitee besteht aus einer Anzahl von Mitgliedern, entweder natürliche oder juristische Personen,

welche zwischen drei (3) und sieben (7) liegt. Das Investitionskomitee soll aber aus mindestens (i) zwei (2) Mitgliedern
des Vorstands des Managers, und (ii) anerkannten Immobilienexperten und Finanzspezialisten, die vom Manager benannt
werden, bestehen. Mitglieder des Investitionskomitees werden für eine Dauer von drei (3) Jahren gewählt.

Das  Investitionskomitee  soll  jede  Investitions-  und  De-Investitionsentscheidung  der  Gesellschaft  untersuchen,  be-

trachten  und  einschätzen  und  soll  Rahmenbedingungen  für  alle  Investitionsmöglichkeiten  entwickeln.  Es  soll  auch
Investitionsrichtlinien für den Manager entwickeln, welche sich auf die Erkennung, Erforschung und Ermittlung verschie-
dener Investmentmöglichkeiten in verschiedenen Feldern beziehen.

Das Investitionskomitee soll sich regelmäßig (mindestens vier (4) Mal jährlich) treffen und auch dann wie von Zeit zu

Zeit vorgesehen, um seine Tätigkeiten ausführen zu können.

Jedes Mitglied des Investitionskomitees soll in seinem Amt verbleiben, solange er auch sein Amt als Geschäftsführer

des Managers innehat.

Sollte ein Mitglied des Investitionskomitees von seinem Amt zurücktreten, egal für welchen Grund, wird durch den

Manager sofort ein neues Mitglied ernannt, um das ausscheidende Mitglied zu ersetzen.

Der Manager kann an den Treffen des Investitionskomitees teilnehmen, aber er hat keinen Anspruch auf ein Stimmrecht

in der Sitzung und er wird auch nicht bei der Ermittlung des Quorums berücksichtigt.

Das Investitionskomitee soll seine Beschlüsse mit Mehrheit seiner Mitglieder fassen.
Die Gesellschaft hat keine Verpflichtung, in Objekte zu investieren, welche von dem Investitionskomitee identifiziert

wurden und sie ist auch in keiner Weise an Investitionsempfehlungen des Investitionskomitees gebunden.

Die Gesellschaft wird die Mitglieder des Investitionskomitees für die Erbringung ihrer Leistungen wie in dieser Satzung

beschrieben sowie für die Kosten im Zusammenhang mit der Durchsicht und dem due diligence der Investitionsobjekte
entschädigen, inklusive aller Kosten für Drittberater, Reisen, Übernachtung und Büroausgaben, vorausgesetzt, das die
Gesamtentschädigung einen Betrag von EUR 350.000,- jährlich nicht überschreitet. Ausgaben, welche diesen Betrag über-
schreiten, sind ausschließlich von den Mitgliedern des Investitionskomitees zu tragen.

20.2 Berater
Berater werden durch den Manager ernannt und abgewählt.
Berater beraten den Manager hinsichtlich aller Investitions- und De-Investitionsentscheidungen, Strategieüberlegungen,

Investitionszielen und der Investitionspolitik. Die Gesellschaft hat keine Verpflichtung, in Objekte zu investieren, welche
vom Berater identifiziert wurden und sie ist auch in keiner Weise an Investitionsempfehlungen des Beraters gebunden.

Der Berater kann mit externen Beratern zusammenarbeiten. Der Berater soll aber die Ernennung externer Berater

dem Manager empfehlen zwecks Genehmigung durch den Manager.

Der Berater kann an den Treffen des Investitionskomitees teilnehmen bis dieser Umstand durch das Investitionsko-

mitee anders entscheiden wird.

Der Berater hat kein Stimmrecht hinsichtlich der vom Investitionskomitee und dem Manager zu treffenden Entschei-

dungen.

Weder der Berater noch einer seiner Beschäftigten haben die Berechtigung, Verträge im Namen des Managers der

Gesellschaft zu schließen, bindende Verhandlungen zu führen oder in sonstiger Weise den Manager oder die Gesellschaft
zu verpflichten.

Art. 21. Geschäftsjahr / Konten. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober eines jeden Jahres und

endet am dreißigsten September des Folgejahres, mit der Ausnahme, dass das erste Geschäftsjahr am Tag der Gesell-
schaftsgründung beginnt und am 30. September 2007 endet.

Der Begriff «Geschäftsjahr», wie er in dieser Satzung verwendet wird bezieht sich auf die Periode, welche am (inklusive)

Bilanztag endet und am Tag der Gründung oder am Tag folgend eines Bilanztages beginnt. Der Begriff «Bilanztag», wie er
in dieser Satzung verwendet wird, soll den 30. September 2007 meinen und jeden 30. September der Folgejahre oder (im
Falle des letzten Geschäftsjahres) der Tag des Abschlusses der Liquidation der Gesellschaft.

Der Manager soll selbst oder mittels einer von ihm benannten ausreichend qualifizierten Person die Bilanz der Ge-

sellschaft hinsichtlich eines jeden Geschäftsjahres im Einklang mit anerkannten Bilanzierungsrichtlinien und Vorschriften
luxemburgischen Rechts erstellen, inklusive einer Bilanzübersicht und einer Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Konten sollen in Euro geführt werden. Der Manager wird dafür Sorge tragen, dass die Konten durch einen Prüfer

geprüft werden, welcher vom Manager vorgeschlagen und durch die Hauptversammlung der Aktionäre gewählt wird. Ein
Kompendium der geprüften Konten inklusive des Berichtes des Prüfers sollen jedem Aktionär mindestens fünfzehn (15)
Geschäftstage vor der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre zugesendet werden.

32184

Der Manager soll außerdem innerhalb von neunzig (90) Geschäftstagen nach Ende eines jeden Semesters eines Ge-

schäftsjahres und innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Ende Geschäftsjahres an jeden Aktionär einen Bericht senden
oder versenden lassen, welcher eine Erklärung zu den Investitionen und der Vermögenssituation der Gesellschaft zum
Ende einer solchen Periode umfasst und Details bezüglich der in dieser Periode gekauften und verkauften Investments
beinhaltet. Der Bericht, welcher sich auf das Ende des Geschäftsjahres bezieht, soll von einem Prüfer geprüft werden.

Art. 22. Gesetzliche Reserve - Zinszahlungen und Ausschüttungen. Von dem jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft

sollen fünf Prozent (5%) abgezogen und einer Reserve zugeführt werden. Dieser Abzug soll dann beendet werden, wenn
die Reserve einen Wert von zehn Prozent (10%) des Aktienkapitals erreicht (Aktienagio ausgenommen).

Jedes Jahr und zum ersten Mal achtzehn (18) Monate nachdem die erste Investition getätigt wurde, soll der Manager

vorschlagen, dass, nach Abzug aller Beträge, die der gesetzlichen Reserve und jeder anderen vom Manager begründeten
Reserve zugeführt werden müssen, die verbliebene Summe in der folgenden Reihenfolge ausgeschüttet werden soll:

1) Erstens, an alle Kommanditisten im Verhältnis zu ihren Verpflichtungsbeiträgen, welche bisher an die Gesellschaft

bezahlt wurden bis eine solche Ausschüttung eine Gesamtsumme erreicht, die sich aus folgenden Elementen zusammen-
setzt:

a. Den eingezahlten Verpflichtungsbeiträgen; und
b. Einem bevorzugten Gewinn (der «Gewinn»), der acht Prozent (8%) p.a. des Betrages unter 1) a. ab dem Datum der

Zahlungsaufforderung zur Zahlung der Verpflichtungsbeiträge entspricht; und

2) Zweitens, einhundert Prozent (100%) des verbleibenden Betrages sollen an die Inhaber von C Aktien ausgezahlt

werden bis diese eine Summe von zwanzig Prozent (20%) des Gewinns unter 1) b. oben erhalten haben; und

3) Drittens, nach den Ausschüttungen unter 1) und 2) oben, sollen achtzig Prozent (80%) des Restbetrages an die

Kommanditisten im Verhältnis ihrer Verpflichtungsbeiträge und zwanzig Prozent (20%) des Restbetrages an die Inhaber
von C Aktien als Dividendenzulage gezahlt werden; und

4) Viertens, jeglicher Betrag, der nach den unter 1) bis 3) benannten Ausschüttungen noch verbleibt, steht zur Verfügung

der Hauptversammlung der Aktionäre.

Die Ausschüttungen unter den Punkten 1) bis 3) oben sollen zu solchen Zeiten vorgenommen werden, welche der

Manager bestimmt, und Ausschüttungen unter 4) erfolgen zu den von der Hauptversammlung der Aktionäre bestimmten
Zeiten.

Ausschüttungen können während der Existenz der Gesellschaft, beginnend am Ende eines jeden Geschäftsjahres und

am Ende der Investitionsperiode in bar oder durch Sachleistungen erfolgen, wobei der Manager darüber im Sinne der
folgenden Vorschriften von Zeit zu Zeit entscheiden kann.

Ausschüttungen unter den Punkten 1) and 4) oben sollen auf folgende Art und Weise erfolgen:
- der Manager benachrichtigt zunächst die Aktionäre schriftlich mindestens zehn (10) Tage vor einem Ausschüttungs-

datum, wobei diese schriftliche Benachrichtigung das Datum der vorgeschlagenen Ausschüttung, die auszuschüttenden
Vermögenswerte (eingeschränkt durch mögliche Geheimhaltungsvorschriften), sowie den Wert der auszuschüttenden
Vermögenswerte wiedergeben muss (oder einen Hinweis auf die Grundlage der Berechnung eines solchen Wertes, wie
berechnet zum Datum der Ausschüttung);

- Ausschüttungen in Form von Sachleistungen durch Wertpapiere jeglicher Klasse sollen auf derselben Grundlage

erfolgen wie Barausschüttungen, so dass jeder betroffene Aktionär den entsprechenden Betrag der Gesamtwertpapiere
einer solchen Klasse erhält, welche zur Ausschüttung zur Verfügung steht, oder (falls eine solche Methode der Ausschüt-
tung sich als unpraktisch erweist) auf eine solche Art, dass jeder Aktionäre so viele Wertpapiere einer Aktienklasse wie
möglich erhält plus eines Ausgleichsbetrages, so dass ein jeder solcher Aktionäre im Endeffekt die Summe an Ausschüt-
tungen erhält, die ihm unter diesem Artikel zusteht; und

- eine jede dieser Ausschüttungen als Sachleistung soll in derselben Reihenfolge wie oben erwähnt erfolgen im Wert

der betroffenen Vermögenswerte erfolgen.

Für den Zweck dieses Artikels soll eine Verweisung auf Zahlungen oder Ausschüttungen an die Kommanditisten oder

den Komplementär die Bruttozahlungen meinen oder die Gesamtausschüttung für eine solche Person, ohne die Beträge
zu berücksichtigen, welche durch die Gesellschaft bezüglich dieser Zahlungen oder Ausschüttungen an der Quelle abzu-
ziehen sind.

Art. 23. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschaft soll unter den folgenden Bedingungen aufgelöst und liquidiert

werden:

(a) Abwahl des Managers in seiner Kapazität als Geschäftsführer der Gesellschaft folgend des luxemburgischen Rechts

und den Vorschriften dieser Satzung, unter der Bedingung, dass der Manager umgehend durch einen anderen Geschäfts-
führer, der nach dieser Satzung zu wählen ist, abgelöst wird; oder

(b) zu jeder Zeit nach einem Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher nach einem Vorschlag des

Managers oder des Kommanditisten gefasst wurde.

Im Falle der Auflösung und Liquidation der Gesellschaft soll die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren

(welcher eine natürliche oder juristische Person sein kann) vorgenommen werden, wobei dieser Liquidator durch die

32185

Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt werden soll, welche über die Einleitung der Liquidation entschieden hat. Eine
solche Hauptversammlung soll die Kompetenzen und die Entschädigung des/der Liquidator(en) bestimmen.

Für die Zwecke dieser Satzung soll der Begriff «Investitionsperiode» die Periode meinen, welche am Tag der Gründung

der Gesellschaft beginnt und am 31. März 2015 endet, oder an einem darauf folgenden Tag sollte der Manager die Inves-
titionsperiode verlängern.

Der/die Liquidatoren sollen die Nettoerträge der Liquidation, welche bar oder anderer Natur sein können, in der

folgenden Reihenfolge verteilen:

1) Erstens, vollständige Rückzahlung des Nominalwertes der CPECs und/oder PECs (außer derjenigen CPECs und/

oder PECs welche von Pflichtverletzenden Kommanditisten gehalten werden);

2) Zweitens, vollständige Rückzahlung des Emissionspreises der Klasse A und C Aktien (außer derjenigen Klasse A

und C Aktien welche von Pflichtverletzenden Kommanditisten gehalten werden);

3) Drittens, vollständige Rückzahlung des Emissionspreises der Klasse B Aktien;
4) Viertens, vollständige Rückzahlung des Emissionspreises der Klasse A und C Aktien und des Nominalwertes der

CPECs und/oder PECs der Pflichtverletzenden Kommanditisten; und

5) Fünftens, der Restbetrag soll (am Tag der Beendigung der Gesellschaft) an die Halter von Klasse A Aktien und Klasse

B Aktien und Klasse C Aktien im Einklang mit Artikel 22 Punkte 1) bis 4) dieser Satzung ausgeschüttet werden.

Zum Zwecke der Auflösung der Gesellschaft sollen die von der Hauptversammlung ernannten Liquidatoren berechtigt

sein, Ausschüttungen von Vermögenswerten im Einklang mit den Vorschriften des luxemburgischen Rechts in Form von
Sachleistungen vorzunehmen.

Im Falle der Insolvenz der Gesellschaft ist die Haftung der Kommanditisten auf den Betrag ihrer Verpflichtungsbeiträge

begrenzt, egal ob diese voll oder nicht voll eingezahlt wurden.

Art. 24. Änderung dieser Satzung. Diese Satzung kann von Zeit zu Zeit durch eine Entscheidung der Hauptversammlung

der Aktionäre im Einklang mit den Vorschriften des luxemburgischen Rechts abgeändert werden.

Änderungen dieser Satzung erfordern ein Quorum von mindestens fünfzig Prozent (50%) des bestehenden Aktienka-

pitals und eine Stimmmehrheit von zwei Dritteln (2/3) aller auf der Hauptversammlung anwesenden oder vertretenen
Stimmrechte.

Art. 25. Anwendbares Recht. Alle Angelegenheiten, welche nicht von den Vorschriften dieser Satzung geregelt werden,

unterliegen den Vorschriften des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915, wie abgeändert, und entsprechenden
Vorschriften.

<i>Übergangsvorschrift

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung und endet am 30. September 2007.

<i>Zeichnung

Nachdem diese Satzung beschlossen wurde, erklären die erschienen Parteien, das emittierte Aktienkapital wie folgt

zu zeichnen:

SYCAMORE LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Klasse «A» Aktie

EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.799 Klasse «B» Aktien
EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 Klasse «C» Aktien

Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.900 Aktien

Die vierundzwanzigtausendneunhundert (24.900) Aktien wurden vollständig zu einem jeweiligen Nominalwert pro

Aktie von einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) eingezahlt, was eine Summe von einundreissigtausendein-
hundertfünfundzwanzig  Euro  (EUR  31.125,-)  ergibt  und  zusammen  mit  einer  Summe  von  achtundneunzig  Euro  und
fünfundsiebzig Cents (EUR 98,75) als Aktienagio auf die «A» Aktie eine Gesamtsumme in bar, welche der Gesellschaft
zur Verfügung gestellt wurde, von einundreissigtausendzweihundertdreiundzwanzig Euro und fünfundsiebzig Cents (EUR
31.223,75) ergibt.

Im Ergebnis steht der Gesellschaft ab diesem Zeitpunkt eine Summe von einundreissigtausendzweihundertdreiund-

zwanzig Euro und fünfundsiebzig Cents (EUR 31.223,75) zur Verfügung, welcher Umstand dem Notar, welcher diese
Urkunde ausfertigt, nachgewiesen wurde.

<i>Ausgaben

Die Ausgaben, Kosten, Entschädigungen oder ähnliche Gebühren in jeglicher Form, welche von der Gesellschaft als

Ergebnis ihrer Gründung zu tragen sind, belaufen sich auf ungefähr viertausend Euro (€ 4.000,-).

<i>Außerordentliche Hauptversammlung

Nachdem diese Satzung soeben aufgezeichnet wurde, haben die oben benannten Aktionäre entschieden, umgehend

eine außerordentliche Hauptversammlung abzuhalten. Nachdem sie sichergestellt haben, dass die Hauptversammlung
wirksam zusammengetreten ist, haben die Aktionäre die folgenden Beschlüsse gefasst:

1) Der Sitz der Gesellschaft ist in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg;

32186

2) Als Manager der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wurde ernannt:
EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, société à responsabilité

limitée, gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 73, Côte d'Eich, L-1450
Luxemburg.

3) Als Mitglieder des Aufsichtsrates wurden für eine unbestimmte Zeitdauer ernannt:
a) Herr Fabien Wannier, geboren am 18. Juli 1977 in Bern (Schweiz), Finanzanalytiker, wohnhaft in Tour Eglantines/

1075, CH-3963 Aminona;

b) Herr Stephan Wörnle, geboren am 5. April 1969 in Lausanne (Schweiz), Finanzanalytiker, wohnhaft in 30C, Chemin

da Pré Langard, CH-1223 Cologny; und

c) Herr Dan Amar, geboren am 27. März 1982 in Genf (Schweiz), Finanzanalytiker, wohnhaft in 16, rue Le Corbusier,

CH-1208 Genf.

4) Als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für alle in dieser Satzung benannten Zwecke für das Geschäftsjahr bis und

inklusive dem 30. September 2008 wurde ernannt:

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1014 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg

unter der Nummer B 65.477.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anweisung

der oben erschienen Parteien die vorliegende Satzung in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Version verfasst
ist, und dass auf Hinweis derselben erschienen Parteien im Falle von inhaltlichen Unterschieden zwischen den sprachlichen
Versionen, die englische Version entscheidend sein soll.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.
Nachdem diese Urkunde der anwesenden Person, welche dem unterzeichneten Notar durch Name, Nachname, Fa-

milienstand und Anschrift bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die anwesende Person zusammen mit dem Notar diese
Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Peter, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, vol. 31CS, fol. 86, case 12. — Reçu 312,24 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 14. Februar 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007031736/202/1453.
(070026408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2007.

IN.A.MA Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 63.614.

Les comptes annuels au 31 août 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007032343/267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04615. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

International Consultant Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 23, rue Jean-Pierre Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 59.347.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

32187

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2007032351/506/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2007, réf. LSO-CB03700. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

S.E.T.I. Société Européenne de Transactions Immobilières S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 30.918.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007032345/677/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01788. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070026908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Solidal Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8370 Hobscheid, 6A, rue de Kreuzerbuch.

R.C.S. Luxembourg B 87.539.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007032347/677/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01787. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Eliop International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 83.518.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 13 février 2007 que:
- La démission de Messieurs David De Marco, Bruno Beernaerts et Luigi Profumo en qualité d'administrateur a été

acceptée.

- Ont été nommés administrateurs:
- Monsieur Giovanni Vittore, né le 29 mai 1955 à Turi, Italie, demeurant professionnellement au 4, rue de l'Eau, L-1449

Luxembourg.

- Monsieur Rémy Meneguz, né le 22 mai 1950 à Tressange, France, demeurant professionnellement au 4, rue de l'Eau,

L-1449 Luxembourg.

- Monsieur Frédéric Noel, né le 13 septembre 1967 à Algrange, France, demeurant au 8, Quartier de l'Eglise, L-4987

Sanem.

Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2008.
Le mandat de la société CERTIFICA LUXEMBOURG S.à r.l., RC B 86770, en tant que commissaire aux comptes est

confirmé, il est renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2007.

32188

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007032414/799/26.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04255. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Foncière CG &amp; Associés S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 101.813.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007032348/677/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00580. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(070026912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Esmeralda S.A., Société Anonyme,

(anc. Regana S.A.).

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 72.721.

L'an deux mille sept, le vingt-cinq janvier,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REGANA S.A., avec siège

social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B, numéro 72.721, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 novembre 1999, publié au
Mémorial C, numéro 60 du 19 janvier 2000.

La  séance  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Monsieur  Paul  Lutgen,  licencié  en  sciences  économiques  appliquées,

demeurant à Luxembourg,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Schoppach, licenciée en droit, demeurant à Lu-

xembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l'article 1 

er

 , alinéa 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Il est formé une société

anonyme sous la dénomination de ESMERALDA S.A.»

2) Modification de l'article 8, alinéa 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «L'assemblée générale annuelle

se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 16.00 heures.»

3) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l'actionnaire représenté et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires
présents, le mandataire de l'actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III. Qu'il résulte de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l'intégralité du capital social de

cinquante mille euros (50.000,- €) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

32189

Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 1 

er

 des statuts pour lui donner dorénavant la

teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . alinéa 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ESMERALDA S.A.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 8 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur

suivante:

«  Art. 8. alinéa 1 

er

 .  L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à

16.00 heures.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lutgen, N. Schoppach, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, vol. 157S, fol. 72, case 7. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 20 février 2007.

P. Frieders.

Référence de publication: 2007032352/212/57.
(070027347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Eleven Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 86.024.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Catherine Guffanti, comptable, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au

207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
<i>ELEVEN INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032360/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02831. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

De Hauke Finance S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 49.644.

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 15 février 2007

Après avoir constaté que Monsieur Alain Peigneux avait démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d'adminis-

trateur de la Société, le Conseil d'Administration a décidé de pourvoir à la place d'administrateur devenue vacante en

32190

procédant avec effet immédiat à la nomination provisoire par cooptation de Monsieur Antonio Longo, né le 29 mai 1975
à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

L'Assemblée Générale des Actionnaires, lors de sa première réunion, devra procéder à l'élection définitive de Monsieur

Antonio Longo.

Signature.

Référence de publication: 2007032444/1005/17.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04458. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Immobilière Azur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 58.092.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IMMOBILIERE AZUR S.A.
Représentée par ProServices MANAGEMENT S.à r.l.
<i>Administrateur
Représentée par Monsieur Matthijs Bogers
<i>Gérant

Référence de publication: 2007032361/1084/16.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05004. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Eastern Overseas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 102.611.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme. Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France) demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
EASTERN OVERSEAS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032362/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02832. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Loca-Physio Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8509 Redange-sur-Attert, 8, rue de Beckerich.

R.C.S. Luxembourg B 110.271.

Par la présente, je soussigné Eric Van Acker, demeurant à B-6600 Bastogne, Bourcy 45, associé unique de la société à

responsabilité limitée LOCA-PHYSIO sàrl, constituée le 29 août 2005 par-devant Maître Holtz, notaire à L-Wiltz, inscrite

32191

au RC sous le numéro 110.271, décide ce jour de transférer le siège social de la société à la rue de Beckerich 8 à L-8509
Redange-sur-Attert.

Ce changement prend effet au 1 

er

 février 2007.

E. Van Acker

Référence de publication: 2007032389/822/15.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08781. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070027411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Finalfe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 61.209.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007032364/43/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05022. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070026809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Finstyle - Promotion Industrielle et Financière - S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 48.264.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Catherine Guffanti, comptable, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au

207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
FINSTYLE PROMOTION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032366/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02833. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Findata S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 120.323.

<i>Extrait des resolutions prises lors du Conseil d'Administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.

32192

- Mme Catherine Guffanti, comptable, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au

207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
FINDATA S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032368/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02834. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070026893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Due Esse S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 38.539.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007032369/43/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05023. - Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Positronia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 88.779.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007032373/43/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05024. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Blufin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 95.872.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Mme Catherine GuffantI, comptable, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au

207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, le nouvel administrateur est coopté jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire

statutaire qui procédera à son élection définitive.

32193

Pour extrait sincere et conforme
BLUFIN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032374/1022/21.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02826. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Evendine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 62.658.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme. Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France) demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
EVENDINE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032375/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02828. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Targa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 67.250.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2007032377/43/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05025. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Eurobrick Participations Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 53.413.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.

32194

- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France) demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
EUROBRICK PARTICIPATIONS HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032379/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02829. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070026880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Bourse Immobilière de Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 95, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 107.792.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007032378/1286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03068. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Bistrot Nicolas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3650 Kayl, 42, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 96.996.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007032380/1286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03070. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Eurinvestex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 112.368.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Catherine Guffanti, comptable, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au

207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

32195

Pour extrait sincère et conforme
EURINVESTEX S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032381/1022/24.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02830. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Gesin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 44.953.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.

- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France) demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.

Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
GESIN S.A.
<i>Un mandataire
Signature

Référence de publication: 2007032382/1022/24.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02626. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Recholding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 35.940.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.

- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France) demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.

Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

32196

Pour extrait sincère et conforme
RECHOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032384/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02631. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Dunas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 97.834.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France) demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
DUNAS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032386/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02805. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Transocean Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 14.845.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2007.

P. Frieders
<i>Notaire

Référence de publication: 2007032385/212/12.
(070027346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Ducal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 81.248.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.

32197

- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France) demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
DUCAL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032388/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02824. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070026862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Dominvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 94.230.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France) demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
DOMINVEST S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032390/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02825. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Carloalberto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 110.138.

<i>Extrait de résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 12 février 2007

<i>Déliberations

L'assemblée transfère le siège social de la société au 27, rue des Glacis L-1628 Luxembourg.
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Thierry Nowankiewicz de son mandat d'administrateur.
L'assemblée nomme Maître Chrstian-Charles Lauer, avocat à la Cour, demeurant au 27, rue des Glacis L-1628 Lu-

xembourg aux fonctions d'administrateur pour un mandat échéant à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en
l'an 2012.

L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de Messieurs Alessandro Fasol, travailleur indépendant, demeu-

rant au 25, Piazza della Republica I-20100 Milan et Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant professionnellement
au 32, avenue Monterey L-2163 Luxembourg, pour des mandats échéants à l'issue de l'assemblée générale statutaire à
tenir en l'an 2012.

L'assemblée nomme la société GLOBAL CORPORATE ADVISORS S.A., avec siège social au 32, avenue Monterey

L-2163 Luxembourg aux fonctions de commissaire aux comptes pour un mandat échéant à l'issue de l'assemblée générale
statutaire à tenir en l'an 2012.

32198

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 12 février 2007.

<i>Pour la société
Le conseil d'administration
Signature

Référence de publication: 2007032392/1134/29.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04329. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Agrifin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 80.460.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 12 février 2007

Aux termes d'une délibération en date du 12 février 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France) demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, le nouvel administrateur est coopté jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire

statutaire qui procédera à son étecflon définitive.

Pour extrait sincère et conforme
AGRIFIN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032393/1022/21.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, réf. LSO-CB04093. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Marbo Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 53.835.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 7 janvier 2007 que:
Le siège social est transféré du 4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Lu-

xembourg

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2007032395/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, réf. LSO-CB03925. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Dixor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 114.254.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 12 février 2007

Aux termes d'une délibération en date du 12 février 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France) demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

32199

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, le nouvel administrateur eet coopté jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire

statutaire qui procédera à son élection définitive.

Pour extrait sincère et conforme
DIXOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032397/1022/21.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, réf. LSO-CB04092. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070026858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Duran and Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 121.276.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France) demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
DURAN AND PARTNERS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032400/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02803. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Tymara Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 60.768.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France) demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

32200

Pour extrait sincère et conforme
TYMARA HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032402/1022/24.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02716. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Arno Glass, Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 116.204.

En date du 22 janvier 2007, l'Administrateur C de la société a changé de dénomination de LUXINVESTMENT S.à r.l.

à ENILEC S.à r.l, (n 

o

 RCS B105.176).

Poux mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2007.

<i>Pour ARNO GLASS S.A.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2007032440/1005/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02918. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Four and Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 117.509.

<i>Extrait des resolutions prises lors du Conseil d'Administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.

- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France) demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.

Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
FOUR AND PARTNERS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032404/1022/24.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02759. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

32201

Velodo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 73.127.

<i>Extrait des resolutions prises lors du Conseil d'Administration du 17 janvier 2007

Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel

administrateur:

- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France) demeurant professionnellement

au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-

naire statutaire qui procédera aux élections définitives.

Pour extrait sincère et conforme
VELODO S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032406/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02765. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070026854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Internationale Beteiligungen Holding AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 86.940.

<i>Ext

<i>société en date du 5 janvier 2007 à 11.00 heures

<i>Décisions

L'assemblée, à l'unanimité, a décidé:
- d'accepter la démission de Jean-Louis Casanova de ses fonctions de Verwaltungsratsmitglied.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007032408/4286/18.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, réf. LSO-CB03900. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Picoty Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 88.386.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 8 février 2007 que:
- La démission de Messieurs David De Marco et Bruno Beernaerts en qualité d'administrateur a été acceptée.
- Ont été nommés administrateurs avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2007:

- Monsieur Giovanni Vittore, né le 29 mai 1955 à Turi, Italie, demeurant professionnellement au 4, rue de l'Eau, L-1449

Luxembourg.

- Monsieur Rémy Meneguz, né le 22 mai 1950 à Tressange, France, demeurant professionnellement au 4, rue de l'Eau,

L-1449 Luxembourg.

32202

- Monsieur Cyril Lamorlette, né le 1 

er

 septembre 1974 à Metz, France, demeurant professionnellement au 65, rue

des Romains, L-8041 Strassen.

- Monsieur Pierre François Wery, né le 30 octobre 1965 à Liège, Belgique, demeurant professionnellement au 65, rue

des Romains, L-8041 Strassen.

Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007032410/799/25.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04252. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070027447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Dacomi Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 66.585.

EXTRAIT

Il résuite du Procès -Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue en date du 30 janvier 2007 que:

- Monsieur David de Marco a démissionné de sa fonction d'administrateur.

- Monsieur Philippe Cosich, né à Paris le 8 juillet 1952, demeurante 5, rue de Logelbach 75116 Paris, France, a été

nommé administrateur, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2010.

- Monsieur Jan Rottiers a démissionné de sa fonction d'administrateur.

- Mademoiselle Vesna Cosich, née à Paris le 31 décembre 1985, avec adresse au 55, boulevard Lannes 75116 Paris, a

été nommée administrateur, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2010.

- Mademoiselle Claire Eva Cosich, née à Paris le 14 octobre 1984, avec adresse au 55, boulevard Lannes 75116 Paris,

a été nommée administrateur, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2010.

- Le mandat d'administrateur de Monsieur Jacques Benzeno a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra

en l'an 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007032417/799/25.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04259. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

SANZAR Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 115.066.

La dénomination de l'associé NEW ZEALAND RUGBY FOOTBALL UNION INCORPORATED est désormais la

suivante: NEW ZEALAND RUGBY UNION.

Le siège social de l'associé AUSTRALIAN RUGBY UNION LIMITED est désormais le suivant: Ground Floor 29-57

Christie Street, St Leonards, NSW 2065, Australie.

Luxembourg, le 19 février 2007.

32203

Pour avis sincère et conforme
<i>SANZAR EUROPE S.à r.l.
C. Speecke
<i>Gérant B

Référence de publication: 2007032412/6742/18.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05691. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Soloverte Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 98.350.

Constituée en date du 15 décembre 2003 suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-

Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil C n 

o

 198 du 18 février 2004.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 24 janvier 2007 que, suite au

décès de Mademoiselle Elisabeth Antona survenu en date du 10 décembre 2006, Mademoiselle Jeanne Piek, employée
privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt a été cooptée comme adminis-
tratrice en remplacement de Mademoiselle Elisabeth Antona. Mademoiselle Jeanne Piek terminera le mandat de son
prédécesseur.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de l'assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 25 janvier 2007.

<i>Pour SOLOVERTE FINANCE S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2007032413/687/21.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02545. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

"Sagewood Finance S.A.", Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 91.624.

Constituée en date du 18 décembre 2002 suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-

Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil C n 

o

 294 du 19 mars 2003.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 24 janvier 2007 que, suite au

décès de Mademoiselle Elisabeth Antona survenu en date du 10 décembre 2006, Madame Claude Kraus, expert-comp-
table, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt a été cooptée comme adminis-
tratrice  en  remplacement  de  Mademoiselle  Elisabeth  Antona.  Madame  Claude  Kraus  terminera  le  mandat  de  son
prédécesseur.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de l'assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 25 janvier 2007.

<i>Pour SAGEWOOD FINANCE S.A.
FIDCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2007032418/687/21.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02544. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

32204

Immobilière Centenaire S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 79.891.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 13 dé-

cembre 2000, publié au Mémorial, Recueil C n 

o

 611 en date du 8 août 2001.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 23 janvier 2007 que, suite au

décès de Mademoiselle Elisabeth Antona survenu en date du 10 décembre 2006, Madame Claude Kraus, expert-comp-
table, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt a été cooptée comme adminis-
tratrice  en  remplacement  de  Mademoiselle  Elisabeth  Antona.  Madame  Claude  Kraus  terminera  le  mandat  de  son
prédécesseur.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de l'assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 24 janvier 2007.

<i>Pour IMMOBILIERE CENTENAIRE S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2007032421/687/21.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02542. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Luxgala S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 111.677.

<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés de la Société le 9 février 2007

Il résulte des résolutions des associés du 9 février 2007 que:
- Les associés ont accepté la démission de Monsieur Alistair Peel, en tant que gérant de classe B de la Société, avec

effet immédiat;

- Les associés ont nommé Gérard Conway, né le 13 novembre 1968 à Merton, Grande Bretagne, ayant son adresse

professionnelle au 20 Old Bailey, London, EC4M -7LN, Grande Bretagne, en tant que nouveau gérant de classe B, avec
effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Il en résulte qu'à compter du 9 février 2007, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:

<i>- Class A:

- Eddy Perrier
- John Marren

<i>- Class B:

- Gerard Conway
- Bruno Bagnouls

<i>- Class C:

- Daniele Arendt-Michels
- Kevin Whale

E. Perrier
<i>Gérant de classe A

Référence de publication: 2007032431/3794/29.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, réf. LSO-CB04058. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

32205

Mass Metropolitan International AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6760 Grevenmacher, 26, rue de Muenschecker.

R.C.S. Luxembourg B 69.504.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom Freitag, dem 15. Dezember 2006

<i>Beschlüsse

1. Herr Paul-Hubertus Nelke scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft aus.
2. Herr Yury Kozhemyakin, wohnhaft in 22, Grand-Rue, L-6730 Grevenmacher, wird mit sofortiger Wirkung zum

Mitglied des Verwaltungsrates bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2010 statt finden wird, berufen.

3. Die Berufung des Herrn Franc Smidt, wohnhaft in 24, rue de Strasbourg, L-2560 Luxembourg und des Herrn Vladislav

Reger, wohnhaft in Ostallee 19, D-54290 Trier in den Verwaltungsrat und zur täglichen Geschäftsführung wird in der
bestehenden Form bis zur Generalversammlung, die im Jahr 2010 stattfinden wird, bestätigt.

4. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft ABAKUS SERVICE S.A. als Rechnungskommissar nach 50, rue Nicolas

Martha, L-2133 Luxembourg, wird zur Kenntnis genommen.

Für die Richtigkeit des Auszuges
ABAKUS SERVICE S.A.
Unterschrift

Référence de publication: 2007032422/2323/22.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08770. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070027391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Sabinade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 103.488.

Constituée en date du 29 septembre 2004 suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-

Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil C n 

o

 1301 du 18 décembre 2004.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 29 janvier 2007 que, suite au

décès de Mademoiselle Elisabeth Antona survenu en date du 10 décembre 2006, Mademoiselle Jeanne Piek, employée
privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt a été cooptée comme adminis-
tratrice en remplacement de Mademoiselle Elisabeth Antona. Mademoiselle Jeanne Piek terminera le mandat de son
prédécesseur.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de l'assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 30 janvier 2007.

<i>Pour la société SABINADE S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2007032423/687/21.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02552. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

York S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 53.862.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 29 août 2005 que:
1) Ont été réélus Administrateurs:
- Madame Sonja Linz, demeurant professionnellement au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
- Monsieur Georges Deitz, demeurant professionnellement au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
2) Est réélu Commissaire aux Comptes:
- CERTIFICA LUXEMBOURG S.àr.l., domicilié au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

32206

Les Administrateurs ainsi que le Commissaire aux Comptes sont élus jusqu'à l'Assemblée qui statuera sur les comptes

arrêtés au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007032425/799/22.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, réf. LSO-CA00243. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070027371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Picarus N.V. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 111.407.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 17 octobre

2005, publié au Mémorial Recueil C n 

o

 318 du 13 février 2006.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 29 janvier 2007 que, suite au

décès de Mademoiselle Elisabeth Antona survenu en date du 10 décembre 2006, Madame Claude Kraus, expert-comp-
table, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt a été cooptée comme adminis-
trateur  en  remplacement  de  Mademoiselle  Elisabeth  Antona,  Madame  Claude  Kraus  terminera  le  mandat  de  son
prédécesseur.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de l'assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 30 janvier 2007.

<i>Pour PICARUS NV S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2007032426/687/21.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02551. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Espro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 76.961.

Gegründet am 24. Juli 2000, gemäß Urkunde des Notars Robert Schuman, Notar mit Amtssitz in L-Differdingen, veröf-

fentlicht im Mémorial, Recueil C n 

o

 894 vom 16. Dezember 2000;

Statuten geändert am 19. Dezember 2000, gemäß Urkunde des oben genannten Notars, veröffentlicht im Mémorial,
Recueil C n 

o

 53 vom 18. Januar 2003.

Aus dem Protokoll der Versammlung des Verwaltungsrates vom 29. Januar 2007 geht hervor, dass aufgrund des Todes

von Frau Elisabeth Antona, welcher am 10. Dezember 2006 eintrat, Frau Claude Kraus, diplomierte Buchhalterin, mit
beruflichem Wohnsitz in L-2450 Luxemburg, 15, boulevard Roosevelt, als Verwaltungsratsmitglied hinzugewählt wurde.

Frau Claude Kraus beendet das Mandat ihrer Vorgängerin.
Diese Zuwahl wird Gegenstand einer Ratifizierung in der nächsten Generalversammlung der Aktionäre sein.

Luxemburg, den 30. Januar 2007.

<i>Für ESPRO S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Unterschrift

Référence de publication: 2007032429/687/22.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02550. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

32207

Orellana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 65.755.

La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 16 juillet 1998, publié au Mémorial Recueil des Sociétés

et Associations C numéro 765 du 22 octobre 1998, dont la dernière modification des statuts est intervenue suivant
acte de Maître Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 avril 2000, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 726 du 5 octobre 2000.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007032485/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03201. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070026850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Envipro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 54.854.

Gegründet am 25. April 1996, gemäß Urkunde des Notars Paul Bettingen, Notar mit Amtssitz in L-Niederanven, veröf-

fentlicht im Mémorial, Recueil C n 

o

 389 vom 13. August 1996.

Statuten wurden zuletzt geändert am 30. Mai 2005, gemäß Urkunde des Notars Emile Schlesser, Notar mit Amtssitz
in L-Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C n 

o

 1081 vom 22. Oktober 2005.

Aus dem Protokoll der Versammlung des Verwaltungsrates vom 23. Januar 2007 geht hervor, dass aufgrund des Todes

von Frau Elisabeth Antona, welcher am 10. Dezember 2006 eintrat, Frau Claude Kraus, diplomierte Buchhalterin, mit
beruflichem Wohnsitz in L-2450 Luxemburg, 15, boulevard Roosevelt, als Verwaltungsratsmitglied hinzugewählt wurde.

Frau Claude Kraus beendet das Mandat ihrer Vorgängerin.
Diese Zuwahl wird Gegenstand einer Ratifizierung in der nächsten Generalversammlung der Aktionäre sein.

Luxemburg, den 24. Januar 2007.

<i>Für ENVIPRO S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Unterschriften

Référence de publication: 2007032430/687/22.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02566. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070027335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Header Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 45.470.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 45.707 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007032075/211/11.
(070027295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

32208


Document Outline

Agrifin S.A.

Arno Glass

Bistrot Nicolas S.à r.l.

Blufin S.A.

Bourse Immobilière de Luxembourg

Carloalberto S.A.

Dacomi Investissements S.A.

De Hauke Finance S.A.

Dixor S.A.

Dominvest S.A.

Ducal S.A.

Due Esse S.A.

Dunas S.A.

Duran and Partners S.A.

Eastern Overseas S.A.

Eleven Investment S.A.

Eliop International S.A.

Envipro S.A.

Esmeralda S.A.

Espro S.A.

Eurinvestex S.A.

Eurobrick Participations Holding S.A.

Evendine S.A.

Even RX Properties S.C.A.

Finalfe S.A.

Findata S.A.

Finstyle - Promotion Industrielle et Financière - S.A.

Foncière CG &amp; Associés S.A.

Four and Partners S.A.

Gesin S.A.

Header Holding S.A.

Immobilière Azur S.A.

Immobilière Centenaire S.A.

IN.A.MA Invest S.à r.l.

IN.A.MA S.à r.l.

International Consultant Company S.A.

Internationale Beteiligungen Holding AG

Loca-Physio Sàrl

Luxgala S.àr.l.

Marbo Holding S.A.

Mass Metropolitan International AG

Orellana S.à r.l.

Picarus N.V. S.A.

Picoty Europe S.A.

Positronia S.A.

Recholding S.A.

Regana S.A.

Sabinade S.A.

"Sagewood Finance S.A."

SANZAR Europe S.à r.l.

S.E.T.I. Société Européenne de Transactions Immobilières S.A.

Solidal Luxembourg S.A.

Soloverte Finance S.A.

Targa S.A.

Transocean Properties S.A.

Tymara Holding S.A.

Velodo S.A.

York S.A.