logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 581

11 avril 2007

SOMMAIRE

Adomex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27874

Aircargo Trucking S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27886

Albarossa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27876

Albarossa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27872

BRE/GH II Dresden V Manager S. à r.l.  . . .

27854

BRE/GH II Leipzig II Manager S. à r.l.  . . . .

27842

BRE/GH II Property I Manager S. à r.l.  . . .

27848

Capgemini Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .

27887

Colombo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27878

De Beers Ukraine Prospecting S.A.  . . . . . .

27878

Doria S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27879

Eaglemax S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27874

Edwin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27881

Extrabold S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27887

Fingi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27888

Forme et Coiffure S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

27887

GEA Happel Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

27875

GENPASA Environmental Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27882

GENPASA Environmental Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27888

Global Logistic Partners S.A.  . . . . . . . . . . . .

27886

Holta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27876

Imovestlux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27875

INTRAWEST Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

27875

KRD-Services S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27876

LBREP II Europe Holdings S.à r.l. . . . . . . . .

27860

L.G.L. Luxembourg Genuine Leather S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27872

Mizel Guy NESS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27873

Morley International Fund  . . . . . . . . . . . . . .

27873

Novator Pharma S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

27882

Novator Telecom Poland II S.à r.l. . . . . . . .

27881

Popoff Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27883

Private Trustees S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27875

Safia International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27883

SOGETI Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

27887

Teilen Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27872

The Multinational Consortium for General

Trade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27877

The Multinational Holding Consortium

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27880

Turton Limited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27877

Turton Limited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27876

Valene S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27883

Valentine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27878

Vespucci S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27880

Vicky Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27882

Videma S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27879

Volgacote S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27888

Waterlemon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27865

W.A.T. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27886

Wininvest Holdings SA  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27873

27841

BRE/GH II Leipzig II Manager S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 124.012.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the eleventh day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 118.245.

here represented by Mrs Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal in Luxembourg, on 9 January 2007.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and in particular in German «Kommanditgesellschaften» as general partner and any other form of
investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes or other securities of any kind and the administration, control and devel-
opment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is to borrow money in any form and give securities for any borrowings.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration,  control  and  development.  For  that  purpose,  the  Company  may  require  and  retain  the  assistance  of  other
advisors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/GH II LEIPZIG II MANAGER S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of

27842

the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.

Art. 10. The death, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of the shareholders may for any reason affix seals on assets or

documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.

The sole manager or the board of managers may grant powers of attorney by authentic proxy or by private instrument.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman, and

may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager,
and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

27843

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies, as
amended.

Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:
- five hundred (500) shares by BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the thirty-first

day of December 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having

its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under section B number 96.323, is appointed manager of the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, den elften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

BRE/GERMAN  HOTEL  HOLDING  II  S.à  r.l.,  eine  société  à  responsabilité  limitée  gegründet  nach  dem  Recht  des

Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-
und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 118.245,

27844

hier vertreten durch Frau Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschrift-

lichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 9. Januar 2007.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend  die  «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

insbesondere an deutschen Kommanditgesellschaften als Komplementär und Investitionen jeder Art, der Erwerb durch
Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise von Aktien,
Obligationen, Schuldscheinen und anderen Wertpapieren jeglicher Art und die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung
ihres Wertpapierbestandes.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Kreditaufnahme jeglicher Art und die Gewährung von Sicherheiten für

jegliche Kreditaufnahme.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den für die Verwaltung,

Kontrolle und Verwertung notwendigen Dienstleistungen versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/GH II LEIPZIG II MANAGER S.à r.I.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der (i) Mehrheit der Gesellschafter (ii) wobei

diese Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der

Gesellschaft.

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-

genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

27845

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus mindestens

zwei Geschäftsführern, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich oder aufgrund

notariell beglaubigter Urkunde erteilt.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-

sellschaft nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

27846

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

Art. 20. Die Gesellschaft darf nie mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Natürliche Personen können nicht Ge-

sellschafter der Gesellschaft werden.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- fünfhundert 500 Anteile wurden von BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

eintausendneunhundert Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit

Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter
Sektion B Nummer 96.323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: N. Schmidt-Troje, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 60, case 10. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

27847

Mersch, den 26. Januar 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007026024/242/325.
(070020598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.

BRE/GH II Property I Manager S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 124.008.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the eleventh day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 118.245.

here represented by Mrs Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal in Luxembourg, on 9 January 2007.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and in particular in German «Kommanditgesellschaften» as general partner and any other form of
investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes or other securities of any kind and the administration, control and devel-
opment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is to borrow money in any form and give securities for any borrowings.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration,  control  and  development.  For  that  purpose,  the  Company  may  require  and  retain  the  assistance  of  other
advisors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/GH II PROPERTY I MANAGER S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

27848

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.

Art. 10. The death, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of the shareholders may for any reason affix seals on assets or

documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.

The sole manager or the board of managers may grant powers of attorney by authentic proxy or by private instrument.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman, and

may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager,
and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

27849

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies, as
amended.

Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:
- five hundred (500) shares by BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the thirty-first

day of December 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having

its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under section B number 96.323, is appointed manager of the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

27850

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, den elften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

BRE/GERMAN  HOTEL  HOLDING  II  S.à  r.l.,  eine  société  à  responsabilité  limitée  gegründet  nach  dem  Recht  des

Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-
und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 118.245,

hier vertreten durch Frau Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschrift-

lichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 9. Januar 2007.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

insbesondere an deutschen Kommanditgesellschaften als Komplementär und Investitionen jeder Art, der Erwerb durch
Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise von Aktien,
Obligationen, Schuldscheinen und anderen Wertpapieren jeglicher Art und die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung
ihres Wertpapierbestandes.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Kreditaufnahme jeglicher Art und die Gewährung von Sicherheiten für

jegliche Kreditaufnahme.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den für die Verwaltung,

Kontrolle und Verwertung notwendigen Dienstleistungen versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/GH II PROPERTY I MANAGER S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter (ii) wobei

diese Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der

Gesellschaft.

27851

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-

genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus mindestens

zwei Geschäftsführern, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich oder aufgrund

notariell beglaubigter Urkunde erteilt.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-

sellschaft nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

27852

D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

Art. 20. Die Gesellschaft darf nie mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Natürliche Personen können nicht Ge-

sellschafter der Gesellschaft werden.

E. Geschäftsjahr - Kontengewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- fünfhundert 500 Anteile wurden von BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

eintausendneunhundert Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit

Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter
Sektion B Nummer 96.323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

27853

Gezeichnet: N. Schmidt-Troje, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 60, case 11. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Mersch, den 26. Januar 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007026025/242/325.
(070020531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.

BRE/GH II Dresden V Manager S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 124.006.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the eleventh day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 118.245.

here represented by Mrs Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal in Luxembourg, on 9 January 2007.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and in particular in German «Kommanditgesellschaften» as general partner and any other form of
investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes or other securities of any kind and the administration, control and devel-
opment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is to borrow money in any form and give securities for any borrowings.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration,  control  and  development.  For  that  purpose,  the  Company  may  require  and  retain  the  assistance  of  other
advisors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/GH II DRESDEN V MANAGER S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

27854

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.

Art. 10. The death, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of the shareholders may for any reason affix seals on assets or

documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.

The sole manager or the board of managers may grant powers of attorney by authentic proxy or by private instrument.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman, and

may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager,
and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

27855

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies, as
amended.

Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:
- five hundred (500) shares by BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the thirty-first

day of December 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having

its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under section B number 96.323, is appointed manager of the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.

27856

The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, den elften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

BRE/GERMAN  HOTEL  HOLDING  II  S.à  r.l.,  eine  société  à  responsabilité  limitée  gegründet  nach  dem  Recht  des

Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-
und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 118.245,

hier vertreten durch Frau Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschrift-

lichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 9. Januar 2007.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

insbesondere an deutschen Kommanditgesellschaften als Komplementär und Investitionen jeder Art, der Erwerb durch
Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise von Aktien,
Obligationen, Schuldscheinen und anderen Wertpapieren jeglicher Art und die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung
ihres Wertpapierbestandes.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Kreditaufnahme jeglicher Art und die Gewährung von Sicherheiten für

jegliche Kreditaufnahme.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den für die Verwaltung,

Kontrolle und Verwertung notwendigen Dienstleistungen versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/GH II DRESDEN V MANAGER S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter (ii) wobei

diese Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

27857

Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der

Gesellschaft.

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-

genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus mindestens

zwei Geschäftsführern, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich oder aufgrund

notariell beglaubigter Urkunde erteilt.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-

sellschaft nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

27858

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

Art. 20. Die Gesellschaft darf nie mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Natürliche Personen können nicht Ge-

sellschafter der Gesellschaft werden.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- fünfhundert 500 Anteile wurden von BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

eintausendneunhundert Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit

Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter
Sektion B Nummer 96.323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

27859

Gezeichnet: N. Schmidt-Troje, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 61, case 2. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Mersch, den 26. Januar 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007026032/242/325.
(070020518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.

LBREP II Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 774.475,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 106.232.

In the year two thousand and six, on the sixth of November.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appear:

HARBOR BERMUDA, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered office at

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 36.838;

LBPOL BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered

office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 36.831;

SERICO BERMUDA, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered office at

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 36.987;

IPPOCRATE BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its

registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37.035;

POSEIDON  BERMUDA  HOLDINGS,  L.P.,  a  limited  partnership  organized  under  the  laws  of  Bermuda,  having  its

registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37.034;

ATEMI BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered

office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37.532;

LINCO BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered

office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37.695;

WILLIAM BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its regis-

tered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37.769;

LE PROVENCAL BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its

registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37893;

SIERRA BLANCA BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having

its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 36811;

ANGEL CITY BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its

registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37771;

WILLIAM  II  BERMUDA  HOLDINGS,  L.P.,  a  limited  partnership  organized  under  the  laws  of  Bermuda,  having  its

registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 38357,

TORMARANCIA BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its

registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 38628,

CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having

its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 38644,
and

ZOLIBORZ  BERMUDA  HOLDINGS,  L.P.,  a  limited  partnership  organized  under  the  laws  of  Bermuda,  having  its

registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 38212,

SEGOVIA BERMUDA HOLDINGS L.P., an exempted partnership, having its registered office at Clarendon House, 2

Church Street, Hamilton HM II, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 39005

DUNA BERMUDA HOLDINGS L.P., an exempted partnership, having its registered office at Clarendon House, 2

Church Street, Hamilton HM II, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 39033

all here represented by Mr Grégoire Fraisse, employee, with professional address at 1 B, Heienhaff, L-1736 Sennin-

gerberg, by virtue of seventeen (17) proxies established on September 20th, 2006 and October 27th, 2006.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

27860

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité limitée»)

existing in Luxembourg under the name of LBREP II EUROPE HOLDINGS S.à r.l. with registered office at 1B Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, under number 106.232,
incorporated by a deed of the undersigned notary of January 19, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 600 dated June 22, 2005, and whose bylaws have been last amended by an extraordinary general
meeting held on September 20, 2006 in front of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is fixed at six hundred forty-two thousand eight hundred Euros (EUR 642,800.-) divided

into six hundred fifty-five (655) class A ordinary shares, six hundred and three (603) class B ordinary shares, one thousand
seven hundred forty-five (1,745) class C ordinary shares, two thousand two hundred fifty-four (2,254) class D ordinary
shares, three hundred ninety (390) class E ordinary shares, six thousand seventy-five (6,075) class F ordinary shares, one
hundred and one (101) class G ordinary shares, six thousand sixty-one (6,061) class H ordinary shares, forty (40) class I
ordinary shares, forty (40) class J ordinary shares and forty (40) class K ordinary shares, seventy-five (75) class L ordinary
shares, seventy-five (75) class M ordinary shares, seventy-five (75) class N ordinary shares, seventy-five (75) class O
ordinary shares, two thousand eight hundred and ninety-three (2,893) class P ordinary shares, seventy-five (75) class Q
ordinary shares, three thousand eight hundred and forty (3,840) class R ordinary shares, seventy-five (75) class S ordinary
shares, seventy-five (75) class T ordinary shares, seventy-five (75) class U ordinary shares, seventy-five (75) class V ordinary
shares, seventy-five (75) class W ordinary shares, seventy-five (75) class X ordinary shares, seventy-five (75) class Y
ordinary shares, seventy-five (75) class Z ordinary shares, all with a nominal value of twenty-five Euros (€ 25.-) each.

III. The shareholders resolve to increase the Company's corporate capital to the extent of one hundred thirty-five

thousand eight hundred and fifty Euros (EUR 135,850.-) to raise it from its present amount of six hundred forty-two
thousand eight hundred Euros (EUR 642,800.-) to seven hundred seventy-eight thousand six hundred and fifty Euros (EUR
778,650.-) by creation and issue of five thousand four hundred and thirty-four (5,434) class C ordinary shares, all with a
nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each (the «New Shares»).

IV. HARBOR BERMUDA, L.P. prenamed, LBPOL BERMUDA HOLDINGS, L.P. prenamed, IPPOCRATE BERMUDA

HOLDINGS, L.P prenamed, POSEIDON BERMUDA HOLDINGS, L.P. prenamed, ATEMI BERMUDA HOLDINGS, L.P.
prenamed, WILLIAM BERMUDA HOLDINGS L.P. prenamed, SIERRA BLANCA BERMUDA HOLDINGS, L.P. prenamed,
ANGEL CITY BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, LE PROVENÇAL BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, TOR-
MARANCIA BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, WILLIAM II BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, CANNON
BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, LINCO BERMUDA HOLDINGS, L.P prenamed, ZOLIBORZ BER-
MUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, SEGOVIA BERMUDA HOLDINGS LP, prenamed and DUNA BERMUDA HOLD-
INGS LP, prenamed, resolve to waive their preferential subscription right in favour of SERICO BERMUDA, L.P. prenamed,
to the subscription for the New Shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

SERICO BERMUDA, L.P prenamed, declared to subscribe the five thousand four hundred and thirty-four (5,434) new

class C ordinary shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, together with a share premium in the
amount of twenty Euros (EUR 20.-), and have them fully paid up in the total amount of one hundred thirty-five thousand
eight hundred and seventy Euros (EUR 135,870.-) by contribution in kind consisting in one hundred thirty-five thousand
eight hundred and seventy (135,870) preferred equity certificates with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and
an aggregate value of one hundred thirty-five thousand eight hundred and seventy Euros (EUR 135,870.-), held by SERICO
BERMUDA, L.P. pursuant to the terms and conditions of a subscription agreement executed between the Company and
SERICO BERMUDA, L.P. on August 31, 2005, and according to which the Company issued in favour of Serico Bermuda
L.P. seven million one hundred twenty-two thousand eight hundred and thirty-eight (7,122,838) preferred equity certif-
icates (the «Agreement»).

Proof of the existence and the holding of the preferred equity certificates have been given to the undersigned Notary

by a copy of the Agreement.

VI. Pursuant to the above increase of capital, article 5, first paragraph of the Company's articles of association is

amended and shall henceforth read as follows:

« Art. 5. First paragraph. The issued capital of the Company is set at seven hundred seventy-eight thousand six hundred

and fifty Euros (EUR 778,650.-) divided into six hundred fifty-five (655) class A ordinary shares, six hundred and three
(603) class B ordinary shares, seven thousand one hundred and seventy-nine (7,179) class C ordinary shares, two thousand
two hundred fifty-four (2,254) class D ordinary shares, three hundred ninety (390) class E ordinary shares, six thousand
seventy-five (6,075) class F ordinary shares, one hundred and one (101) class G ordinary shares, six thousand sixty one
(6,061) class H ordinary shares, forty (40) class I ordinary shares, forty (40) class J ordinary shares, forty (40) class K
ordinary shares, seventy-five (75) class L ordinary shares, seventy-five (75) class M ordinary shares, seventy-five (75) class
N ordinary shares, seventy-five (75) class O ordinary shares, two thousand eight hundred and ninety-three (2,893) class
P ordinary shares, seventy-five (75) class Q ordinary shares, three thousand eight hundred and forty (3,840) class R
ordinary shares, seventy-five (75) class S ordinary shares, seventy-five (75) class T ordinary shares, seventy-five (75) class
U ordinary shares, seventy-five (75) class V ordinary shares, seventy-five (75) class W ordinary shares, seventy-five (75)

27861

class X ordinary shares, seventy-five (75) class Y ordinary shares, seventy-five (75) class Z ordinary shares, all with a
nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.»

VII. The shareholders resolve to decrease the Company's share capital from seven hundred seventy-eight thousand

six hundred and fifty Euros (EUR 778,650.-) to seven hundred seventy-four thousand four hundred and seventy-five Euros
(EUR 774,475.-) by an amount of four thousand one hundred and seventy-five Euros (€ 4,175.-) through the cancellation
of one hundred and sixty-seven (167) Class E shares, all with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, by
reimbursement to POSEIDON BERMUDA HOLDINGS, L.P. prenamed, of the amount of four thousand one hundred
and seventy-five Euros (EUR 4,175.-).

VIII. Pursuant to the above decrease of capital, article 5, first paragraph of the Company's articles of association is

amended and shall henceforth read as follows:

« Art. 5. First paragraph. The issued capital of the Company is set at seven hundred seventy-four thousand four hundred

and seventy-five Euros (EUR 774,475.-) divided into six hundred fifty-five (655) class A ordinary shares, six hundred and
three (603) class B ordinary shares, seven thousand one hundred and seventy-nine (7,179) class C ordinary shares, two
thousand two hundred fifty-four (2,254) class D ordinary shares, two hundred and twenty-three (223) class E ordinary
shares, six thousand seventy-five (6,075) class F ordinary shares, one hundred and one (101) class G ordinary shares, six
thousand sixty-one (6,061) class H ordinary shares, forty (40) class I ordinary shares, forty (40) class J ordinary shares
and forty (40) class K ordinary shares, seventy-five (75) class L ordinary shares, seventy-five (75) class M ordinary shares,
seventy-five (75) class N ordinary shares, seventy-five (75) class O ordinary shares, two thousand eight hundred and
ninety-three (2,893) class P ordinary shares, seventy-five (75) class Q ordinary shares, three thousand eight hundred and
forty (3,840) class R ordinary shares, seventy-five (75) class S ordinary shares, seventy-five (75) class T ordinary shares,
seventy-five (75) class U ordinary shares, seventy-five (75) class V ordinary shares, seventy-five (75) class W ordinary
shares,  seventy-five  (75)  class  X  ordinary  shares,  seventy-five  (75)  class  Y  ordinary  shares,  seventy-five  (75)  class  Z
ordinary shares, all with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately three thousand five hundred Euros (EUR 3,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le six novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

HARBOR BERMUDA L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton

HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 36.838;

LBPOL BERMUDA HOLDINGS L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 36.831;

SERICO BERMUDA L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton

HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 36.987;

IPPOCRATE BERMUDA HOLDINGS L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37.035;

POSEIDON BERMUDA HOLDINGS L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37.034;

ATEMI BERMUDA HOLDINGS L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street,

Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37.532;

LINCO BERMUDA HOLDINGS L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37.695;

WILLIAM BERMUDA HOLDINGS L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37.769;

27862

LE PROVENCAL BERMUDA HOLDINGS L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2

Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37893;

SIERRA BLANCA BERMUDA HOLDINGS L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2

Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 36811; et

ANGEL CITY BERMUDA HOLDINGS L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37771;

WILLIAM II BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 38357;

TORMARANCIA BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2

Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 38628;

CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House,

2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 38644;

ZOLIBORZ BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 38212;

SEGOVIA BERMUDA HOLDINGS L.P., un exempted partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 39005;

DUNA BERMUDA HOLDINGS L.P., un exempted partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 39033;

tous ici représentés par M. Grégoire Fraisse, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, en vertu de dix-sept (17) procurations données les 20 septembre et 27 octobre 2006.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomi-

nation  de  LBREP  II  EUROPE  HOLDINGS  S.à  r.l.  (la  «Société»),  ayant  son  siège  social  au  1B,  Heienhaff,  L-1736
Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro
106.232, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 19 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 600 en date du 22 juin 2005, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 20 septembre 2006 tenue devant le notaire soussigné, en cours
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à six cent quarante-deux mille huit cents Euros (EUR 642.800,-) divisé en six

cent cinquante-cinq (655) parts sociales ordinaires de classe A, six cent trois (603) parts sociales ordinaires de classe B,
mille sept cent quarante-cinq (1.745) parts sociales ordinaires de classe C, deux mille deux cent cinquante-quatre (2.254)
parts sociales ordinaires de classe D, trois cent quatre-vingt-dix (390) parts sociales ordinaires de classe E, six mille
soixante-quinze (6.075) parts sociales ordinaires de classe F, cent une (101) parts sociales ordinaires de classe G, six mille
soixante et une (6.061) parts sociales ordinaires de classe H, quarante (40) parts sociales ordinaires de classe I, quarante
(40) parts sociales ordinaires de catégorie J, quarante (40) parts sociales ordinaires de catégorie K, soixante-quinze (75)
parts sociales ordinaires de catégorie L, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie M, soixante-quinze
(75) parts sociales ordinaires de catégorie N, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie O, deux mille
huit cent quatre-vingt-treize (2.893) parts sociales ordinaires de catégorie P, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires
de catégorie Q, trois mille huit cent quarante (3.840) parts sociales ordinaires de catégorie R, soixante-quinze (75) parts
sociales ordinaires de catégorie S, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie T, soixante-quinze (75) parts
sociales ordinaires de catégorie U, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie V, soixante-quinze (75)
parts sociales ordinaires de catégorie W, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie X, soixante-quinze
(75) parts sociales ordinaires de catégorie Y et soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie Z, ayant toutes
une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

III. Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent trente-cinq mille huit cent

cinquante Euros (EUR 135.850,-) pour le porter de son montant actuel de six cent quarante-deux mille huit cents Euros
(EUR 642.800,-) à sept cent soixante-dix-huit mille six cent cinquante Euros (EUR 778.650,-) par la création et l'émission
de cinq mille quatre cent trente-quatre (5.434) parts sociales ordinaires de classe C d'une valeur nominale de vingt-cinq
Euros (EUR 25,-) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»).

IV. HARBOR BERMUDA, L.P. prénommé, LBPOL BERMUDA HOLDINGS, L.P. prénommé, IPPOCRATE BERMUDA

HOLDINGS, L.P prénommé, POSEIDON BERMUDA HOLDINGS, L.P. prénommé, ATEMI BERMUDA HOLDINGS, L.P.
prénommé, WILLIAM BERMUDA HOLDINGS L.P. prénommé, SIERRA BLANCA BERMUDA HOLDINGS, L.P. prén-
ommé, ANGEL CITY BERMUDA HOLDINGS, L.P prénommé, LE PROVENÇAL BERMUDA HOLDINGS L.P., prénom-
mé, TORMARANCIA BERMUDA HOLDINGS, L.P., prénommé, WILLIAM II BERMUDA HOLDINGS, L.P., prénommé,
LINCO BERMUDA HOLDINGS, L.P., prénommé, CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P., prénommé, Z ,
L.P., prénommé, SEGOVIA BERMUDA HOLDINGS, L.P., prénommé, et DUNA BERMUDA HOLDINGS, L.P., prénom-

27863

mé, décident de renoncer à leur droit de souscription préférentiel en faveur de SERICO BERMUDA, L.P. prénommé,
pour la souscription des Nouvelles Parts Sociales.

<i>Intervention - Souscription - Libération

SERICO BERMUDA, L.P., précité, déclare souscrire aux cinq mille quatre cent trente-quatre (5.434) nouvelles parts

sociales ordinaires de classe C de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune et les libère intégralement pour un montant de
cent trente-cinq mille huit cent cinquante Euros (EUR 135.850,-), ensemble avec une prime d'émission d'un montant de
vingt Euros (EUR 20,-), par apport en nature d'un montant total de cent trente-cinq mille huit cent soixante-dix Euros
(EUR 135.870,-) consistant en cent trente-cinq mille huit cent soixante-dix (135.870) preferred equity certificates détenus
par SERICO BERMUDA, L.P., en vertu d'un contrat de souscription exécuté entre la Société et SERICO BERMUDA, L.P.
le 31 août 2005, en vertu duquel la Société à émis au profit de SERICO BERMUDA L.P. sept million cent vingt-deux mille
huit cent trente-huit (7.122.838) preferred equity certificates (le «Contrat»).

Preuve de l'existence et de la détention des preferred equity certificates a été donnée au notaire instrumentant par

une copie du Contrat.

VI. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 5, premier paragraphe des statuts de la Société est modifié pour

avoir désormais la teneur suivante:

«  Art. 5. 1 

er

 Paragraphe.  Le capital social émis de la Société est fixé à sept cent soixante-dix-huit mille six cent

cinquante Euros (EUR 778.650,-) divisé en six cent cinquante-cinq (655) parts sociales ordinaires de classe A, six cent
trois (603) parts sociales ordinaires de classe B, sept mille cent soixante-dix-neuf (7.179) parts sociales ordinaires de
classe C, deux mille deux cent cinquante-quatre (2.254) parts sociales ordinaires de classe D, trois cent quatre-vingt-dix
(390) parts sociales ordinaires de classe E, six mille soixante-quinze (6.075) parts sociales ordinaires de classe F, cent une
(101) parts sociales ordinaires de classe G, six mille soixante et une (6.061) parts sociales ordinaires de classe H, quarante
(40) parts sociales ordinaires de classe I, quarante (40) parts sociales ordinaires de catégorie J, quarante (40) parts sociales
ordinaires de catégorie K, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie L, soixante-quinze (75) parts sociales
ordinaires de catégorie M, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie N, soixante-quinze (75) parts so-
ciales ordinaires de catégorie O, deux mille huit cent quatre-vingt-treize (2.893) parts sociales ordinaires de catégorie P,
soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie Q, trois mille huit cent quarante (3.840) parts sociales ordi-
naires de catégorie R, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie S, soixante-quinze (75) parts sociales
ordinaires de catégorie T, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie U, soixante-quinze (75) parts sociales
ordinaires  de  catégorie  V,  soixante-quinze  (75)  parts  sociales  ordinaires  de  catégorie  W,  soixante-quinze  (75)  parts
sociales ordinaires de catégorie X, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie Y et soixante-quinze (75)
parts sociales ordinaires de catégorie Z, ayant toutes une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»

VII. Les associés décident de réduire le capital social de la Société à concurrence de quatre mille cent soixante-quinze

Euros (EUR 4.175,-) pour le porter de son montant actuel de sept cent soixante-dix-huit mille six cent cinquante Euros
(EUR 778.650,-) à sept cent soixante-quatorze mille quatre cent soixante-quinze Euros (EUR 774.475,-) par l'annulation
cent soixante-sept (167) parts sociales ordinaires de classe E d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune,
par le remboursement à POSEIDON BERMUDA HOLDINGS, L.P. prénommé, de la somme de quatre mille cent soixante-
quinze Euros (EUR 4.175,-).

VIII. Suite à la réduction de capital ci-dessus, l'article 5, premier paragraphe des statuts de la Société est modifié pour

avoir désormais la teneur suivante:

«  Art. 5. 1 

er

 Paragraphe.  Le capital social émis de la Société est fixé à sept cent soixante-quatorze mille quatre cent

soixante-quinze Euros (EUR 774.475,-) divisé en six cent cinquante-cinq (655) parts sociales ordinaires de classe A, six
cent trois (603) parts sociales ordinaires de classe B, sept mille cent soixante-dix-neuf (7.179) parts sociales ordinaires
de classe C, deux mille deux cent cinquante-quatre (2.254) parts sociales ordinaires de classe D, deux cent vingt-trois
(223) parts sociales ordinaires de classe E, six mille soixante-quinze (6.075) parts sociales ordinaires de classe F, cent une
(101) parts sociales ordinaires de classe G, six mille soixante et une (6.061) parts sociales ordinaires de classe H, quarante
(40) parts sociales ordinaires de classe I, quarante (40) parts sociales ordinaires de catégorie J, quarante (40) parts sociales
ordinaires de catégorie K, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie L, soixante-quinze (75) parts sociales
ordinaires de catégorie M, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie N, soixante-quinze (75) parts so-
ciales ordinaires de catégorie O, deux mille huit cent quatre-vingt-treize (2.893) parts sociales ordinaires de catégorie P,
soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie Q, trois mille huit cent quarante (3.840) parts sociales ordi-
naires de catégorie R, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie S, soixante-quinze (75) parts sociales
ordinaires de catégorie T, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie U, soixante-quinze (75) parts sociales
ordinaires  de  catégorie  V,  soixante-quinze  (75)  parts  sociales  ordinaires  de  catégorie  W,  soixante-quinze  (75)  parts
sociales ordinaires de catégorie X, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie Y et soixante-quinze (75)
parts sociales ordinaires de catégorie Z, ayant toutes une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille cinq cents Euros (EUR 3.500,-).

27864

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état

et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: G. Fraisse, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 24, case 9. — Reçu 1.358,70 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2006.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007026661/211/295.
(070021374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2007.

Waterlemon, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 124.051.

STATUTES

In the year two thousand seven, the second of February,
Before us Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg),

There appeared

The Company LWM HOLDINGS I CORP., with registered office in Panama, East 54th Street, Arango - Orillac Building,

2nd Floor, Republic of Panama,

duly represented by Mr Eric Leclerc, employé privé, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy delivered in Luxembourg, on January 30th, 2007.
The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the notary executing, remains

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as herefore indicated, requests the notary executing, to drawn up the following

articles of a joint stock company which it intends to organize as sole associate or with any persons who may become
shareholder of the company in the future.

Name - Registered office - Duration -Object - Capital

Art. 1. A joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of WATERLEMON.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders'
meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other

27865

manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities
of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and

debentures.

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. Moreover, the company may
pledge its assets for the benefit of its associate/shareholders. It may also conduct all real estate transactions, such as
buying, selling, renting, development and management of real estate.

The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (€31,000.-) divided into one hundred

(100) shares with a par value of three hundred and ten euro (€ 310.-) each.

The shares maybe registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-

scribes the registered form.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, associate/shareholders or not, who

are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed
at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy.

In this case the next general meeting will proceed to the final elections.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, e-mail or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors'

meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the

debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August
10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the compe-
tence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be associate/shareholders of the company.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A

and one B signatory director or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his
powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose
signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, associate/shareholders or not, who are

appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at
any time.

The term of the mandate of the statutory auditor is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. If there is a sole associate, this sole associate exercises the powers of the general assembly of shareholders.

27866

If there a several shareholders the general meeting represents the whole body of shareholders.
The general meeting has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the on the second Monday of the month of June, at 11 a.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing at least ten percent of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in

case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

In case one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such

contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong

to the usufructuary.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these

articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2007.
The first annual general meeting shall be held in 2008.
The first directors and the first auditor are elected by the sole associate acting in place of the extraordinary general

shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the sole associate acting in place of the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of
directors of the company.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed and paid-up as follows:

Subscriber

Number

Amount

of shares subscribed to

subscribed and paid-up in

(one

EURO

hundred)

(thirty-one

thousand)

LWM HOLDINGS I CORP. prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

31,000.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

31,000.-

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of thirty

one thousand euro (€ 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.

27867

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two

thousand six hundred euro (€ 2,600.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named party, represented as therefore indicated, acting as sole associate, representing the whole subscribed

capital, considering himself acting in place of an extraordinary general meeting and unanimously passed the following
resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be held in the

year 2012:

<i>A signatory:

Mrs Martine Kapp, employée privée, born in Luxembourg on the 10th of December 1960, residing professionally in

L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

<i>B signatory:

Mr  Eric  Leclerc,  employé  privé,  born  in  Luxembourg  on  the  4th  of  April,  1967,  residing  professionally  in  L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,

Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg on the 15th of August, 1952, residing professionally in L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be held

in the year 2012:

Mr. Pascal Fabeck, employé privé, born in Arlon (B), the 16th of November 1968, residing professionally in L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

<i>Third resolution

The company's registered office is located at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
The undersigned Notary who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the

above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the
same appearing person, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the

notary by his surname, Christian name, civil status and residence, said person appearing signed together with us, Notary,
the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille sept, le deux février,
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société LWM HOLDINGS I CORP., ayant son siège social à Panama, East 54th Street, Arango - Orillac Building,

2nd Floor, Republique de Panama,

ici représentée par Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 30 janvier 2007.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes

avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter, ainsi qu'il suit, les statuts

d'une société anonyme qu'il va constituer en tant qu'associé unique ou avec toute autre personne qui deviendrait ac-
tionnaire de la société par la suite.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WATERLEMON.

27868

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle peut également donner ses avoirs
en gage, dans l'intérêt de ses associé/actionnaires. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles
que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000,-) représenté par cent (100) actions d'une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- €) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associé/ac-

tionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et
toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommée par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, e-mail ou

telefax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

27869

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être associé/actionnaires de la société.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la
signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, associé/actionnaires ou non, nommés par l'assem-

blée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. S'il y a un associé unique, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires.
En cas de pluralité d'actionnaires l'assemblée générale des actionnaires réunit tous les actionnaires.
L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans

les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le deuxième lundi du mois de juin à 11.00 heures du matin.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le com-

missaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant au moins dix pourcent du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l'usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au commissaire.

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l'usufruitier.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007. La

première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.

27870

Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l'associé unique statuant en lieu et place d'as-

semblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'associé unique

statuant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Souscripteurs

Nombre

Montant

d'actions

souscrit et

souscrites

libéré en

(cent)

EURO

(trente-et-

un mille)

La société LWM HOLDINGS I CORP prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

31.000,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

31.000,-

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille

euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatations

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille six cents euros

(2.600,- €)

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant l'associé unique représenté comme il est dit ci-avant agissant en lieu et place d'une assemblée générale

extraordinaire a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012:

<i>Signature catégorie A:

Madame Martine Kapp, employée privée, née à Luxembourg le 10 décembre 1960, demeurant professionnellement à

L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

<i>Signatare catégorie B:

Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionellement à L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en

2012:

Monsieur Pascal Fabeck, employé privé, né à Arlon (B), le 16 novembre 1968, demeurant professionnellement à L-1347

Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite à la personne comparante qui a requis le notaire de documenter le présent

acte en langue anglaise, la personne comparante a signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance
personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d'une traduction française. En cas de divergences entre le

texte anglais et le texte français le texte anglais primera.

Signé: E. Leclerc, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 février 2007, vol. 538, fol. 31, case 10, GRE/2007/516. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

27871

Pour expédition conforme, délivrée sur papier timbré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 6 février 2007.

J. Gloden.

Référence de publication: 2007026739/213/360.
(070021193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2007.

Albarossa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 21, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 105.798.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2006.

<i>Pour ALBAROSSA S.A.
Signature

Référence de publication: 2007027325/278/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2006, réf. LSO-BW04700. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(070021681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

L.G.L. Luxembourg Genuine Leather S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 90.208.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 5 février 2007 que:
- Le siège social est transféré du 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522

Luxembourg

- Monsieur Benoit Sirot a démissionné de sa fonction d'administrateur
- Monsieur Natale Capula né à Villa S. Giovanni (Italie), le 1 

er

 novembre 1961, demeurant professionnellement à 12,

rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg a été élu administrateur. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée
Générale qui se tiendra en l'an 2012.

- Monsieur Olivier Dorier a démissionné de sa fonction de Commissaire.
- La société F.G.S. CONSULTING LLC, ayant son siège social à 520 S. 7th Street, Suite C Las Vegas, NV 89101 a été

élu Commissaire. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007027240/799/24.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01591. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Teilen Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 115.258.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 5 février 2007 que:
- Le siège social est transféré du 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522

Luxembourg

- Monsieur Benoit Sirot a démissionné de sa fonction d'administrateur.

27872

- Monsieur Natale Capula né à Villa S. Giovanni (Italie), le 1 

er

 novembre 1961, demeurant professionnellement à 12,

rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg a été élu administrateur. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée
Générale qui se tiendra en l'an 2012.

- Monsieur Olivier Dorier a démissionné de sa fonction de Commissaire.
- La société F.G.S. CONSULTING LLC, ayant son siège social à 520 S. 7th Street, Suite C Las Vegas, NV 89101 a été

élu Commissaire. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007027243/799/24.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01585. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070021451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Morley International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 66.614.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

W. Gilson
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007027334/649/13.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00934. - Reçu 56 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Mizel Guy NESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3873 Schifflange, 2, rue du Pont.

R.C.S. Luxembourg B 75.656.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027315/6709/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07697. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070021625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Wininvest Holdings SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5751 Frisange, 40A, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 68.890.

Le bilan approuvé au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027318/6709/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07662. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070021628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

27873

Eaglemax S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 93.251.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

C. Dogat.

Référence de publication: 2007027320/732/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07680. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(070021632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Adomex, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 121.385.

L'an deux mille six, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ADOMEX, ayant

son siège social à 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 121.385, constituée suivant acte reçu le 16 octobre 2006, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2303 du 9 décembre 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Flora Gibert, juriste, de-

meurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l'article 2, premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«  Art. 2. 1 

er

 alinéa.  La Société a pour objet l'activité de travaux d'assistance administrative et de secrétariat.»

2.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale extraordinaire, les associés décident ce qui suit:

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier l'article 2, premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«  Art. 2. 1 

er

 alinéa.  La Société a pour objet l'activité de travaux d'assistance administrative et de secrétariat.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite membres du bureau, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Galiotto, F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 4, case 5. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27874

Luxembourg, le 31 janvier 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007027520/211/44.
(070021730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

GEA Happel Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-4940 Bascharage, 124, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 91.947.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 de la société anonyme de droit belge, GEA HAPPEL BELGIUM S.A., avec

siège social à B-1130 Bruxelles, Dobbelenbergstraat 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 7 février 2007.

<i>Pour GEA HAPPEL
FIDUNORD S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007027322/667/17.
Enregistré à Diekirch, le 5 février 2007, réf. DSO-CB00044. - Reçu 68 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): M. Siebenaler.

(070021712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

INTRAWEST Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 63.994.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par les actionnaires en date du 25 janvier 2007

Les actionnaires ont décidé:
- D'accepter la démission de M. John Currie à la fonction d'administrateur avec effet immédiat.
- De nommer M. Randal Nardone, né le 22 juin 1955 à New York, USA, demeurant professionnellement au 1345,

avenue of the Americas, 46th Floor, New York 10105, USA, à la fonction d' administrateur avec effet immédiat pour une
durée déterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027144/5564/17.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00438. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Imovestlux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 69A, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 90.732.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

C. Dogat.

Référence de publication: 2007027321/6709/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07714. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070021634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Private Trustees S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 74.700.

Le bilan approuvé au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27875

Luxembourg, le 9 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027311/6709/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07687. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070021624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Turton Limited, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 84.025.

<i>Extrait de procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 12 septembre 2006

«Il en résulte que la démission de Monsieur Michael Barrie Page est acceptée avec effet au 1 

er

 août 2006.»

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007027141/2778/13.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01313. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070021842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Holta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 39.061.

Le bilan de la société au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007027340/655/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2007, réf. LSO-CB00376. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

KRD-Services S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 88.617.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

<i>Pour KRD-SERVICES S.à r.l.
Signature
<i>Gérant

Référence de publication: 2007027307/2624/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02275. - Reçu 99 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Albarossa Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 21, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 105.799.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27876

Luxembourg, le 8 février 2007.

<i>Pour ALBAROSSA HOLDING S.A.
Signature

Référence de publication: 2007027330/278/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02611. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070021686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

The Multinational Consortium for General Trade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 109.861.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 23 janvier 2007

L'Assemblée, après en avoir délibéré, aborde son ordre du jour et prend les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

La société révoque Maître Eyal Grumberg, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon de son poste

d'administrateur.

<i>Deuxième Résolution

La société révoque Maître Nicolas Bannasch, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon de son poste

d'administrateur.

<i>Troisième Résolution

La société révoque Mademoiselle Sanae Igri, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon de son poste

d'administrateur.

<i>Quatrième Résolution

La société nomme la société LDF DIRECTOR II GROUP LTD, établie et ayant son siège social à OVERSEAS MANA-

GEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD., OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
inscrite au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le n 

o

 1070672, représentée par leurs directeurs

actuellement en fonctions, au poste d'administrateur.

<i>Cinquième Résolution

La société nomme la société LDF DIRECTOR I LTD, établie et ayant son siège social à OVERSEAS MANAGEMENT

COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD., OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite
au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le n 

o

 1070671, représentée par leurs directeurs actuellement

en fonctions, au poste d'administrateur.

<i>Sixième Résolution

La société nomme la société FIDUCIAIRE DI FINO &amp; ASSOCIES S.à.r.l, établie et ayant son siège social à L-2537

Luxembourg, 19, rue Sigismond, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n 

o

 B 103.178,

représentée par son gérant Monsieur Luca Di Fino actuellement, en fonctions, au poste d'administrateur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée,

Luxembourg, le 23 janvier 2007.

THE MULTINATIONAL CONSORTIUM FOR GENERAL TRADE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007027033/1351/38.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2007, réf. LSO-CB00196. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Turton Limited, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 84.025.

<i>Extrait de la résolution des Membres du Conseil d'Administration du 1 

<i>er

<i> août 2006

«Il en résulte que la démission de Monsieur Anthony Richard Attwood est acceptée et que Monsieur Bernard Olivier

de 9, rue Sainte Zithe, Luxembourg est nommé comme administrateur avec effet au 1 

er

 août 2006.»

27877

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007027136/2778/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01311. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Colombo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 112.725.

<i>Extrait des résolutions prises par les gérants de la Société, datées du 3 décembre 2006

Les gérants de la Société ont décidé en date du 3 décembre 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 décembre 2006.

Luxembourg, le 5 janvier 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA
Signatures

Référence de publication: 2007027388/710/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01424. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Valentine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 102.796.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 26 janvier 2007 que:
- Le siège social est transféré du 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522

Luxembourg

- Monsieur Benoit Sirot a démissionné de sa fonction d'administrateur.
- Monsieur Natale Capula né à Villa S. Giovanni (Italie), le 1 

er

 novembre 1961, demeurant professionnellement à 12,

rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg a été élu administrateur. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée
Générale qui se tiendra en l'an 2012.

- Monsieur Olivier Dorier a démissionné de sa fonction de Commissaire.
- La société F.G.S. CONSULTING LLC, ayant son siège social à 520 S. 7th Street, Suite C Las Vegas, NV 89101 a été

élu Commissaire. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007027384/799/24.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01827. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

De Beers Ukraine Prospecting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 103.411.

<i>Extrait de la résolution des Membres du Conseil d'Administration du 1 

<i>er

<i> août 2006

«Il en résulte que le démission de Monsieur Anthony Richard Attwood, est accepté et que Monsieur Bernard Olivier

de 9, rue Sainte Zithe, Luxembourg est nommé administrateur de la société avec effet au 1 

er

 août 2006.»

27878

DE BEERS UKRAINE PROSPECTING S.A.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2007027134/2778/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01309. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Doria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 112.723.

<i>Extrait des résolutions prises par les gérants de la Société, datées du 3 décembre 2006

Les gérants de la Société ont décidé en date du 3 décembre 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 décembre 2006.

Luxembourg, le 5 janvier 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA
Signatures

Référence de publication: 2007027392/710/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01425. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Videma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 113.353.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 23 janvier 2007

L'Assemblée, après en avoir délibéré, aborde son ordre du jour et prend les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

La société révoque Maître Eyal Grumberg, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon de son poste

d'administrateur.

<i>Deuxième Résolution

La société révoque Maître Nicolas Bannasch, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon de son poste

d'administrateur.

<i>Troisième Résolution

La société révoque Mademoiselle Elvedina Krusko, demeurant à L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond de son poste

d'administrateur.

<i>Quatrième Résolution

La société nomme la société LDF DIRECTOR II GROUP LTD, établie et ayant son siège social à OVERSEAS MANA-

GEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD., OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
inscrite au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le n 

o

 1070672, représentée par leurs directeurs

actuellement en fonctions, au poste d'administrateur.

<i>Cinquième Résolution

La société nomme la société LDF DIRECTOR I LTD, établie et ayant son siège social à OVERSEAS MANAGEMENT

COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD., OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite
au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le n 

o

 1070671, représentée par leurs directeurs actuellement

en fonctions, au poste d'administrateur.

<i>Sixième Résolution

La société nomme la société FIDUCIAIRE DI FINO &amp; ASSOCIES S.a.r.l., établie et ayant son siège social à L-2537

Luxembourg, 19, rue Sigismond, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n 

o

 B 103.178,

représentée par son gérant Monsieur Luca Di Fino actuellement en fonctions, au poste d'administrateur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Luxembourg, le 23 janvier 2007.

27879

VIDEMA S.A.
Signature

Référence de publication: 2007027024/1351/38.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2007, réf. LSO-CB00163. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Vespucci S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 112.724.

<i>Extrait des résolutions prises par les gérants de la Société, datées du 3 décembre 2006

Les gérants de la Société ont décidé en date du 3 décembre 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 décembre 2006.

Luxembourg, le 5 janvier 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA
Signatures

Référence de publication: 2007027394/710/15.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01426. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

The Multinational Holding Consortium S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 109.844.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 23 janvier 2007

L'Assemblée, après en avoir délibéré, aborde son ordre du jour et prend les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

La société révoque Maître Eyal Grumberg, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon de son poste

d'administrateur

<i>Deuxième Résolution

La société révoque Maître Nicolas Bannasch, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon de son poste

d'administrateur.

<i>Troisième Résolution

La société révoque Mademoiselle Sanae Igri, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon de son poste

d'administrateur.

<i>Quatrième Résolution

La société nomme la société LDF DIRECTOR II GROUP LTD, établie et ayant son siège social à OVERSEAS MANA-

GEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD., OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
inscrite au registre de commerce des lies Vierges Britanniques sous le n 

o

 1070672, représentée par leurs directeurs

actuellement en fonctions, au poste d'administrateur.

<i>Cinquième Résolution

La société nomme la société LDF DIRECTOR I LTD, établie et ayant son siège social à OVERSEAS MANAGEMENT

COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD., OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite
au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le n 

o

 1070671, représentée par leurs directeurs actuellement

en fonctions, au poste d'administrateur.

<i>Sixième Résolution

La société nomme la société FIDUCIAIRE DI FINO &amp; ASSOCIES S.a.r.l, établie et ayant son siège social à L-2537

Luxembourg, 19, rue Sigismond, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n 

o

 B 103.178,

représentée par son gérant Monsieur Luca Di Fino actuellement en fonctions, au poste d'administrateur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Luxembourg, le 23 janvier 2007.

27880

THE MULTINATIONAL HOLDING CONSORTIUM S.A.
Signature

Référence de publication: 2007027027/1351/38.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2007, réf. LSO-CB00180. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Novator Telecom Poland II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.500,00.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 108.272.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 15 décembre 2006 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 560 A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au 85-91, route de

Thionville, L-2611 Luxemboutg, en date du 1 

er

 janvier 2007.

Luxembourg, le 2 février 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007027396/802/17.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01278. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Edwin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 92.397.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 26 janvier 2007 que:

- Le siège social est transféré du 560A, rue de Neudorf L - 2220 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522

Luxembourg

- Monsieur Benoit Sirot a démissionné de sa fonction d'administrateur.

- Monsieur Natale Capula né à Villa S. Giovanni (Italie), le 1 

er

 novembre 1961, demeurant professionnellement à 12,

rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg a été élu administrateur. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée
Générale qui se tiendra en l'an 2012.

- Monsieur Olivier Dorier a démissionné de sa fonction de Commissaire.

- La société F.G.S. CONSULTING LLC, ayant son siège social à 520 S. 7th Street, Suite C Las Vegas, NV 89101 a été

élu Commissaire. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2011

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 26 janvier 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007027375/799/24.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01825. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

27881

Novator Pharma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 115.376.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 15 décembre 2006 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 560 A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au 85-91, route de

Thionville, L-2611 Luxembourg, en date du 1 

er

 janvier 2007.

Luxembourg, le 2 février 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007027397/802/17.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01274. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070021612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

GENPASA Environmental Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 86.510.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GENPASA ENVIRONMENTAL HOLDINGS S.à r.l.
EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur
M. Bogers
<i>Gérant

Référence de publication: 2007027369/1084/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01670. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Vicky Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 113.403.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 26 janvier 2007 que:
- Le siège social est transféré du 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522

Luxembourg

- Monsieur Benoit Sirot a démissionné de sa fonction d'administrateur.

- Monsieur Natale Capula né à Villa S. Giovanni (Italie), le 1 

er

 novembre 1961, demeurant professionnellement à 12,

rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg a été élu administrateur. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée
Générale qui se tiendra en l'an 2012.

- Monsieur Olivier Dorier a démissionné de sa fonction de Commissaire.
- La société F.G.S. CONSULTING LLC, ayant son siège social à 520 S. 7th Street, Suite C Las Vegas, NV 89101 a été

élu Commissaire. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2011

Pour mention aux fins de la publications au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2007.

27882

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007027358/799/24.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01824. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Valene S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 56, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 86.626.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

C. Dogat.

Référence de publication: 2007027355/6709/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07694. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(070021635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Popoff Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 109.556.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007027365/43/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01675. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Safia International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 124.105.

STATUTS

L'an deux mille six, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,

A comparu:

La société GRANDBRIDGE CORP. ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina 3,

Panama, République de Panama, immatriculée sous le numéro 526831,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, ci-après qualifié,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration paraphée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné sera annexée au présent acte

pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.

Lequel comparant, par son mandataire, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer

comme actionnaire unique:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SAFIA INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social

27883

pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale

des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2.  La  société  a  pour  objet,  tant  à  Luxembourg  qu'à  l'étranger,  toutes  opérations  généralement  quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d'une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l'acte du 21 décembre 2006 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette
date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;

- à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations

effectives du capital et enfin;

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme

d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d'administration élit en son sein son président.

27884

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'admi-
nistration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante

en cas de partage des voix.

La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 22 mai à 11.15 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2008.

<i>Souscription et Libération

Toutes les actions ont été entièrement souscrites par le comparant et libérées en espèces de sorte que le montant

de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Michael Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au 18,

rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Monsieur Sébastien Gravière, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18,

rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

27885

d) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnel-

lement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- La société CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatri-

culée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n 

o

 B 79.327.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l'an 2011.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé: M. Koeune, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 2007, vol. 540, fol. 50, case 6. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 8 février 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007027557/231/148.
(070021848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Aircargo Trucking S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 54.693.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

<i>Pour AIRCARGO TRUCKING S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007027350/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11083. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070021703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

W.A.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 30.256.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

<i>Pour W.A.T. S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007027354/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11084. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070021706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Global Logistic Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 85.342.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27886

Luxembourg, le 9 février 2007.

<i>Pour GLOBAL LOGISTIC PARTNERS SA
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007027357/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11086. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070021708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

SOGETI Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. Capgemini Luxembourg S.A.).

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 42.610.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

<i>Pour SOGETI LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007027349/503/16.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11082. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070021702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Forme et Coiffure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 118.353.

Par la présente, nous vous informons la dénonciation du siège social de la société

Strassen, le 21 décembre 2006.

FORME ET BEAUTE
Signature

Référence de publication: 2007027160/6709/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07470. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070021622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Extrabold S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3360 Leudelange, 80, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 94.434.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

<i>Pour EXTRABOLD S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA
Signature

Référence de publication: 2007027343/503/15.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11080. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070021698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

27887

GENPASA Environmental Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 86.510.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GENPASA ENVIRONMENTAL HOLDINGS S.à r.l.
EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur
M. Bogers
<i>Gérant

Référence de publication: 2007027372/1084/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01674. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070021578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Volgacote S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 121.690.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 23 janvier 2007

L'Assemblée, après en avoir délibéré, aborde son ordre du jour et, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La société révoque Maître Eyal Grumberg, demeurant à L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon de son poste

d'administrateur.

<i>Deuxième résolution

La société nomme la société LDF DIRECTOR I LTD, établie et ayant son siège social à OVERSEAS MANAGEMENT

COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD., OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite
au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le n 

o

 1070671, représentée par leurs directeurs actuellement

en fonctions, au poste d'administrateur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Luxembourg, le 23 janvier 2007.

VOLGACOTE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007027021/1351/23.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11298. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070021721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Fingi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 58.991.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FINGI S.A.
M. Bogers
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007027368/1084/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01590. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

27888


Document Outline

Adomex

Aircargo Trucking S.A.

Albarossa Holding S.A.

Albarossa S.A.

BRE/GH II Dresden V Manager S. à r.l.

BRE/GH II Leipzig II Manager S. à r.l.

BRE/GH II Property I Manager S. à r.l.

Capgemini Luxembourg S.A.

Colombo S.à r.l.

De Beers Ukraine Prospecting S.A.

Doria S.à r.l.

Eaglemax S.A.

Edwin S.A.

Extrabold S.A.

Fingi S.A.

Forme et Coiffure S.à r.l.

GEA Happel Luxembourg

GENPASA Environmental Holdings S.à r.l.

GENPASA Environmental Holdings S.à r.l.

Global Logistic Partners S.A.

Holta S.A.

Imovestlux S.àr.l.

INTRAWEST Luxembourg S.A.

KRD-Services S.à.r.l.

LBREP II Europe Holdings S.à r.l.

L.G.L. Luxembourg Genuine Leather S.A.

Mizel Guy NESS S.A.

Morley International Fund

Novator Pharma S.à r.l.

Novator Telecom Poland II S.à r.l.

Popoff Investment S.A.

Private Trustees S.A.

Safia International S.A.

SOGETI Luxembourg S.A.

Teilen Invest S.A.

The Multinational Consortium for General Trade S.A.

The Multinational Holding Consortium S.A.

Turton Limited

Turton Limited

Valene S.A.

Valentine S.A.

Vespucci S.à r.l.

Vicky Invest S.A.

Videma S.A.

Volgacote S.A.

Waterlemon

W.A.T. S.A.

Wininvest Holdings SA