logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 578

11 avril 2007

SOMMAIRE

2XTV S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27725

ABN AMRO Rainbow Fund  . . . . . . . . . . . . .

27722

ABN AMRO V.I.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27714

Actaris Expansion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27725

Adanel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27735

AEF Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27724

Akeler Marlow S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27698

Akeler Marlow S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27734

Antinori International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

27740

Astrad S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27734

BIGF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27724

BRE/GH II Berlin III Manager S. à r.l.  . . . .

27706

BRE/GH II Berlin II Manager S. à r.l.  . . . . .

27715

BRE/GH II Berlin I Manager S. à r.l.  . . . . . .

27726

Buttercup S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27732

Carpathian Cable Investments S.à r.l.  . . . .

27722

Carpathian Cable Luxembourg S.à r.l.  . . .

27723

Cash.Life Funding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27741

Claremont Villas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27733

Competrol (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . .

27725

Corluy Rainbow Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27722

Corluy V.I.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27714

Diamor International Holding S.A.  . . . . . .

27733

East Coast Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . .

27744

Equity Trust Fund Services (Luxembourg)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27706

European Real Estate Financing Company

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27743

Forbach Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27705

Halm B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27724

Highgate Finance & Holding S.A.  . . . . . . . .

27732

I Chateau VII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27698

Ilona Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27714

Interlab S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27725

Internationale Handelsunion AG  . . . . . . . .

27741

Itaca S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27704

J. Hirsch & Co International  . . . . . . . . . . . . .

27721

J.P. Morgan Partners Global Investors

(Selldown) Luxembourg, S.à r.l.  . . . . . . . .

27740

Kart S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27723

Kulicke and Soffa Luxembourg S.à r.l. . . . .

27742

Luxemburger Patentgesellschaft A.G.  . . .

27740

Majorcan Hotels Luxembourg S.à r.l.  . . . .

27705

Mojo Limited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27736

MTZ International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27744

Parabole S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27735

Parana Corporation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

27722

Patagonia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27723

Patagonia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27734

Patagonia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27734

Patagonia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27741

Peguform Luxembourg Holding S.à r.l.  . .

27742

Pharmacos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27733

PTL Holdings Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . .

27713

PTL Holdings Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . .

27723

Raiffeisen R01 (Luxembourg) S.A.  . . . . . . .

27706

Repco 27 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27715

Résidences LES CHARMES Sàrl  . . . . . . . . .

27724

Sabina International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

27733

Saint Guy Immo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27713

Sevsyl S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27732

SHRM Corporate Services S.à r.l. . . . . . . . .

27713

Soparfi 10 L S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27742

Tanglewood Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

27705

Tanglewood Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

27712

Urbana S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27741

Whitebay S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27743

27697

Akeler Marlow S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 65.763.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés le 13 novembre 2006

1) Les associés ont nommé avec effet au 14 novembre 2006 et pour une durée indéterminée:
- M. Enzo Guastaferri, employé privé, né le 7 novembre 1968 à Messancy, Belgique, résidant professionnellement au

46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- M. Philippe Van Der Beken, employé privé, né le 1 

er

 octobre 1975 à Aalst, Belgique, résidant professionnellement

au 8, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg;

et ont accepté la démission avec effet immédiat de M. James Quille et de Mme Julie Mossong.
Le Conseil de Gérance se compose dorénavant comme suit:
- M. James Cole, M. Enzo Guastaferri et M. Philippe Van Der Beken.
L'associé LLGP HOLDINGS LLC a cédé 5 parts à la société ARLINGTON BUSINESS PARKS PARTNERSHIPS en vertu

d'un acte de cession de parts avec effet au 14 novembre 2006.

A la suite de cette vente, il résulte que les associés détiennent respectivement le nombre de parts suivant:

AKELER HOLDINGS S.A., 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg; parts détenues . . . . . . . . . . . . . 495
ARLINGTON BUSINESS PARKS PARTNERSHIPS, Arlington House, Arlington Business Park, Theale, Reading

RG 7 4SA, United Kingdom; parts détenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait le 5 février 2007.

<i>Pour AKELER MARLOW S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007027037/1649/30.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01817. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

I Chateau VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 122.960.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the fifteenth day of November.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CHATEAU HOLDINGS VII S.à r.l., a private limited liability company (société à reponsabilité limitée) existing under

the laws of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg to be registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register,

here represented by Mr Florent Trouiller, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in the United States of America on 15 December 2006.
This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to enact as follows the

articles of association (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby
formed.

Title I. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the

Company) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of association.

27698

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio as well as realising real estate property investments.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form and privately issue bonds or notes.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-

plishment and development of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will exist under the corporate name of I CHATEAU VII S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. Within the same municipality, it may be

transferred by resolution of the managers. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg
by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be established either in
Luxembourg or abroad by resolution of the managers.

Title II. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of the partners representing at least

three quarters of the share capital of the Company.

Art. 8. The shares are indivisible regarding the Company which will recognize only one holder per share. The joint co-

owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of at least three
quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital belonging to the surviving partners. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in accordance
with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Civil Code.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

Title III. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not necessarily be partners. In dealing with

third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to act in the
name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose.
The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term of his
(their) office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of one A manager and one B manager.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers; in his absence the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be

27699

required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers and only if at least one A manager and one B manager are present or represented.
Decisions shall be taken by the majority of the votes of the managers present or represented at such meeting provided
that at least one A and one B manager have voted in favour of such decisions.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, the entirety
forming the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of his (their) position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

Art. 17. The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment of

interim dividends.

Art. 18. The manager, or if there is more than one, the board of managers may delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

Title IV. Decisions of the Sole Partner - Collective Decisions of the Partners

Art. 19. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 20. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners representing more than half of the share capital.

The  partners  may  not  change  the  nationality  of  the  Company  otherwise  than  by  unanimous  consent.  Any  other

amendment of the articles of association requires the approval of a majority of the partners representing at least three
quarters of the share capital of the Company.

Art. 21. Any partner may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a partner, to represent

him at the general meeting and to vote in his name.

Art. 22. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

Title V. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 23. The Company's financial year begins on the first of December of each year and ends on the thirtieth of

November of the next year.

Art. 24. Each year on the thirtieth of November, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 25. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the sole partner or, as the case may be,
the general meeting of the partners.

Title VI. Dissolution - Liquidation

Art. 26. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.

27700

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Title VII. Applicable law

Art. 27. For all matters not governed by these articles of association the partners refer to the provisions of the law

of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, CHATEAU HOLD-

INGS VII S.à r.l., this party has subscribed for the five hundred (500) shares.

All the shares so subscribed have been fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro

(EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirtieth of

November 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately two thousand one hundred euro (EUR 2,100.00).

<i>Resolutions of the sole partner

The above named party, representing the entire subscribed capital has immediately passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following persons are appointed members of the board of managers of the Company for an indefinite period:
- as A manager
- Mr. Jeffrey M. Kaplan, real estate investment professional, born on 8 November 1965 in New York, with professional

address at 1370, Avenue of the Americas, 2800 New York, 10019-4602 United States of America;

- as B managers
- Mrs. Catherine Koch, general manager, born on 12 February 1965 in Sarreguemines (France), with professional

address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;

- Mr. Francesco Biscarini, manager, born on 23 February 1971 in Perugia (Italy), with professional address at 8-10, rue

Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the
same appearing proxyholder and in case of divergence between the English and the French text, the English version will
prevail.

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, the said proxyholder appearing

signed together with Us the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille six, le quinze décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

CHATEAU HOLDINGS VII S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Luxembourg,

ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, en cours d'enregistrement au registre du com-
merce et des sociétés de Luxembourg.

ici représentée par M 

e

 Florent Trouiller, avocat, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée aux Etats-Unis d'Amérique, le 15 décembre 2006.
Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualité en vertu de laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts

(ci-après les Statuts) d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

Titre I 

er

 . Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée (ci-après la Société) qui sera régie par

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre

27701

manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations ainsi que la réalisation d'investissements dans des propriétés
immobilières.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations.
La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement et le développement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société adopte la dénomination sociale de I CHATEAU VII S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans la même commune par décision des gérants.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.
La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays par
décision des gérants.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cent

(500) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par contrat sous seing privé. Un telle cession n'est

opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle, suivant les règles sur le
transport des créances établies par l'article 1690 du Code Civil sur le transport des créances.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

Titre III. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Vis-à-vis des tiers, le

gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le(s) gérant(s)
est (sont) nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixe(nt) la durée de son (leur) mandat.
Le(s) gérant(s) est (sont) librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'il y a plusieurs gérants,

par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-

président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le  conseil  de  gérance  se  réunira  sur  convocation  du  président  ou  de  deux  gérants  au  lieu  indiqué  dans  l'avis  de

convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés

27702

dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéo-conférence

ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance et pour autant qu'au moins un gérant A et un B soient présents ou
représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion pour
autant qu'au moins un gérant A et un gérant B aient voté en faveur de telles décisions.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par
écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.

Art. 15. Le décès ou la démission d'un gérant, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 17. Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au paiement

d'acomptes sur dividendes.

Art. 18. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs

pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Titre IV. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 19. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 20. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Art. 21. Tout associé peut, par procuration écrite, autoriser toute autre personne, associé ou non, à le représenter

lors d'une assemblée générale des associés et à voter en son nom.

Art. 22. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Titre V. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 23. L'année sociale de la Société commence le premier décembre de chaque année et se termine le trente no-

vembre de l'année d'après.

Art. 24. Chaque année, au trente novembre, les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de la Société de l'inventaire et du bilan.

Art. 25. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve statutaire jusqu'à ce que

celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde sera à la libre disposition de l'associé unique ou, le cas échéant,
de l'assemblée générale des associés.

Titre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 26. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non,

nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera ses (leurs) pouvoirs et ses (leurs) émoluments. Sauf décision contraire

27703

le ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de
la Société.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Titre VII. Loi applicable

Art. 27. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

La partie comparante, CHATEAU HOLDINGS VII S.à r.l. prénommée, telle que représentée, ayant ainsi arrêté les

Statuts de la Société, a souscrit aux cinq cent (500) parts sociales.

Toutes les parts ainsi souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cent euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le trente novembre 2007.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la

Société en raison de sa constitution est évalué environ deux mille cent euros (EUR 2.100,00).

<i>Résolutions de l'associé unique

L'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société sera est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. Sont nommés membres du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée:
- en tant que gérant A
- M. Jeffrey M. Kaplan, real estate investment professional, né le 8 novembre 1965 à New York, ayant son adresse

privée au 1370, Avenue of the Americas, 2800 New York, 10019-4602 Etats-Unis d'Amérique;

- en tant que gérants B
- Mme Catherine Koch, directeur général, née le 12 février 1965 à Sarreguemines (France), ayant son adresse pro-

fessionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;

- M. Francesco Biscarini, administrateur de sociétés, né le 23 février 1971 à Perugia (Italie), ayant son adresse profes-

sionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire à la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

Nous notaire.

Signé: F. Trouiller, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 97, case 3. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2006.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007010501/230/332.
(070001641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.

Itaca S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 27, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 51.520.

Le bilan au 31 mars 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27704

Luxembourg, le 5 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027216/802/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01392. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Forbach Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 119.224.

Il résulte des résolutions de l'associé unique du 15 janvier 2007 que l'associé a accepté
- la démission de TMF CORPORATE SERVICES S.A. en tant gérant de la société
- les nominations, en remplacement du gérant démissionnaire, et jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra

en 2007, de:

- M. Paul van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam, Pays-Bas, résidant professionnellement au 1, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg

- M. Jorge Perez Lozano, né le 17 août 1973 à Manheim, Allemagne, résidant professionnellement au 1, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg

- Mme Xenia Kotoula, née le 30 novembre 1973 à Athènes, Grèce, résidant professionnellement au 1, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg

- M. Ian Baker, né le 3 février 1961 à Carshalton, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 166, Sloane Street,

SW1 X9QF Londres, Royaume-Uni

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2007.

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007027047/805/28.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01533. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Tanglewood Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 87.210.

En date du 16 décembre 2004, PEPSI BOTTLING GROUP GLOBAL FINANCE S.à r.l. a cédé la totalité de ses 360

parts sociales à PBG HOLDING DE ESPANA, ETVE, SL.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027052/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01444. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Majorcan Hotels Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 96.187.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27705

Luxembourg, le 6 février 2007.

D. van der Molen.

Référence de publication: 2007027196/710/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00764. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Equity Trust Fund Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F.Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 66.384.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007027186/2147/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01370. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070021541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Raiffeisen R01 (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 87.659.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 24 janvier 2007 que les actionnaires ont décidé

avec effet immédiat de prolonger les mandats jusqu'au 31 décembre 2007 de:

- TMF SECRETARIAL SERVICES, TMF CORPORATE SERVICES S.A. et TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. en

tant qu'administrateurs de la Société;

- L'ALLIANCE REVISION S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2007.

Pour avis conforme
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007027040/805/20.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01531. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

BRE/GH II Berlin III Manager S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 124.000.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the eleventh day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 118.245.

here represented by Mrs Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal in Luxembourg, on 9 January 2007.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

27706

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and in particular in German «Kommanditgesellschaften» as general partner and any other form of
investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes or other securities of any kind and the administration, control and devel-
opment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is to borrow money in any form and give securities for any borrowings.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration,  control  and  development.  For  that  purpose,  the  Company  may  require  and  retain  the  assistance  of  other
advisors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/GH II BERLIN III MANAGER S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.

Art. 10. The death, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of the shareholders may for any reason affix seals on assets or

documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.

The sole manager or the board of managers may grant powers of attorney by authentic proxy or by private instrument.

27707

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman, and

may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager,
and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the Sole Shareholder - Collective decisions of the _Shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies, as
amended.

Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

27708

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:
- five hundred (500) shares by BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the thirty-first

day of December 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having

its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under section B number 96.323, is appointed manager of the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, den elften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

BRE/GERMAN  HOTEL  HOLDING  II  S.à  r.l.,  eine  société  à  responsabilité  limitée  gegründet  nach  dem  Recht  des

Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-
und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 118.245,

hier vertreten durch Frau Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschrift-

lichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 9. Januar 2007.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter  werden,  eine Gesellschaft mit beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend  die  «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

insbesondere an deutschen Kommanditgesellschaften als Komplementär und Investitionen jeder Art, der Erwerb durch
Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise von Aktien,

27709

Obligationen, Schuldscheinen und anderen Wertpapieren jeglicher Art und die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung
ihres Wertpapierbestandes.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Kreditaufnahme jeglicher Art und die Gewährung von Sicherheiten für

jegliche Kreditaufnahme.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den für die Verwaltung,

Kontrolle und Verwertung notwendigen Dienstleistungen versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/GH II BERLIN III MANAGER S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter (ii) wobei

diese Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der

Gesellschaft.

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-

genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus mindestens

zwei Geschäftsführern, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich oder aufgrund

notariell beglaubigter Urkunde erteilt.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen.

27710

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-

sellschaft nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

Art. 20. Die Gesellschaft darf nie mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Natürliche Personen können nicht Ge-

sellschafter der Gesellschaft werden.

E. Geschäftsjahr - Kontengewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

27711

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- fünfhundert 500 Anteile wurden von BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

eintausendneunhundert Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit

Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels -und Gesellschaftsregister unter
Sektion B Nummer 96.323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: N. Schmidt-Troje, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 60, case 2. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Mersch, den 26. Januar 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007026009/242/325.
(070020470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.

Tanglewood Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 87.210.

Par résolution signée en date du 23 janvier 2007, l'associé unique a accepté la démission de Madame Jude Lemke,

demeurant au 1, Pepsi Way, NY-10589 Somers, Etats-Unis, de son mandat de gérant avec effet au 5 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27712

Luxembourg, le 2 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027055/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01441. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

PTL Holdings Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 63.102.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007027198/2460/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00447. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070021544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

SHRM Corporate Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 78.100.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2007.

<i>Pour SHRM CORPORATE SERVICES S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007027183/1081/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01323. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Saint Guy Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 119.337.

Il résulte des résolutions de l'associé unique du 15 janvier 2007 que l'associé a accepté
- la démission de TMF CORPORATE SERVICES S.A. en tant gérant de la société
- les nominations, en remplacement du gérant démissionnaire, et jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra

en 2007, de:

- M. Paul van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam, Pays-Bas, résidant professionnellement au 1, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg

- M. Jorge Perez Lozano, né le 17 août 1973 à Manheim, Allemagne, résidant professionnellement au 1, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg

- Mme Xenia Kotoula, née le 30 novembre 1973 à Athènes, Grèce, résidant professionnellement au 1, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg

- M. Ian Baker, né le 3 février 1961 à Carshalton, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 166, Sloane Street,

SW1 X9QF Londres, Royaume-Uni

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2007.

27713

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2007027049/805/28.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01532. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Ilona Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 106.224.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 11 janvier 2007 que:
1. Monsieur Hans De Graaf, Monsieur Pieter Van Nugteren et la société à responsabilité limitée UNIVERSAL MA-

NAGEMENT SERVICES S.à r.l., ont démissionné de leur mandat d'administrateur.

2. jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire des actionnaires de 2010, le Conseil d'administration se compose

comme suit:

a) M. Philippe Toussaint, administrateur de sociétés, né le 2 septembre 1975 à Arlon (Belgique), domicilié profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

b) M. Daniel Baptista Galhano, administrateur de sociétés, né le 13 juillet 1976 à Moyeuvre-Grande (France), domicilié

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

c) M. Eric Magrini, administrateur de sociétés, né le 20 avril 1963 à Luxembourg, domicilié professionnellement à

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Il ressort du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 janvier 2007 que:
- Monsieur Eric Magrini a été nommé président et administrateur-délégué du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 26 janvier 2007.

<i>Pour ILONA INVESTMENTS S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007027097/29/27.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2007, réf. LSO-CA09993. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070021948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

ABN AMRO V.I.P., Société d'Investissement à Capital Variable,

(anc. Corluy V.I.P.).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 63.191.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 18 octobre 2006

L'Assemblée a renouvelé pour une durée indéterminée le mandat des administrateurs:
- M. Koenraad van der Borght, ayant pour adresse professionnelle le 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- M. Sybren de Vries, ayant pour adresse professionnelle le 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; et
- ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., représentée par M. Antoine Baronnet et par M. Julian Kramer, ayant son

siège social au 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

L'Assemblée a renouvelé le mandat du Réviseur d'Entreprises KMPG AUDIT S.à r.l, ayant son siège social au 31, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2007.

27714

K. Van Der Borght
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007027061/44/22.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00483. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Repco 27 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 118.328.

<i>Extrait des resolutions prises à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 25 janvier 2007

L'Assemblée des actionnaires a nommé Monsieur Derek McDonald, banquier, né le 9 août 1967 à Paisley, Ecosse,

demeurant 8, Glen Sannox Grove, Craigmarloch, UK-Cumbernauld G68 OGH, en tant qu'administrateur B de la Société
jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027093/280/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00797. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

BRE/GH II Berlin II Manager S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 124.001.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the eleventh day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 118.245.

here represented by Mrs. Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal in Luxembourg, on 9 January 2007.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and in particular in German «Kommanditgesellschaften» as general partner and any other form of
investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes or other securities of any kind and the administration, control and devel-
opment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is to borrow money in any form and give securities for any borrowings.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

27715

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration,  control  and  development.  For  that  purpose,  the  Company  may  require  and  retain  the  assistance  of  other
advisors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/GH II BERLIN II MANAGER S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.

Art. 10. The death, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of the shareholders may for any reason affix seals on assets or

documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.

The sole manager or the board of managers may grant powers of attorney by authentic proxy or by private instrument.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman, and

may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager,
and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

27716

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies, as
amended.

Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:
- five hundred (500) shares by BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12.500,-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the thirty-first

day of December 2007.

27717

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having

its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under section B number 96,323, is appointed manager of the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, den elften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

BRE/GERMAN  HOTEL  HOLDING  II  S.à  r.l.,  eine  société  à  responsabilité  limitée  gegründet  nach  dem  Recht  des

Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-
und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 118.245,

hier vertreten durch Frau Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschrift-

lichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 9. Januar 2007.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend  die  «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

insbesondere an deutschen Kommanditgesellschaften als Komplementär und Investitionen jeder Art, der Erwerb durch
Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise von Aktien,
Obligationen, Schuldscheinen und anderen Wertpapieren jeglicher Art und die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung
ihres Wertpapierbestandes.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Kreditaufnahme jeglicher Art und die Gewährung von Sicherheiten für

jegliche Kreditaufnahme.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den für die Verwaltung,

Kontrolle und Verwertung notwendigen Dienstleistungen versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/GH II BERLIN II MANAGER S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.

27718

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf (i) der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter (ii) wobei

diese Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der

Gesellschaft.

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-

genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus mindestens

zwei Geschäftsführern, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich oder aufgrund

notariell beglaubigter Urkunde erteilt.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

27719

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-

sellschaft nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

Art. 20. Die Gesellschaft darf nie mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Natürliche Personen können nicht Ge-

sellschafter der Gesellschaft werden.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- fünfhundert 500 Anteile wurden von BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet;
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.

27720

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

eintausendneunhundert Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit

Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter
Sektion B Nummer 96.323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: N. Schmidt-Troje, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 60, case 3. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt.

Mersch, den 26. Januar 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007026010/242/325.

(070020471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.

J. Hirsch &amp; Co International, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 102.323.

En vertu de la convention de cession de parts sociales datée du 29 décembre 2006, la société RAUPUS CONSUL-

TADORIA e MARKETING LDA, ayant son siège social à Rua dos Murças, 88-3 

o

 , P-9000 Funchal (Madeira), Portugal a

transféré la totalité de ses parts détenues dans la Société à Responsabilité Limitée J. HIRSCH &amp; CO INTERNATIONAL
de la manière suivante:

-125 parts sociales d'une valeur de EUR 100,- chacune, à la société J. HIRSCH &amp; CO. LLP ayant son siège social à

Colmore Row n. 55, Birmingham B3 2AS, United Kingdom.

Dès lors, l'intégralité des 125 parts de la société à responsabilité limitée J. HIRSCH &amp; CO INTERNATIONAL sont

détenues par la société J. HIRSCH &amp; Co LLP.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2007.

<i>Pour J. HIRSCH &amp; CO INTERNATIONAL
R. Thillens / C. Blondeau
<i>Gérant / <i>Gérant

Référence de publication: 2007027364/565/23.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01175. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

27721

ABN AMRO Rainbow Fund, Société d'Investissement à Capital Variable,

(anc. Corluy Rainbow Fund).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 82.875.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 18 octobre 2006

L'Assemblée a renouvelé pour une durée indéterminée le mandat des administrateurs:
- M. Koenraad van der Borght, ayant pour adresse professionnelle le 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- M. Sybren de Vries, ayant pour adresse professionnelle le 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; et
- ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., représentée par M. Antoine Baronnet et par M. Julian Kramer, ayant son

siège social au 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

L'Assemblée a renouvelé le mandat du Réviseur d'Entreprises KMPG AUDIT S.à r.l, ayant son siège social au 31, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2007.

K. Van Der Borght
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007027067/44/22.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00478. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Carpathian Cable Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 107.814.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 17 janvier 2007

L'associé unique a renouvelé les mandats de Monsieur Nicholas Campsie, en sa qualité de gérant B et de Maîtres

Georges Gudenburg et Pierre Metzler en leur qualité de gérants A de la Société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
ordinaire devant se tenir pour statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2007027084/280/18.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00792. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Parana Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 111.203.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2007027193/693/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00744. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

27722

Carpathian Cable Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.325.000,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 104.285.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 17 janvier 2007

L'associé unique a renouvelé les mandats de Monsieur Jacques Reckinger, et Maîtres Georges Gudenburg et Pierre

Metzler en qualité de gérants de la Société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir pour statuer
sur les comptes clos au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2007027078/280/18.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00796. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070021878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

PTL Holdings Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 63.102.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007027200/2460/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00454. - Reçu 50 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Kart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 112.680.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007027220/43/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01672. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Patagonia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 55.361.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2007027234/322/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01581. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

27723

AEF Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 133.000.000,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 101.687.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 16 janvier 2007

L'associé unique a renouvelé les mandats de Monsieur Jacques Reckinger, et Maîtres Georges Gudenburg et Pierre

Metzler en qualité de gérants de la Société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée devant se tenir en
2007 pour statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027086/280/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00800. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070021894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Résidences LES CHARMES Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5823 Fentange, 19, Op der Sterz.

R.C.S. Luxembourg B 69.125.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2007027187/3581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02407. - Reçu 93 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Halm B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 68.100,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 113.533.

Siège de la société mère: Den Haag, The Netherlands.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour HALM BV/S.àr.l.
Signature

Référence de publication: 2007027208/260/15.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01700. - Reçu 36 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

BIGF, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann.

R.C.S. Luxembourg B 95.780.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27724

Signature.

Référence de publication: 2007027215/802/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01383. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Actaris Expansion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 95.102.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ACTARIS EXPANSION S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007027201/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01373. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070021546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Competrol (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 46.016.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2007027194/710/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00779. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

2XTV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 107.101.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2XTV S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2007027203/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01375. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Interlab S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 67.197.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27725

Signature.

Référence de publication: 2007027218/43/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01667. - Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

BRE/GH II Berlin I Manager S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 123.996.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the eleventh day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 118,245.

here represented by Mrs. Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal in Luxembourg, on 9 January 2007.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and in particular in German «Kommanditgesellschaften» as general partner and any other form of
investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes or other securities of any kind and the administration, control and devel-
opment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is to borrow money in any form and give securities for any borrowings.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration,  control  and  development.  For  that  purpose,  the  Company  may  require  and  retain  the  assistance  of  other
advisors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/GH II BERLIN I MANAGER S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters of the share capital.

27726

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.

Art. 10. The death, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of the shareholders may for any reason affix seals on assets or

documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.

The sole manager or the board of managers may grant powers of attorney by authentic proxy or by private instrument.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman, and

may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager,
and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

27727

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies, as
amended.

Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:
- five hundred (500) shares by BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the thirty-first

day of December 2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having

its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under section B number 96,323, is appointed manager of the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

27728

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, den elften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

BRE/GERMAN  HOTEL  HOLDING  II  S.à  r.l.,  eine  société  à  responsabilité  limitée  gegründet  nach  dem  Recht  des

Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels
-und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 118.245,

hier vertreten durch Frau Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschrift-

lichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 9. Januar 2007.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

insbesondere an deutschen Kommanditgesellschaften als Komplementär und Investitionen jeder Art, der Erwerb durch
Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise von Aktien,
Obligationen, Schuldscheinen und anderen Wertpapieren jeglicher Art und die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung
ihres Wertpapierbestandes.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Kreditaufnahme jeglicher Art und die Gewährung von Sicherheiten für

jegliche Kreditaufnahme.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den für die Verwaltung,

Kontrolle und Verwertung notwendigen Dienstleistungen versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/GH II BERLIN I MANAGER S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter (ii) wobei

diese Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der

Gesellschaft.

27729

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-

genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus mindestens

zwei Geschäftsführern, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich oder aufgrund

notariell beglaubigter Urkunde erteilt.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-

sellschaft nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

27730

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung  gemäß  Sektion  XII  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften,  neue  Fassung,
zustehen.

Art. 20. Die Gesellschaft darf nie mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Natürliche Personen können nicht Ge-

sellschafter der Gesellschaft werden.

E. Geschäftsjahr - Kontengewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- fünfhundert 500 Anteile wurden von BRE/GERMAN HOTEL HOLDING II S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet;
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

eintausend neunhundert Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit

Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels -und Gesellschaftsregister unter
Sektion B Nummer 96.323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

27731

Gezeichnet: N. Schmidt-Troje, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 60, case 4. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Mersch, den 26. Januar 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007026011/242/325.
(070020441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2007.

Buttercup S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 117.636.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 30 janvier 2007

1. La société MONTEREY SERVICES S.A. a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Madame Elizabeth Le Poidevin, née le 26 août 1954 à Woking (Jersey), avec adresse professionnelle à La Motte

Chambers, St Helier, Jersey JE1 1BJ a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire
de 2012.

Luxembourg, le 1 

er

 février 2007.

<i>Pour BUTTERCUP S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007027094/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00633. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Sevsyl S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 103.494.

Le bilan au 30 septembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2007.

<i>Pour SEVSYL S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Référence de publication: 2007027204/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01493. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Highgate Finance &amp; Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 30.438.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27732

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2007027229/565/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01577. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Claremont Villas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 20, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 46.982.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007027222/759/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2007, réf. LSO-CA09691. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(070021515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Sabina International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 38.129.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2004 ainsi que l'affectation du résultat, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007027177/1134/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00833. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Pharmacos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 81.153.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2007027230/565/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01579. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Diamor International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 82.715.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27733

Luxembourg, le 22 décembre 2006.

S. Livoir.

Référence de publication: 2007027383/1197/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, réf. LSO-BX05163. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070021587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Patagonia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 55.361.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2007027236/322/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01583. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070021583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Patagonia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 55.361.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2007027238/322/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01586. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Akeler Marlow S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 65.763.

Les bilans aux 31 décembre 1998 et 1999 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AKELER MARLOW S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2007027277/1649/13.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01874. - Reçu 44 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Astrad S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 62.648.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27734

Luxembourg, le 9 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027271/1215/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01552. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Parabole S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 18.513.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2007.

<i>Pour PARABOLE S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Référence de publication: 2007027219/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01518. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Adanel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 123.753.

<i>Extrait de transfert de parts sociales

Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 15 janvier 2007 que:

LAYCA (MANAGEMENT) S.A., société anonyme, avec siège social 2 

nd

 Floor, Abbott Building, Road Town, Tortola,

immatriculée au registre des Iles Vierges Britanniques sous le numéro IBC 591194,

A cédé:
- 500 (cinq cents) parts sociales qu'elle détenait dans la société ADANEL SARL

A PROMAK NY, INC., société de droit américain, avec siège social à 8345 North West 66 

ème

 rue, 7438, Miami -

Floride, 33166 2626, USA.

Suite à ce transfert, les parts sociales de ADANEL S.A R.L. sont désormais réparties comme suit:

parts sociales

PROMAK NY, INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2007.

<i>Pour ADANEL SARL
MERCURIA SERVICES
<i>Mandataire
Signature

Référence de publication: 2007027367/1005/28.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10696. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070021485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

27735

Mojo Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4067 Esch-sur-Alzette, 29, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 124.121.

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-eight day of December.
Before us M 

e

 Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

1.- Mr Andrew Schmidt, Master of Business Administration in Strategic Planning, born in St. Paul, Minnesota (U.S.A.),

on July 26tn, 1977 residing in D-54290 Trier, Stockplatz 2

acting in his own name as well as in his capacity of proxyholder of
2.- Mr José Rodrigues, private employee, born in Luxembourg, on June 19th, 1979 residing in L-6615 Wasserbillig, 32,

rue des Celtes

3.- Mr Alex Johnson, Highschool graduate in Education, born in St. Paul, Minnesota, (U.S.A.), on September 14th, 1985

residing in MN 55025 Forsest Lake, 631 NW, 3rd Street U.S.A.and

4.- Mr Samuel Johnson, High School Graduate, born in St. Paul, Minnesota, (U.S.A.), on May 15th, 1985 residing in MN

55025 Forsest Lake, 631 NW, 3rd Street (USA)

the last three here represented by virtue of three proxies given on December 26th, 27th, and 28th, 2006,
said proxies after being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to

the present deed.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company to be incorporated.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.
The name of the company is MOJO LIMITED

Art. 2. The registered office is established in the municipality of Esch-sur-Alzette.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are the exploitation of a Pub with alcoholic and non-alcoholic

drinks and snacks.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,400.- (twelve thousand four hundred Euro) divided

into 100 (one hundred) corporate units with a nominal value of EUR 124.- (one hundred twenty-four Euro) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial

Companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate units transfer inter vivos to non-

members is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members' general meeting or of at least seventy-
five percent of the company's capital. In the case of the death of a member, the corporate units transfer to non-members
is subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the
remaining members have a pre-emption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to
a non-member.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to

pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by one or several managers who need not to be members and who are appointed

by the general meeting of members.

Towards third parties the managers have, by the joint signature of any two of them, the most extensive powers to act

on behalf of the company in all circumstances. If the managers are temporarily unable to act, the company's affairs can be
managed by two members acting under their joint signature.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

27736

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the

capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the
members representing three quarters of the capital.

Art. 15. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

Art. 16. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year has to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution

will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the corporate capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not be

members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,

pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant

legislation.

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st 2007.

<i>Subscription and payment

The 100 (one hundred) corporate units have been subscribed as follows:

1.- Mr Andrew Schmidt, fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.- Mr José Rodrigues, thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.- Mr Alex Johnson, ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.- Mr Samuel Johnson, ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Total: one hundred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

All the corporate units have been entirely paid up in cash so that the company has now at its disposal the sum of EUR

12,400.- (twelve thousand four hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

1,300.- EUR

<i>Resolutions of the members

The members, acting as foresaid, representing the whole of the corporate capital, passed the following resolutions:

<i>First resolution

The following have been elected as managers:
Mr José Rodrigues, prenamed, technical manager, and Mr Andrew Schmidt, prenamed administrative manager;
with the powers indicated in article 11 of the Articles of Incorporation.
The managers are elected for an undetermined period.

<i>Second resolution

The company's registered office is located at L-4067 Esch-sur-Alzette, 29, rue du Commerce.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above person

appearing, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person appearing
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

27737

The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the

notary by his surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with us, Notary,
the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- M. Andrew Schmidt, Master of Business Administration in Strategic Planning, né à St. Paul, Minnesota, U.S.A, le 26

juillet 1977 demeurant à D-54290 Trier, Stockplatz 2, agissant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire pour

2.- M. José Rodpjgues, employé privé, né à Luxembourg le 19 juin 1979 demeurant à L-6615 Wasserbillig, 32, rue des

Celtes

3.- M. Alex Johnson, Highschool Graduate in Education, ne a St. Paul, Minnesota, (U.S.A.), le September 14th, 1985

demeurant a MN 55025 Forsest Lake, 631 NW, 3rd Street U.S.A. y

4.- M. Samuel Johnson, High School Graduate, né à St. Paul, Minnesota, (U.S.A.) le 15 mai 1985 demeurant à MN 55025

Forsest Lake, 631 NW, 3rd Street (USA),

les trois derniers ici représentés en vertu de trois procurations données sous seing privé le 26, 27 et 28 décembre

2006,

lesquelles procuration après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera

annexé aux présentes.

Lesquels comparants ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée à constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les dispositions légales.

La société à responsabilité limitée prend la dénomination de MOJO LIMITED.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision collective des

associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées avec petite restau-

ration.

Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et

immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou
développer la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à 12.400,- EUR (douze mille quatre cents euros) représenté par 100 (cent) parts sociales

d'une valeur nominale de 124,-EUR (cent vingt-quatre euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des

associés.

Vis-à-vis des tiers, les gérants ont, par les signatures conjointes de deux d'entre eux, les pouvoirs les plus étendus pour

agir au nom de la société dans toutes les circonstances. En cas d'empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales
peuvent être gérées par deux associés, agissant conjointement.

27738

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est

une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les
articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007.

<i>Souscription et paiement

Les 100 (cent) parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit

1.- M. Andrew Schmidt, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.- M. José Rodrigues, trente parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.- M. Alex Johnson, dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.- M. Samuel Johnson, dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de

12.400,- EUR (douze mille quatre cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant
été donnée au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 1.300,- EUR.

<i>Assemblée constitutive

Les associés prédésignés, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérants:
- Monsieur José Rodrigues, prénommé; gérant technique, et Monsieur Andrew Schmidt, prénommé, gérant adminis-

tratif;

avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts.
Le mandat des gérants est établis pour une durée indéterminée.
Les gérants est rééligibles.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au L-4067 Esch-sur-Alzette, 29, rue du Commerce.

27739

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par noms, prénoms, états et demeures,

le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Schmidt, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 25, case 11. — Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 10 janvier 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007027382/206/219.
(070021953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

J.P. Morgan Partners Global Investors (Selldown) Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 105.131.

RECTIFICATIF

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (bilan

rectifié déposé le 18 décembre 2006 sous la réf. L060137970).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027281/780/14.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2007, réf. LSO-CB01360. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Antinori International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 51.236.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2006.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2007027241/535/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB01035. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Luxemburger Patentgesellschaft A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 56.640.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027253/1215/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01547. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

27740

Urbana S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 70.743.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027250/1215/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01755. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070021888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Internationale Handelsunion AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 70.713.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027262/1215/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01758. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Patagonia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 55.361.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 24 janvier 2007 au siège social

Il a été décidé ce qui suit:
- L'Assemblée décide nommer FIDALPHA S.A., 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg comme nouveau Commis-

saire au Comptes en remplacement de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Commissaire aux Comptes
démissionnaire.

Le mandat du nouveau Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'issue de L'Assemblée Générale Annuelle de

2010.

Pour extrait certifié conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2007027395/322/19.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01567. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Cash.Life Funding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 87.835.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 14 décembre 2006

Le Conseil d'Administration a décidé de transférer, avec effet au 1 

er

 décembre 2006, le siège social de la société à

l'adresse suivante:

- 16, avenue de la Porte Neuve, 2 

ème

 étage, L-2227 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2007.

27741

<i>Pour CASH. LIFE FUNDING S.A.
Signature
<i>Avocat

Référence de publication: 2007027313/267/18.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2007, réf. LSO-CA05948. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070021665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Peguform Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 97.587.

Le bilan et l'affectation des résultats au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2007.

<i>PEGUFORM LUXEMBOURG HOLDING S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Référence de publication: 2007028975/683/17.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB02077. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070022661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.

Soparfi 10 L S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 24.927.

<i>Extrait de résolutions prises lors de l'Assemblée Générale statutaire reportée tenue le 4 janvier 2007

<i>Délibération

L'Assemblée nomme la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. avec siège social au 5, boulevard de la Foire

L-1528 Luxembourg aux fonctions de Commissaire aux Comptes pour un mandat échéant à l'issue de l'Assemblée Gé-
nérale statutaire à tenir en l'an 2007.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 4 janvier 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007027390/1134/20.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00838. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Kulicke and Soffa Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 111.770.

<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 15 janvier 2007

L'actionnaire unique a:
1) Pris acte de la démission de Monsieur Robert F. Amweg de sa fonction de gérant de la société avec effet au 31

décembre 2006.

27742

2) Décidé de nommer Monsieur Michael J. Morris, Trésorier, demeurant à 149 Medinah Drive, Blue Bell, PA USA

19422, né le 21 octobre 1968 en Pennsylvanie, USA à la fonction de gérant de la société avec pouvoir de signature B, à
compter de ce jour et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de la société
au 30 septembre 2006.

Dès lors, le conseil de gérance est composé à ce jour des personnes suivantes:

<i>Signature A:

- François Brouxel.

<i>Signature B:

- Michael J. Morris;
- David J. Anderson;
- Charles Scott Kulicke;
- Maurice Eugène Carson.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 24 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007027072/280/28.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10342. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): D. Hartmann.

(070021874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

European Real Estate Financing Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 85.670.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2007.

<i>Pour EUROPEAN REAL ESTATE FINANCING COMPANY S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007027217/29/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01515. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Whitebay S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 105.720.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 26 janvier 2007 que:
- Le siège social est transféré du 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522

Luxembourg

- Monsieur Benoit Sirot a démissionné de sa fonction d'administrateur.
- Monsieur Natale Capula né à Villa S. Giovanni (Italie), le 1 

er

 novembre 1961, demeurant professionnellement à 12,

rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg a été élu administrateur. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée
Générale qui se tiendra en l'an 2012.

- Monsieur Olivier Dorier a démissionné de sa fonction de Commissaire.
- La société F.G.S. CONSULTING LLC, ayant son siège social à 520 S. 7th Street, Suite C Las Vegas, NV 89101 a été

élu Commissaire. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2011

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2007.

27743

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007027285/799/24.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01812. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

East Coast Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 114.412.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 26 janvier 2007 que:
- Le siège social est transféré du 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522

Luxembourg

- Monsieur Benoit Sirot a démissionné de sa fonction d'administrateur.
- Monsieur Natale Capula né à Villa S. Giovanni (Italie), le 1 

er

 novembre 1961, demeurant professionnellement à 12,

rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg a été élu administrateur. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée
Générale qui se tiendra en l'an 2012.

- Monsieur Olivier Dorier a démissionné de sa fonction de Commissaire.
- La société F.G.S. CONSULTING LLC, ayant son siège social à 520 S. 7th Street, Suite C Las Vegas, NV 89101 a été

élu Commissaire. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2011

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007027293/799/24.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01819. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

MTZ International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 89.436.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 26 janvier 2007 que:
- Le siège social est transféré du 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522

Luxembourg

- Monsieur Benoit Sirot a démissionné de sa fonction d'administrateur.
- Monsieur Natale Capula né à Villa S. Giovanni (Italie), le 1 

er

 novembre 1961, demeurant professionnellement à 12,

rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg a été élu administrateur. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée
Générale qui se tiendra en l'an 2012.

- Monsieur Olivier Dorier a démissionné de sa fonction de Commissaire.
- La société F.G.S. CONSULTING LLC, ayant son siège social à 520 S. 7th Street, Suite C Las Vegas, NV 89101 a été

élu Commissaire. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2011

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007027304/799/24.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01831. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070021946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

27744


Document Outline

2XTV S.A.

ABN AMRO Rainbow Fund

ABN AMRO V.I.P.

Actaris Expansion S.A.

Adanel S.à r.l.

AEF Holding S.à r.l.

Akeler Marlow S.à r.l.

Akeler Marlow S.à r.l.

Antinori International S.A.

Astrad S.A.

BIGF

BRE/GH II Berlin III Manager S. à r.l.

BRE/GH II Berlin II Manager S. à r.l.

BRE/GH II Berlin I Manager S. à r.l.

Buttercup S.A.

Carpathian Cable Investments S.à r.l.

Carpathian Cable Luxembourg S.à r.l.

Cash.Life Funding S.A.

Claremont Villas S.A.

Competrol (Luxembourg) S.à r.l.

Corluy Rainbow Fund

Corluy V.I.P.

Diamor International Holding S.A.

East Coast Investment S.A.

Equity Trust Fund Services (Luxembourg) S.A.

European Real Estate Financing Company S.A.

Forbach Invest S.à r.l.

Halm B.V.

Highgate Finance &amp; Holding S.A.

I Chateau VII S.à r.l.

Ilona Investments S.A.

Interlab S.A.

Internationale Handelsunion AG

Itaca S.A.

J. Hirsch &amp; Co International

J.P. Morgan Partners Global Investors (Selldown) Luxembourg, S.à r.l.

Kart S.A.

Kulicke and Soffa Luxembourg S.à r.l.

Luxemburger Patentgesellschaft A.G.

Majorcan Hotels Luxembourg S.à r.l.

Mojo Limited

MTZ International S.A.

Parabole S.A.

Parana Corporation S.à r.l.

Patagonia S.A.

Patagonia S.A.

Patagonia S.A.

Patagonia S.A.

Peguform Luxembourg Holding S.à r.l.

Pharmacos S.A.

PTL Holdings Luxembourg Sàrl

PTL Holdings Luxembourg Sàrl

Raiffeisen R01 (Luxembourg) S.A.

Repco 27 S.A.

Résidences LES CHARMES Sàrl

Sabina International S.A.

Saint Guy Immo S.à r.l.

Sevsyl S.A.

SHRM Corporate Services S.à r.l.

Soparfi 10 L S.A.

Tanglewood Finance S.à r.l.

Tanglewood Finance S.à r.l.

Urbana S.A.

Whitebay S.A.